MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

12.11.2007

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

Zumtobel Lighting GmbH

 

 

Registered Office :

Schweizerstraße  30, A-6850 Dornbirn

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

30.04.2007

 

 

Date of Incorporation :

1989-09-18

 

 

Legal Form :

Limited Liability Company

 

 

Line of Business :

Manufacture of lighting equipment and electric lamps

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Aa

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

Large

 

Maximum Credit Limit :

EUR  7.438.000

 

 

Status :

Excellent

 

 

Payment Behaviour :

Regular

 

 

Litigation :

Clear


Basic company information

 

Company name:

Zumtobel Lighting GmbH

Status:

active company

Locations:

Schweizerstraße  30, A-6850 Dornbirn

Phone:

(5572) 390

Fax:

(5572) 390 – 104

E-mail:

info@zumtobel.com

Internet:

http://www.zumtobel.com

Activities:

Önace 315000 80% Manufacture of lighting equipment and electric lamps

 

Önace 514301 10% Wholesale of electrical household appliances

 

Önace 333000 10% Manufacture of industrial process control equipment

 

General Assessment:

Very low risk

 

The Rating of this company is better than industry average.

 

 

Recommendation

We recommends to establish a business and credit relationship, and to benefit from arising business opportunities.

 

Detail Assessment:

Payment

Payments are sometimes made using cash discounts or according to conditions.

 

 

Assessment

Company's financial situation is in order. Earnings potential is positive.

 

 

Maximum credit EUR  7.438.000,00

 

Additional company information

 

 

 

 

Year of incorporation:

1989

 

Type of company:

industry

 

Legal form:

limited liability company since 1989-09-18

 

Firmenbuchnummer:

FN 62900 a Feldkirch 1989-11-03

 

Activities:

 

 

VAT number:

ATU 36137006

 

number - Austrian National Bank:

1346792

 

 

 

Import 

Country 

 

 

 

Import

Australia

 

2007

 

Import

Belgium

 

2007

 

Import

France

 

2007

 

Import

Germany

 

2007

 

Import

Italy

 

2007

 

Import

Netherlands

 

2007

 

Import

Switzerland

 

2007

 

Import

Great Britain and Northern Ireland / United Kingdom

 

2007

 

 

 

Export 

Country 

 

 

 

Export

world-wide

 

2007

 

 

 

Financial data

 

total turnover (total sales)

2006

EUR  323.353.307,06

(exact)

total turnover (total sales)

2005

EUR  287.055.118,43

(exact)

total turnover (total sales)

2004

EUR  272.742.720,84

(exact)

total turnover (total sales)

2003

EUR  254.486.969,79

(exact)

total turnover (total sales)

2002

EUR  257.372.297,60

(exact)

turnover (sales) - group

2006

EUR  1.233.951.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2005

EUR  1.167.994.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2004

EUR  1.129.169.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2003

EUR  1.142.216.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2002

EUR  1.186.505.000,00

(exact)

total employees

2007

1167

(exact)

white collar workers

2007

551

(exact)

blue collar workers

2007

557

(exact)

apprentices

2007

59

(exact)

total stock

2006

EUR  26.146.000,00

(approx.)

total investments

2006

EUR  31.106.160,46

(exact)

total company vehicles

2007

37

(approx.)

leasing vehicles

2007

37

(approx.)

 

 

Extraxt from the Companies' House

 

firm (style):

   56      Zumtobel Lighting GmbH

legal form:

    1      Gesellschaft mit beschränkter Haftung

registered office:

    1      politischer Gemeinde Dornbirn

business adress:

    5      Schweizerstraße 30
           6850 Dornbirn

capital:

   58      EUR 7.500.000

reference date annual accounts:

    1      30. April

annual accounts:

   61      zum 30.04.2006 eingereicht am 11.12.2006

power of representation:

    1      Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäfts-
           führer bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis.
           Gemischte Vertretung möglich.

proxy:

         J   Keith Lobo, geb. 19.03.1956
    1        vertritt seit 06.05.1991 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
         M   Fritz Riggenmann, geb. 24.03.1947
   28        vertritt seit 01.01.2000 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        AJ   DIng Klaus Vamberszky, geb. 15.08.1961
   18        vertritt seit 01.04.1998 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        AN   Helmut Kuhlmann, geb. 16.07.1954
   36        vertritt seit 08.03.2002 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        AO   Klaus Klocker, geb. 14.10.1956
   36        vertritt seit 08.03.2002 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        AQ   DI Dietmar Zembrot, geb. 15.03.1962
   37        vertritt seit 01.05.2002 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        AT   Lindsay Small, geb. 14.03.1953
   56        vertritt seit 01.03.2006 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        AY   Reinhardt Wurzer, geb. 27.05.1952
   48        vertritt seit 06.12.2004 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        AZ   Ralf Peter Knorrenschild, geb. 22.08.1964
   48        vertritt seit 06.12.2004 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        BB   Armin Heim, geb. 19.08.1957
   50        vertritt seit 07.02.2005 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        BE   Stefan Broscheid, geb. 20.04.1960
   51        vertritt seit 12.01.2005 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
        BF   Dr Eckart Schmitt, geb. 15.03.1965
   56        vertritt seit 01.03.2006 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        BG   Ing Thomas Bischof, geb. 10.06.1968
   56        vertritt seit 01.03.2006 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        BJ   Ing Christian Warum, geb. 30.11.1966
   62        vertritt seit 01.05.2007 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen

 

supervisory board:

        AS   Dr Andreas Ludwig, geb. 27.12.1959
   42        Vorsitzender
        AV   Dipl Wirtsch-Ing Thomas Spitzenpfeil, geb. 22.12.1962
   45        Stellvertreter des Vorsitzenden
        AW   Christian Schröder, geb. 19.11.1961
   45        Mitglied
        BA   Ludwig Auer, geb. 19.07.1955
   48        Mitglied
        BK   Mario Johannes Wintschnig, geb. 29.05.1961
   62        Mitglied

managing director:

        AL   Dr Peter Matt, geb. 27.10.1961
   29        vertritt seit 01.04.2000 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
        AM   Dkfm Gerd Pechura, geb. 13.10.1958
   50        vertritt seit 07.02.2005 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen

shareholder:

         Y   ZUMTOBEL AG
   60        .....................................  EUR 7.500.000
   60        ...............................................................................  EUR 7.500.000
                        ---------------------------------------------------------------------------------
                 Summen:                     EUR 7.500.000                  EUR 7.500.000

general table:

 Landesgericht Feldkirch
   1 datenersterfaßt am 24.11.1993                                  Geschäftsfall 915 Fr   238/93 g
       Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
   2 Ersterfassung abgeschlossen am 24.11.1993             Geschäftsfall 915 Fr   239/93 h
       Übernahme in das ADV-Firmenbuch
   3 eingetragen am 29.01.1994                                       Geschäftsfall  15 Fr   263/94 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.01.1994
   4 eingetragen am 12.04.1994                                       Geschäftsfall  15 Fr  1175/94 a
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.04.1994
   5 eingetragen am 06.05.1994                                       Geschäftsfall  15 Fr  1547/94 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.05.1994
   6 eingetragen am 27.05.1994                                       Geschäftsfall  15 Fr  1770/94 a
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.05.1994
   7 eingetragen am 24.12.1994                                       Geschäftsfall  15 Fr  4098/94 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.12.1994
   8 eingetragen am 02.02.1995                                       Geschäftsfall  15 Fr   368/95 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 31.01.1995
   9 eingetragen am 10.02.1995                                       Geschäftsfall  15 Fr   483/95 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.02.1995
  10 eingetragen am 01.09.1995                                      Geschäftsfall  15 Fr  3317/95 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.08.1995
  11 eingetragen am 28.11.1995                                      Geschäftsfall  15 Fr  4322/95 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.11.1995
  12 eingetragen am 27.09.1996                                      Geschäftsfall  15 Fr  3405/96 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.09.1996
  13 eingetragen am 26.11.1996                                      Geschäftsfall  15 Fr  4132/96 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 06.11.1996


  14 eingetragen am 13.05.1997                                      Geschäftsfall  15 Fr  1864/97 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.05.1997
  15 eingetragen am 10.09.1997                                      Geschäftsfall  15 Fr  3477/97 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.09.1997
  16 eingetragen am 04.10.1997                                      Geschäftsfall  15 Fr  3592/97 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.09.1997
  17 eingetragen am 07.05.1998                                      Geschäftsfall  15 Fr  1125/98 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.05.1998
  18 eingetragen am 07.05.1998                                      Geschäftsfall  15 Fr  1126/98 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.05.1998
  19 eingetragen am 07.05.1998                                      Geschäftsfall  15 Fr  1127/98 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.05.1998
  20 eingetragen am 14.08.1998                                      Geschäftsfall  15 Fr  2234/98 v
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.08.1998
  21 eingetragen am 04.09.1998                                      Geschäftsfall  15 Fr  2553/98 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 01.09.1998
  22 eingetragen am 31.12.1998                                      Geschäftsfall  15 Fr  4429/98 x
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.11.1998
  23 eingetragen am 19.03.1999                                      Geschäftsfall  15 Fr  5265/98 a
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.12.1998
  24 eingetragen am 26.06.1999                                      Geschäftsfall  15 Fr  4068/99 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.06.1999
  25 eingetragen am 29.09.1999                                      Geschäftsfall  15 Fr  6589/99 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.09.1999
  26 eingetragen am 29.09.1999                                      Geschäftsfall  15 Fr  6772/99 a
       Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 17.09.1999
  27 eingetragen am 11.02.2000                                      Geschäftsfall  15 Fr   945/00 h
       amtswegige Nachbearbeitung
  28 eingetragen am 11.02.2000                                      Geschäftsfall  15 Fr   944/00 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 10.02.2000
  29 eingetragen am 01.06.2000                                      Geschäftsfall  15 Fr  2627/00 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.04.2000
  30 eingetragen am 18.01.2001                                          Geschäftsfall  12 Fr  2803/00 v
       Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 13.11.2000
  31 eingetragen am 21.02.2001                                      Geschäftsfall  12 Fr   695/01 b
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 06.02.2001
  32 eingetragen am 21.02.2001                                      Geschäftsfall  12 Fr   916/01 b
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.02.2001
  33 eingetragen am 08.03.2001                                      Geschäftsfall  12 Fr  1229/01 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.03.2001
  34 eingetragen am 23.01.2002                                      Geschäftsfall  12 Fr  5390/01 g
       Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 20.12.2001
  35 eingetragen am 08.03.2002                                      Geschäftsfall  12 Fr   534/02 z
       amtswegige Nachbearbeitung
  36 eingetragen am 08.03.2002                                      Geschäftsfall  12 Fr   533/02 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.02.2002
  37 eingetragen am 18.06.2002                                      Geschäftsfall  12 Fr  2013/02 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.05.2002
  38 eingetragen am 07.12.2002                                      Geschäftsfall  12 Fr  4839/02 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 06.12.2002
  39 eingetragen am 11.12.2002                                      Geschäftsfall  12 Fr  4901/02 x
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 10.12.2002
  40 eingetragen am 18.02.2003                                      Geschäftsfall  12 Fr   237/03 x
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.01.2003
  41 eingetragen am 12.03.2003                                      Geschäftsfall  12 Fr   474/03 w
       Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 12.02.2003
  42 eingetragen am 04.09.2003                                      Geschäftsfall  12 Fr  3401/03 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.09.2003
  43 eingetragen am 26.03.2004                                      Geschäftsfall  12 Fr  1080/04 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.03.2004
  44 eingetragen am 16.06.2004                                      Geschäftsfall  12 Fr  2244/04 g
       Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 28.05.2004
  45 eingetragen am 16.06.2004                                      Geschäftsfall  12 Fr  2372/04 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.06.2004
  46 eingetragen am 03.12.2004                                      Geschäftsfall  12 Fr  4624/04 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 01.12.2004
  47 eingetragen am 13.01.2005                                      Geschäftsfall  12 Fr    89/05 x
       Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 07.01.2005
  48 eingetragen am 08.02.2005                                      Geschäftsfall  12 Fr   414/05 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.02.2005
  49 eingetragen am 18.02.2005                                      Geschäftsfall  12 Fr   516/05 z
       amtswegige Nachbearbeitung
  50 eingetragen am 18.02.2005                                      Geschäftsfall  12 Fr   515/05 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.02.2005
  51 eingetragen am 19.05.2005                                      Geschäftsfall  12 Fr  1338/05 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.05.2005
  52 eingetragen am 15.06.2005
  53 eingetragen am 07.12.2005                                      Geschäftsfall  12 Fr  3291/05 f
       amtswegige Nachbearbeitung
  55 eingetragen am 07.12.2005                                      Geschäftsfall  12 Fr  3269/05 y
       Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 02.12.2005
  56 eingetragen am 19.04.2006                                      Geschäftsfall  48 Fr    28/06 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 10.04.2006
  58 eingetragen am 19.05.2006                                      Geschäftsfall  48 Fr   149/06 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.05.2006
  59 eingetragen am 20.05.2006                                      Geschäftsfall  48 Fr   156/06 v
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.05.2006
  60 eingetragen am 23.05.2006                                      Geschäftsfall  48 Fr   157/06 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.05.2006
  61 eingetragen am 16.12.2006                                      Geschäftsfall  48 Fr  1127/06 x
       Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 11.12.2006
  62 eingetragen am 22.05.2007                                      Geschäftsfall  48 Fr   563/07 a
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.05.2007

 

Comment on Legal Information

 

Real estate

 

Private data

 

Surname

 

 

Date of birth

 

 

Address

 

 

Executive positions

 

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Dr.  Peter Matt

1961-10-27 

9442 Berneck Gstaldenstraße 7

manager

2

Dkfm.  Gerd Pechura

 

1958-10-13 

 

63263 Neu-Isenburg Freiherr vom Steinstraße 22

manager

 

0

 

Ing.  Thomas Bischof

 

1968-06-10 

 

6850 Dornbirn Schweizerstraße 30(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Stefan Broscheid

 

1960-04-20 

 

6850 Dornbirn Schweizerstraße 30(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Dipl-Ing.Dr.  Armin Heim

1957-08-19 

 

6923 Lauterach Dammstraße 12(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Klaus Klocker

 

1956-10-14 

 

6850 Dornbirn Schweizerstraße 30(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Ralf Peter Knorrenschild

 

1964-08-22 

 

6850 Dornbirn Schweizerstraße 30(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Helmut Kuhlmann

 

1954-07-16 

 

6850 Dornbirn Schweizerstraße 30(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Keith Lobo

 

1956-03-19 

 

6850 Dornbirn Schützenstraße 1 b

joint signing clerk,

head of sales

 

0

 

Fritz Riggenmann

 

1947-03-24 

 

6850 Dornbirn Schweizerstraße 30(c/o)

joint signing clerk,

head of purchasing

 

0

 

Dr.  Eckart Schmitt

 

1965-03-15 

 

6850 Dornbirn Schweizerstraße 30(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Lindsay Small

 

1953-03-14 

 

6850 Dornbirn Höchsterstraße 8(c/o)

joint signing clerk

 

1

 

Dipl-Ing.  Klaus Vamberszky

1961-08-15 

 

6850 Dornbirn Schweizerstraße 30(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Christian Warum

1966-11-30 

1210 Wien Pichelwangergasse 24

joint signing clerk

1

Reinhardt Wurzer

 

1952-05-27 

 

6850 Dornbirn Schweizerstraße 30(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Dipl-Ing.  Dietmar Zembrot

1962-03-15 

 

6850 Dornbirn Schweizerstraße 30(c/o)

joint signing clerk,

head of marketing

 

0

 

Dr.  Andreas Johannes Ludwig

1959-12-27 

 

6060 Hall Tirol Milserstraße 3

chairman of the supervisory board

 

5

 

Dipl-Vw  Thomas Spitzenpfeil

1962-12-22 

 

88131 Lindau Schneehalde 33

 

deputy chairman of the supervisory board

 

6

 

Ludwig Auer

 

1955-07-19 

 

6850 Dornbirn Höchsterstraße 8(c/o)

member of the supervisory board

 

1

 

Christian Schröder

 

1961-11-19 

 

6850 Dornbirn Höchsterstraße 8(c/o)

member of the supervisory board

 

2

 

Mario Johannes Wintschnig

1961-05-29 

6890 Lustenau Vorachstraße 66

member of the supervisory board

1

Markus Fössler

 

  

 

6850 Dornbirn Schweizerstraße 30(c/o)

head of accounting

 

0

 

Edwin Fritz

1938-09-11 

6850 Dornbirn Wieden 35

head of purchasing

0

Dipl-Ing.  Hans Achim Quitmann

1954-03-19 

 

6850 Dornbirn Höchsterstraße 8(c/o)

head of EDP

 

1

 

Dr.  Thomas Wand

  

9494 Schaan Krüzbündt 1

technical director

0

Mag.  Gernot Natter

 

  

 

6850 Dornbirn Schweizerstraße 30(c/o)

head of personnel

 

0

 

 

 

Balance Sheet  (absolute) all amounts in EUR 

 

 

2007-04-30 

 

 

 

 

Franchises, patents, licences, trademarks and similar rights and advantages

1.881.150,33

 

 

 

 

Sum intangible assets

1.881.150,33

 

 

 

 

 

Building investments in third party (leased) res residential and business buildings

169.477,00

 

 

 

 

Technical plants and machines

17.269.731,00

 

 

 

 

Advanced payments and constructions in progress

2.229.744,41

 

 

 

 

Sum tangible assets

22.959.093,49

 

 

 

 

 

Shares on related firms

167.728.218,20

 

 

 

 

Loans to related firms

88.094.045,12

 

 

 

 

Other financial assets, values and securities of fixed assets

37.066.253,71

 

 

 

 

Sum financial assets

292.888.517,03

 

 

 

 

 

Sum fixed assets

317.728.760,85

 

 

 

 

 

Raw-, auxiliary materials and supplies

6.178.914,67

 

 

 

 

Unfinished products

3.453.098,18

 

 

 

 

Finished products

19.713.384,32

 

 

 

 

Sum stock

29.345.397,17

 

 

 

 

 

Claims from delivered goods and performed services

1.825.018,02

 

 

 

 

Other claims and assets

4.937.115,39

 

 

 

 

Claims against companies with shareholding relationship

1.542.784,40

 

 

 

 

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

142.134.917,65

 

 

 

 

Sum claims

150.439.835,46

 

 

 

 

 

Cash on hand, cheques and bank deposits

8.090.242,35

 

 

 

 

Sum cash and bank

8.090.242,35

 

 

 

 

 

Sum current assets

187.875.474,98

 

 

 

 

 

Deferred charges

373.034,60

 

 

 

 

Sum deferred charges

373.034,60

 

 

 

 

Assets

505.977.270,43

 

 

 

 

 

Subscribed/declared capital

7.500.000,00

 

 

 

 

Committed capital reserves

136.998.949,48

 

 

 

 

Not committed capital reserves

28.251.815,82

 

 

 

 

Free reserves

5.813.826,73

 

 

 

 

Balance sheet profit/balance sheet loss

102.530.899,57

 

 

 

 

Thereof profit/loss carried forward

101.022.316,39

 

 

 

 

Sum equity capital

281.095.491,60

 

 

 

 

 

Valuation reserves due to special depreciations and

95.601,11

 

 

 

 

Sum reserves before taxes

95.601,11

 

 

 

 

 

Reserves for severance pays

14.857.647,00

 

 

 

 

Other reserves

14.657.932,41

 

 

 

 

Sum reserves

29.515.579,41

 

 

 

 

 

Liabilities against credit institutes

157.642.596,18

 

 

 

 

Received advanced payments for orders

62.248,38

 

 

 

 

Liabilities from delivered goods and performed services from the acceptance of drafts and emission of promissory notes

14.049.081,95

 

 

 

 

Liabilities against related firms

17.530.370,10

 

 

 

 

Liabilities against firm with shareholding relationship

1.202.704,74

 

 

 

 

Other liabilities

4.783.596,96

 

 

 

 

Sum liabilities

195.270.598,31

 

 

 

 

 

Liabilities

505.977.270,43

 

 

 

 

 

Contingent liabilities

129.800.350,07

 

 

 

 

Balance sheet sum

505.977.270,43

 

 

 

 

 

 

P / L Account  (absolute) all amounts in

EUR 

 

 

2007-04-30 

 

 

 

 

Gross sales 

323.353.307,06

 

 

 

 

Increase or decrease in finished and unfinished goods and in service claims 

-7.300.083,89

 

 

 

 

Other manufacturing costs capitalized 

341.609,72

 

 

 

 

Sum turnover or sum gross profit 

316.394.832,89

 

 

 

 

 

Profits from retirement of fixed assets, except financial assets 

22.755,00

 

 

 

 

Income from dissolution of reserves 

259.539,00

 

 

 

 

Other operating profits 

18.777.318,96

 

 

 

 

Other operating profits totally 

19.059.612,96

 

 

 

 

 

Costs for obtained services 

-5.748.205,93

 

 

 

 

Special account material costs 

-190.490.137,53

 

 

 

 

Costs for obtained services totally 

-196.238.343,46

 

 

 

 

 

Wages 

-15.413.105,52

 

 

 

 

Salaries 

-30.013.055,15

 

 

 

 

Costs for severance pays 

-897.386,59

 

 

 

 

Costs for old age pension 

-32.392,68

 

 

 

 

Legal fringe benefits and other payments depending on salaries 

-11.850.935,20

 

 

 

 

Other social fringe benefits 

-1.204.152,86

 

 

 

 

Personnel expenses totally 

-59.411.028,00

 

 

 

 

 

Depreciation of intangible assets, tangible assets, activated expenses for the set up and expansion of business operation 

-8.293.857,47

 

 

 

 

Depreciation tangible assets / intangible assets totally 

-8.293.857,47

 

 

 

 

 

Different operating costs 

-46.110.369,36

 

 

 

 

Other taxes 

-390.305,43

 

 

 

 

Other operating costs totally 

-46.500.674,79

 

 

 

 

 

Operating result totally 

25.010.542,13

 

 

 

 

 

Profits from shareholdings 

7.040.105,86

 

 

 

 

Interest income, securities income and similar income 

302.551,92

 

 

 

 

Profits from the retirement of and investment in financial assets 

2.700.000,00

 

 

 

 

Financial profits 

12.015.962,28

 

 

 

 

Interest and similar disbursements 

-12.470.322,08

 

 

 

 

Financial expenses 

-41.446.756,93

 

 

 

 

Financial profits totally 

-31.858.458,95

 

 

 

 

 

Results from usual business activity totally 

-6.847.916,82

 

 

 

 

 

Extraordinary profits 

8.360.000,00

 

 

 

 

Extraordinary result totally 

8.360.000,00

 

 

 

 

 

Taxes on income and profits 

-3.500,00

 

 

 

 

Taxes on income and profits totally 

-3.500,00

 

 

 

 

Annual surplus/annual deficit totally 

1.508.583,18

 

 

 

 

 

Annual profit/annual loss totally 

1.508.583,18

 

 

 

 

 

Profit and loss carried forward from previous year 

101.022.316,39

 

 

 

 

Transfer of profits totally 

101.022.316,39

 

 

 

 

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account 

102.530.899,57

 

 

 

 

 

 

Key ratios

 

 

2007  

 

 

 

 

 

Cash flow II

  9.802.440,65

 

 

 

 

 

Debt amortisation period

  22,10

 

 

 

 

 

Bank indebtedness

  31,15

 

 

 

 

 

Equity capital share

  55,57

 

 

 

 

 

Social capital share

  2,93

 

 

 

 

 

Fixed assets coverage

  93,17

 

 

 

 

 

Net profit ratio

  -2,16

 

 

 

 

 

Capital turnover

  0,62

 

 

 

 

 

Return on investment

  1,11

 

 

 

 

 

Cash flow in % of operating performance

  3,09

 

 

 

 

 

Cash flow I

  1.445.940,65

 

 

 

 

 

Gross productivity

  5,32

 

 

 

 

 

Net productivity

  2,02

 

 

 

 

 

Operating performance

  316.394.832,89

 

 

 

 

 

Inventories in % of operating performance

  9,27

 

 

 

 

 

Gross profit

  120.156.489,43

 

 

 

 

 

 

 

Locations

 

Type

Locations

Description

 

 

E-mail 

operational 

Schweizerstraße  30, A-6850 Dornbirn

registered office 

 

 

 

operational 

Schweizerstraße  30, A-6850 Dornbirn

registered headquarters, rented premises 

 

 

info@zumtobel.com

operational 

Postfach  198, A-6850 Dornbirn

postbox 

 

 

 

operational 

Höchsterstraße  8, A-6850 Dornbirn

branch office 

 

 

 

operational 

Schmelzhütterstraße  26, A-6850 Dornbirn

branch office 

 

 

 

former 

Hans Maierstraße  1, A-6020 Innsbruck

branch office 

 

 

 

former 

Sandgasse  41, A-8020 Graz

branch office 

 

 

 

former 

Ramsauerstraße  23, A-9020 Klagenfurt

branch office 

 

 

 

former 

Höchsterstraße  8, A-6850 Dornbirn

factory 

 

 

 

former 

Jasomirgottstraße  3-5, A-1010 Wien

showroom 

 

 

 

former 

Lassallestraße  7 a, A-1020 Wien

branch office 

 

 

 

former 

Hafenstraße  43, A-4020 Linz

branch office 

 

 

 

former 

Richard Neutragasse  6, A-1210 Wien

branch office 

 

 

 

former 

Paschingerstraße  47, A-4060 Leonding

branch office 

 

 

 

former 

Ginzkeyplatz  3, A-5020 Salzburg

branch office 

 

 

 

related companies

 

Company name

 

Postal code

 

Stake in %

 

Companies House

 

 

ZUMTOBEL AG

 

Höchsterstraße  8, A-6850 Dornbirn

100 % 1989-09-18

 

FN 62309 g

 

 

 

 

This company holds 100% of the shares in:

Zumtobel TRUST Gesellschaft m.b.H.

Höchsterstraße  8, A-6850 Dornbirn

100 % 2004-12-02

 

FN 62848 z

 

 

Zumtobel Licht GmbH

 

Schweizerstraße  30, A-6850 Dornbirn

100 % 1994-11-03

 

FN 124928 v

 

 

 

This company holds 50% to 99% of the shares in:

LEDON Lighting GmbH

 

Lustenau Millennium Park  2, A-6890 Lustenau

51 % 2006-01-21

 

FN 272558 x

 

 

 

Affiliated companies and further participations:

THORN Licht Gesellschaft m.b.H.

Schweizerstraße  30, A-6850 Dornbirn

 

 

FN 55302 b

 

 

Taxiflug-Gesellschaft m.b.H. in Liqu.

Höchsterstraße  8, A-6850 Dornbirn

 

 

FN 62323 b

 

 

Zumtobel TRUST Gesellschaft m.b.H.

Höchsterstraße  8, A-6850 Dornbirn

 

 

FN 62848 z

 

 

Zumtobel Holding Gesellschaft mbH

Höchsterstraße  8, A-6850 Dornbirn

 

 

FN 137114 p

 

 

TridonicAtco GmbH

 

Färbergasse  15, A-6850 Dornbirn

 

 

FN 218015 k

 

 

 

 

Bankers

 

 

 

 

Banker

Bank sort code

Type of banking connection

Bank Austria Creditanstalt AG, 6901 Bregenz

 

12000

 

main bank connection

 

Dornbirner Sparkasse, 6850 Dornbirn

 

20602

 

main bank connection

 

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft, 1011 Wien

 

14000

 

secondary banking connection

 

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktienges., 6021 Innsbruck

 

16000

 

secondary banking connection

 

Vorarlberger Volksbank, 6830 Rankweil

 

45710

 

secondary banking connection

 

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktienges., 6901 Bregenz

 

58000

 

secondary banking connection

 

 

 

Historical development

 

Year of incorporation:

1989

Date of registration:

1989-11-03

 

Change of company name:

From

To

Company name

   

  2006-04-19

Zumtobel Staff GmbH 

  2006-04-19

   

Zumtobel Lighting GmbH 

 

Change in share capital:

From

To

Capital

   

  2002-12-09

ATS  100.000.000,00

  2002-12-09

  2006-05-19

EUR  7.267.400,00

  2006-05-19

   

EUR  7.500.000,00

 

Former executives:

From

To

Function

Name

   

  1997-05-13

manager 

Dr. Gerhardt Oberlechner 

   

  1997-05-13

manager 

Dr. Michael Steudel 

  1998-09-04

  1999-06-26

manager 

Erwin Huber 

  1998-09-04

  1999-06-26

manager 

Jozef Slaets 

  1997-05-13

  1999-09-29

manager 

Wilhelm Richard Tschol 

  1997-05-13

  2000-02-11

manager 

Elmar Fröis 

  2004-03-26

  2005-12-07

manager 

Marcus Billmann 

  1999-09-29

  2006-05-19

manager 

Dr. Jürgen Koprio 

  2005-02-08

  2007-05-22

manager 

Dr. Thomas Wand 

   

  1996-11-26

joint signing clerk 

Kurt Gmeiner 

   

  1997-05-13

joint signing clerk 

Elmar Fröis 

   

  1998-05-07

joint signing clerk 

Ing. Heinrich Empl 

   

  1998-05-07

joint signing clerk 

Ing. Gustav Heuschmidt 

   

  1998-05-07

joint signing clerk 

Ing. Paul Heinz Schwendinger 

   

  1998-05-07

joint signing clerk 

Ing. Roman Smutny 

   

  1998-05-07

joint signing clerk 

Herwig Waldhof 

   

  1998-08-14

joint signing clerk 

Elmar Sohm 

   

  1998-08-14

joint signing clerk 

Ing. Heinz Stieger 

  1998-05-07

  1998-09-04

joint signing clerk 

Erwin Huber 

  1998-05-07

  1998-09-04

joint signing clerk 

Jozef Slaets 

  1999-06-26

  1999-09-29

joint signing clerk 

Dr. Jürgen Koprio 

   

  2001-02-21

joint signing clerk 

Gerald Nosko 

   

  2002-03-08

joint signing clerk 

Mag. Peter Simma 

   

  2002-06-18

joint signing clerk 

Edwin Fritz 

  1997-05-13

  2003-02-18

joint signing clerk 

Dr. Andreas Hartweg 

  1999-06-26

  2005-02-08

joint signing clerk 

Jozef Slaets 

  2002-03-08

  2005-02-17

joint signing clerk 

Dkfm. Gerd Pechura 

  1997-05-13

  2005-06-15

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Hermann Eberle 

  1998-05-07

  2005-06-15

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Richard Eberle 

  1999-06-26

  2005-12-07

joint signing clerk 

Erwin Huber 

  2005-02-17

  2006-04-19

joint signing clerk 

Daniel Burkard 

  2005-02-17

  2006-04-19

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Joachim Geiginger 

  2002-03-08

  2006-04-19

joint signing clerk 

Mag. Norbert Steiner 

  1993-11-24

  2003-09-04

chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing. Jürg Zumtobel 

   

  2003-09-04

deputy chairman of the supervisory board 

Walter Martin Dünser 

  2003-09-04

  2005-05-19

deputy chairman of the supervisory board 

Dr. Peter Kleinitzer 

   

  2005-05-19

deputy chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing. Fritz Zumtobel 

   

  2004-06-16

member of the supervisory board 

Dr. Peter Kleinitzer 

  2003-09-04

  2004-06-16

member of the supervisory board 

Lindsay Small 

   

  2005-02-08

member of the supervisory board 

Stefan Meusburger 

   

  2007-05-22

member of the supervisory board 

Hubert Buyle 

 

Former shareholders:

From

To

Function

Name

  2002-12-07

  2002-12-11

partner 

Kathrein & Co. II Vermögens- verwaltungs GmbH 

  2006-05-19

  2006-05-20

partner 

Kathrein & Co Vierte Vermögens verwaltungs und Beteiligungs GmbH & Co KG 

  2006-05-20

  2006-05-23

partner 

Kathrein & Co. Fünfte Vermögen sverwaltungs GmbH 

 

Former shareholdings:

From

To

Name

  1962-12-04

  1999-09-28

Bartenbach Lichtsysteme GmbH 

  2001-04-27

  2005-02-16

Thorn Lighting Group Holding GmbH 

  2003-01-22

  2007-09-14

Zumtobel Pool GmbH 

  1997-11-28

  1998-11-28

LUXMATE Controls GmbH 

 

Mergers:

Date

Function

Name

   

merged with 

GAC Beteiligungsverwaltungs GmbH 

  2004-12-13

merged with 

LUXMATE Controls GmbH 

   

merged with 

GAF Beteiligungsverwaltungs GmbH 

 

 


 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Unfavourable & favourable factors carry similar weight in credit consideration. Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

NR

In view of the lack of information, we have no basis upon which to recommend credit dealings

No Rating

 

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions