MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :            

23.04.2011

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Correct Name :

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG

 

 

Formerly Known As :

ROSENBAUER INTERNATIONAL Aktiengesellschaft 

 

 

Registered Office :

Paschingerstraße  90, A-4060 Leonding, (Verwaltung und Werk)

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

31.12.2010

 

 

Date of Incorporation :

03.11.1992

 

 

Legal Form :

Joint Stock Company

 

 

Line of Business :

Manufacture of motor vehicles

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

A

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

Fairly Large

 

Maximum Credit Limit :

EUR  7.872.000,00

Status :

Good

Payment Behaviour :

Regular

Litigation :

Clear

 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – December 31, 2010

 

Country Name

Previous Rating

                   (30.09.2010)                  

Current Rating

(31.12.2010)

Austria

a2

a2

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


Basic company information

 

Company name:

Rosenbauer International AG

Status:

active company

Locations:

Paschingerstraße  90, A-4060 Leonding, (Verwaltung und Werk)

Phone:

0043 (732) 6794

Fax:

0043 (732) 6794 - 89

E-mail:

ir@rosenbauer.co.at

Internet:

http://www.rosenbauer.com

Activities:

Önace 29100 70% Manufacture of motor vehicles

 

Önace 28290 30% Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c.

 

General Assessment:

The Rating of this company is better than industry average.

 

Recommendation

We recommends to establish a business and credit relationship, and to benefit from arising business opportunities. The solvency of the company is above average, risk is considered very low.

 

Detail Assessment:

Payments are made correctly.

 

Financial situation is very good. Earnings potential is positive. situation is regarded to be positive.

 

Maximum credit EUR  7.872.000,00

 

 

Additional company information

 

Year of incorporation:

1866

 

Type of company:

Manufacturing

 

Legal form:

joint stock company since 1992-08-28

 

companies' house number:

FN 78543 f Linz 1992-11-03

 

Activities:

 

 

VAT number:

ATU 22669609

 

number - Austrian National Bank:

1875710

 

 

 

 

Import 

Country 

 

 

 

Import

Germany

 

2011

 

Import

USA

 

2011

 

 

 

Export 

Country 

 

 

 

Export

world-wide

 

2011

 

 


Financial data

 

total turnover (total sales)

2010

EUR  342.223.929,51

(exact)

total turnover (total sales)

2009

EUR  323.000.447,54

(exact)

total turnover (total sales)

2008

EUR  267.156.848,67

(exact)

total turnover (total sales)

2007

EUR  224.492.174,55

(exact)

total turnover (total sales)

2006

EUR  175.693.000,75

(exact)

turnover (sales) - group

2010

EUR  595.687.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2009

EUR  541.808.200,00

(exact)

turnover (sales) - group

2008

EUR  500.349.300,00

(exact)

turnover (sales) - group

2007

EUR  426.128.300,00

(exact)

turnover (sales) - group

2006

EUR  371.966.000,00

(exact)

total employees

2011

883

(average)

total investments

2010

EUR  12.511.904,88

(exact)

 

 

Extraxt from the Companies' House

 

firm (style):

   40      Rosenbauer International AG

legal form:

    1      Aktiengesellschaft

registered office:

    1      politischer Gemeinde Leonding

business adress:

    1      Paschinger Str. 90
           4060 Leonding

capital:

   34      EUR 13.600.000

reference date annual accounts:

    1      31. Dezember

annual accounts:

   40      zum 31.12.2009 eingereicht am 09.08.2010

reference date consolidated accounts:

   38      31. Dezember

consolidated accounts:

   40      zum 31.12.2009 eingereicht am 09.08.2010

power of representation:

    1      Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder
           bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder
           durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen
           vertreten.

other provisions:

    1      Der Vorstand besteht aus ein bis sechs Personen.

board of directors:

         A   Julian Wagner, geb. 28.07.1950
    1        Vorsitzender
             vertritt seit 03.11.1992 gemeinsam mit
             einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
         C   Mag. Robert Kastil, geb. 15.04.1949
    1        vertritt seit 01.10.1993 gemeinsam mit
             einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
         D   Mag. Manfred Schwetz, geb. 25.08.1946
    1        vertritt seit 01.10.1993 gemeinsam mit
             einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
         W   Dipl.-Ing. Gottfried Brunbauer, geb. 31.07.1960
   19        vertritt seit 28.09.2000 gemeinsam mit
             einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
        AE   Dr. Dieter Siegel, geb. 20.09.1964
   42        vertritt seit 01.01.2011 gemeinsam mit
             einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

proxy:

         E   Wolfram Walter Mücke, geb. 23.03.1950
    1        vertritt seit 03.11.1992 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren
             Gesamtprokuristen
         Q   Mag. Josef Kern, geb. 16.05.1957
    5        vertritt seit 14.09.1995 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied.
         S   Dr. Markus Josef Öttl, geb. 27.03.1950
    5        vertritt seit 14.09.1995 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied.
         X   Dipl.-Ing. Hubert Heissl, geb. 24.05.1961
    9        vertritt seit 18.12.1997 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied.
         Y   Hans Detzlhofer, geb. 01.07.1961
   10        vertritt seit 24.06.1998 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied.
         Z   Mag. Winfried Brandlhofer, geb. 04.12.1947
   13        vertritt seit 21.12.1998 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied
        AB   Ing. Ralph Schmid, geb. 18.08.1959
   13        vertritt seit 21.12.1998 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied
        AC   Dipl.-Ing. Christian Kleebauer, geb. 03.01.1960
   16        vertritt seit 23.12.1999 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied
        AD   Dipl.-Ing.Dr. Rudolf Hammerschmid, geb. 08.07.1959
   20        vertritt seit 03.04.2001 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied
        AH   Dipl.Ing. Gerhard Wierer, geb. 31.07.1968
   29        vertritt seit 02.03.2005 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied
        AJ   Mag. Michael Wagner, geb. 07.10.1969
   30        vertritt seit 22.07.2005 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied
        AN   Ing. Wilhelm Pötscher, geb. 20.07.1955
   39        vertritt seit 28.08.2010 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied
        AP   Dipl.-Ing. Stefan Hofbauer, geb. 17.01.1972
   43        vertritt seit 18.03.2011 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied

supervisory board:

        AF   Dr. Alfred Hutterer, geb. 14.09.1947
   33        Vorsitzender
        AG   Ing. Rudolf Aichinger, geb. 26.01.1962
   26        Mitglied
        AI   Alfred Greslehner, geb. 15.01.1960
   31        Mitglied
        AK   Dr. Christian Reisinger, geb. 18.09.1960
   33        Stellvertreter
        AL   DI Karl Ozlsberger, geb. 03.10.1948
   33        Mitglied
        AM   Mag. Dr. Rainer Siegel, MBA, geb. 05.10.1963
   38        Mitglied

general table:

 Landesgericht Linz
   1 Ersterfassung abgeschlossen am 09.02.1994  Geschäftsfall 914 Fr    49/94 w
       Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
   3 eingetragen am 23.09.1994                  Geschäftsfall  17 Fr  4001/94 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.09.1994
   5 eingetragen am 23.09.1995                  Geschäftsfall  12 Fr  4256/95 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.09.1995
   9 eingetragen am 31.12.1997                  Geschäftsfall  12 Fr  7598/97 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.12.1997
  10 eingetragen am 30.06.1998                  Geschäftsfall  13 Fr  2981/98 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.06.1998
  13 eingetragen am 19.01.1999                  Geschäftsfall  13 Fr  9745/98 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.12.1998
  15 eingetragen am 15.10.1999                  Geschäftsfall  34 Fr  3456/99 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 15.09.1999
  16 eingetragen am 20.01.2000                  Geschäftsfall  34 Fr  5366/99 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 27.12.1999
  19 eingetragen am 09.02.2001                  Geschäftsfall  32 Fr   116/01 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.01.2001
  20 eingetragen am 13.04.2001                  Geschäftsfall  32 Fr  1191/01 v
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.04.2001
  23 eingetragen am 09.07.2002                  Geschäftsfall  32 Fr  2804/02 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.06.2002
  25 eingetragen am 06.09.2003                  Geschäftsfall  32 Fr  3208/03 b
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.07.2003
  26 eingetragen am 20.09.2003                  Geschäftsfall  32 Fr  4118/03 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.09.2003
  27 eingetragen am 22.07.2004                  Geschäftsfall  32 Fr  3487/04 x
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.07.2004
  28 eingetragen am 15.10.2004                  Geschäftsfall  32 Fr  4318/04 v
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 10.09.2004
  29 eingetragen am 02.03.2005                  Geschäftsfall  32 Fr   868/05 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.02.2005
  30 eingetragen am 22.07.2005                  Geschäftsfall  32 Fr  3681/05 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.07.2005
  31 eingetragen am 25.08.2005                  Geschäftsfall  32 Fr  3597/05 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.07.2005
  32 eingetragen am 25.07.2006                  Geschäftsfall  32 Fr  3205/06 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.06.2006
  33 eingetragen am 01.06.2007                  Geschäftsfall  32 Fr  2424/07 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 31.05.2007
  34 eingetragen am 09.06.2007                  Geschäftsfall  32 Fr  2425/07 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 31.05.2007
  35 eingetragen am 19.07.2008                  Geschäftsfall  32 Fr  2680/08 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 27.06.2008
  38 eingetragen am 27.06.2009                  Geschäftsfall  32 Fr  2838/09 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.06.2009
  39 eingetragen am 28.08.2010                  Geschäftsfall  32 Fr  4053/10 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.08.2010
  40 eingetragen am 30.09.2010                  Geschäftsfall  32 Fr  3857/10 v
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.08.2010
  42 eingetragen am 21.01.2011                  Geschäftsfall  32 Fr   256/11 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.01.2011
  43 eingetragen am 24.03.2011                  Geschäftsfall  32 Fr  2859/11 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.03.2011

 

 

Real estate

 

Registration number of real estate  2680  Cadastral register  45306  Leonding O  Number and date of entry  1813/2008  Status of  2010-08-05 

Part A - type of real estate  :

   2003/1   G GST-Fläche        *     3741
              Baufl.(Gebäude)         1245
              Sonstige                2496
              (Werksgelände)                Paschinger Straße 90-92
   2005/3   G GST-Fläche        *    48756
              Baufl.(Gebäude)        18740
              Sonstige               30016
              (Werksgelände)                Paschinger Straße 90-92
   2007/4   G GST-Fläche             18346
              Baufl.(Gebäude)         7563
              Sonstige               10783
              (Werksgelände)                Paschinger Straße 90-92
   2009     G Baufl.(begrünt)   *      505
   2010/2   G GST-Fläche        *     1663
              Baufl.(Gebäude)          260
              Baufl.(begrünt)         1403  Paschinger Straße 78
    GESAMTFLÄCHE                     73011
    1  a 763/1985 Verpflichtung zur Errichtung und Erhaltung von vier
           Stellplätzen auf Gst 2005/3 (Bescheid 1984-12-11)
    2  a 3703/1987 Tauschvertrag 1986-12-05 Zuschreibung Teilfläche(n) Gst
           2008/5 (Teil 12) aus EZ 3310, Einbeziehung in 2005/3 (P 164/87)
    4  a 3703/1987 Tauschvertrag 1986-12-05 Zuschreibung Teilfläche(n) Gst
           2007/3 (Teil 4) aus EZ 740, Einbeziehung in Gst 2005/3 (P 164/87)
    6  a 3703/1987 Tauschvertrag 1986-12-05 Zuschreibung Teilfläche(n) Gst
           2005/2 (Teil 2) aus EZ 740, Einbeziehung in Gst 2005/3 (P 164/87)
    7  a 3703/1987 Tauschvertrag 1086-12-05 Zuschreibung Teilfläche(n) Gst
           2009 (Teil 6) aus EZ 1131, Einbeziehung in 2005/3 (P 164/87)
    8  a 4432/1993 Verpflichtung zur Errichtung und Erhaltung von 9 Stellplätzen
           auf Gst 2005/3 (Bescheid 1993-05-24, GZ. III/1-871-131/9-6152-1993)
    9  a 843/2003 Verpflichtung zur Errichtung und Erhaltung von zusätzlich 8
           Stellplätzen auf Gst 2005/3
           (Bescheid 2003-01-31, III/1-3112-131/9-2002 Stü/au)
   10  a 1605/2005 Zuschreibung Gst 2007/4 aus EZ 2360
   11  a 1605/2005 GEMEINSAMER BAUPLATZ auf Gst 2005/3 2007/4
           Bescheid 2005-03-09, GZ III/1-549-031/6-2005
   12  a 2287/2005 Verpflichtung zur Errichtung und Erhaltung von
           25 Stellplätzen auf Gst 2005/3
           (Bescheid 21.4.2005, GZ. III/1-0167-131/9-2005 Go/brl)
   13  a 3670/2005 Verpflichtung zur Errichtung und Erhaltung von 34
           Stellplätzen auf Gst 2005/3; Bescheid 2005-07-12, GZ
           III/1-1574-131/9-2005
   14  a 5242/2007 Kaufvertrag 2007-05-11 Zuschreibung Teilfläche(n) Gst
           2007/3 (TF 1) aus EZ 740, Einbeziehung in Gst 2005/3 (P 545/07,
           GZ 1709/07)
   15  a 1813/2008 Bescheid 2008-02-28 Zuschreibung Gst 2003/1 aus EZ 593, Gst
           2009 aus EZ 1131, Gst 2010/2 aus EZ 2582
 

Part B - ownership details  :

    1 ANTEIL: 1/1
      Rosenbauer International Aktiengesellschaft
      ADR: Paschinger Str. 90, Leonding   4060
       c 4443/1988 IM RANG 2839/1988 Einbringungsvertrag 1988-06-17
           Eigentumsrecht
       d 5160/1993 Änderung der Firma
 

Part C - registered charges  :

    1  a 521/1966
           WIEDERKAUFSRECHT gem Pkt Sechstens Kaufvertrag 1965-07-20
           für Ortsgemeinde Leonding
    3  a 2582/1970 466/1975
           DIENSTBARKEIT der Duldung, der Errichtung des Bestandes und
           Betriebes einer Transformatorenstation samt Zubehör gem Pkt
           1) 3) Dienstbarkeitsvertrag 1970-02-10 hins Gst 2005/3 für
           Linzer Elektrizitäts- und Straßenbahn-Aktiengesellschaft
    4  a 2582/1970 466/1975
           DIENSTBARKEIT des Gehens und Fahrens gem Pkt 2)
           Dienstbarkeitsvertrag 1970-02-10 hins Gst 2005/3 für Linzer
           Elektrizitäts- und Straßenbahn-Aktiengesellschaft
    5  a 692/2005
           DIENSTBARKEIT der Duldung einer Gasregelstation samt Gaszu-
           u Gasableitung, Gaszählerstation samt Gaszuleitung sowie
           Gasleitung gem Pkt 1. u 2. Dienstbarkeitsvertrag 2005-01-20
           hins Gst 2005/3 für LINZ GAS/WÄRME GmbH für Erdgas- und
           Wärmeversorgung
            Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS
 

 

 

Private data

 

 

Surname

 

 

Date of birth

 

 

Address

 

 

Executive positions

 

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Mag.  Winfried Brandlhofer

1947-12-04 

 

4060 Leonding Paschingerstraße 90(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Johann Detzlhofer

1961-07-01 

4980 Antiesenhofen Nr. 57

joint signing clerk

0

Dipl-Ing.Dr.  Rudolf Hammerschmid

1959-07-08 

 

4201 Gramastetten Waldingerstraße 14

joint signing clerk

 

1

 

Ing.Dipl-Ing.  Hubert Heissl

1961-05-24 

 

4060 Leonding Paschingerstraße 90(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Dipl-Ing.  Stefan Hofbauer

1972-01-17 

 

4060 Leonding Paschingerstraße 90(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Mag.  Josef Kern

 

1957-05-16 

 

4060 Leonding Paschinger Straße 90 (c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Dipl-Ing.  Christian Kleebauer

1960-01-03 

 

4020 Linz Einfaltstraße 7

 

joint signing clerk

 

0

 

Wolfram Walter Mücke

1950-03-23 

4020 Linz

joint signing clerk,

head of sales

0

Ing.  Wilhelm Pötscher

 

1955-07-20 

 

4060 Leonding Paschingerstraße 90(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Ing.  Ralph Schmid

 

1959-08-18 

 

4060 Leonding Paschingerstraße 90(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Mag.  Michael Wagner

 

1969-10-07 

 

4060 Leonding Paschingerstraße 90(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Dipl-Ing.  Gerhard Wierer

1968-07-31 

 

4060 Leonding Paschingerstraße 90(c/o)

joint signing clerk,

head of purchasing

 

0

 

Dr.  Markus Josef Öttl

 

1950-03-27 

 

4060 Leonding Paschingerstraße 90 (c/o)

joint signing clerk,

head of personnel

 

0

 

KR  Julian Wagner

 

1950-07-28 

 

4020 Linz Schweizerhausgasse 18

chairman of the executive board

 

2

 

Ing.Dipl-Ing.  Gottfried Brunbauer

1960-07-31 

 

4060 Leonding Paschingerstraße 90(c/o)

member of the executive board,

technical director

 

0

 

Mag.  Robert Kastil

1949-04-15 

4020 Linz Aubergstraße 24

member of the executive board

3

 

Finanzkaufmann

Mag.  Manfred Schwetz

 

1946-08-25 

 

4060 Leonding Hartackerstraße 44

member of the executive board,

head of marketing

 

0

 

Dr.  Dieter Siegel

 

1964-09-20 

 

4201 Gramastetten Nöbauerstraße 52

member of the executive board

 

2

 

Dr.  Alfred Hutterer

 

1947-09-14 

 

4061 Pasching Industriepark 24 (c/o)

chairman of the supervisory board

 

4

 

Dipl-Ing.Dr.  Christian Reisinger

1960-09-18 

 

4800 Attnang Puchheim Lenaustraße 11

deputy chairman of the supervisory board

 

4

 

Ing.  Rudolf Aichinger

 

1962-01-26 

 

4060 Leonding Paschingerstraße 90(c/o)

member of the supervisory board

 

0

 

Alfred Greslehner

 

1960-01-15 

 

4060 Leonding Paschingerstraße 90(c/o)

member of the supervisory board

 

0

 

Dipl-Ing.  Karl Ozlsberger

1948-10-03 

 

2100 Korneuburg Jochingergasse 4

member of the supervisory board

 

4

 

Dr.  Rainer Siegel

 

1963-10-05 

 

4060 Leonding Paschingerstraße 90(c/o)

member of the supervisory board

 

1

 

Dipl-Ing.  Markus Schallerböck

  

 

4060 Leonding Paschingerstraße 90(c/o)

head of EDP

 

0

 

 

 


Balance Sheet 

(absolute) all amounts in EUR 

 

 

2010-12-31 

Goodwill

1,00

Franchises, patents, licences, trademarks and similar rights and advantages

769.596,00

Sum intangible assets

769.597,00

Special account land and buildings

24.737.249,00

Building investments in third party (leased) res residential and business buildings

1,00

Technical plants and machines

6.019.565,00

Advanced payments and constructions in progress

162.625,48

Sum tangible assets

40.449.360,48

Shares on related firms

31.604.057,54

Other shareholdings

1.500.137,79

Other financial assets, values and securities of fixed assets

104.784,17

Sum financial assets

33.208.979,50

Sum fixed assets

74.427.936,98

Raw-, auxiliary materials and supplies

34.807.414,95

Unfinished products

39.343.021,93

Finished products

8.562.215,40

Advanced payments

4.296.672,64

Received advanced payments for orders

-7.986.431,49

Stocks

5.113.657,51

Sum stock

84.136.550,94

Claims from delivered goods and performed services

12.669.995,17

Other claims and assets

4.291.257,02

Claims against companies with shareholding relationship

2.263.920,31

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

29.328.995,95

Sum claims

48.554.168,45

Cash on hand, cheques and bank deposits

4.382.253,88

Sum cash and bank

4.382.253,88

Sum current assets

137.072.973,27

Deferred charges

489.365,29

Sum deferred charges

489.365,29

Assets

211.990.275,54

Subscribed/declared capital

13.600.000,00

Committed capital reserves

23.703.398,02

Free reserves

63.252.757,74

Balance sheet profit/balance sheet loss

8.292.940,77

Thereof profit/loss carried forward

183.337,39

Sum equity capital

108.849.096,53

Valuation reserves due to special depreciations and

2.488.499,30

Sum reserves before taxes

2.488.499,30

Reservesfor severance pays

11.374.500,00

Reserves for pensions

213.700,00

Tax reserves

1.533.680,00

Other reserves

29.792.055,50

Sum reserves

42.913.935,50

Liabilities against credit institutes

10.895.552,41

Received advanced payments for orders

9.177.105,35

Liabilities from delivered goods and performed services from the acceptance of drafts and emission of promissory notes

13.460.266,36

Liabilities against related firms

11.629.460,76

Other liabilities

12.540.327,10

Sum liabilities

57.702.711,98

Deferred income

36.032,23

Sum deferred income

36.032,23

Liabilities

211.990.275,54

Contingent liabilities

30.604.668,91

Balance sheet sum

211.990.275,54

 

 

P / L Account 

(absolute) all amounts in EUR 

 

 

2010-12-31 

Gross sales 

342.223.929,51

Increase or decrease in finished and unfinished goods and in service claims 

5.140.122,71

Sum turnover or sum gross profit 

347.364.052,22

Profits from retirement of fixed assets, except financial assets 

31.700,09

Income from dissolution of reserves 

10.955.260,09

Other operating profits 

4.714.401,18

Other operating profits totally 

15.701.361,36

Costs for obtained services 

-8.541.016,10

Special account material costs 

-228.982.337,72

Costs for obtained services totally 

-237.523.353,82

Wages 

-20.498.569,61

Salaries 

-26.956.202,31

Costs for severance pays 

-1.042.173,50

Costs for old age pension 

-16.619,32

Legal fringe benefits and other payments depending on salaries 

-11.122.774,24

Other social fringe benefits 

-374.213,55

Personnel expenses totally 

-60.010.552,53

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation 

-4.846.560,32

Depreciation tangible assets / intangible assets totally 

-4.846.560,32

Different operating costs 

-29.387.323,37

Other taxes 

-82.363,71

Other operating costs totally 

-29.469.687,08

Operating result totally 

31.215.259,83

Profits from shareholdings 

8.055.810,89

Interest income, securties income and similar income 

898.063,10

Financial profits 

7.761,41

Disbursements from other financial assets and from securities of current assets (e.g. depreciations) 

-1.063,50

Interest and similar disbursements 

-783.132,25

Financial profits totally 

8.177.439,65

Results from usual business activity totally 

39.392.699,48

Taxes on income and profits 

-5.437.030,95

Taxes on income and profits totally 

-5.437.030,95

Annual surplus/annual deficit totally 

33.955.668,53

Dissolution reserves before taxes 

8.688,00

Transfer to reserves before taxes 

-554.753,15

Transfer to profit reserves 

-25.300.000,00

Reserves movements totally 

-25.846.065,15

Annual profit/annual loss totally 

8.109.603,38

Profit and loss carried forward from previous year 

183.337,39

Transfer of profits totally 

183.337,39

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account 

8.292.940,77

 

 

Key ratios

 

 

2010  

Cash flow II

  38.802.228,85

Debt amortisation period

  2,24

Bank indebtedness

  5,13

Equity capital share

  54,89

Social capital share

  5,46

Fixed assets coverage

  165,16

Net profit ratio

  11,34

Capital turnover

  1,63

Return on investment

  18,95

Cash flow in % of operating performance

  11,17

Cash flow I

  44.239.259,80

Gross productivity

  5,78

Net productivity

  1,83

Operating performance

  347.364.052,22

Inventories in % of operating performance

  24,22

Gross profit

  109.840.698,40

 

 

Locations

 

Type

Locations

Description

 

 

E-mail 

operational 

Paschingerstraße  90, A-4060 Leonding, (Verwaltung und Werk)

registered headquarters, owned property 

 

 

ir@rosenbauer.co.at

operational 

Paschingerstraße  90, A-4060 Leonding

registered office 

 

 

 

operational 

Pultendorf  13, A-3110 Neidling

factory, owned property 

 

 

st.poelten@rosenbauer.com

former 

Otto Baumgartnerstraße  9, A-8055 Graz Puntigam

branch office 

 

 

 

former 

Hans Liebherr Straße  13, A-6410 Telfs

branch office 

 

 

 

former 

Schadinagasse  9, A-1170 Wien

branch office 

 

 

related companies

 

Company name

 

Postal code

 

Stake in %

 

 

Companies House

 

 

This company holds 100% of the shares in:

Rosenbauer Management Services GmbH

Paschingerstraße  90, A-4060 Leonding

100 % 1994-03-25

 

 

FN 86385 m

 

Rosenbauer Österreich Gesellschaft m.b.H.

Paschingerstraße  90, A-4060 Leonding

100 % 1994-03-25

 

 

FN 86625 s

 

 

 

Bankers

 

Banker

Bank sort code

Type of banking connection

Oberbank AG, 4010 Linz

 

15000

 

main bank connection

 

UniCredit Bank Austria AG, 1011 Wien

 

20151

 

main bank connection

 

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, 4021 Linz

 

34000

 

main bank connection

 

Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktienges., 4041 Linz

 

20320

 

secondary banking connection

 

Raiffeisen Bank International AG, 1011 Wien

 

31000

 

secondary banking connection 

Historical development

 

Year of incorporation:

1866

Date of registration:

1992-11-03

 

Change of company name:

From

To

Company name

   

  2010-09-30

ROSENBAUER INTERNATIONAL Aktiengesellschaft 

  2010-09-30

   

Rosenbauer International AG 

 

Change in share capital:

From

To

Capital

   

  1999-10-18

ATS  170.000.000,00

  1999-10-18

  2007-06-09

EUR  12.359.000,00

  2007-06-09

   

EUR  13.600.000,00

 

Former executives:

From

To

Function

Name

   

  2003-02-05

member of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Hans Hojas 

   

  1997-01-31

joint signing clerk 

Franz Berger 

   

  1998-10-13

joint signing clerk 

Bernd Strohmaier 

  1997-12-31

  1999-08-31

joint signing clerk 

Wilfried Gebhartl 

  1997-12-31

  2000-02-15

joint signing clerk 

Fritz Bucher 

  1997-12-31

  2001-04-13

joint signing clerk 

Ing.Dipl-Ing. Gottfried Brunbauer 

   

  2005-03-02

joint signing clerk 

Ing. Gottfried Kastner 

   

  2008-09-03

joint signing clerk 

MBA. Herbert Landschützer 

  1999-01-19

  2008-12-17

joint signing clerk 

Ing. Gottfried Reiter 

  2010-08-28

  2010-11-23

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Alexander Märk 

  2010-08-28

  2011-01-21

joint signing clerk 

Dr. Dieter Siegel 

   

  2001-12-07

deputy chairman of the executive board 

Dipl-Ing.Dr. Helmut Gumbsch 

   

  2003-02-05

chairman of the supervisory board 

Dkfm.Dr. Klaus Czempirek 

  2003-02-05

  2007-06-01

chairman of the supervisory board 

Peter Louwerse 

  1994-02-09

  2003-02-05

deputy chairman of the supervisory board 

Peter Louwerse 

  2003-02-05

  2006-07-25

deputy chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Hans Hojas 

   

  2002-07-09

member of the supervisory board 

Dr. Peter Neumann 

   

  2003-09-20

member of the supervisory board 

Gerald Grüll 

  2003-09-06

  2007-06-01

member of the supervisory board 

Dr. Alfred Hutterer 

  2006-07-25

  2007-06-01

member of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Christian Reisinger 

  2002-07-09

  2009-06-27

member of the supervisory board 

Dr. Dieter Siegel 

   

  2005-08-25

employee's representative on the supervisory board 

Heinz Hillinger 

 

Former shareholdings:

From

To

Name

   

 

HTK Technologiezentrum Projektierungs- und Entwicklungsgesellschaft m.b.H. 

  1995-12-19

  2004-10-15

Rosenbauer Holding GmbH 

   

 

Konrad Rosenbauer K.G. 

 

Mergers:

Date

Function

Name

  2004-11-16

merged with 

Rosenbauer Holding GmbH 

 


FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.44.30

UK Pound

1

Rs.72.92

Euro

1

Rs.64.69

 

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

 

 

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.