MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :           

02.08.2011

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

SANDOZ GMBH

 

 

Formerly Known As :

Biochemie GmbH 

 

 

Registered Office :

Biochemiestraße  10, A-6250 Kundl

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

31.12.2009

 

 

Date of Incorporation :

26.11.1965

 

 

Legal Form :

Limited Liability Company

 

 

Line of Business :

Manufacture of pharmaceutical preparations

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

A

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

Fairly Large

 

Maximum Credit Limit :

EUR  28.140.000,00

 

 

Status :

Very Good

 

 

Payment Behaviour :

No Complaints

 

 

Litigation :

Clear

 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31st, 2011

 

Country Name

Previous Rating

                   (31.12.2010)                  

Current Rating

(31.03.2011)

Austria

a2

a2

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


Basic company information

 

Company name:

Sandoz GmbH

Status:

active company

Locations:

Biochemiestraße  10, A-6250 Kundl

Phone:

0043 (5338) 200

Fax:

0043 (5338) 200 - 415

E-mail:

info.sandoz@gx.novartis.com

Internet:

http://www.sandoz.com

Activities:

Önace 21200 100% Manufacture of pharmaceutical preparations

 

General Assessment:

 

 

Recommendation

We recommends to establish a business and credit relationship, and to benefit from arising business opportunities.

 

Detail Assessment:

Payments are sometimes made using cash discounts or according to conditions.

 

Financial situation is good.

 

Maximum credit EUR  28.140.000,00

 

 

Additional company information

 

Year of incorporation:

1965

 

Type of company:

Manufacturing

 

Legal form:

limited liability company since 1965-11-18

 

companies' house number:

FN 50587 v Innsbruck 1965-11-26

 

Activities:

 

 

ARA-number:

3462

 

VAT number:

ATU 32425809

 

number - Austrian National Bank:

4812

 

 

 

 

Export 

Country 

 

 

 

Export

world-wide

 

2011

 

 

 

Financial data

 

total turnover (total sales)

2010

EUR  1.340.000.000,00

(approx.)

total turnover (total sales)

2009

EUR  1.315.733.905,62

(exact)

total turnover (total sales)

2008

EUR  1.263.133.197,81

(exact)

total turnover (total sales)

2007

EUR  1.300.456.268,63

(exact)

total turnover (total sales)

2006

EUR  1.184.320.694,21

(exact)

total employees

2011

2900

(approx.)

total investments

2008

EUR  103.228.274,06

(exact)

 

 

Extraxt from the Companies' House

 

firm (style):

   63      Sandoz GmbH

legal form:

    1      Gesellschaft mit beschränkter Haftung

registered office:

    1      politischer Gemeinde Kundl

business adress:

   15      Biochemiestraße 10
           6250 Kundl

capital:

   52      EUR 32.703.000

reference date annual accounts:

    1      31. Dezember

annual accounts:

  116      zum 31.12.2009 eingereicht am 19.11.2010

power of representation:

    1      Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer
           bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
           durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen
           vertreten.

other provisions:

    8      Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.
    1   Gesellschaftsvertrag  vom 18.11.1965                                001
    1   Der Gesellschaftsvertrag wurde mehrfach geändert, zuletzt           002
          mit Beschluss der Generalversammlung  vom 23.05.1986
    1   Verschmelzungsvertrag  vom 30.05.1972                               003
    1   Generalversammlungsbeschluss  vom 19.06.1972                        004
          Die Biochemie Kundl Gesellschaft m.b.H., Kundl wurde mit
          dieser Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen.
    8   Generalversammlungsbeschluss vom 27.06.1994 bzw.                    005
          vom 19.07.1994
          Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
   22   Generalversammlungsbeschluss  vom 30.04.1997                        006
          Änderung des Gesellschaftsvertrages im Artikel 1.
   32   Verschmelzungsvertrag  vom 01.09.1998                               007
   32   Generalversammlungsbeschluss  vom 01.09.1998                        008
          Diese Gesellschaft wurde als
          übernehmende Gesellschaft mit der
          Novartis Handelsgesellschaft m.b.H.
          (FN 143149 p)
          als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
          Sitz der übertragenden Gesellschaft in Wien.
   52   Gesellschaftsvertrag mit Generalversammlungsbeschluss               009
          vom 25.09.2001
          gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.
          Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 224,62.
          Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Artikeln 6, 7, 9,
          10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 und 19.
   63   Generalversammlungsbeschluss  vom 24.04.2003                        010
          Änderung des Gesellschaftsvertrages im Artikel 1.
   79   Verschmelzungsvertrag  vom 28.09.2005                               011
   79   Generalversammlungsbeschluss  vom 28.09.2005                        012
          Diese Gesellschaft wurde als
          übernehmende Gesellschaft mit der
          Grandis Handel mit pharmazeutischen
          Produkten Gesellschaft mbH
          (FN 158417 t)
          als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
          Sitz der übertragenden Gesellschaft in Kundl.
   80   Verschmelzungsvertrag  vom 22.12.2005                               013
   80   Generalversammlungsbeschluss  vom 22.12.2005                        014
          Diese Gesellschaft wurde als
          übernehmende Gesellschaft mit der
          Sandoz GmbH
          (FN 233373 x)
          als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
          Sitz der übertragenden Gesellschaft in Wien.
   87   Einbringungsvertrag  vom 30.01.2006                                 015
          Einbringung eines Teilbetriebes in die
          Nabriva Therapeutics Forschungs GmbH
          (FN 269261 y)
          Teilbetrieb: Antibiotic Research Institute
   98   Generalversammlungsbeschluss  vom 15.12.2008                        016
          Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Artikeln 6, 8, 9,
          11, 12, 15 und 19.
  102   Einbringungsvertrag  vom 21.09.2009                                 017
          Einbringung eines Teilbetriebes der
          Novartis Institutes for BioMedical
          Research GmbH & Co KG
          (FN 253505 b)
          Teilbetrieb: "TopDerm"
  103   Generalversammlungsbeschluss  vom 21.09.2009                        018
          Spaltung
  103   zur Aufnahme in die                                                 019
          Novartis Pharma GmbH
          (FN 41622 i)
          durch Übertragung
          des Teilbetriebes "TopDerm"
          gemäß Spaltungs- und Übernahmsvertrag vom 21.09.2009

proxy:

        CS   Dr. Elmar Dolejsi, geb. 12.10.1960
   26        vertritt seit 01.01.1998 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        CT   Sibylla Härtel, geb. 21.10.1962
   26        vertritt seit 01.01.1998 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        CW   Mag. Ingrid Schwarzenberger, geb. 20.03.1958
   26        vertritt seit 01.01.1998 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        DK   Dr. Maria Schmalzl, geb. 11.08.1960
   53        vertritt seit 03.12.2001 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        EC   Mag. Hans-Peter Amon, geb. 19.01.1975
  100        vertritt seit 01.02.2009 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        EH   Drs. Gerhard Jan van der Meij, geb. 19.08.1968
  111        vertritt seit 01.06.2010 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen

supervisory board:

         C   Dipl.-Ing.Dr. Heinrich Scherfler, geb. 25.08.1945
   89        Mitglied
        CX   Helmut Pancheri, geb. 05.07.1961
   25        Mitglied
        DB   Mag. Christian Seiwald, geb. 25.09.1955
  112        Vorsitzender
        EA   Barbara Nerad, geb. 30.12.1962
   96        Mitglied
        EG   Christina Ackermann-Swistara, geb. 13.01.1965
  112        Stellvertreter des Vorsitzenden
        EI   Dr. Gerhard Schaefer, geb. 20.11.1950
  113        Mitglied

managing director:

        AU   Mag. Richard Kronbichler, geb. 05.11.1952
  115        vertritt seit 01.10.2010 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
        BD   Mag. Hubert Hirzinger, geb. 10.05.1957
   90        vertritt seit 01.06.2007 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
        DU   Ernst Meijnders, geb. 14.12.1956
   82        vertritt seit 01.06.2006 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen
        ED   Mag. Hannes Teißl, geb. 03.02.1965
  106        vertritt seit 01.01.2010 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
        EE   Dr. Günter Stempfer, geb. 09.12.1965
  107        vertritt seit 01.01.2010 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
        EF   Dr. Peter Gasteiger, geb. 30.06.1972
  108        vertritt seit 12.02.2010 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen

shareholder:

        CM   Novartis Holding AG
   85        ........................  EUR 3.000
   85        ...................................................  EUR 3.000
        DW   Novartis Austria GmbH
   85        ...................  EUR 32.700.000
   85        ..............................................  EUR 32.700.000
                        -------------------------------------------------------
                 Summen:          EUR 32.703.000             EUR 32.703.000

general table:

 Landesgericht Innsbruck
   1 datenersterfaßt am 23.09.1993              Geschäftsfall 915 Fr  3046/93 i
       Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
   8 eingetragen am 04.08.1994                  Geschäftsfall  19 Fr  3050/94 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.07.1994
  15 eingetragen am 31.07.1996                  Geschäftsfall  50 Fr  3421/96 b
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 10.07.1996
  18 eingetragen am 22.02.1997                  Geschäftsfall  50 Fr   480/97 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.01.1997
  22 eingetragen am 14.06.1997                  Geschäftsfall  50 Fr  3183/97 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.06.1997
  25 eingetragen am 24.01.1998                  Geschäftsfall  50 Fr   503/98 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.01.1998
  26 eingetragen am 27.01.1998                  Geschäftsfall  50 Fr   356/98 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.01.1998
  32 eingetragen am 24.11.1998                  Geschäftsfall  50 Fr  7458/98 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.09.1998
  52 eingetragen am 05.10.2001                  Geschäftsfall  62 Fr  1934/01 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.09.2001
  53 eingetragen am 19.12.2001                  Geschäftsfall  62 Fr  2508/01 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.12.2001
  59 eingetragen am 10.09.2002                  Geschäftsfall  62 Fr  1740/02 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 06.08.2002
  63 eingetragen am 01.05.2003                  Geschäftsfall  62 Fr   914/03 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.04.2003
  66 eingetragen am 01.10.2003                  Geschäftsfall  62 Fr  1753/03 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.09.2003
  79 eingetragen am 06.10.2005                  Geschäftsfall  62 Fr  1652/05 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.09.2005
  80 eingetragen am 11.02.2006                  Geschäftsfall  62 Fr  2534/05 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.12.2005
  82 eingetragen am 03.06.2006                  Geschäftsfall  62 Fr   809/06 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.05.2006
  85 eingetragen am 27.07.2006                  Geschäftsfall  62 Fr  1055/06 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.07.2006
  86 eingetragen am 31.08.2006                  Geschäftsfall  62 Fr  1258/06 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.08.2006
  87 eingetragen am 10.10.2006                  Geschäftsfall  62 Fr  1543/06 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.09.2006
  88 eingetragen am 09.02.2007                  Geschäftsfall  62 Fr   236/07 x
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.02.2007
  89 eingetragen am 16.03.2007                  Geschäftsfall  62 Fr   269/07 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.02.2007
  90 eingetragen am 06.06.2007                  Geschäftsfall  62 Fr   777/07 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.05.2007
  96 eingetragen am 01.08.2008                  Geschäftsfall  62 Fr  1428/08 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.07.2008
  98 eingetragen am 19.12.2008                  Geschäftsfall  62 Fr  3130/08 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.12.2008
 100 eingetragen am 19.02.2009                  Geschäftsfall  62 Fr   265/09 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.02.2009
 102 eingetragen am 29.10.2009                  Geschäftsfall  62 Fr  2202/09 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.09.2009
 103 eingetragen am 30.10.2009                  Geschäftsfall  62 Fr  2201/09 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.09.2009
 106 eingetragen am 09.01.2010                  Geschäftsfall  62 Fr  3855/09 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.12.2009
 107 eingetragen am 09.01.2010                  Geschäftsfall  62 Fr  3962/09 v
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.12.2009
 108 eingetragen am 20.02.2010                  Geschäftsfall  62 Fr   342/10 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.02.2010
 110 eingetragen am 20.04.2010                  Geschäftsfall  62 Fr   782/10 a
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.04.2010
 111 eingetragen am 18.06.2010                  Geschäftsfall  62 Fr  1235/10 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.06.2010
 112 eingetragen am 29.07.2010                  Geschäftsfall  62 Fr  1543/10 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.07.2010
 113 eingetragen am 22.09.2010                  Geschäftsfall  62 Fr  2075/10 b
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.09.2010
 114 eingetragen am 12.10.2010                  Geschäftsfall  62 Fr  2478/10 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.10.2010
 115 eingetragen am 13.11.2010                  Geschäftsfall  62 Fr  2741/10 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.10.2010
 116 eingetragen am 04.12.2010                  Geschäftsfall  62 Fr  2934/10 s
       Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 19.11.2010

 

 

Real estate

 

Registration number of real estate  100  Cadastral register  83108  Kundl T  Number and date of entry  2463/2009  Status of  2011-03-22 

Part A - type of real estate  :

    GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLäCHE  GST-ADRESSE
     32/1     GST-Fläche               877
              Baufl.(Gebäude)          240
              Baufl.(begrünt)          637  Biochemiestraße 4
     43/2     GST-Fläche              3405
              Baufl.(Gebäude)         1080
              Sonstige                2325
              (Werksgelände)                Biochemiestraße 5
                                            Biochemiestraße 9
                                            Biochemiestraße 11
    478/2   G Baufl.(begrünt)   *     5848
    478/3   G Sonstige          *      152
              (Straßenanlage)
    481/1     Landw. genutzt           344
    484     G GST-Fläche        *   108970
              Baufl.(Gebäude)        40231
              Sonstige               68739
              (Werksgelände)                Biochemiestraße 6
                                            Biochemiestraße 10
    GESAMTFLäCHE                    119596
 

Part B - ownership details  :

    1 ANTEIL: 1/1
      Sandoz GmbH
      ADR: Biochemiestraße 10, Kundl   6250
       a 561/1956 Urkunde und übergabsvertrag 1956-08-13 Eigentumsrecht
       b 1660/2003 Namensänderung
 

Part C - registered charges  :

    3  a 1589/1993
           DIENSTBARKEIT der Verlegung, des Betriebes, der Erhaltund
           und Erneuerung einer Leitung auf Gst 481/1 gem
           Dienstbarkeitsvertrag 1993-04-30 für
           Tiroler Ferngas Gesellschaft mbH
       b 528/2004 übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ
           90043
    4  a 2463/2009
           DIENSTBARKEIT des Gehens und Fahrens auf Gst 478/2 478/3
           484 gemäß Punkt VI. Ziffer 1. Kauf- und
           Dienstbarkeitsvertrag 2009-10-29
           für Gst 477/1 478/1 478/4 1293 in EZ 90030
            Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS
 

 


Private data

 

 

Surname

 

 

Date of birth

 

 

Address

 

 

Executive positions

 

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Dr.  Peter Gasteiger

1972-06-30 

6250 Kundl Biochemiestraße 10

manager,

head of personnel

0

Mag.  Hubert Hirzinger

 

1957-05-10 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10 (p/A Sandoz GmbH)

manager

 

5

 

Mag.  Richard Kronbichler

1952-11-05 

 

6341 Ebbs Oberndorf 50 d

 

manager

 

0

 

Dipl-Ing.  Ernst Meijinders

1956-12-14 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10

 

manager

 

0

 

Dr.  Günter Stempfer

1965-12-09 

6250 Kundl Biochemiestraße 10

manager

0

Mag.  Hannes Teißl

 

1965-02-03 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

manager

 

0

 

Mag.  Hans Peter Amon

 

1975-01-19 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

joint signing clerk,

head of accounting

 

6

 

Dr.  Elmar Dolejsi

 

1960-10-12 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

joint signing clerk

 

2

 

Sibylla Härtel

 

1962-10-21 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Dr.  Maria Schmalzl

1960-08-11 

6236 Alpbach Nr. 637

joint signing clerk

1

 

Hausfrau

Mag.  Ingrid Schwarzenberger

1958-03-20 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Dr.  Gerhard van-der-Meij

1968-08-19 

 

1020 Wien Stella Klein Löwweg 17

joint signing clerk

 

1

 

Mag.  Christian Seiwald

 

1952-10-02 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

chairman of the supervisory board

 

0

 

Christina Ackermann-Swistara

 

1965-01-13 

 

83607 Holzkirchen Industriestraße 25

deputy chairman of the supervisory board

 

0

 

Barbara Nerad

1962-12-30 

6250 Kundl Biochemiestraße 10

member of the supervisory board

0

Helmut Pancheri

 

1961-07-05 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

member of the supervisory board

 

0

 

Dr.  Gerhard Schaefer

 

1950-11-20 

 

83607 Holzkirchen Industriestraße 25

member of the supervisory board

 

0

 

Dipl-Ing.Dr.  Heinrich Scherfler

1945-08-25 

 

6233 Kramsach Nr. 488f

 

member of the supervisory board

 

1

 

Mag.  Max Leitinger

 

  

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

head of EDP

 

0

 

Josef Postl

 

  

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

technical director

 

0

 

 

Balance Sheet 

(absolute) all amounts in EUR 

 

 

2009-12-31 

Franchises, patents, licences, trademarks and similar rights and advantages

14.446.771,51

Sum intangible assets

14.446.771,51

Land and leasehold rights with buildings thereon including building on land owned by third parties

234.295.034,68

Technical plants and machines

154.575.861,69

Advanced payments and constructions in progress

14.806.179,36

Sum tangible assets

415.020.027,51

Shares on related firms

35.906.602,18

Other shareholdings

1.751.901,77

Other financial assets, values and securities of fixed assets

14.644.676,78

Sum financial assets

52.303.180,73

Sum fixed assets

481.769.979,75

Raw-, auxiliary materials and supplies

59.906.747,87

Unfinished products

153.471.475,44

Finished products

45.661.767,31

Advanced payments

-319.451,67

Sum stock

258.720.538,95

Claims from delivered goods and performed services

120.963.991,22

Other claims and assets

88.916.497,36

Claims against companies with shareholding relationship

1.707.250,45

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

137.775.799,92

Sum claims

349.363.538,95

Cash on hand, cheques and bank deposits

602.156,61

Sum cash and bank

602.156,61

Sum current assets

608.686.234,51

Deferred charges

500.424,54

Sum deferred charges

500.424,54

Assets

1.090.956.638,80

Subscribed/declared capital

32.703.000,00

Legal reserves

3.270.300,00

Free reserves

59.656.425,77

Balance sheet profit/balance sheet loss

0,00

Sum equity capital

95.629.725,77

Valuation reserves due to special depreciations and

20.773.598,24

Sum reserves before taxes

20.773.598,24

Investment contributions

873.558,34

Sum floor capital

873.558,34

Reservesfor severance pays

34.046.553,41

Reserves for pensions

47.986.153,73

Other reserves

61.222.968,22

Sum reserves

143.255.675,36

Liabilities against credit institutes

152.252.247,81

Received advanced payments for orders

924.532,71

Liabilities from delivered goods and performed services from the acceptance of drafts and emission of promissory notes

82.500.826,35

Liabilities against related firms

561.853.366,29

Liabilities against firm with shareholding relationship

2.998.803,64

Other liabilities

25.788.187,85

Other loans

3.485.200,00

Sum liabilities

829.803.164,65

Deferred income

620.916,44

Sum deferred income

620.916,44

Liabilities

1.090.956.638,80

Contingent liabilities

9.100.000,00

Balance sheet sum

1.090.956.638,80

 


P / L Account 

(absolute) all amounts in EUR 

 

 

2009-12-31 

Gross sales 

1.315.733.905,62

Increase or decrease in finished and unfinished goods and in service claims 

87.133.937,56

Other manufacturing costs capitalized 

4.578.866,20

Sum turnover or sum gross profit 

1.407.446.709,38

Profits from retirement of fixed assets, except financial assets 

29.283,33

Income from dissolution of reserves 

701.738,78

Other operating profits 

28.120.743,73

Other operating profits totally 

28.851.765,84

Costs for obtained services 

-23.717.138,43

Special account material costs 

-798.915.409,53

Costs for obtained services totally 

-822.632.547,96

Wages 

-24.449.020,66

Salaries 

-112.680.203,00

Costs for severance pays 

-2.754.541,57

Costs for old age pension 

-8.548.179,30

Legal fringe benefits and other payments depending on salaries 

-37.152.173,33

Other social fringe benefits 

-4.624.375,55

Personnel expenses totally 

-190.208.493,41

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation 

-81.783.907,41

Depreciation tangible assets / intangible assets totally 

-81.783.907,41

Different operating costs 

-208.619.416,39

Other taxes 

-382.324,43

Other operating costs totally 

-209.001.740,82

Operating result totally 

132.671.785,62

Profits from shareholdings 

13.981.764,73

Income from other securities and loans of financial assets 

807.370,49

Interest income, securties income and similar income 

51.860,13

Disbursements from other financial assets and from securities of current assets (e.g. depreciations) 

-4.000.000,00

Interest and similar disbursements 

-12.815.911,24

Financial profits totally 

-1.974.915,89

Results from usual business activity totally 

130.696.869,73

Taxes on income and profits 

-265.353,96

Taxes on income and profits totally 

-265.353,96

Annual surplus/annual deficit totally 

130.431.515,77

Dissolution reserves before taxes 

1.116.426,63

Dissolution capital reserves 

4.000.000,00

Transfer to reserves before taxes 

-4.640.056,28

Reserves movements totally 

476.370,35

Annual profit/annual loss totally 

130.907.886,12

Transfer of profit/overcounting of losses from ontract of profit transfer 

-130.907.886,12

Transfer of profits totally 

-130.907.886,12

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account 

0,00

 

 

Key ratios

 

 

2009  

Cash flow II

  212.215.423,18

Debt amortisation period

  4,57

Bank indebtedness

  14,27

Equity capital share

  10,75

Social capital share

  7,51

Fixed assets coverage

  41,37

Net profit ratio

  9,28

Capital turnover

  1,29

Return on investment

  13,15

Cash flow in % of operating performance

  15,07

Cash flow I

  212.480.777,14

Gross productivity

  7,39

Net productivity

  3,07

Operating performance

  1.407.446.709,38

Inventories in % of operating performance

  18,38

Gross profit

  584.814.161,42

 

 

Locations

 

Type

Locations

Description

 

 

E-mail 

operational 

Biochemiestraße  10, A-6250 Kundl

registered office 

 

 

 

operational 

Biochemiestraße  10, A-6250 Kundl

registered headquarters, owned property 

 

 

info.sandoz@gx.novartis.com

operational 

Brunnerstraße  59, A-1230 Wien

branch office, rented premises 

 

 

 

operational 

Schaftenau Biochemiestraße  10, A-6330 Kufstein

factory, owned property 

 

 

 

operational 

Dr. Hans Bachmannstraße  7, A-6250 Kundl, (umben.auf Biochemiestraße 10)

registered headquarters 

 

 

 

former 

Wagramerstraße  19, A-1220 Wien

branch office 

 

 

 

 

 

related companies

 

Company name

 

Postal code

 

Stake in %

 

 

Companies House

 

Shares in this company are held by:

Novartis Austria GmbH

 

Stella Klein Löwweg  17, A-1020 Wien

99.99 % 2006-07-27

 

 

FN 274620 d

 

Novartis Holding AG

 

Lichtstraße  35, CH-4056 Basel

0.01 % 1997-02-22

 

 

 

 

This company holds 100% of the shares in:

HEXAL PHARMA GmbH

 

Stella Klein Löw Weg  17, A-1020 Wien

100 % 2005-12-17

 

 

FN 44896 z

 

Novartis Institutes for Biomedical Research GmbH

Brunnerstraße  59, A-1235 Wien

100 % 1993-08-13

 

 

FN 43251 f

 

Novartis Animal Health GmbH

 

Biochemiestraße  10, A-6250 Kundl

100 % 1996-12-03

 

 

FN 152616 k

 

 

This company holds 50% to 99% of the shares in:

Biozym GmbH

 

Biochemiestraße  10, A-6250 Kundl

51 % 1993-12-17

 

 

FN 47953 w

 

 

Affiliated companies and further participations:

Novartis Pharma GmbH

 

Stella Klein Löwweg  17, A-1020 Wien

 

 

 

FN 41622 i

 

Nabriva Therapeutics AG

 

Leberstraße  20, A-1112 Wien

 

 

 

FN 269261 y

 

Novartis Pharma GmbH

 

Stella Klein Löwweg  17, A-1020 Wien

 

 

 

FN 41622 i

 

CIBA Vision GmbH

 

Stella Klein Löwweg  17, A-1020 Wien

 

 

 

FN 82357 p

 

EBEWE Spezial-Pharma Holding GmbH

Stella Klein Löwweg  17, A-1020 Wien

 

 

 

FN 331193 z

 

Austrian Center of Biopharmaceutical Technology

Muthgasse  18, A-1190 Wien

 

 

 

 

Novartis Institutes for BioMedical Research GmbH & Co KG

Brunnerstraße  59, A-1235 Wien

2004-10-23

 

 

FN 253505 b

 

 

 

Bankers

 

Banker

Bank sort code

Type of banking connection

UniCredit Bank Austria AG, 1011 Wien

 

12000

 

main bank connection

 

 

 

Historical development

 

Year of incorporation:

1965

Date of registration:

1965-11-26

 

Change of company name:

From

To

Company name

   

  2003-05-02

Biochemie GmbH 

  2003-05-02

   

Sandoz GmbH 

 

Change in share capital:

From

To

Capital

   

  2001-10-05

ATS  450.000.000,00

  2001-10-05

   

EUR  32.703.000,00

 

Former executives:

From

To

Function

Name

  1993-09-23

  2010-03-19

joint signing clerk 

Mag. Friedrich Fuchs 

  2008-05-29

  2010-06-18

joint signing clerk 

Dipl-Betriebsw. Björn Komischke 

  2006-06-23

  2011-02-10

joint signing clerk 

Mag. Helmuth Hofer 

  1993-05-10

  1997-05-16

chairman of the supervisory board 

Dr. Urs Bärlocher 

  1997-05-16

  1998-04-18

chairman of the supervisory board 

Pierre Douaze 

  1998-04-18

  1999-10-12

chairman of the supervisory board 

Dr. Argeric Karabelas 

  1999-10-12

  2001-10-02

chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Oswald Sellemond 

  2001-10-02

  2002-05-30

chairman of the supervisory board 

Mag. Christian Seiwald 

  2002-05-30

  2005-04-19

chairman of the supervisory board 

Mag. Christian Seiwald 

  2005-04-19

  2009-02-19

chairman of the supervisory board 

Dr. Andreas Rummelt 

  2009-02-19

  2010-07-29

chairman of the supervisory board 

Dr. Horst Uwe Groh 

  1995-06-21

  1997-05-16

deputy chairman of the supervisory board 

Dr. Daniel Vasella 

  1999-10-12

  2000-11-30

deputy chairman of the supervisory board 

Dr. Argeric Karabelas 

  1997-05-16

  2002-03-12

deputy chairman of the supervisory board 

Dr. Jörg Reinhardt 

  2000-11-30

  2002-05-30

deputy chairman of the supervisory board 

Thomas Ebeling 

  2002-05-30

  2005-04-19

deputy chairman of the supervisory board 

Paul Choffat 

  2005-04-19

  2010-07-29

deputy chairman of the supervisory board 

Mag. Christian Seiwald 

   

  1997-05-16

member of the supervisory board 

Dr. Raymund Breu 

  1998-01-27

  2002-04-25

joint signing clerk 

Mag. Vinzenz Plörer 

  1997-11-07

  2002-10-01

joint signing clerk 

Dr. Helmut Deimel 

  1999-04-15

  2003-03-19

joint signing clerk 

Mag. Gerhard Hörl 

  1993-09-23

  2003-04-29

joint signing clerk 

Mag. Bernhard Sigl 

  1999-08-17

  2003-04-29

joint signing clerk 

Mag.Dr. Franz Stumpf 

  2001-10-02

  2003-12-18

joint signing clerk 

Dr. Johannes Gerstenbauer 

   

  1999-04-13

manager 

Dipl-Ing.Dr. Oswald Sellemond 

   

  2003-04-29

manager 

Werner Meßner 

  2003-04-29

  2004-09-01

manager 

Mag.Dr. Franz Stumpf 

  2003-04-29

  2005-07-28

manager 

Mag. Hubert Hirzinger 

  2003-04-29

  2005-07-28

manager 

Dr. Patrick Vink 

   

  2006-06-03

manager 

Dipl-Ing.Dr. Heinrich Scherfler 

  2004-09-01

  2007-06-06

manager 

Mag. Johannes Schwertner 

  2003-04-29

  2008-02-21

manager 

Mag. Bernhard Sigl 

  2008-02-21

  2010-02-20

manager 

Dipl-Ing. Bianca Stöhr 

  1993-09-23

  1999-02-16

joint signing clerk 

Dr. Paul Inama Sternegg 

  1998-10-20

  1999-04-15

joint signing clerk 

Eric Gorka 

  1993-09-23

  2000-09-13

joint signing clerk 

Dr. Otto Streichsbier 

  1993-09-23

  2000-10-11

joint signing clerk 

Mag. Hubert Hirzinger 

  1993-09-23

  2001-03-13

joint signing clerk 

Dr. Eberhard Pirich 

  1993-09-23

  2001-10-02

joint signing clerk 

Dr. Walter Killiches 

  1998-01-27

  2003-12-18

joint signing clerk 

Mag. Gottfried Rieser 

  2003-05-06

  2004-11-03

joint signing clerk 

Mag. Siegfried Johann Leitner 

  1998-02-02

  2005-03-08

joint signing clerk 

Peter Haselböck 

  1993-09-23

  2005-03-08

joint signing clerk 

Dr. Ernst Leitner 

  1998-01-27

  2006-05-16

joint signing clerk 

Dr. Santiago Alonso Ciriza 

  2004-08-10

  2006-05-16

joint signing clerk 

Knut Ulrich Mager 

  2000-03-14

  2006-05-16

joint signing clerk 

Hans Schaller 

  1993-09-23

  2007-02-09

joint signing clerk 

Mag. Rupert Labner 

  2006-06-23

  2007-06-15

joint signing clerk 

Lorraine Lynne-Christina Perry 

  2003-10-01

  2007-06-15

joint signing clerk 

Mag.Dr. Otto Scheidl 

  2002-07-17

  2007-06-15

joint signing clerk 

Dr. Elisabeth Schneider Scherzer 

  1998-04-02

  2007-06-15

joint signing clerk 

Dr. Bruno Wallnöfer 

  2000-01-12

  2007-06-15

joint signing clerk 

Mag. Barbara Weigl Aman 

  2004-10-06

  2008-05-29

joint signing clerk 

Mag. Elgar Schnegg 

  2000-05-31

  2009-02-19

joint signing clerk 

Kurt Unterkircher 

  2000-01-12

  2010-01-09

joint signing clerk 

Dr. Josef Egerbacher 

   

  1998-04-18

member of the supervisory board 

Daniel Wagniere 

  1998-04-18

  1999-08-06

member of the supervisory board 

Dr. Hans Kindler 

  1997-05-16

  1999-08-06

member of the supervisory board 

Dr. Erwin Schillinger 

  1999-08-06

  1999-10-12

member of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Oswald Sellemond 

  1999-08-06

  2001-10-02

member of the supervisory board 

Mag. Christian Seiwald 

  2001-10-02

  2002-05-30

member of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Oswald Sellemond 

  2002-03-12

  2005-07-14

member of the supervisory board 

Dr. Urs Bärlocher 

  2005-07-14

  2007-03-16

member of the supervisory board 

Kevin Plummer 

  2002-05-30

  2007-06-28

member of the supervisory board 

Dr. Erwin Schillinger 

  1999-08-06

  2008-08-01

member of the supervisory board 

Hermann Egger 

  2007-06-28

  2008-08-01

member of the supervisory board 

Dr. Peter Jager 

  2008-08-01

  2009-03-11

member of the supervisory board 

Knut Mager 

  2009-03-11

  2010-04-20

member of the supervisory board 

Dr. Andreas Rummelt 

  2010-04-20

  2010-07-29

member of the supervisory board 

Christina Ackermann Swistara 

  2010-07-29

  2010-09-22

member of the supervisory board 

Dr. Horst Uwe Groh 

   

  1998-01-24

employee's representative on the supervisory board 

Johann Auer 

   

  1999-08-06

employee's representative on the supervisory board 

Helmuth Stubenvoll 

 

Former shareholders:

From

To

Function

Name

   

  1997-02-22

partner 

Sandoz Holding AG 

  1997-02-22

  2000-08-26

partner 

Novartis AG 

 

Former shareholdings:

From

To

Name

  1996-05-08

  1998-11-24

Novartis Handelsgesellschaft m.b.H. 

  2004-09-16

  2004-10-23

Novartis Forschungsinstitut GmbH 

  2005-01-27

  2005-10-06

Grandis Handel mit pharmazeutischen Produkten Gesellschaft mbH 

  2006-01-24

  2007-11-10

Nabriva Therapeutics AG 

 

Mergers:

Date

Function

Name

  2000-11-24

merged with 

Novartis Handelsgesellschaft m.b.H. 

  2006-12-14

merged with 

Sandoz GmbH 

  2005-10-06

merged with 

Grandis Handel mit pharmazeutischen Produkten Gesellschaft mbH 

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.44.05

UK Pound

1

Rs.72.40

Euro

1

Rs.63.46

 

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

----

NB

New Business

----

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

 

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.