MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

06.12.2011

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

ALCATEL-LUCENT FRANCE

 

 

Registered Office :

Alcatel-Lucent France 3 Av Octave Greard 75007 Paris 7

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2009

 

 

Date of Incorporation :

October 1986

 

 

Com. Reg. No.:

RCS Paris 8 338 966 385

 

 

Legal Form :

Public Limited Company With Board of Directors

 

 

Line of Business :

Manufacture of communication equipment

 

 

No. of Employees :

5 000+ employees

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ca

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

Limited with full security

 

Status :

Poor

 

 

Payment Behaviour :

Unknown

 

 

Litigation :

--

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail: infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – September 30, 2011

 

Country Name

Previous Rating

(30.06.2011)

Current Rating

(30.09.2011)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


Summary

 

 

 

 

 

 

Name

ALCATEL-LUCENT FRANCE

SIRET

338 966 385 00498

 

 

company summary

 

 

 

Activity (APE)

Manufacture of communication equipment (2630Z)

Legal form

Public limited company with board of directors

 

 

Phone

 

RCS Registration

RCS Paris 8 338 966 385

 

 

Fax

 

Share capital

38,857,930 Euros

 

 

Address

ALCATEL-LUCENT FRANCE
3 AV OCTAVE GREARD
75007 PARIS 7

Incorporated Date

10/1986

 

 

Nationality

France

Status

Economically active

 

 

 

 

 

 Last published preferential right

28/10/2009

 

 

 

Ultimate Holding Company

 

Company Name

Safe Number

 

Company number

Click here to view the affiliation links

 

ALCATEL LUCENT

FR11704421

 

542019096

106 companies in 21 countries. Click here to visit linked companies

 

 

 

Current Directors

11

 

 

 

Trading to Date

12/31/2009

12/31/2008

12/31/2007

 

Turnover

2,621,186,000 €

3,015,645,000 €

2,943,476,000 €

 

Gross Operating Surplus

-24,59 % Turnover

-19,96 % Turnover

-22,02 % Turnover

 

Net worth

-384,733,000 €

63,073,000 €

558,264,000 €

 

Employees

5 000+ employees

-

-

 

 

 

Trends

 

 

Profitability

 

Liquidity

 

Net worth

 

 

 

 

company details

 

 

 

 

 

 

 

Activity (APE)

Fabrication d'équipements de communication  (2630Z)

 

RCS Registration

RCS Paris 8 338 966 385

Share capital

38,857,930 Euros

 

Registration Court

Paris (75)

Legal form

Public limited company with board of directors

 

Court Registry Number

19 8 6B117

EU VAT Number

FR55338966385

 

Incorporation Date

10/1986

Formation Date

10/1986

 

Deregistration Date

 

Last account Date

31/12/2009

 

Nationality

France

 

 

 

 

Ultimate Parent

1 ultimate parent company for this company
>  ALCATEL LUCENT  - Activités des sièges sociaux (7010Z)  in PARIS 7  (75007)

 

 

 

 

 

 

 

Activity (APE)

Fabrication d'équipements de communication  (2630Z)

Business Pages FT®

 

 

Postal Address

ALCATEL-LUCENT FRANCE
3 AV OCTAVE GREARD
75007 PARIS 7

Trading Address

3 AVENUE OCTAVE GREARD
75007 PARIS 7

 

Telephone

 

 

Fax

 

 

 

 

 

Type

Head office

Status

Economically active

 

Formation Date

05/2010

Reason for formation

Formation

 

Closure Date

 

Reason for closure

 

 

Reactivation Date

 

Production Role

 

 

Activity Nature

 

Activity Location

 

 

Location surface

 

Seasonality

 

 

 

 

 

Department

 

Region

Ile-de-France

 

District

 

Area

 

 

City

PARIS 7

Size of urban area

 

 

 

 

 

 

 

 

Branches

14 branch entities in this company

 

 

 

Head office

 
> ALCATEL-LUCENT FRANCE <<<  - Fabrication d'équipements de communication (2630Z)  in PARIS 7  (75007)
 

 

 

Secondary establishments

>  ALCATEL - LUCENT FRANCE  - Fabrication d'équipements de communication (2630Z)  in MASSY  (91300)
>  ALCATEL - LUCENT FRANCE  - Fabrication d'équipements de communication (2630Z)  in ORVAULT  (44700)
>  ALCATEL - LUCENT FRANCE  - Fabrication d'équipements de communication (2630Z)  in TOULOUSE  (31100)
>  ALCATEL CIT  - Fabrication d'équipements d'émission et de transmission hertzienne (322A)  in NANTERRE  (92000)
> ...

 

 

 

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas having at least 50% of workforce in same area

 

 

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which no activity grouping more than 50% of workforce

 

 

 

 

 

 

 

Workforce at address

0 employee

Company workforce

5 000+ employees

 

 

 


accounts

 

Active Account |  Passive Account |  Account Results

 

Synthesized Accounts

 

Annual Accounts

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

 

Account period (month)

12

 

12

 

12

 

 

Account Type

Normal

 

Normal

 

Normal

 

 

Deposit date

24/01/2011

 

-

 

-

 

 

Activity Code

2630Z

 

2630Z

 

2630Z

 

 

Employees

6804

 

7736

 

8727

 

 


Active account

Annual Accounts

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Sector Average 2009

 

Capital not called

1 049 982 000

0%

1 049 982 000

0%

1 049 982 000

3 240 760,03

32299,3%

Total fixed assets

293 326 000

-5,5%

310 262 000

-11,7%

351 192 000

2 112 695,41

13784,0%

- Intangible assets

195 321 000

33,2%

146 598 000

-3,1%

151 312 000

2 368 338,35

8147,2%

- Tangible assets

57 297 000

-7,6%

62 003 000

-17,7%

75 337 000

510 097,82

11132,6%

- Financial assets

89 337 000

-12,1%

101 661 000

-18,4%

124 543 000

463 624,25

19169,3%

Net current assets

1 919 110 000

-33,8%

2 898 135 000

21,4%

2 387 484 000

15 203 287,01

12523,0%

- Stocks

321 570 000

-20,1%

402 243 000

9,1%

368 657 000

2 458 436,87

12980,3%

- Advanced payments

7 505 000

-33,8%

10 396 000

-56,2%

23 757 000

249 769,49

2904,8%

- Receivables

1 282 907 000

-34,3%

1 951 813 000

7,9%

1 808 894 000

9 375 310,03

13583,9%

- Securities and cash

307 128 000

-42,5%

533 683 000

186,7%

186 176 000

3 119 375,63

9745,8%

- Prepaid expenses

-

-

-

-

-

2 364,98

-

Accounts of regularization

1 781 000

86,5%

955 000

-74,9%

3 810 000

11 447,59

15457,9%

Total Assets

3 264 199 000

-23,4%

4 259 334 000

12,3%

3 792 468 000

20 024 762,36

16200,8%


Passive Account

Annual Accounts

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Sector Average 2009

 

Shareholders' equity

-384 733 000

-710,0%

63 073 000

-88,7%

558 264 000

1 197 267,90

-32234,2%

Share capital

38 858 000

0%

38 858 000

-97,7%

1 665 340 000

1 882 770,85

1963,9%

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

38 788,05

0%

Risk Provisions

653 428 000

-36,4%

1 028 133 000

-6,8%

1 103 404 000

2 669 299,32

24379,4%

Liabilities

2 995 504 000

-5,4%

3 168 128 000

48,7%

2 130 800 000

16 117 562,20

18485,3%

- Financial liabilities

1 801 235 000

4,9%

1 717 378 000

194,9%

582 289 000

5 709 148,85

31450,0%

- Advanced payments received

128 455 000

-56,0%

292 232 000

40,2%

208 366 000

3 078 761,35

4072,3%

- Trade account payables

668 771 000

-17,8%

814 012 000

-13,7%

943 461 000

4 512 548,67

14720,3%

- Tax and social liabilities

158 556 000

-22,5%

204 526 000

-11,5%

231 191 000

2 034 756,42

7692,4%

- Other debts and fixed assets liabilities

32 864 000

-39,6%

54 390 000

-35,3%

84 123 000

465 500,87

6959,9%

Account regularization

205 623 000

140,2%

85 590 000

5,2%

81 370 000

798 614,14

25647,5%

Total liabilities

3 264 199 000

-23,4%

4 259 334 000

12,3%

3 792 468 000

20 024 762,39

16200,8%


Results

Annual Accounts

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Sector Average 2009

 

Sales of Goods

3 757 048 000

-13,8%

4 360 536 000

1,9%

4 277 885 000

21 921 737,37

17038,5%

Net turnover

2 621 186 000

-13,1%

3 015 645 000

2,5%

2 943 476 000

17 968 481,24

14487,7%

- of which net export turnover

0

0%

0

0%

0

3 268 077,32

0%

Operating charges

4 110 398 000

-14,2%

4 790 104 000

-2,0%

4 889 651 000

22 671 606,14

18030,2%

Operating profit/loss

-353 350 000

17,7%

-429 568 000

29,8%

-611 766 000

-749 868,77

-47021,6%

Financial income

84 166 000

-34,6%

128 746 000

15,4%

111 611 000

531 214,45

15744,1%

Financial charges

157 791 000

39,2%

113 345 000

104,5%

55 427 000

666 914,44

23559,9%

Financial profit/loss

-73 625 000

-578,1%

15 401 000

-72,6%

56 184 000

-135 699,97

-54155,7%

Pretax net operating income

-426 975 000

-3,1%

-414 167 000

25,5%

-555 582 000

-862 791,14

-49387,6%

Extraordinary income

61 228 000

24,3%

49 241 000

-34,8%

75 575 000

367 759,49

16548,9%

Extraordinary charges

119 119 000

-24,3%

157 416 000

-64,6%

444 843 000

741 564,97

15963,2%

Extraordinary profit/loss

-57 891 000

-314,6%

-108 175 000

70,7%

-369 268 000

-373 805,48

-15386,9%

Net result

-448 449 000

9,4%

-495 191 000

45,6%

-909 736 000

-1 108 320,98

-40362,0%


 

 

 

 

Normal Account

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Months

 

12

 

12

 

12


Accounts - Active
Current Assets |  Equalization accounts |  Reference

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Grand Total (I to VI)

Net

3 264 199 000

-23,4%

4 259 334 000

12,3%

3 792 468 000

 

Gross

CO

3 891 213 000

-21,4%

4 949 533 000

11,8%

4 427 388 000

 

Amortisation

1A

627 014 000

-9,2%

690 199 000

8,7%

634 920 000


Non declared distributed capital (I)

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Non declared distributed capital (I)

AA3

1 049 982 000

0%

1 049 982 000

0%

1 049 982 000

 

Gross

AA

1 049 982 000

-

-

-

-


Active fixed asset (II)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Total Active fixed asset (II)

Net

293 326 000

-5,5%

310 262 000

-11,7%

351 192 000

 

Gross

BJ

807 711 000

-8,3%

880 342 000

-1,4%

892 752 000

 

Amortisation

BK

514 385 000

-9,8%

570 080 000

5,3%

541 560 000


Intangilble fixed assets

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R & D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AE

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

486 000

50,0%

324 000

-45,4%

593 000

 

Gross

AF

39 695 000

-14,8%

46 606 000

-1,6%

47 341 000

 

Amortisation

AG

39 209 000

-15,3%

46 282 000

-1,0%

46 748 000

Goodwill

Net

194 804 000

33,3%

146 175 000

-2,9%

150 595 000

 

Gross

AH

194 804 000

0%

194 804 000

0%

194 804 000

 

Amortisation

AI

48 629 000

0%

48 629 000

10,0%

44 209 000

Other intangible fixed assets

Net

31 000

-68,7%

99 000

-20,2%

124 000

 

Gross

AJ

71 000

-45,0%

129 000

-10,4%

144 000

 

Amortisation

AK

40 000

33,3%

30 000

50,0%

20 000

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible Assets

Net

195 321 000

33,2%

146 598 000

-3,1%

151 312 000



Tangilble fixed assets

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Lands

Net

2 157 000

0,2%

2 152 000

0,9%

2 132 000

 

Gross

AN

2 999 000

0,5%

2 984 000

1,5%

2 940 000

 

Amortisation

AO

842 000

1,2%

832 000

3,0%

808 000

Buildings

Net

19 907 000

2,2%

19 471 000

12,9%

17 249 000

 

Gross

AP

101 157 000

2,5%

98 665 000

7,9%

91 432 000

 

Amortisation

AQ

81 250 000

2,6%

79 194 000

6,8%

74 183 000

Plant

Net

23 678 000

-7,9%

25 716 000

-20,4%

32 289 000

 

Gross

AR

246 675 000

-9,5%

272 553 000

-3,9%

283 688 000

 

Amortisation

AS

222 997 000

-9,7%

246 837 000

-1,8%

251 399 000

Other tangible fixed assets

Net

8 174 000

-5,2%

8 622 000

-17,7%

10 473 000

 

Gross

AT

53 598 000

-22,2%

68 869 000

-4,2%

71 910 000

 

Amortisation

AU

45 424 000

-24,6%

60 247 000

-1,9%

61 437 000

Fixed assets in construction

Net

3 381 000

-44,0%

6 042 000

-54,2%

13 194 000

 

Gross

AV

3 381 000

-44,0%

6 042 000

-54,2%

13 194 000

 

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AX

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Tangible asset

Net

57 297 000

 

62 003 000

 

75 337 000



Financial assets

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

82 443 000

-15,4%

97 396 000

-18,3%

119 274 000

 

Gross

CU

148 778 000

-15,3%

175 622 000

1,8%

172 459 000

 

Amortisation

CV

66 335 000

-15,2%

78 226 000

47,1%

53 185 000

Inter-company receivables

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BC

0

0%

0

0%

0

Other investment securities

Net

139 000

0%

139 000

0%

139 000

 

Gross

BD

5 616 000

0%

5 616 000

0%

5 616 000

 

Amortisation

BE

5 477 000

0%

5 477 000

0%

5 477 000

Loans

Net

1 806 000

-0,4%

1 814 000

-0,3%

1 820 000

 

Gross

BF

1 806 000

0%

1 814 000

0%

1 820 000

 

Amortisation

BG

0

 

0

 

0

Other financial assets

Net

4 949 000

114,1%

2 312 000

-30,2%

3 310 000

 

Gross

BH

9 131 000

37,6%

6 638 000

-10,3%

7 404 000

 

Amortisation

BI

4 182 000

-3,3%

4 326 000

5,7%

4 094 000

 

Sub Total Financial Assets

 

89 337 000

 

101 661 000

 

124 543 000

 

Current Assets (III)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Total Assets

Net

1 919 110 000

-33,8%

2 898 135 000

21,4%

2 387 484 000

 

Gross

CJ

2 031 739 000

-32,7%

3 018 254 000

21,7%

2 480 844 000

 

Amortisation

CK

112 629 000

-6,2%

120 119 000

28,7%

93 360 000



Stocks

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Raw materials

Net

22 058 000

80,6%

12 216 000

16,1%

10 518 000

 

Gross

BL

43 516 000

-19,5%

54 028 000

23,9%

43 608 000

 

Amortisation

BM

21 458 000

-48,7%

41 812 000

26,4%

33 090 000

Work in progress (goods)

Net

195 117 000

0%

0

0%

0

 

Gross

BN

198 069 000

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BO

2 952 000

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

233 570 000

5,9%

220 490 000

 

Gross

BP

0

0%

240 423 000

3,8%

231 572 000

 

Amortisation

BQ

0

0%

6 853 000

-38,2%

11 082 000

Semi-finished and finished products

Net

104 395 000

-33,3%

156 457 000

13,7%

137 649 000

 

Gross

BR

140 247 000

-10,4%

156 457 000

13,7%

137 649 000

 

Amortisation

BS

35 852 000

0%

0

0%

0

Goods for resale

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BT

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BU

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Stocks

Net

321 570 000

-20,1%

402 243 000

9,1%

368 657 000



Advance payments to suppliers

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Advance payments to suppliers

Net

7 505 000

-27,8%

10 396 000

-56,2%

23 757 000

 

Gross

BV

7 505 000

-27,8%

10 396 000

-56,2%

23 757 000

 

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0



Debtors

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Trade accounts receivable

Net

1 051 759 000

-34,4%

1 602 386 000

-1,8%

1 632 458 000

 

Gross

BX

1 103 186 000

-33,7%

1 664 489 000

-0,5%

1 672 164 000

 

Amortisation

BY

51 427 000

-17,2%

62 103 000

56,4%

39 706 000

Other debtors

Net

130 594 000

-46,0%

242 040 000

76,0%

137 548 000

 

Gross

BZ

131 534 000

-47,7%

251 391 000

71,0%

147 030 000

 

Amortisation

CA

940 000

-89,9%

9 351 000

-1,4%

9 482 000

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Debtors

Net

1 182 353 000

-35,9%

1 844 426 000

4,2%

1 770 006 000



Divers

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Investment securities

Net

265 000

-90,6%

2 819 000

0%

0

 

Gross

CD

265 000

-90,6%

2 819 000

0%

0

 

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

306 863 000

-42,2%

530 864 000

185,1%

186 176 000

 

Gross

CF

306 863 000

-42,2%

530 864 000

185,1%

186 176 000

 

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Divers

Net

307 128 000

-42,5%

533 683 000

186,7%

186 176 000



Prepaid expenses

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Prepaid expenses

Net

100 554 000

-6,4%

107 387 000

176,1%

38 888 000

 

Gross

CH

100 554 000

-6,4%

107 387 000

176,1%

38 888 000

 

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts (IV to VI)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Multi-period charges

CW3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

-

-

-

-

 

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

-

-

-

-

 

Currency differential gain

CN3

1 781 000

86,5%

955 000

-74,9%

3 810 000

 

Gross

 

1 781 000

-

-

-

-

 

References

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

 

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Accounts - Passive
Other capital resources | Provisions for risks and charges | Liabilities | Translation loss | Equalization accounts | References

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Grand Total (I to V)

EE

3 264 199 000

-23,4%

4 259 334 000

12,3%

3 792 468 000


Shareholder Equity (I)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Total shareholders' equity (Total I)

DL

-384 733 000

-710,0%

63 073 000

-88,7%

558 264 000

 

Equity and shareholders' equity

DA

38 858 000

0%

38 858 000

-97,7%

1 665 340 000

 

Issue and merger premiums

DB

643 000

0%

0

0%

0

 

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

 

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

 

Legal reserve

DD

7 983 000

0%

7 983 000

0%

7 983 000

 

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

 

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

 

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

 

Other reserves

DG

33 223 000

-93,5%

511 423 000

1439,4%

33 223 000

 

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

 

0

0%

0

 

Profits or losses brought forward

DH

-16 991 000

0%

0

0%

-238 546 000

 

Profit or loss for the period

DI

-448 449 000

9,4%

-495 191 000

45,6%

-909 736 000

 

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

 

Special tax-allowable reserves

DK

0

0%

0

0%

0

 

Other capital resources (II)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

 

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

 

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

 

Provisions for risks and charges (III)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

653 428 000

-36,4%

1 028 133 000

-6,8%

1 103 404 000

 

Risk provisions

DP

0

0%

1 028 133 000

0%

0

 

Reserves for charges

DQ

653 428 000

0%

0

0%

1 103 404 000

 

Liabilities (IV)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Total Liabilities (Total IV)

EC

2 995 504 000

-5,4%

3 168 128 000

48,7%

2 130 800 000

 

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

 

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

 

Bank loans and liabilities

DU

1 800 074 000

4,8%

1 717 282 000

195,0%

582 165 000

 

Sundry loans and financial liabilities

DV

1 161 000

1109,4%

96 000

-22,6%

124 000

 

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

 

Advance payments received for current orders

DW

128 455 000

-56,0%

292 232 000

40,2%

208 366 000

 

Trade accounts payables

DX

668 771 000

-17,8%

814 012 000

-13,7%

943 461 000

 

Tax and social security liabilities

DY

158 556 000

-22,5%

204 526 000

-11,5%

231 191 000

 

Fixed asset liabilities

DZ

5 574 000

-47,7%

10 654 000

-21,9%

13 637 000

 

Other debts

EA

27 290 000

-37,6%

43 736 000

-38,0%

70 486 000

 

Translation loss (V)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Translation loss (Total V)

ED

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Deferred income

EB

205 623 000

140,2%

85 590 000

5,2%

81 370 000

 

References

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

 

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

 

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Result account
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges | Financial income | Financial charges | Financial charges | Extraordinary charges | Employee profit sharing | Tax on profits | References

1- Operating result (I-II)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Operating result (Total I-II)

GG

-353 350 000

17,7%

-429 568 000

29,8%

-611 766 000


2 - Financial result (V - VI)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Financial result (Total V-VI)

GV

-73 625 000

-578,1%

15 401 000

-72,6%

56 184 000


3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

-426 975 000

-3,1%

-414 167 000

25,5%

-555 582 000


4 - Extraordinary result (VII-VIII)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

-57 891 000

46,5%

-108 175 000

70,7%

-369 268 000


Profit or loss

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Profit or loss

HN

-448 449 000

9,4%

-495 191 000

45,6%

-909 736 000


Total Income (I+III+V+VII)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Total Income (I+III+V+VII)

HL

3 902 442 000

-14,0%

4 538 523 000

1,6%

4 465 071 000


Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

4 350 891 000

-13,6%

5 033 713 000

-6,3%

5 374 807 000


Operating income (I)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Total operating income (Total I)

FR

3 757 048 000

-13,8%

4 360 536 000

1,9%

4 277 885 000


Operating income (details)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Sale of goods for resale

FC

0

0%

0

0%

0

 

France

FA

0

0%

0

0%

0

 

Export

FB

0

0%

0

0%

0

Sale of goods produced

FF

0

0%

0

0%

0

 

France

FD

0

0%

0

0%

0

 

Export

FE

0

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

2 621 186 000

-13,1%

3 015 645 000

2,5%

2 943 476 000

 

France

FG

2 621 186 000

-13,1%

3 015 645 000

2,5%

2 943 476 000

 

Export

FH

0

0%

0

0%

0

Net turnover

FL

2 621 186 000

-13,1%

3 015 645 000

2,5%

2 943 476 000

 

France

FJ

2 621 186 000

-13,1%

3 015 645 000

2,5%

2 943 476 000

 

Export

FK

0

0%

0

0%

0

 

Stocked production

FM

100 458 000

-26,8%

137 194 000

-4,5%

143 629 000

 

Self-constructed assets

FN

3 092 000

-45,5%

5 676 000

-14,6%

6 645 000

 

Operating grants

FO

2 343 000

-34,0%

3 551 000

-34,3%

5 401 000

 

Release of reserves and provisions

FP

913 125 000

-6,6%

977 501 000

-2,3%

1 000 789 000

 

Other income

FQ

116 844 000

-47,1%

220 969 000

24,2%

177 945 000


Operating charges (II)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Total operating charges (Total II)

GF

4 110 398 000

-14,2%

4 790 104 000

-2,0%

4 889 651 000


Exploitation charges

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Purchase of goods for resale

FS

0

0%

0

0%

0

 

Change in stocks of goods for resale

FT

0

0%

0

0%

0

 

Purchase of raw materials

FU

852 899 000

-26,4%

1 158 697 000

-9,9%

1 286 277 000

 

Change in stocks of raw materials

FV

152 852 000

49,0%

102 615 000

2,0%

100 606 000

 

Other external purchases and charges

FW

1 653 815 000

2,1%

1 620 235 000

7,8%

1 503 658 000

 

Tax, duty and similar payments

FX

48 101 000

-32,9%

71 681 000

17,5%

61 018 000

 

Payroll

FY

462 359 000

-21,7%

590 219 000

5,8%

557 986 000

 

Social security costs

FZ

201 636 000

-8,6%

220 500 000

-7,2%

237 616 000


Depreciation

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Depreciation of fixed assets

GA

24 956 000

-14,7%

29 262 000

-16,4%

35 020 000

 

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

0

 

Depreciation/amortisation of current assets

GC

79 418 000

14,7%

69 230 000

91,1%

36 225 000

 

Provisions for risks and charges

GD

378 929 000

-42,4%

658 262 000

-21,6%

839 803 000


Other charges

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Other charges

GE

255 433 000

-5,2%

269 403 000

16,4%

231 442 000

 

Operating charges (III-IV)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

 

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

 

Financial income (V)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Total financial income (Total V)

GP

84 166 000

-34,6%

128 746 000

15,4%

111 611 000

 

Share financial income

GJ

1 074 000

-96,1%

27 763 000

-52,5%

58 462 000

 

Other investment income & capitalised receivables

GK

200 000

-50,1%

401 000

9,9%

365 000

 

Other interest and similar income

GL

10 564 000

-12,2%

12 026 000

19,8%

10 040 000

 

Released provisions and transferred charges

GM

29 601 000

212,3%

9 479 000

-57,6%

22 347 000

 

Exchange gains

GN

42 727 000

-46,0%

79 077 000

287,7%

20 397 000

 

Net income from disposal of investment securities

GO

0

0%

0

0%

0

 

Financial Charge (VI)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Total financial charge (Total VI)

GU

157 791 000

39,2%

113 345 000

104,5%

55 427 000

 

Financial reserves and provisions

GQ

31 190 000

-11,6%

35 277 000

155,9%

13 786 000

 

Interest and similar charges

GR

49 147 000

-13,9%

57 094 000

67,0%

34 190 000

 

Exchange losses

GS

77 454 000

269,3%

20 974 000

181,5%

7 451 000

 

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

 

Financial Charge (VII)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Total extraordinary income (Total VII)

HD

61 228 000

24,3%

49 241 000

-34,8%

75 575 000

 

Extraordinary operating income

HA

10 830 000

55,3%

6 975 000

-61,9%

18 312 000

 

Extraordinary income from capital transactions

HB

700 000

-74,1%

2 702 000

-89,1%

24 823 000

 

Released provisions and transferred charges

HC

49 698 000

25,6%

39 564 000

22,0%

32 440 000

 

Extraordinary charges (VIII)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

119 119 000

-24,3%

157 416 000

-64,6%

444 843 000

 

Extraordinary operating charges

HE

73 376 000

-41,5%

125 478 000

-61,4%

325 082 000

 

Extraordinary charges from capital transactions

HF

9 243 000

96,9%

4 694 000

-87,9%

38 867 000

 

Extraordinary reserves and provisions

HG

36 500 000

34,0%

27 244 000

-66,3%

80 894 000

 

Employee profit sharing (IX)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

0

0%

0

0%

0

 

Tax on profits (X)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Tax on profits (Total X)

HK

-36 417 000

-34,1%

-27 151 000

-79,6%

-15 114 000

 

References

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

 

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

 

Of which transferred charges

A1

0

0%

0

0%

0

 

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

 

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Other incomer tax return forms
Reserve for depreciation | Provisions included in balance sheet | State deadlines claims and debts at the end of period
Table allocation results and other information

Fixed Assets
Grand Total Fixed Assets (I to IV)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Gross value at begin of period

OG

0

0%

892 752 000

1,0%

884 010 000

 

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

18 585 000

-91,9%

229 878 000

 

Decreasess by budget item transfer

OK1

44 000

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

OK2

70 076 000

126,1%

30 996 000

-86,0%

221 136 000

 

Gross value at the end of period

OL

807 710 000

-8,3%

880 342 000

-1,4%

892 752 000


Research and development Charge (Total I)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

C01

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

C02

0

0%

0

0%

0

 

Gross value at the end of period

D0

0

0%

0

0%

0


Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Gross value at begin of period

KD

241 539 000

-0,3%

242 289 000

24,8%

194 133 000

 

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

1 032 000

616,7%

144 000

-99,8%

58 834 000

 

Decreasess by budget item transfer

LV1

47 000

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

LV2

7 954 000

789,7%

894 000

-91,6%

10 678 000

 

Gross value at the end of period

LW

234 570 000

-2,9%

241 539 000

-0,3%

242 289 000


Tangible fixed assets (Total III)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Gross value at begin of period

LN

449 113 000

-3,0%

463 164 000

1,1%

458 054 000

 

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

20 092 000

34,3%

14 957 000

-90,3%

154 069 000

 

Decreasess by budget item transfer

NG1

-3 000

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NG2

61 398 000

111,7%

29 009 000

-80,5%

148 959 000

 

Gross value at the end of period

NH

407 810 000

-9,2%

449 113 000

-3,0%

463 164 000


Fiancial assets (Total IV)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Gross value at begin of period

LQ

189 690 000

1,3%

187 299 000

-19,2%

231 823 000

 

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

-23 636 000

-778,4%

3 484 000

-79,5%

16 975 000

 

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NJ2

724 000

-33,8%

1 093 000

-98,2%

61 499 000

 

Gross value at the end of period

NK

165 330 000

-12,8%

189 690 000

1,3%

187 299 000

 

Reserve for depreciation
Situation and movement of reserve for depreciation
Grand total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Reserve for depreciation value at begin of period

0N

0

0%

436 440 000

-1,2%

441 768 000

Increases

0P

0

0%

17 957 000

-44,1%

32 120 000

Decreasess

0Q

0

0%

29 366 000

-78,7%

137 782 000

 

Reserve for depreciation value at the end of period

0R

0

0%

425 031 000

-2,6%

436 439 000


Research and development charge (Total I)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0


Other intangible assets (Total II)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

48 910 000

-1,1%

49 465 000

-8,3%

53 913 000

Increases

PF

990 000

208,4%

321 000

-92,7%

4 394 000

Decreasess

PG

7 924 000

804,6%

876 000

-90,5%

9 236 000

 

Decreasess by budget item transfer

PH

41 976 000

-14,2%

48 910 000

-1,1%

49 464 000


Total fixed assets amotisation (Total III)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

376 121 000

-2,8%

386 975 000

-0,2%

387 855 000

Increases

QV

30 566 000

73,3%

17 636 000

-36,4%

27 726 000

Decreases

QW

61 063 000

114,3%

28 490 000

-77,8%

128 546 000

 

Decreasess by budget item transfer

QX

345 624 000

-8,1%

376 121 000

-2,8%

386 975 000


Movements during period affecting charge allocated over several period
Charges à répartir ou frais d'émission d'emprunt

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0


Premium refund of obligations

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Net value at begining of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

 

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

 

Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Value at begining of period

7C

1 116 162 000

-8,2%

1 215 348 000

20,3%

1 009 900 000

Increases

UB

445 752 000

-47,2%

844 326 000

-10,5%

943 296 000

Decreases

UC

832 491 000

-4,5%

872 058 000

23,3%

707 392 000

 

Value at the end of period

UD

729 423 000

-38,6%

1 187 616 000

-5,6%

1 257 713 000

Includes Total allocations

 

Operating

UE

0

0%

0

0%

0

 

Financial

UG

0

0%

0

0%

0

 

Exceptional

UJ

0

0%

0

0%

0

Includes Total Withdrawal

 

Operating

UF

0

0%

0

0%

0

 

Financial

UH

0

0%

0

0%

0

 

Exceptional

UK

0

0%

0

0%

0


Total regulated provisions (Total I)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Value at begining of period

3Z

0

0%

0

0%

0

Increases

TS

0

0%

0

0%

0

Decreases

TT

0

0%

0

0%

0

 

Value at the end of period

TU

0

0%

0

0%

0


Total risk and charge provisions (Total II)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Value at begining of period

5Z

1 028 133 000

-6,8%

1 103 404 000

23,8%

891 306 000

Increases

TV

428 883 000

-44,9%

778 980 000

-12,5%

890 697 000

Decreases

TW

803 588 000

-5,9%

854 251 000

23,8%

689 917 000

 

Value at the end of period

TX

653 428 000

-36,4%

1 028 133 000

-6,8%

1 103 404 000


Total Provision for depreciation (Total III)

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Value at begining of period

7B

88 029 000

-21,4%

111 944 000

-5,6%

118 594 000

Increases

TY

16 869 000

-74,2%

65 346 000

24,2%

52 599 000

Decreases

TZ

28 903 000

62,3%

17 807 000

1,9%

17 475 000

 

Value at the end of period

UA

75 995 000

-52,3%

159 483 000

3,4%

154 309 000

 

State deadlines claims and debts at the end of period
State claims

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Gross value

VT

0

0%

0

0%

0

 

1 year at most

VU

0

0%

0

0%

0

 

More than one year

VV

0

0%

0

0%

0


State of loans

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Claims related to holdings (gross)

UL

0

0%

0

0%

0

 

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

0%

0

0%

0

 

Loans (gross)

UP

0

0%

0

0%

0

 

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

0

0%

0

 

Other financial assets (gross)

UT

0

0%

0

0%

0

 

Other financial assets (1 year at most)

UV

0

0%

0

0%

0


Receivables statement of assets

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Customers doubtful or disputed

VA

0

0%

0

0%

0

 

Other claims customer

UX

0

0%

0

0%

0

 

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

 

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

 

Personnel and associated accounts

UY

0

0%

0

0%

0

 

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

0

0%

0

 

Income taxes

VM

0

0%

0

0%

0

 

Value added tax

VB

0

0%

0

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

VN

0

0%

0

0%

0

 

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

0

0%

0

 

Group and Associates

VC

0

0%

0

0%

0

 

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

0

0%

0

0%

0


Prepaid

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Prepaid

VS

0

0%

0

0%

0


State Debt

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Total debt (gross)

VY

2 789 881 000

-9,5%

3 082 538 000

50,4%

2 049 429 000

1 year at most

VZ2

359 000

-100,0%

3 082 442 000

50,4%

2 049 429 000

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

2 789 522 000

0%

0

0%

0

More than 5 years

VZ4

0

0%

0

0%

0


Details

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VG2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VH2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

1 801 234 000

4,9%

1 717 378 000

194,9%

582 288 000

1 year at most

8A2

358 000

-100,0%

1 717 282 000

194,9%

582 288 000

More than 1 year and 5 years at most

8A3

1 800 876 000

0%

0

0%

0

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

668 771 000

-17,8%

814 012 000

-13,7%

943 461 000

1 year at most

8B2

668 771 000

-17,8%

814 012 000

-13,7%

943 461 000

More than 1 year and 5 years at most

8B3

668 771 000

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8C2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

158 556 000

-22,5%

204 526 000

-11,5%

231 192 000

1 year at most

8D2

0

0%

204 526 000

-11,5%

231 192 000

More than 1 year and 5 years at most

8D3

158 556 000

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (gross)

VW1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VW2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VQ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

5 574 000

-47,7%

10 654 000

-21,9%

13 637 000

1 year at most

8J2

0

0%

10 654 000

-21,9%

13 637 000

More than 1 year and 5 years at most

8J3

5 574 000

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VI2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More 5 years

VI4

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

155 745 000

-53,6%

335 968 000

20,5%

278 851 000

1 year at most

8K2

0

0%

335 968 000

20,5%

278 851 000

More than 1 year and 5 years at most

8K3

155 745 000

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8L2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0


References

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Loans made during the period

VJ

0

0%

0

0%

0

 

Debt repaid during the period

VK

0

0%

0

0%

0

 

Table allocation results and other information
Dividends distributed

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0


Commitments

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

 

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

 

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0


Other charges Externes

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

 

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

 

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

 

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

 

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

 

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

 

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0


Taxes and Fees

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

 

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0


VAT

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

 

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0


Average number of employees

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Average number of employees

YP

6 804

-12,0%

7 736

-11,4%

8 727


Groups and Shareholders

 

 

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

 

Groups and Shareholders

ZR

0

-

0

-

-

 

 

 

Display parameter

Comparison mode

Average

Median


Ratios
Structure and liquidity | Management or rotation | Profitability of the business | Return on capital

Structure and Liquidity

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Avg sector 2009

 

Fixed Asset Financing

 

1,90

-28,3%

2,65

36,6%

1,94

5,77

-67,1%

Global Debt

 

411 days

8,7%

378 days

44,8%

261 days

807,19 days

-49,1%

Working Capital Fund overall net

 

100 days

-42,2%

173 days

68,0%

103 days

281,05 days

-64,4%

Financial independence

 

-79,70%

-38,7%

-57,47%

32,0%

-84,46%

137229,54%

-100,1%

More ratios

Solvability

 

-11,79%

-896,6%

1,48%

-89,9%

14,72%

32,81%

-135,9%

Capacity debt futures

 

%

-

%

-

%

92480,50%

-

Coverage of current assets by net working capital overall

 

37,62%

-24,3%

49,71%

44,0%

34,51%

39,21%

-4,1%

General Liquidity

 

0

0%

0

0%

0

4,18

0%

Restricted Liquidity

 

855,51

503141,2%

0,17

88,9%

0,09

9,56

8848,8%


Management or rotation

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Sector Average 2009

 

Need background in operating working capital

 

72 days

-32,1%

106 days

24,7%

85 days

67,90 days

6,0%

Treasury

 

42 days

-34,4%

64 days

178,3%

23 days

163,93 days

-74,4%

Inventory turnover of goods

 

days

-

days

-

days

70572,38 days

-

Average length of credit granted to customers

 

152 days

-23,6%

199 days

-2,9%

205 days

105,63 days

43,9%

Average length of credit obtained suppliers

 

91 days

-10,8%

102 days

-13,6%

118 days

286,28 days

-68,2%

More ratios

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

 

18 days

5,9%

17 days

41,7%

12 days

630,92 days

-97,1%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

 

days

-

days

-

days

939,11 days

-

Rotation tangible assets

 

642,75%

-4,3%

671,47%

5,7%

635,51%

1376,08%

-53,3%


Profitability of the business

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Sector Average 2009

 

Margin trading

 

0%

0%

0%

0%

0

7,56%

0%

Profitability of the business

 

-24,59

-23,2%

-19,96

9,4%

-22,02

-60,46%

59,3%

Net profit

 

-17,11%

-4,2%

-16,42%

46,9%

-30,91%

-52,58%

67,5%

More ratios

Growth rate of turnover (excluding VAT)

 

-13,08%

-633,9%

2,45%

157,5%

-4,26%

0,91%

-1537,4%

Rates integration

 

2,49%

-72,9%

9,18%

33,0%

6,90%

6,69%

-62,8%

Rate leasing furniture

 

0%

0%

0%

0%

0%

0,52%

0%

Work Factor

 

1018,87%

248,1%

292,71%

-25,2%

391,52%

97,18%

948,4%

Weight interests

 

6,02

60,1%

3,76%

100%

1,88%

2,47%

143,7%


Return on capital

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Sector Average 2009

 

Cash flow from the overall profitability

 

-13,25%

0,5%

-13,31%

48,8%

-26,02%

-38,73%

65,8%

Rates of economic profitability

 

-46%

-35,3%

-34%

40,4%

-57%

70,39%

-165,4%

Financial profitability

 

-1434715000%

-45,4%

-986909000%

-100,7%

-491718000%

-1477512,42%

-97003,4%

Return on investment

 

-20,52%

4,3%

-21,45%

71,4%

-74,90%

27,74%

-174,0%

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

Comparison mode

Average

Median


Soldes Intermédiaires de Gestion

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

31/12/2007

Sector Average 2009

 

Turnover

2 621 186 000

-13,1%

3 015 645 000

2,5%

2 943 476 000

17 968 481 € 

14487,7%  

 

Sales of goods

0

0%

0

0%

0

 

 

- Purchase of goods

0

0%

0

0%

0

 

 

+/- Stock of goods variation

0

0%

0

0%

0

 

 

Trading margin

0 €

0%

0 €

0%

0 €

544275,46 € 

0%  

 

0,00 % CA

0%

0,00 % CA

0%

0,00 % CA

8,44 % CA 

0%  

 

Sale of goods produced

2 621 186 000

-13,1%

3 015 645 000

2,5%

2 943 476 000

 

 

+/- Stocked production

100 458 000

-26,8%

137 194 000

-4,5%

143 629 000

 

 

+ Self-constructed assets

3 092 000

-45,5%

5 676 000

-14,6%

6 645 000

 

 

Period production

2 724 736 000 €

-13,7%

3 158 515 000 €

2,1%

3 093 750 000 €

16838166,58 € 

16081,9%  

 

103,95 % CA

-0,8%

104,74 % CA

-0,4%

105,11 % CA

82,64 % CA 

25,8%  

 

Trading margin

0

0%

0

0%

0

544275,46 

0%  

+ Period Production

2 724 736 000

-13,7%

3 158 515 000

2,1%

3 093 750 000

16838166,58 

16081,9%  

- Purchase of raw materials

852 899 000

-26,4%

1 158 697 000

-9,9%

1 286 277 000

 

 

+/- Change in stocks of raw materiels

152 852 000

49,0%

102 615 000

2,0%

100 606 000

 

 

- Other external purchases and charges

1 653 815 000

2,1%

1 620 235 000

7,8%

1 503 658 000

 

 

Added value

65 170 000 €

-76,5%

276 968 000 €

36,3%

203 209 000 €

3359115,92 € 

1840,1%  

 

2,49 % CA

-72,9%

9,18 % CA

33,0%

6,90 % CA

6,69 % CA 

-62,8%  

 

Added value

65 170 000 €

-76,5%

276 968 000 €

36,3%

203 209 000 €

3359115,92 € 

1840,1%  

+ Operating grants

2 343 000

-34,0%

3 551 000

-34,3%

5 401 000

 

 

- Tax, duty and similar payments

48 101 000

-32,9%

71 681 000

17,5%

61 018 000

 

 

- Personal charges

663 995 000

-18,1%

810 719 000

1,9%

795 602 000

 

 

Gross operating surplus

-644 583 000 €

-7,1%

-601 881 000 €

7,1%

-648 010 000 €

-1683943,28 € 

-38178,2% 

 

-24,59 % CA

-23,2%

-19,96 % CA

9,4%

-22,02 % CA

-60,46 % CA 

59,3%  

 

Gross operating surplus

-644 583 000 €

-7,1%

-601 881 000 €

7,1%

-648 010 000 €

-1683943,28 € 

-38178,2% 

+ Release of reserves and provisions

913 125 000

-6,6%

977 501 000

-2,3%

1 000 789 000

 

 

+ Other operating income

116 844 000

-47,1%

220 969 000

24,2%

177 945 000

 

 

- Depreciation/Amortisation

483 303 000

-36,1%

756 754 000

-16,9%

911 048 000

 

 

- Other charges

255 433 000

-5,2%

269 403 000

16,4%

231 442 000

 

 

Operating result

-353 350 000 €

17,7%

-429 568 000 €

29,8%

-611 766 000 €

-749868,66 € 

-47021,6%  

 

-24,59 % CA

-23,2%

-19,96 % CA

9,4%

-22,02 % CA

-61,79 % CA 

60,2%  

 

Operating result

-353 350 000 €

17,7%

-429 568 000 €

29,8%

-611 766 000 €

-749868,66 € 

-47021,6%  

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Financial income

84 166 000

-34,6%

128 746 000

15,4%

111 611 000

 

 

- Financial charges

157 791 000

39,2%

113 345 000

104,5%

55 427 000

 

 

Pre-tax result

-426 975 000 €

-3,1%

-414 167 000 €

25,5%

-555 582 000 €

-908346,25 € 

-46905,8%  

 

-16,29 % CA

-18,6%

-13,73 % CA

27,3%

-18,88 % CA

-105,41 % CA 

84,5%  

 

Extraordinary income

61 228 000

24,3%

49 241 000

-34,8%

75 575 000

367759,49 

16548,9%  

- Extraordinary charges

119 119 000

-24,3%

157 416 000

-64,6%

444 843 000

 

 

Extraordinary result

-57 891 000 €

46,5%

-108 175 000 €

70,7%

-369 268 000 €

-373805,48 € 

-15386,9%  

 

-2,21 % CA

38,4%

-3,59 % CA

71,4%

-13 % CA

-11,28 % CA 

80,4%  

 

Pre-tax result

-426 975 000 €

-3,1%

-414 167 000 €

25,5%

-555 582 000 €

-908346,25 € 

-46905,8%  

Extraordinary result

-57 891 000 €

46,5%

-108 175 000 €

70,7%

-369 268 000 €

-373805,48 € 

-15386,9%  

- Employee profit sharing

0

0%

0

0%

0

 

 

- Tax on profits

-36 417 000

-34,1%

-27 151 000

-79,6%

-15 114 000

 

 

Net result

-448 449 000 €

9,4%

-495 191 000 €

45,6%

-909 736 000 €

-1153714,65 € 

-38770,0%  

 

-17,11 % CA

-4,2%

-16,42 % CA

46,9%

-30,91 % CA

-99,38 % CA 

82,8%  

 

 

judgements

 

Collective procedures

 

 

No judgment information for the company

 

 

 

 

 

 

   Social security, pension funds preferential rights | Tax office preferential rights

Preferential rights details and history

Summary of preferential rights

Company monitored since

18/09/2007

 

 

Status of Monitoring

This company is under monitoring with at least one active preferential right

Number of active preferential rights

1

Total amount

985 119 EUR

Due remaining amount

188 649 EUR

Tax office preferential rights

Number of active preferential rights

1

Total amount

985 119 EUR

Due remaining amount

188 649 EUR

Date of last preferential right

28/10/2009

 

Active

Registration number

Registration date

Date of the planned end

Creditor

Amount of the debt

Due remaining amount

40908479

28/10/2009

28/10/2013

COMPTABLE DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

985 119 EUR

188 649 EUR

Paid off amount

796 470 EUR

 

 

Court

Paris

Creditor

COMPTABLE DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
8 R COURTOIS 93505, PANTIN CEDEX

Debtor

SA ALCATEL
12 R DE LA BAUME 75008 PARIS

 

Historical Data

Registration number

Registration date

Date of the planned end

Creditor

Amount of the debt

Due remaining amount

40604614

27/02/2006

27/02/2010

RECETTE PRINCIPALE

36 782 EUR

-

Reason for closure

Void

Court

Paris

Creditor

RECETTE PRINCIPALE
8 R COURTOIS 93505, PANTIN CEDEX

Debtor

SA ALCATEL
12 R DE LA BAUME 75008 PARIS

   

Group data

 

Ultimate parent company

ALCATEL LUCENT

Direct parent

ALCATEL LUCENT PARTICIPATIONS - 100 %

Group – Number of companies

89

Linkages – Number of companies

106

Number of countries

21

Go directly to the current company

Display only where participation % > 33 %

Display all participations

This company is a part of several groups, choose the group you wish to see the structure

Display the group

ALCATEL LUCENT

loading data...

Raison sociale

 

Safe Number

SIREN

Parts

Limite

Derniers
comptes
publiés

ALCATEL LUCENT

 

FR11704421

542019096

-

250 000 €

31/12/2010

RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE

 

FR11814805

659804397

100%

460 000 €

31/12/2010

CGTI

 

FR03437186

393502430

100%

0 €

31/12/2010

ALCATEL-LUCENT SUBMARINE NETWORKS

 

FR03155633

389534256

100%

250 000 €

31/12/2010

ALCATEL SUBMARINE INC.

 

-

-

100%

-

-

ALDA MARINE

 

FR05929663

431958073

51%

0 €

31/12/2010

CORALEC

 

FR12214340

393525761

100%

250 000 €

31/12/2010

ALCATEL HOLDINGS CANADA CORPORATION

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL-LUCENT CANADA INC

 

-

-

100%

-

-

FLORELEC

 

FR12231931

420765125

100%

250 000 €

31/12/2009

EVOLIUM SAS

 

FR12240787

432941144

100%

2 000 000 €

31/12/2010

ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS

 

FR12192134

333150043

100%

0 €

31/12/2010

ALCATEL-LUCENT UK LIMITED

 

UK02515452

02855052

100%

0 £

31/12/2010

ALCATEL-LUCENT TELECOM LIMITED

 

UK02311639

02650571

100%

2 400 000 £

31/12/2010

ALCATEL-LUCENT HOLDING GMBH

 

DE02267950

HRB 14755

75%

2 500 €

31/12/2009

ALCATEL-LUCENT DEUTSCHLAND AG

 

DE01735298

HRB 4026

100%

3 550 000 €

31/12/2010

RADIO FREQUENCY SYSTEMS GMBH

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL LUCENT HOLDINGS INC

 

-

-

100%

-

-

GENESYS TELECOMMUNICATIONS LABORATORIES ...

 

-

-

100%

-

-

INFORMIAM LLC

 

-

-

Majoritaire

-

-

SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEERING

 

-

-

Majoritaire

-

-

ALCATEL-LUCENT USA INC

 

-

-

100%

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC

 

-

-

100%

-

-

ASCEND COMMUNICATIONS INC.

 

-

-

100%

-

-

STRATUS WORLD TRADE CORPORATION

 

-

-

100%

-

-

SRA COMPUTER C.V.

 

NL01698015

30147003

89%

6 000 €

-

LUCENT TECHNOLOGIES IREL...

 

IE00289200

IE295146

100%

-

31/12/2008

LUCENT TECHNOLOGIES IN...

 

IE00292461

IE298410

100%

-

31/12/2008

SRA HOLDINGS LLC

 

-

-

100%

-

-

SRA INVESTMENTS LLC

 

-

-

100%

-

-

STRATUS COMPUTER INC.

 

-

-

100%

-

-

LGS INNOVATIONS LLC

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL HOLDINGS IN...

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL-LUCENT INDIA LIMITED

 

-

-

63.40%

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES INVESTMENT CO LTD

 

-

-

100%

-

-

RADIO FREQUENCY SYSTEMS INC

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL-LUCENT CHINA INVESTMENT CO LTD

 

-

-

100%

-

-

CHATEAU MALESCASSE SA

 

FR01619132

335186300

100%

67 500 €

31/12/2010

SPATIAL WIRELESS

 

-

-

Majoritaire

-

-

ALCATEL LUCENT SERVICOS EM TELECOMMUNICA...

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL-LUCENT POLSKA SPZOO

 

-

-

68.41%

-

-

ALCATEL LUCENT HOLDING SA DE C.V.

 

-

-

99.99%

-

-

ALCATEL LUCENT MEXICO SA DE CV

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL LUCENT AUSTRALIA LIMITED

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE

 

FR12656882

602033185

100%

0 €

31/12/2010

ALCATEL BUSINESS SYSTEMS LIMITED

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL-LUCENT N.V.

 

NL01418378

27149369

100%

350 000 €

31/12/2010

ALCATEL-LUCENT BELL NV

 

BE00027898

404621642

100%

9 450 000 €

31/12/2010

ALCATEL ZAO

 

-

-

100%

-

-

BELL FINOPA NV

 

-

-

99.99%

-

-

KBTP NV

 

-

-

99.96%

-

-

ALCATEL LUCENT ITALIA S.P.A.

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL-LUCENT AUSTRIA A.G.

 

-

-

99.98%

-

-

ALCATEL-LUCENT PORTUGAL SA

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL-LUCENT NEDERLAND B.V.

 

NL01410069

27125800

100%

2 700 000 €

31/12/2009

ALCATEL-LUCENT SCHWEIZ AG

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL-LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON ...

 

-

-

65%

-

-

ALCATEL LUCENT ESPANA SA

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL TAISEL

 

-

-

60%

-

-

ALCATEL-LUCENT FRANCE

 

FR01704531

338966385

100%

0 €

31/12/2009

ADIXEN VACUUM PRODUCTS

 

FR00095494

085980357

100%

2 000 000 €

31/12/2010

ALCATEL VACUUM TECHNOLOGY UK

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL VACUUM TECHNOLOGY KORÉA

 

-

-

51%

-

-

ALCATEL VACUUM SYSTEMS SPA

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL VACUUM PRODUCTS

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL HOCHVAKUUM TECHNIK GMBH

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL VACUUM TECHNOLOGY NETHERLANDS

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL VACUUM TECHNOLOGY INDIA

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL-LUCENT SINGAPORE PTE LTD

 

-

-

100%

-

-

BK-ADIXEN

 

-

-

68%

-

-

TEKNOVID

 

-

-

72%

-

-

ALCATEL VACUUM TECHNOLOGY TAIWAN

 

-

-

100%

-

-

ADIXEN SCANDINAVIA AB

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL-LUCENT JAPAN LTD

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL VACUUM TECHNOLOGY SHANGHAI

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL LUCENT & CENTRAL AFRICA

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS CHIN...

 

FR13418644

424693216

100%

250 000 €

31/12/2010

ALCATEL LUCENT BRASIL SA

 

-

-

87.10%

-

-

ALCATEL LUCENT TECHNOLOGIES B.V.

 

NL01838909

32041830

100%

7 800 000 €

31/12/2010

ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL

 

FR09365841

493378939

100%

2 000 000 €

31/12/2010

SOC ELECTRO BANQUE

 

FR12656561

562064287

100%

250 000 €

-

ELECTRO RÉ

 

-

-

100%

-

-

ALCATEL-LUCENT NORWAY AS

 

-

916186398

100%

1 530 000 €

31/12/2010

NETDEVICES

 

-

-

Majoritaire

-

-

TROPIC NETWORKS

 

-

-

100%

-

-

DATANG MOBILE

 

-

-

Majoritaire

-

-

VELOCIX LIMITED

 

UK04006802

04358049

Majoritaire

7 500 £

31/12/2010

MOTIVE

 

-

2363585

Majoritaire

-

-

MOBILE NEWS CHANNEL

 

-

-

Majoritaire

-

-

 

Linkages

Ultimate parent company

ALCATEL LUCENT

Direct parent

ALCATEL LUCENT PARTICIPATIONS - 100 %

Group – Number of companies

89

Linkages – Number of companies

106

Number of countries

21

 

 

Safe Number

SIREN

Dernier bilan

Limite

CA

FANUC

 

-

2381

31/03/2011

50 000 000 €

3 826 143 253 €

FUJITSU

 

-

2062

31/03/2011

50 000 000 €

38 830 765 141 €

SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES

 

-

189535

31/03/2011

18 800 000 €

1 208 405 148 €

FUJITSU FRONTECH

 

-

2054909

31/03/2011

5 050 000 €

897 075 091 €

NIFTY

 

-

2554610

31/03/2011

3 600 000 €

887 565 491 €

FUJITSU BROAD SOLUTION

 

-

2549093

31/03/2011

3 200 000 €

264 708 152 €

FDK CORP

 

-

1939

31/03/2011

1 300 000 €

809 739 408 €

ALCATEL-LUCENT FINANZ BETEILIGUNGS- UND ...

 

DE01503021

HRB 18368

31/12/2009

50 000 €

-

RADIO FREQUENCY SYSTEMS GESELLSCHAFT MIT...

 

DE01393731

HRB 52392

31/12/2010

600 000 €

112 106 000 €

ALCATEL-LUCENT SUBMARINE NETWORKS LIMITE...

 

UK01417329

01750343

31/12/2010

2 100 000 £

271 400 000 £

ALCATEL-LUCENT SERVICES INTERNATIONAL B....

 

NL01418379

27149372

31/12/2009

325 000 €

-

BNR EUROPE LIMITED

 

UK01417330

01750344

31/12/2002

-

0 £

ALCATEL-LUCENT IRELAND LIMITED

 

IE00079346

IE085214

31/12/2010

60 000 €

10 550 143 €

ALCATEL-LUCENT SWEDEN AB

 

SE00581892

5560924440

31/12/2010

25 000 KSEK

214 863 KSEK

ALCAD LIMITED

 

UK01341424

01674043

31/12/2010

-

0 £

SENSISTOR AB

 

SE00936779

5565367934

01/12/2006

-

9 KSEK

ALCATEL-LUCENT SUOMI OY

 

-

01141171

31/12/2010

50 000 €

23 750 000 €

LUCENT TECHNOLOGIES HOLDING AND FINANCE ...

 

IE00131340

IE137208

30/09/2006

-

0 €

LUCENT TECHNOLOGIES COMMUNICATIONS LIMIT...

 

IE00131339

IE137207

30/09/2006

-

152 802 €

ALCATEL TELECOM BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT...

 

DE02264112

HRB 19856

31/12/2008

-

-

ALCATEL-LUCENT DIGITALFUNK BETRIEBSGESEL...

 

DE02131223

HRB 125990 B

31/12/2010

40 000 €

25 111 936 €

INFICON AB

 

SE00640835

5562099001

31/12/2010

2 150 KSEK

32 577 KSEK

LUCENT TECHNOLOGIES NEDERLAND B.V.

 

NL01838035

32038419

30/09/2006

-

84 000 000 €

ALCATEL-LUCENT NETWORKS GMBH

 

DE01793672

HRB 110190

31/12/2009

69 000 €

-

ALCATEL-LUCENT INTERNETWORKING DEUTSCHLA...

 

DE00816897

HRB 115530

31/12/2009

26 500 €

-

ALCATEL SEL UNTERSTÜTZUNGS-GMBH

 

DE01002548

HRB 15792

31/12/2009

120 000 €

-

ALCATEL-LUCENT NETWORK SERVICES GMBH

 

DE02186773

HRB 55564

31/12/2010

315 000 €

234 173 000 €

GENESYS TELECOMMUNICATIONS LABORATORIES ...

 

NL01225559

24293219

31/12/2009

93 000 €

5 917 143 €

ALCATEL-LUCENT NETWORK OPERATIONS AND BU...

 

NL01460657

27246886

31/12/2009

11 000 €

-

GATESHEAD TECHNOLOGY INNOVATION LIMITED

 

UK06341042

06698414

31/12/2010

1 000 £

17 137 £

LUCENT TECHNOLOGIES NETWORK SYSTEMS UK L...

 

UK01688234

02022888

30/09/2006

-

135 801 000 £

LUCENT TECHNOLOGIES TREASURY SERVICES

 

IE00357987

IE365839

31/12/2008

-

11 669 911 €

ALCATEL PENSION TRUSTEES LIMITED

 

UK01147235

01478508

31/12/2010

1 000 £

206 400 £

ALCATEL IP NETWORKS LIMITED

 

UK03587923

03934955

31/12/2010

100 000 £

9 051 819 £

STC

 

UK00012278

00106921

31/12/2010

-

-

ALCATEL NETWORKS LIMITED

 

UK01686044

02020682

31/12/2010

-

-

GENESYS TELECOMMUNICATIONS LABORATORIES ...

 

UK02639633

02979911

31/12/2010

1 200 000 £

84 954 000 £

ALCATEL NETWORKS SERVICES LIMITED

 

UK03062520

03404726

31/12/2010

-

-

EUROPE * STAR LIMITED

 

UK03218708

03562015

31/12/2009

-

-

EUROPE*STAR MARKETING INTERNATIONAL LIMI...

 

UK03609854

03957108

31/12/2009

-

-

GTI HOLDINGS LIMITED

 

UK06515593

06873277

30/04/2010

-

-

NORTEL NETWORKS

 

-

185

31/12/2010

-

430 286 626 €

GENESYS TELECOMMUNICATIONS LABORATORIES

 

-

18252919

-

2 000 €

-

FUJITSU ACCESS

 

-

184745

-

-

-

FUJITSU DEVICES

 

-

2061505

-

-

-

NEXTIRAONE ANTILLES-GUYANE

 

FR00500116

303160485

-

24 000 €

-

BELL FINOPA NV

 

BE00258178

444599302

31/12/2010

0 €

-

OFIPAR NV

 

BE01500108

449418024

-

-

-

FUJITSU SYSTEMS CONSTRUCTION

 

-

582389

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES

 

-

864387

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES BETEILIGUNGS- UND VE...

 

DE01192921

HRB 17867

-

-

-

ALCATEL-LUCENT INTEGRATION SERVICES GMBH

 

DE01497968

HRB 53127

-

-

-

DUNKERMOTOREN GMBH

 

DE02306190

HRB 703736

31/12/2009

-

-

ALCATEL SEL FACHHANDEL GMBH

 

DE00631651

HRB 2898

-

-

-

ALCATEL PARTICIPATIONS

 

-

-

-

-

-

ALCATEL SPACECOM SOCIETE PAR ACTIONS SIM

 

-

-

-

-

-

ALCATEL-LUCENT PARTICIPATION S.A.

 

-

-

-

-

-

ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS

 

-

-

-

-

-

ALCATEL-LUCENT USA INC

 

-

-

-

-

-

ASCEND COMMUNICATIONS (BERMUDA

 

-

-

-

-

-

ASCEND COMMUNICATIONS, INC.

 

-

-

-

-

-

BELL LABORATORIES, INC.

 

-

-

-

-

-

DAY INVESTMENT CORP.

 

-

-

-

-

-

FIRST BEACON INSURANCE COMPANY

 

-

-

-

-

-

KED FUNDING LLC

 

-

-

-

-

-

LTI NJ FINANCE LLC

 

-

-

-

-

-

LTI PROPERTIES FINANCE LLC

 

-

-

-

-

-

LTI PROPERTIES HOLDINGS LLC

 

-

-

-

-

-

LUCENT ASSET MANAGEMENT CORPOR

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES (CHINA) CO

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES (SHENZHEN)

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES BETEILIGUN

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES CANADA COR

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES CANADA LLC

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES CAPITAL IR

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES COMERCIO E

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES CONSTRUCTI

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES EL SALVADO

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES EMEA B.V.

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES GRL LLC

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES GROUP UK L

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES HINDUSTAN

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES HOLDINGS A

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES HOLDINGS L

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES HOLDINGS U

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES INTEGRATED

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES INTERNATIO

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES MANAGEMENT

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES OPTICAL NE

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES PARSIPANIS

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES QINGDAO TE

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES THAILAND I

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES TREASURY S

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES UK LIMITED

 

-

-

-

-

-

LUCENT TECHNOLOGIES WORLD SERV

 

-

-

-

-

-

LUCENT VENTURE PARTNERS INC.

 

-

-

-

-

-

NCS OSP DEVELOPMENT CORP.

 

-

-

-

-

-

NEW JERSEY NANOTECHNOLOGY CONS

 

-

-

-

-

-

SRA HOLDINGS LLC

 

-

-

-

-

-

SRA INVESTMENTS LLC

 

-

-

-

-

-

STRATUS COMPUTER, INC.

 

-

-

-

-

-

STRATUS WORLD TRADE CORP.

 

-

-

-

-

-

TELICA, INC.

 

-

-

-

-

-

WESTERN ELECTRIC COMPANY, INCO

 

-

-

-

-

-

WM FUNDING LLC

 

-

-

-

-

-

 


event history

 

 

 

 

 

 

Date

Description

17/05/2010

Economically active

 

 

 

 

 

 

Publication date

Gazette Name

Description

 

20/09/2011

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

8214 - 338966385 RCS. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 3 avenue Octave Gréard 75007 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2010.

21/06/2011

JAL

Appointment of the social representative

 

 

Semaine de l'Ile-de-France (La)


Société faisant l'objet d'une nomination : 501654537 - INEO CV 11, 1 PL DES DEGRES, - TOUR VOLTAIRE, PUTEAUX, 92800 PUTEAUX
Nominé :
En la fonction de : Président
Nominé : Monsieur François JOBARD, 21 Rue des Deux Cousins, 78150 LE CHESNAY
En la fonction de : Membre du Comité de direction
Nominé : Monsieur Gilles PARMENTIER, 48 Avenue du Général Foy, 75008 PARIS 08
En la fonction de : Membre du Comité de direction
Nominé : Monsieur Gautier CHATELUS, 14 Rue Portefoin, 75003 PARIS 03
En la fonction de : Membre du Comité de direction
Nominé : Monsieur Patrick VANDEVOORDE, 76 Avenue de Suffren, 75015 PARIS 15
En la fonction de : Membre du Comité de direction
Nominé : Monsieur Pascal HOMSY, 6 Allée de l'Abbé Emile Bois, 78560 LE PORT MARLY
En la fonction de : Membre du Comité de direction
Nominé : Monsieur Guy LACROIX, 14 Rue de Corblin, La Bate, 78730 LONGVILLIERS
En la fonction de : Membre du Comité de direction
Date d'effet : 20/05/2011

17/11/2010

JAL

Continuation of activity in spite of stockholders' equity become lower in the middle of the share capital

 

 

Affiches parisiennes (Les)


Date de décision : 29/10/2010
Poursuite d'activité malgré des fonds propres devenus inférieurs à la moitié du capital social de la société 338966385 -  ALCATEL - LUCENT FRANCE, 3 AV OCTAVE GREARD, 75007 PARIS 7
Date d'effet : 29/10/2010

20/09/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

5218 - 338966385 RCS. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 3 AV OCTAVE GREARD 75007 PARIS. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

10/08/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

943 - 338 966 385 RCS Paris. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : nomination de l'Administrateur : Coqueran, Régine. Capital : 38857930 EUR.
Adresse du siège social : 3 avenue Octave Gréard, 75007 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

07/07/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Société faisant l'objet d'une nomination : 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 3 AV OCTAVE GREARD, 75007 PARIS 7
Nominé : Madame Régine COQUERAN, 91 RUE VILLIERS DE L ISLE ADAM, 75020 PARIS
En la fonction de : Administrateur
Pour une durée de 72 mois

24/06/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2028 - 338 966 385 RCS Paris. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 38857930 EUR. Adresse de l’établissement principal : 7-9 avenue Morane Saulnier, 78140 Velizy Villacoublay.
Adresse du siège social : 3 avenue Octave Gréard, 75007 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'adresse du siège.

15/06/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1887 - 338 966 385 RCS Paris. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Directeur général délégué partant : Sieger, Guy. Capital : 38857930 EUR.
Adresse du siège social : 12 rue de La Baume, 75008 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

09/06/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1198 - 338 966 385 RCS Paris. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Barnabe, Pierre, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Homsy, Pascal, nomination du Directeur général délégué : Coffinieres, Pierre. Capital : 38857930 EUR.
Adresse du siège social : 12 rue de La Baume, 75008 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

25/05/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1851 - 338 966 385 RCS Paris. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : nomination du Directeur général délégué : Baichere, Didier. Capital : 38857930 EUR.
Adresse du siège social : 12 rue de La Baume, 75008 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

12/05/2010

JAL

Head Office Transfer

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Date de décision : 31/03/2010
Transfert du siège social de la société 338966385 -  ALCATEL - LUCENT FRANCE
Adresse du nouveau siège : 3 AVENUE OCTAVE GREARD, 75007 PARIS
Ancienne localisation : 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8

10/05/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Société faisant objet d'une nomination : 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Nominé : Monsieur Fadi RAAD, 9 RUE 9 RUE DU STADE, 91400 SACLAY
En la fonction de : Directeur général délégué
Pour une durée de 36 mois

10/05/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Société faisant objet d'une nomination : 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Nominé : Monsieur Loïc LE GROUIEC, 10 ALLEE 10 ALLEE DES JACINTHES, 91300 MASSY
En la fonction de : Directeur général délégué

10/05/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Société faisant objet d'une nomination : 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Nominé : Monsieur Albert GOYET, 45 AVENUE 45 AVENUE BERTHELOT, 92500 RUEIL MALMAISON
En la fonction de : Directeur général délégué
Pour une durée de 36 mois

10/05/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Société faisant objet d'une nomination : 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Nominé : Monsieur Pierre COFFINIERES, 52 BOULEVARD 52 BOULEVARD SAINT DENIS, 92400 COURBEVOIE
En la fonction de : Directeur général délégué
Pour une durée de 36 mois

10/05/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Société faisant objet d'une nomination : 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Nominé : Monsieur Didier BAICHERE, 15 RUELLE 15 RUELLE DU GRAND LAVOIR, 78530 BUC
En la fonction de : Directeur général délégué
Pour une durée de 36 mois

10/05/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Société faisant objet d'une nomination : 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Nominé : Monsieur Pascal HOMSY, 6 ALLEE 6 ALLEE DE L ABBE EMILE BOIS, 78560 LE PORT MARLY
En la fonction de : DG - Directeur Général

10/05/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Société faisant objet d'une nomination : 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Nominé : Monsieur Pascal HOMSY, 6 ALLEE 6 ALLEE DE L ABBE EMILE BOIS, 78560 LE PORT MARLY
En la fonction de : Président du Conseil d'Administration

10/05/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Société faisant objet d'une nomination : 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Nominé : Monsieur Pascal HOMSY, 6 ALLEE 6 ALLEE DE L ABBE EMILE BOIS, 78560 LE PORT MARLY
En la fonction de : Administrateur

10/05/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Date de décision : 06/05/2010
La société 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Fait l'objet du départ de Monsieur Pierre BARNABE

10/05/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Date de décision : 06/05/2010
La société 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Fait l'objet du départ de Monsieur Fadi RAAD

10/05/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Date de décision : 06/05/2010
La société 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Fait l'objet du départ de Monsieur Loïc LE GROUIEC

10/05/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Date de décision : 06/05/2010
La société 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Fait l'objet du départ de Monsieur Albert GOYET

10/05/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Date de décision : 06/05/2010
La société 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Fait l'objet du départ de Monsieur Didier BAICHERE

10/05/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Date de décision : 06/05/2010
La société 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Fait l'objet du départ de Monsieur Pierre BARNABE

10/05/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Date de décision : 06/05/2010
La société 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Fait l'objet du départ de Monsieur Pierre BARNABE

09/04/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Société faisant objet d'une nomination : 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Nominé : Monsieur Didier BAICHERE, 15 RUELLE 15 RUELLE DU GRAND LAVOIR, 78530 BUC
En la fonction de : Directeur général délégué
Pour une durée de 36 mois

19/02/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1163 - 338 966 385 RCS Paris. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Directeur général délégué et Administrateur partant : Beretti, Pierre, Administrateur partant : Haddad, nom d'usage : Guillaumin, Caroline, nomination de l'Administrateur : Delahaye, Michel. Capital : 38857930 EUR.
Adresse du siège social : 12 rue de La Baume, 75008 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

20/01/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Société faisant objet d'une nomination : 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Nominé : Monsieur Michel DELAHAYE, 77 AVENUE 77 AVENUE DE SAINT CLOUD, 78000 VERSAILLES
En la fonction de : Administrateur

20/01/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Date de décision : 22/12/2009
La société 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Fait l'objet du départ de Madame Caroline GUILLAUMIN

20/01/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Date de décision : 22/12/2009
La société 338966385 - ALCATEL - LUCENT FRANCE, 12 RUE DE LA BAUME, 75008 PARIS 8
Fait l'objet du départ de Monsieur Pierre BERETTI

10/12/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

6044 - 338966385 RCS. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 12 R DE LA BAUME 75008 PARIS. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2006.

24/09/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

4856 - 338966385 RCS. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 12 rue de La Baume 75008 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

22/07/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1070 - 338 966 385 RCS Paris. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : nomination de l'Administrateur : Haddad, nom d'usage : Guillaumin, Caroline. Capital : 38857930 EUR.
Adresse du siège social : 12 rue de La Baume, 75008 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

03/03/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

884 - 338 966 385 RCS Paris. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Baujard, Olivier, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Barnabe, Pierre, Directeur général délègué partant : Nesci, Vincenzo, Directeur général délègué partant : Barre, Nicolas, nomination du Directeur général délègué : Goyet, Albert, nomination du Directeur général délègué : Le Grouiec, Loïc, nomination du Directeur général délègué : Raad, Fadi, Administrateur partant : Barth, Jean-Paul, Administrateur partant : Fouques, Etienne, nomination de l'Administrateur : Thomas, Rémi, nomination de l'Administrateur : Mathieu, nom d'usage : Gauthey, Gabrielle. Capital : 38857930 EUR.
Adresse du siège social : 12 rue de La Baume, 75008 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

28/02/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

4235 - 338 966 385 RCS Paris. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire ERNST & YOUNG ET AUTRES. Capital : 38857930 EUR. Activité : L'étude, la fabrication, le montage, la commercialisation, toutes opérations de commission, courtage, portant sur tous biens ou ensembles de biens concernant les industries électriques, électroniques ou connexes ainsi que toutes autres industries pouvant se rattacher aux industries précitées ou pouvant concourir a Leurdeveloppement. L'exploitation et la gestion par tous moyens de tous biens immobiliers, meubles corporels et incorporels, de tous brevets, procèdes et marques réalises ou a réaliser par la société, acquis ou a elle apportes, a quelque titre que ce soit. Laprise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toute société ou entreprise créée ou a créer par tous moyens, alliances, apports, fusions souscriptions d'actions, obligations ou autres titres acquisitions de droits sociaux et sous toutes autres formes utilisées en france ou a l'étranger.
Adresse du siège social : 12 rue de La Baume, 75008 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration.

22/10/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

6886 - 338966385 RCS. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 12 rue de La Baume 75008 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

15/10/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1392 - 338 966 385 RCS Paris. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur partant : Cornu, Jozef, nomination de l'Administrateur : Fouques, Etienne. Capital : 1665339840 EUR.
Adresse du siège social : 12 rue de La Baume, 75008 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

13/10/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1064 - 338 966 385 RCS Paris. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 1665339840 EUR. Activité : L'étude, la fabrication, le montage, la commercialisation, toutes opérations de commission, courtage, portant sur tous biens ou ensembles de biens concernant les industries électriques, électroniques ou connexes ainsi que toutes autres industries pouvant se rattacher aux industries précitées ou pouvant concourir a Leurdeveloppement. L'exploitation et la gestion par tous moyens de tous biens immobiliers, meubles corporels et incorporels, de tous brevets, procèdes et marques réalises ou a réaliser par la société, acquis ou a elle apportes, a quelque titre que ce soit. Laprise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toute société ou entreprise créée ou a créer par tous moyens, alliances, apports, fusions souscriptions d'actions, obligations ou autres titres acquisitions de droits sociaux et sous toutes autres formes utilisées en france ou a l'étranger.
Adresse du siège social : 12 rue de La Baume, 75008 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

12/08/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2102 - 338 966 385 RCS Paris. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Directeur général délègué partant : Gerardin, Eric, nomination du Directeur général délègué : Barre, Nicolas. Capital : 1665339840 EUR. Activité : L'étude, la fabrication, le montage, la commercialisation, toutes opérations de commission, courtage, portant sur tous biens ou ensembles de biens concernant les industries électriques, électroniques ou connexes ainsi que toutes autres industries pouvant se rattacher aux industries précitées ou pouvant concourir a Leurdeveloppement. L'exploitation et la gestion par tous moyens de tous biens immobiliers, meubles corporels et incorporels, de tous brevets, procèdes et marques réalises ou a réaliser par la société, acquis ou a elle apportes, a quelque titre que ce soit. Laprise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toute société ou entreprise créée ou a créer par tous moyens, alliances, apports, fusions souscriptions d'actions, obligations ou autres titres acquisitions de droits sociaux et sous toutes autres formes utilisées en france ou a l'étranger.
Adresse du siège social : 12 rue de La Baume, 75008 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

03/07/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1631 - 338 966 385 RCS paris. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : modification du Directeur général délègué et Administrateur Beretti, Pierre, nomination du Directeur général délègué : Barnabe, Pierre, nomination du Directeur général délègué : Nesci, Vincenzo, nomination du Directeur général délègué : Gerardin, Eric, nomination du Directeur général délègué : Sieger, Guy. Capital : 1665339840 EUR. Activité : L'étude, la fabrication, le montage, la commercialisation, toutes opérations de commission, courtage, portant sur tous biens ou ensembles de biens concernant les industries électriques, électroniques ou connexes ainsi que toutes autres industries pouvant se rattacher aux industries précitées ou pouvant concourir a Leurdeveloppement. L'exploitation et la gestion par tous moyens de tous biens immobiliers, meubles corporels et incorporels, de tous brevets, procèdes et marques réalises ou a réaliser par la société, acquis ou a elle apportes, a quelque titre que ce soit. Laprise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toute société ou entreprise créée ou a créer par tous moyens, alliances, apports, fusions souscriptions d'actions, obligations ou autres titres acquisitions de droits sociaux et sous toutes autres formes utilisées en france ou a l'étranger.
Adresse du siège social : 12 rue de La Baume, 75008 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

05/06/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1572 - 338 966 385 RCS Paris. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Giroux, Jean-Christophe, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Baujard, Olivier, Directeur général délègué partant : Le Grouiec, Loic, Directeur général délègué partant : Picard, Olivier, Directeur général délègué partant : Sieger, Guy, modification de l'Administrateur Beretti, Pierre, Administrateur partant : Rouanne, Marc François, nomination de l'Administrateur : Keryer, Philippe. Capital : 1665339840 EUR. Activité : L'étude, la fabrication, le montage, la commercialisation, toutes opérations de commission, courtage, portant sur tous biens ou ensembles de biens concernant les industries électriques, électroniques ou connexes ainsi que toutes autres industries pouvant se rattacher aux industries précitées ou pouvant concourir a Leurdeveloppement. L'exploitation et la gestion par tous moyens de tous biens immobiliers, meubles corporels et incorporels, de tous brevets, procèdes et marques réalises ou a réaliser par la société, acquis ou a elle apportes, a quelque titre que ce soit. Laprise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toute société ou entreprise créée ou a créer par tous moyens, alliances, apports, fusions souscriptions d'actions, obligations ou autres titres acquisitions de droits sociaux et sous toutes autres formes utilisées en france ou a l'étranger.
Adresse du siège social : 12 rue de La Baume, 75008 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

04/05/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1068 - 338 966 385 RCS Paris. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 1665339840 EUR. Activité : L'étude, la fabrication, le montage, la commercialisation, toutes opérations de commission, courtage, portant sur tous biens ou ensembles de biens concernant les industries électriques, électroniques ou connexes ainsi que toutes autres industries pouvant se rattacher aux industries précitées ou pouvant concourir a Leurdeveloppement. L'exploitation et la gestion par tous moyens de tous biens immobiliers, meubles corporels et incorporels, de tous brevets, procèdes et marques réalises ou a réaliser par la société, acquis ou a elle apportes, a quelque titre que ce soit. Laprise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toute société ou entreprise créée ou a créer par tous moyens, alliances, apports, fusions souscriptions d'actions, obligations ou autres titres acquisitions de droits sociaux et sous toutes autres formes utilisées en france ou a l'étranger.
Adresse du siège social : 12 rue de La Baume, 75008 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

23/03/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2508 - 338 966 385 RCS Paris. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Directeur général délègué partant : Chapuis, Jehan-Eric, nomination du Directeur général délègué : Sieger, Guy. . Capital : 265364340 EUR. Activité : L'étude, la fabrication, le montage, la commercialisation, toutes opérations de commission, courtage, portant sur tous biens ou ensembles de biens concernant les industries électriques, électroniques ou connexes ainsi que toutes autres industries pouvant se rattacher aux industries précitées ou pouvant concourir a Leurdeveloppement. L'exploitation et la gestion par tous moyens de tous biens immobiliers, meubles corporels et incorporels, de tous brevets, procèdes et marques réalises ou a réaliser par la société, acquis ou a elle apportes, a quelque titre que ce soit. Laprise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toute société ou entreprise créée ou a créer par tous moyens, alliances, apports, fusions souscriptions d'actions, obligations ou autres titres acquisitions de droits sociaux et sous toutes autres formes utilisées en france ou a l'étranger.
Adresse du siège social : 12 rue de La Baume, 75008 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

15/03/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1821 - RCS Paris B 338 966 385. RC 86-B 11760. ALCATEL-LUCENT FRANCE. Forme : S.A. Capital : 265 364 340 euros. Adresse du siège social : 12 rue de la Baume,, 75008 Commentaires : modification survenue sur la dénomination et l'administration. Administration : modification d'un directeur général délégué et administrateur : BERETTI (Pierre). Nomination de directeurs généraux délégués : CHAPUIS (Jehan-Eric) LE GROUIEC (Loïc) PICARD (Olivier).

06/02/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1158 - RCS Paris B 338 966 385. RC 86-B 11760. ALCATEL CIT. Forme : S.A. Capital : 265 364 340 euros. Adresse du siège social : 12 rue de la Baume,, 75008 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d'administration et directeur général partant : CALEMARD (Olivier, Charles, Jacques). Administrateur partant : CALEMARD (Olivier, Charles, Jacques). Modification du président du conseil d'administration et directeur général : GIROUX (Jean-Christophe).

24/12/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1466 - RCS Paris B 338 966 385. RC 86-B 11760. ALCATEL CIT. Forme : S.A. Capital : 265 364 340 euros. Adresse du siège social : 12 rue de la Baume,, 75008 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un directeur général délégué : GIROUX (Jean-Christophe).

23/09/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

1751 - RCS Paris B 338 966 385. RC 86-B 11760. ALCATEL CIT. Forme: S.A. Adresse du siège social: 12, R de la Baume,Paris, 75008 Paris. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

23/08/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1888 - RCS Paris B 338 966 385. RC 86-B 11760. ALCATEL CIT. Forme : S.A. Capital : 265 364 340 euros. Adresse du siège social : 12 rue de la Baume,, 75008 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : DE LAAGE DE MEUX (François, Hervé, Israël, Théobald, Marie). Nomination d'un administrateur : BERETTI (Pierre).

23/08/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1890 - RCS Paris B 338 966 385. RC 86-B 11760. ALCATEL CIT. Forme : S.A. Capital : 265 364 340 euros. Adresse du siège social : 12 rue de la Baume,, 75008 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification d'un administrateur : BARTH (Jean-Paul). Modification du président du conseil d'administration et directeur général : CALEMARD (Olivier, Charles, Jacques).

23/08/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1889 - RCS Paris B 338 966 385. RC 86-B 11760. ALCATEL CIT. Forme : S.A. Capital : 265 364 340 euros. Adresse du siège social : 12 rue de la Baume,, 75008 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : DUNOGUE (Jacques). Nomination d'un administrateur : ROUANNE (Marc, François).

06/10/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

782 - RCS Paris B 338 966 385. RC 86-B 11760. ALCATEL CIT. Forme: S.A. Adresse du siège social: 12, R de la Baume,Paris, 75008 Paris. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

10/08/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1574 - RCS Paris B 338 966 385. RC 86-B 11760. ALCATEL CIT. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU. Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES S.A.

17/06/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Versailles B 338966385 RC 89-B 2928 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'adresse de l'établissement principal Etablissement principal: Adresse : 7-9 avenue Morane- Saulnier, 78140 Vélizy-Villacoublay.

26/12/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338966385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : BARBIER FRINAULT & AUTRES S. A.S. Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : MACIOCE (Pascal).

13/02/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338966385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Capital : 218 056 230 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

13/02/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338966385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Capital : 218 293 230 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

06/02/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338966385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Capital : 265 364 340 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

27/08/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338966385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : commissaire aux comptes titulaire partant : BARBIER FRINAULT ET AUTRES S. C.P. Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU. Commissaire aux comptes suppléant partant : PEUCH-LESTRADE ( Philippe). Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : BEAS.

21/08/2002

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS B 433990777 RC 02-B 115 SANMINA FRANCE. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 46 rue Pierre-Curie, Les Gatines, 78370 Plaisir ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : production en série d'équipements complets pour la transmission de la radio terrestre de type P.D.H . et d'industrialisation d' équipement de transmission de radio. Adresse : 260 rue des Noisetiers, 50110 Tourlaville Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 4 780 355,05 euros Date de début d' activité: 21 mai 2002. Précédent propriétaire : ALCATEL CIT. RCS B 338966385 Publication légale: L' Agriculteur normand du 30 mai 2002. Oppositions : au fonds.

17/07/2002

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS B 433990777 SANMINA FRANCE. Forme : S. A.S. Capital : 40 000 euros. Adresse du siège social : 46 rue Pierre-Curie, 78370 Plaisir Etablissement principal: Activité : production en série d' équipements complets pour la transmission de radio terrestre de type P.D.H . et industrialisation d' équipements de transmission de radio. Adresse : 260 rue des Noisetiers, 50110 Tourlaville Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 4 780 355,05 euros. Date d'effet : 21 mai 2002. Précédent propriétaire : ALCATEL CIT. RCS Paris B 338966385 RC 89-B 216 Publication légale: L'Agriculteur normand du 30 mai 2002. Oppositions : au fonds et Société sanima France, 46 rue Pierre-Curie, 78370 Plaisir, pour la correspondance.

16/06/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338966385 RC 86-B 11760 ALCATEL C.I.T. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : nomination du directeur général délégué et administrateur : CALEMARD (Olivier, Charles, Jacques). Administrateur partant : DE WILDE (Julien).

17/04/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338966385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : modification du P.-D.G. : BARTH (Jean- Paul).

26/02/2002

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS Paris B 433145117 RC AP-B 284 S.A. BRUMELEC. Forme : S.A. Capital : 40 000 euros. Adresse du siège social : 12 rue de la Baume, 75008 Paris Etablissement principal: Activité : division d' activité < Modem D.S.L. >. Adresse : 12 rue de la Baume, 75008 Paris Partie de fonds correspondant à la division d' activité < Modem D.S.L. > acquise par cession au prix stipulé de 1 750 000 euros. Date d'effet : 13 décembre 2001. Précédent propriétaire : ALCATEL CIT. RCS B 338966385 Publication légale: Les Petites affiches du 7 février 2002. Oppositions : au fonds.

24/02/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338966385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Capital : 206 056 230 euros. Adresse du siège social : 12 rue de la Baume, 75008 Paris. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation). Fusion- absorption de la STE NEWBRIDGE NETWORKS avec effet rétroactif au 1 e r mai 2001.

01/03/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338966385 RC 86-B 11760 ALCATEL C.I.T. Forme : S.A. Capital : 200 332 440 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital ( augmentation).

06/12/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338966385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : administrateur partant : DEGA (Gérard, Pierre).

11/10/2000

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS B 420864324 A dater du: 19 septembre 2000 RC 00-B 1643 ALCATEL SAINTES. Forme : S.A. à conseil d' administration. Adresse du siège social : 12 rue de la Baume, 75008 Paris Etablissement principal: Activité : études, conception, fabrication et commercialisation d'habillage, de coffrets, d'armoires et de conteneurs. Adresse : 12 rue de la Baume, 75008 Paris ETABLISSEMENT PRINCIPAL nouvelle situation. Adresse : Z.I. Ormeau de Pied, 17100 Saintes Branche d'activité d' ensembles électroniques acquise par apport au montant net évalué à 27 000 000 F Date de début d'activité: 1 e r juillet 2000. Précédent propriétaire : SOCIETE ALCATEL CIT Publication légale: Les Petites affiches du 26 mai 2000.

07/09/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338966385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Capital : 223 920 000 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

10/08/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

*. RCS Paris B 338 966 385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : suppression : administrateur : HALBRON ( Jean-Pierre, Léopold).

10/08/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

*. RCS Paris B 338 966 385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : nomination en qualité d'administrateur : DE LAAGE DE MEUX (François, Hervé, Israel, Théobald, Marie).

10/08/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

*. RCS Paris B 338 966 385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : suppression : président du conseil d' administration : GORDILLO FLORENCIO ( Manuel, Luis). Nomination en qualité de président du conseil d'administration : BARTH (Jean-Paul).

23/12/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

*. RCS Paris B 338 966 385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Capital : 360 000 000 d'euros. Activité : toutes opérations concernant les télécommunications, l' informatique, la télématique, les industries électriques, électroniques, mécaniques ou connexes, ainsi que toutes activités d'étude, ingénierie, fabrication, montage, prestation de services et commercialisation pouvant se rattacher directement ou indirectement aux domaines et industries précités ou concourir à leur développement. Adresse du siège social : 12, rue de la Baume 75008 Paris. Commentaires : apport partiel d'actif de la branche d'activité stations terriennes à la SOCIETE ALCATEL SPACE,. RCS B 414 725 101, sis 12, rue de la Baume, 75008 Paris. Modification survenue sur l'activité.

23/09/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

*. RCS Paris B 338 966 385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : modification : président du conseil d' administration : GORDILLO (Florencio, Manuel, Luis) Suppression : administrateur : MONIOTTE (Henri). Modification : administrateur : DUNOGUE (Jacques).

25/07/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338966385 RC 86-B 11760 ALCATEL C.I.T. Forme : S.A. Capital : 360 000 000 d'euros. Commentaires : modification survenue sur le capital ( augmentation).

21/02/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Evry B 338 966 385 RC 90-B 710 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Capital : 1 000 000 000 de F. Adresse du siège social : 12 rue de la Baume 75008 Paris. Commentaires : c'est à tort qu'il a été déclaré la STE ALCATEL TELSPACE comme société absorbée au lieu de la STE ALCATEL ALSTHOM RECHERCHE concernant l' établissement secondaire, route de Nozay, 91460 Marcoussis.

10/11/1998

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

725 720 114. RCS Chalon-sur-Saone. RC 57-B 11 FONDERIE ET AJUSTAGE REUNIS. Forme : S.A. Adresse du siège social : 70 rue de la Paix, 71210 Montchanin Fonds secondaire acquis par achat, au prix stipulé de 500 000 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : fabrication de réflecteur d'antennes. Adresse : 38160 Saint-Romans Date de début d'activité: 30 juin 1998 Précédente propriétaire SOCIETE ALCATEL CIT 338 966 385. RCS Paris. Publication légale: La Terre dauphinoise du 30 septembre 1998. Oppositions : au fonds.

03/11/1998

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS Paris B 338 966 385 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Adresse du siège social : 12 rue de la Baume, 75008 Paris Fonds complémentaire acquis par fusion- absorption au montant de l'apport évalué à 1 400 000 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Cherbourg 89-B 216. Adresse : 120 rue Roger-Glinel, 50460 Querqueville Etablissement Complémentaire. Activité : production de faisceaux hertziens. Adresse : 260 rue des Noisetiers, 50110 Tourlaville. Date d'effet : 1er juin 1998 Précédente propriétaire SOCIETE ALCATEL TELSPACE RC 85-B 25 Publication légale: La Loi du 15 juin 1998.

31/07/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Paris B 338 966 385 RC RC 86- B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Administration : nomination en qualité de président du conseil d' administration : GORDILLO (Florencio, Manuel, Luis) Modification : administrateur : DEGA (Gérard, Pierre). Suppression : administrateur : BRAVO ( Alain, Pierre, Marie). Commentaires : modification survenue sur l' administration.

26/07/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338 966 385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Capital : 689 225 500 F. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

26/06/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Paris B 338 966 385 RC RC 86- B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Administration : suppression : administrateur : HUSSON (Jean-Claude, Gaston, Paul). Suppression : commissaire aux comptes titulaire : ACER - CABINET PAYER ET ASSOCIES. Suppression : commissaire aux comptes suppléant : HARENG (Philippe). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

07/06/1998

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS Toulouse B 403 216 062 A dater du: 24 avril 1998 THOMSON-CSF INSTRUMENTATION SERVICES. Forme : S.A. Capital : 250 000 F. Adresse du siège social : 105 avenue du Général- Eisenhower, 31000 Toulouse Fonds principal acquis par cession, au prix global stipulé de 905 000 F. Commentaires : prix global comprenant également une partie de fonds de commerce à Ormes (45) Etablissement principal: Activité : service A3M ( appareils de mesure , maintenance et métrologie), d'Alcatel Cit qui a pour mission d'assurer la maintenance ( vérifications et réparations), calibrage (métrologie) des appareils de test et de mesure. Adresse : 4 rue Louis- Broglie, 22300 Lannion. Date d'effet : 1er avril 1998 Précédente propriétaire ALCATEL CIT. RCS Paris B 338 966 385 RC 90-B 158 Publication légale: Ouest- France du 15 avril 1998. Oppositions : au fonds.

05/04/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338 966 385 RC 86-B 11760 ALCATEL C.I.T. Forme : S.A. Capital : 550 000 000 de F. Commentaires : modification survenue sur le capital (diminution).

13/09/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS B 338 966 385 RC 89-B 2928 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Capital : 1 000 000 000 de F. Adresse du siège social : 12 rue de la Baume 75008 Paris. Commentaires : l' établissement secondaire sis 10 rue Latécoère, 78140 Vélizy-Villacoublay devient établissement principal. Date d'effet : 30 juin 1997.

05/08/1997

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS *. RCS Nanterre B 399 275 254 ALCATEL RESEAUX D'ENTREPRISE. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 226 145 700 F. Adresse du siège social : 29, rue Emeriau 75015 Paris Etablissement principal: Activité : commercialisation et maintenance en France des produits et services de P.M. R. analogique. Adresse : 32, avenue Kléber 92700 Colombes Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 856 452 F. Date d'effet : 14 mars 1997. Précédent propriétaire : : ALCATEL CIT. RCS RCS B 338 966 385 Publication légale: La Loi du 9 juillet 1997. Oppositions : pour la correspondance : Alcatel Réseaux d' Entreprise, 71, rue Albert, 75013 Paris et au fonds pour la validité.

22/09/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338 966 385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Administration : P.-D.G. : DEGA (Gérard, Pierre). Administrateurs : CORNU (Jozef) DE WILDE (Julien) MONIOTTE (Henri) DUNOGUE (Jacques) HUSSON (Jean-Claude, Gaston, Paul) HALBRON (Jean-Pierre, Léopold) BRAVO (Alain, Pierre, Marie). Commissaires aux comptes titulaires : ACER CABINET PAYER ET ASSOCIES S.C.P. BARBIER FRINAULT ET AUTRES. Commissaires aux comptes suppléants : HARENG (Philippe) PEUCH-LESTRADE ( Philippe). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

01/09/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338 966 385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Capital : 1 000 000 000 de F. Commentaires : modification survenue sur le capital.

05/06/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Paris B 338 966 385 RC RC 86- B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Administration : président-directeur général : DEGA (Gérard, Pierre) Administrateurs : LIBOIS (Louis, Joseph, Marie) CORNU (Jozef) DE WILDE (Julien) MONIOTTE (Henri) DUNOGUE (Jacques) HUSSON (Jean- Claude, Gaston, Paul) HALBRON (Jean- Pierre, Léopold). Commissaires aux comptes titulaires : ACER - CABINET PAYER ET ASSOCIES BARBIER FRINAULT ET AUTRES SCP. Commissaires aux comptes suppléants : HARENG (Philippe) PEUCH-LESTRADE (Philippe). Commentaires : modification survenue sur l' administration.

18/02/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338 966 385 RC 86-B 11760 ALCATEL C.I.T. Forme : S.A. Capital : 1 675 000 000 de F. Commentaires : modification survenue sur le capital.

06/02/1996

Bodacc A

Vente et cession

 

 

RCS non encore inscrit ALCATEL T.I.T.N. ANSWARE. Forme : S.A. Capital : 128 040 000 F. Adresse du siège social : 12 rue de la Baume 75008 Paris Etablissement principal: Adresse : parc des Grillons, 60 route de Sartrouville 78320 Le Pecq. Activité : études, développement, fourniture et/ou maintenance de certains systèmes d'aide à l' exploitation et à la maintenance de réseaux de télécommunication Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 1 208 000 F. Date d'effet : 1er janvier 1996. Précédent propriétaire : ALCATEL C.I.T. S. A. RCS B 338 966 385 Publication légale: La Semaine de l'Ile-de-France du 5 janvier 1996. Oppositions : Alcatel C.I.T. 10 rue Latécoère, 78141 Vélizy et chez Alcatel T.I.T.N. Answare, 1 rue Galvani, 91747 Massy.

06/02/1996

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS B 682 007 398 ALCATEL TITN ANSWARE. Forme : S.A. Capital : 128 040 000 F. Adresse du siège social : 12 rue de la Baume 75008 Paris Etablissement principal: Adresse : route de Nozay 91620 La Ville-du-Bois. Activité : études, développement, fourniture et/ou maintenance de certains systèmes d'aide à l'exploitation et à la maintenance de réseaux de télécommunication Cession de l'établissement principal au prix stipulé de 1 208 000 F. Date d'effet : 1er janvier 1996. Précédent propriétaire : ALCATEL CIT. RCS B 338 966 385 Publication légale: La Semaine de l'Ile- de-France du 11 janvier 1996. Oppositions : Alcatel Cit, 10 rue Latecoère, 78141 Vélizy et Alcatel Titn Answare, 1 rue Galvani, 91747 Massy.

26/11/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338 966 385 RC 86-B 11760 ALCATEL C.I.T. Forme : S.A. Administration : P.-D.G. : DEGA (Gérard, Pierre). Administrateurs : FONDANAICHE (Philippe) BOVIS (Claude, Constant, Louis) FERRONI (Umberto) LIBOIS (Louis, Joseph, Marie) CORNU (Jozef) DE WILDE (Julien) MONIOTTE (Henri). Commissaires aux comptes titulaires : ACER CABINET PAYER ET ASSOCIES BARBIER FRINAULT ET AUTRES. Commissaires aux comptes suppléants : HARENG (Philippe) PEUCH-LESTRADE ( Philippe). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

09/09/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338 966 385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Administration : P.-D.G. : DEGA (Gérard, Pierre). Administrateurs : GUICHET (Pierre) FONDANAICHE (Philippe) BOVIS (Claude, Constant, Louis) FERRONI (Umberto) LIBOIS (Louis, Joseph, Marie) MASSON ( Jean-Marie, René) CORNU (Jozef) DE WILDE (Julien) MONIOTTE (Henri). Commissaires aux comptes titulaires : ACER CABINET PAYER ET ASSOCIES S.C.P. BARBIER FRINAULT ET AUTRES. Commissaires aux comptes suppléants : HAREND (Philippe) PEUCH-LESTRADE ( Philippe). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

06/09/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Paris B 338 966 385 RC RC 86- B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Administration : président-directeur général : DEGA (Gérard, Pierre) Administrateurs : FONDANAICHE ( Philippe) BOVIS (Claude, Constant, Louis) FERRONI (Umberto) LIBOIS ( Louis, Joseph, Marie) CORNU (Jozef) DE WILDE (Julien) MONIOTTE (Henri). Commissaires aux comptes titulaires : ACER CABINET PAYER ET ASSOCIES BARBIER FRINAULT ET AUTRES S.C.P. Commissaires aux comptes suppléants : HAREND (Philippe) PEUCH-LESTRADE ( Philippe). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

03/01/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 338 966 385 RC 86-B 11760 ALCATEL CIT. Forme : S.A. Administration : P.-D.G. : GUICHET (Pierre). Vice- président et administrateur : DEGA ( Gérard, Pierre). Administrateurs : FONDANAICHE (Philippe) BOVIS (Claude, Constant, Louis) FERRONI (Umberto) LIBOIS (Louis, Joseph, Marie) MASSON ( Jean-Marie, René) CORNU (Jozef) GOOSSENS (Johny, Léon, Jacques, Marie). Commissaires aux comptes titulaires : ACER CABINET PAYER ET ASSOCIES BARBIER FRINAULT ET AUTRES S.C.P. Commissaires aux comptes suppléants : HAREND (Philippe) PEUCH-LESTRADE ( Philippe). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

 

 

 

 

 

 

Date

Description

23/09/2011

Minutes of general meeting of shareholders

23/09/2011

New auditor

20/09/2011

Bodacc C : Deposit accounts notice

03/06/2011

New subsidiarie(s) detected

20/05/2011

Legal Gazette: Appointment of the social representative

01/04/2011

Partial contribution

23/11/2010

Continuation of business despite loss of equity

23/11/2010

Minutes of general meeting of shareholders

29/10/2010

Legal Gazette: Continuation of activity

20/09/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

03/09/2010

New participations in other companies

10/08/2010

Bodacc B: Various editing or changing

28/07/2010

Payment incident closed

23/07/2010

Minutes of general meeting of shareholders

23/07/2010

Changes to the Board of Directors

23/07/2010

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

30/06/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

24/06/2010

Bodacc B: Various editing or changing

15/06/2010

Bodacc B: Various editing or changing

09/06/2010

Bodacc B: Various editing or changing

08/06/2010

Updated articles of association

08/06/2010

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

25/05/2010

Payment incident detected

25/05/2010

Bodacc B: Various editing or changing

20/05/2010

New chairman (CEO, CoB)

20/05/2010

Changes to the Board of Directors

20/05/2010

Minutes of Board meeting

17/05/2010

Update of Company Head Office Identifier

17/05/2010

Transfer of Establishment

12/05/2010

Legal Gazette: Head Office Transfer

10/05/2010

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

06/05/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

04/05/2010

Changes to the Board of Directors

31/03/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

27/02/2010

A Tax Office Preferential right lapsed

19/02/2010

Bodacc B: Various editing or changing

01/02/2010

Changes to the Board of Directors

20/01/2010

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

18/01/2010

Payment incident closed

31/12/2009

New accounts available

22/12/2009

Legal Gazette: Appointment of the social representative

10/12/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

08/12/2009

Part unfiling of a Tax Office preferential right

08/12/2009

Preferential right lapsed

13/11/2009

Payment incident detected

28/10/2009

New Filling of Tax Office preferential right

12/10/2009

Payment incident closed

24/09/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

18/09/2009

Payment incident closed

28/07/2009

Payment incident detected

23/07/2009

Payment incident detected

22/07/2009

Bodacc B: Various editing or changing

03/07/2009

Appointment/resignation of company officers

03/07/2009

Private document

03/07/2009

Changes to the Board of Directors

03/07/2009

Minutes of general meeting of shareholders

22/04/2009

Payment incident closed

04/03/2009

Payment incident closed

03/03/2009

New Bodacc B ads detected

03/03/2009

Bodacc B: Various editing or changing

02/03/2009

Payment incident closed

28/02/2009

Bodacc B: Various editing or changing

28/02/2009

New Bodacc B ads detected

11/02/2009

Minutes of Board meeting

11/02/2009

Changes to the Board of Directors

11/02/2009

New chairman (CEO, CoB)

11/02/2009

Private document

11/02/2009

Appointment/resignation of company officers

21/01/2009

Payment incident detected

20/01/2009

Payment incident detected

19/01/2009

Updated articles of association

19/01/2009

Private document

19/01/2009

Capital reduction

19/01/2009

Minutes of general meeting of shareholders

31/12/2008

Update of Company Name

31/12/2008

Modification to Company Identifier

31/12/2008

New accounts available

16/12/2008

Payment incident detected

15/12/2008

Payment incident closed

09/12/2008

Partial contribution

09/12/2008

Power of attorney

09/12/2008

Minutes of Board meeting

09/12/2008

Minutes of general meeting of shareholders

09/12/2008

Declaration of conformity

09/12/2008

Private document

18/11/2008

Minutes of general meeting of shareholders

18/11/2008

Continuation of business despite loss of equity

18/11/2008

Private document

27/10/2008

Partial contribution

27/10/2008

Planned merger

27/10/2008

Appointment/resignation of company officers

27/10/2008

Amendment

27/10/2008

Minutes of Board meeting

27/10/2008

Private document

22/10/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

15/10/2008

Payment incident detected

15/10/2008

New Bodacc B ads detected

15/10/2008

Bodacc B: Various editing or changing

13/10/2008

New Bodacc B ads detected

13/10/2008

Bodacc B: Various editing or changing

29/09/2008

Appointment/resignation of company officers

29/09/2008

Changes to the Board of Directors

29/09/2008

Private document

29/09/2008

Minutes of general meeting of shareholders

12/08/2008

Bodacc B: Various editing or changing

12/08/2008

New Bodacc B ads detected

03/07/2008

Minutes of Board meeting

03/07/2008

Changes to the Board of Directors

03/07/2008

Modification du Conseil d'Administration

03/07/2008

Minutes of general meeting of shareholders

03/07/2008

New Bodacc B ads detected

03/07/2008

PV d'Assemblée

03/07/2008

Appointment/resignation of company officers

03/07/2008

Bodacc B: Various editing or changing

03/07/2008

Private document

05/06/2008

Bodacc B: Various editing or changing

05/06/2008

New Bodacc B ads detected

04/05/2008

New Bodacc B ads detected

04/05/2008

Bodacc B: Various editing or changing

17/04/2008

Minutes of Board meeting

17/04/2008

Appointment/resignation of company officers

17/04/2008

Private document

17/04/2008

Changes to the Board of Directors

17/04/2008

Modification du Conseil d'Administration

23/03/2008

Bodacc B: Various editing or changing

23/03/2008

New Bodacc B ads detected

18/02/2008

Changement de Président (PDG, PCA)

18/02/2008

Appointment/resignation of company officers

18/02/2008

Private document

18/02/2008

Changes to the Board of Directors

18/02/2008

Minutes of Board meeting

18/02/2008

Modification du Conseil d'Administration

18/02/2008

New chairman (CEO, CoB)

31/12/2007

New accounts available

28/12/2007

Minutes of general meeting of shareholders

28/12/2007

Private document

28/12/2007

Certificat de dépôt des fonds

28/12/2007

Fund deposit certificate

28/12/2007

PV d'Assemblée

28/12/2007

Capital increase

28/12/2007

Updated articles of association

28/12/2007

Statuts mis à jour

28/12/2007

Augmentation de Capital

31/10/2007

Modification du Conseil d'Administration

31/10/2007

Appointment/resignation of company officers

31/10/2007

Minutes of Board meeting

31/10/2007

Changes to the Board of Directors

31/10/2007

Private document

19/09/2007

Filling of Preferential Right

18/09/2007

Collection of preferential rights activated for this company

10/07/2007

Déclaration de conformité

10/07/2007

Minutes of general meeting of shareholders

10/07/2007

PV d'Assemblée

10/07/2007

Private document

10/07/2007

Declaration of conformity

10/07/2007

Capital increase

10/07/2007

Fusion

10/07/2007

Audit or Management Report

10/07/2007

Merger

10/07/2007

Rapport des Commissaires ou du Gérant

30/04/2007

Amendment

30/04/2007

Projet de Fusion

30/04/2007

Planned merger

30/04/2007

Private document

15/02/2007

Updated articles of association

15/02/2007

Statuts mis à jour

15/02/2007

Minutes of Board meeting

15/02/2007

Changement de dénomination sociale

15/02/2007

New company name

15/02/2007

Minutes of general meeting of shareholders

15/02/2007

Appointment/resignation of company officers

15/02/2007

Modification du Conseil d'Administration

15/02/2007

Private document

30/01/2007

Application and court order

29/01/2007

Requête et Ordonnance

17/01/2007

Modification du Conseil d'Administration

17/01/2007

Appointment/resignation of company officers

17/01/2007

Private document

17/01/2007

Minutes of Board meeting

31/12/2006

New accounts available

04/12/2006

Modification du Conseil d'Administration

04/12/2006

Minutes of Board meeting

04/12/2006

Appointment/resignation of company officers

04/12/2006

Private document

23/10/2006

Partial contribution

23/10/2006

Apport Partiel

23/10/2006

Procuration

23/10/2006

Minutes of Board meeting

23/10/2006

Minutes of general meeting of shareholders

23/10/2006

PV d'Assemblée

23/10/2006

Declaration of conformity

23/10/2006

Déclaration de conformité

23/10/2006

Private document

23/10/2006

Capital increase

23/10/2006

Spin-off

10/08/2006

Changement de Commissaire aux Comptes

10/08/2006

Minutes of Board meeting

10/08/2006

PV du Conseil d'Administration

10/08/2006

Fusion

10/08/2006

Acte sous seing privé

10/08/2006

Private document

10/08/2006

New auditor

10/08/2006

Merger

10/08/2006

Appointment/resignation of company officers

10/08/2006

Nomination/démission des organes de gestion

10/08/2006

Minutes of general meeting of shareholders

10/08/2006

PV d'Assemblée

04/08/2006

Private document

04/08/2006

Acte modificatif

04/08/2006

Planned merger

04/08/2006

Projet de Fusion

04/08/2006

Amendment

04/08/2006

Acte sous seing privé

04/08/2006

Apport Partiel

26/06/2006

Changement de Président (PDG, PCA)

26/06/2006

New chairman (CEO, CoB)

26/06/2006

Changes to the Board of Directors

26/06/2006

Modification du Conseil d'Administration

26/06/2006

Acte sous seing privé

26/06/2006

Private document

26/06/2006

Appointment/resignation of company officers

26/06/2006

Nomination/démission des organes de gestion

26/06/2006

Minutes of Board meeting

26/06/2006

PV du Conseil d'Administration

27/02/2006

New Filling of Tax Office preferential right

31/12/2005

New accounts available

29/07/2005

Private document

29/07/2005

Acte sous seing privé

29/07/2005

PV d'Assemblée

29/07/2005

Minutes of general meeting of shareholders

29/07/2005

Acte modificatif

29/07/2005

Changement de Commissaire aux Comptes

29/07/2005

Amendment

16/02/2005

Minutes of general meeting of shareholders

16/02/2005

PV d'Assemblée

16/02/2005

Minutes of Board meeting

16/02/2005

PV du Conseil d'Administration

16/02/2005

Déclaration de conformité

16/02/2005

Declaration of conformity

16/02/2005

Private document

16/02/2005

Acte sous seing privé

16/02/2005

Amendment

16/02/2005

Acte modificatif

16/02/2005

Procuration

16/02/2005

Audit or Management Report

16/02/2005

Rapport des Commissaires ou du Gérant

16/02/2005

Fusion

02/02/2005

Projet de Fusion

02/02/2005

Acte sous seing privé

02/02/2005

Planned merger

02/02/2005

Private document

31/12/2004

New accounts available

10/12/2004

Continuation malgré perte supérieure à la moitié du capital

10/12/2004

Continuation of business despite loss of equity

10/12/2004

Private document

10/12/2004

Acte sous seing privé

10/12/2004

Minutes of general meeting of shareholders

10/12/2004

PV d'Assemblée

19/11/2004

Projet de Fusion

19/11/2004

Planned merger

19/11/2004

Minutes of Board meeting

19/11/2004

Amendment

19/11/2004

Acte modificatif

19/11/2004

PV du Conseil d'Administration

19/11/2004

Private document

19/11/2004

Acte sous seing privé

07/10/2004

Application and court order

07/10/2004

Requête et Ordonnance

31/12/2003

New accounts available

15/12/2003

PV d'Assemblée

15/12/2003

Acte sous seing privé

15/12/2003

Nomination/démission des organes de gestion

30/07/2003

Nomination/démission des organes de gestion

30/07/2003

Acte sous seing privé

30/07/2003

PV d'Assemblée

22/01/2003

Reconstitution de l'Actif Net

22/01/2003

Acte sous seing privé

22/01/2003

Certificat de dépôt des fonds

22/01/2003

Statuts mis à jour

22/01/2003

PV d'Assemblée

22/01/2003

Augmentation de Capital

28/11/2002

Acte sous seing privé

28/11/2002

Augmentation de Capital

28/11/2002

Statuts mis à jour

28/11/2002

PV du Conseil d'Administration

28/11/2002

PV d'Assemblée

28/11/2002

Déclaration de conformité

28/11/2002

Acte modificatif

28/11/2002

Fusion

18/10/2002

Acte sous seing privé

18/10/2002

Rapport des Commissaires ou du Gérant

27/09/2002

PV du Conseil d'Administration

27/09/2002

Projet de Fusion

27/09/2002

Acte modificatif

27/09/2002

Acte sous seing privé

13/08/2002

Nomination/démission des organes de gestion

13/08/2002

Continuation malgré perte supérieure à la moitié du capital

13/08/2002

Changement de Commissaire aux Comptes

13/08/2002

PV d'Assemblée

13/08/2002

Acte sous seing privé

02/08/2002

Requête et Ordonnance

23/07/2002

Modification du Conseil d'Administration

23/07/2002

Statuts mis à jour

23/07/2002

PV du Conseil d'Administration

23/07/2002

PV d'Assemblée

23/07/2002

Acte sous seing privé

23/07/2002

Nomination/démission des organes de gestion

10/07/2002

Requête et Ordonnance

04/06/2002

Acte sous seing privé

04/06/2002

Modification du Conseil d'Administration

04/06/2002

Nomination/démission des organes de gestion

04/06/2002

PV du Conseil d'Administration

12/02/2002

PV d'Assemblée

12/02/2002

Déclaration de conformité

12/02/2002

Acte modificatif

12/02/2002

Augmentation de Capital

12/02/2002

Statuts mis à jour

12/02/2002

Modification de l'objet social

12/02/2002

Fusion

12/02/2002

Acte sous seing privé

18/12/2001

Rapport des Commissaires ou du Gérant

18/12/2001

Acte sous seing privé

27/11/2001

Acte sous seing privé

27/11/2001

Projet de Fusion

06/08/2001

PV d'Assemblée

06/08/2001

Acte sous seing privé

06/08/2001

Acte modificatif

25/05/2001

Nomination/démission des organes de gestion

25/05/2001

Requête et Ordonnance

30/01/2001

Acte modificatif

30/01/2001

Déclaration de conformité

30/01/2001

Nomination/démission des organes de gestion

30/01/2001

PV d'Assemblée

30/01/2001

PV du Conseil d'Administration

30/01/2001

Statuts mis à jour

30/01/2001

Apport Partiel

30/01/2001

Augmentation de Capital

30/01/2001

Modification du Conseil d'Administration

30/01/2001

Acte sous seing privé

08/01/2001

Réduction de Capital

08/01/2001

PV d'Assemblée

08/01/2001

Acte sous seing privé

20/12/2000

Rapport des Commissaires ou du Gérant

20/12/2000

Acte sous seing privé

21/11/2000

Nomination/démission des organes de gestion

21/11/2000

PV du Conseil d'Administration

21/11/2000

Modification du Conseil d'Administration

21/11/2000

Acte sous seing privé

20/11/2000

PV du Conseil d'Administration

20/11/2000

Apport Partiel

20/11/2000

Acte sous seing privé

20/11/2000

Projet de Fusion

17/11/2000

Apport Partiel

17/11/2000

Projet de Fusion

17/11/2000

Acte sous seing privé

24/08/2000

Réduction de Capital

24/08/2000

Acte sous seing privé

24/08/2000

Statuts mis à jour

24/08/2000

Rapport des Commissaires ou du Gérant

24/08/2000

PV d'Assemblée

02/08/2000

Nomination/démission des organes de gestion

02/08/2000

Requête et Ordonnance

25/07/2000

Modification du Conseil d'Administration

25/07/2000

PV du Conseil d'Administration

25/07/2000

Nomination/démission des organes de gestion

25/07/2000

PV d'Assemblée

25/07/2000

Changement de Président (PDG, PCA)

25/07/2000

Statuts mis à jour

25/07/2000

Acte sous seing privé

07/07/2000

Acte sous seing privé

07/07/2000

Réduction de Capital

07/07/2000

PV d'Assemblée

09/06/2000

Rapport des Commissaires ou du Gérant

09/06/2000

Acte sous seing privé

24/05/2000

Projet de Fusion

24/05/2000

Apport Partiel

24/05/2000

Acte sous seing privé

26/11/1999

Déclaration de conformité

26/11/1999

Acte sous seing privé

26/11/1999

Acte modificatif

26/11/1999

Fusion

26/11/1999

Rapport des Commissaires ou du Gérant

26/11/1999

PV d'Assemblée

26/11/1999

PV du Conseil d'Administration

28/10/1999

Projet de Fusion

28/10/1999

Acte sous seing privé

24/09/1999

Apport Partiel

24/09/1999

Projet de Fusion

24/09/1999

Acte sous seing privé

24/09/1999

Acte modificatif

07/09/1999

PV d'Assemblée

07/09/1999

Acte sous seing privé

07/09/1999

Modification du Conseil d'Administration

07/09/1999

Nomination/démission des organes de gestion

09/07/1999

Acte sous seing privé

09/07/1999

Statuts mis à jour

09/07/1999

Réduction de Capital

09/07/1999

Conversion du Capital Social en Euros

09/07/1999

Augmentation de Capital

09/07/1999

PV d'Assemblée

09/07/1999

Certificat de dépôt des fonds

08/06/1999

Réduction de Capital

08/06/1999

Acte sous seing privé

08/06/1999

PV d'Assemblée

20/01/1999

Rapport des Commissaires ou du Gérant

20/01/1999

Acte sous seing privé

20/01/1999

Déclaration de conformité

20/01/1999

Fusion

20/01/1999

PV d'Assemblée

01/01/1999

Requête et Ordonnance

01/01/1999

Nomination/démission des organes de gestion

14/12/1998

Acte sous seing privé

14/12/1998

Rapport des Commissaires ou du Gérant

20/11/1998

Acte modificatif

20/11/1998

Acte sous seing privé

20/11/1998

PV du Conseil d'Administration

20/11/1998

Projet de Fusion

27/10/1998

Nomination/démission des organes de gestion

27/10/1998

Requête et Ordonnance

13/07/1998

PV du Conseil d'Administration

13/07/1998

Modification du Conseil d'Administration

13/07/1998

Acte sous seing privé

13/07/1998

Nomination/démission des organes de gestion

13/07/1998

Changement de Président (PDG, PCA)

13/07/1998

Changement de Gérant

29/06/1998

Fusion

29/06/1998

PV d'Assemblée

29/06/1998

Modification de l'objet social

29/06/1998

Augmentation de Capital

29/06/1998

Statuts mis à jour

26/06/1998

Statuts mis à jour

26/06/1998

Acte modificatif

26/06/1998

Acte sous seing privé

26/06/1998

Nomination/démission des organes de gestion

26/06/1998

PV d'Assemblée

26/06/1998

PV du Conseil d'Administration

26/06/1998

Fusion

26/06/1998

Augmentation de Capital

26/06/1998

Modification de l'objet social

10/06/1998

Nomination/démission des organes de gestion

10/06/1998

Statuts mis à jour

10/06/1998

Acte sous seing privé

10/06/1998

Modification du Conseil d'Administration

10/06/1998

PV d'Assemblée

10/06/1998

Scission

10/06/1998

Apport Partiel

10/06/1998

Déclaration de conformité

20/05/1998

Acte sous seing privé

20/05/1998

Rapport des Commissaires ou du Gérant

18/05/1998

Acte sous seing privé

18/05/1998

Rapport des Commissaires ou du Gérant

29/04/1998

Acte modificatif

29/04/1998

PV du Conseil d'Administration

29/04/1998

Projet de Fusion

28/04/1998

Projet de Fusion

28/04/1998

PV du Conseil d'Administration

28/04/1998

Acte sous seing privé

28/04/1998

Apport Partiel

24/04/1998

Acte sous seing privé

24/04/1998

Rapport des Commissaires ou du Gérant

27/03/1998

Acte modificatif

27/03/1998

Acte sous seing privé

27/03/1998

Projet de Fusion

27/03/1998

PV du Conseil d'Administration

27/03/1998

Apport Partiel

23/03/1998

PV d'Assemblée

23/03/1998

Statuts mis à jour

23/03/1998

Réduction de Capital

21/03/1998

Réduction de Capital

23/01/1998

Acte sous seing privé

23/01/1998

Requête et Ordonnance

19/01/1998

Acte sous seing privé

19/01/1998

Requête et Ordonnance

01/01/1998

Acte sous seing privé

01/01/1998

Requête et Ordonnance

29/07/1997

PV du Conseil d'Administration

29/07/1997

PV d'Assemblée

29/07/1997

Fusion

29/07/1997

Déclaration de conformité

29/07/1997

Nomination/démission des organes de gestion

29/07/1997

Acte sous seing privé

27/06/1997

PV d'Assemblée

27/06/1997

Déclaration de conformité

27/06/1997

Apport Partiel

27/06/1997

Acte sous seing privé

27/06/1997

Augmentation de Capital

18/06/1997

Rapport des Commissaires ou du Gérant

18/06/1997

Acte sous seing privé

28/04/1997

Projet de Fusion

28/04/1997

PV du Conseil d'Administration

28/04/1997

Acte sous seing privé

21/04/1997

Apport Partiel

21/04/1997

Acte sous seing privé

21/04/1997

Projet de Fusion

01/04/1997

Requête et Ordonnance

01/04/1997

Acte sous seing privé

16/08/1996

Modification du Conseil d'Administration

16/08/1996

Statuts mis à jour

16/08/1996

Apport Partiel

16/08/1996

Fusion

16/08/1996

Réduction de Capital

16/08/1996

Acte sous seing privé

16/08/1996

PV d'Assemblée

16/08/1996

Nomination/démission des organes de gestion

16/08/1996

Acte modificatif

19/06/1996

Acte modificatif

19/06/1996

Rapport des Commissaires ou du Gérant

21/05/1996

PV du Conseil d'Administration

21/05/1996

Nomination/démission des organes de gestion

21/05/1996

Modification du Conseil d'Administration

21/05/1996

Acte modificatif

20/05/1996

Fusion

20/05/1996

PV du Conseil d'Administration

20/05/1996

Acte modificatif

20/05/1996

Acte sous seing privé

28/02/1996

Requête et Ordonnance

26/01/1996

Augmentation de Capital

26/01/1996

Statuts mis à jour

26/01/1996

PV d'Assemblée

26/01/1996

Acte modificatif

26/01/1996

Acte sous seing privé

26/01/1996

Projet de Fusion

14/12/1995

Acte modificatif

14/12/1995

Rapport des Commissaires ou du Gérant

24/11/1995

Acte modificatif

24/11/1995

Projet de Fusion

24/11/1995

Acte sous seing privé

25/09/1995

Requête et Ordonnance

03/08/1995

Modification du Conseil d'Administration

03/08/1995

Changement de Président (PDG, PCA)

03/08/1995

PV du Conseil d'Administration

03/08/1995

PV d'Assemblée

03/08/1995

Acte modificatif

03/08/1995

Nomination/démission des organes de gestion

16/12/1994

Acte modificatif

16/12/1994

PV du Conseil d'Administration

16/12/1994

Nomination/démission des organes de gestion

16/12/1994

Modification du Conseil d'Administration

26/08/1994

PV d'Assemblée

26/08/1994

Acte modificatif

26/08/1994

Changement de Commissaire aux Comptes

03/02/1994

Acte modificatif

12/08/1992

PV d'Assemblée

12/08/1992

Acte modificatif

 

 

 

 

 

 

Date

Description

28/06/2011

Update of phone numbers

25/01/2011

Update Limit

25/01/2011

Update Rating

21/01/2011

Update Rating

05/10/2010

Update of phone numbers

04/09/2010

Update Limit

03/09/2010

Update Rating

17/05/2010

Formation of Head office (after transfer)

31/12/2008

Update of Establishment Workforce

 

 

 

directors

 

 

 

 

Name

M. HOMSY PASCAL

 

Manager position

Directeur général, Président du conseil d'administration

Date of birth

25/04/1965

 

Place of birth

BEYROUTH(LIBAN)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. RAAD FADI

 

Manager position

Directeur général délégué

Date of birth

30/01/1957

 

Place of birth

MAZRAA(LIBAN)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. GOYET ALBERT

 

Manager position

Directeur général délégué

Date of birth

03/05/1959

 

Place of birth

ST ETIENNE (42000)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. BAICHERE DIDIER

 

Manager position

Directeur général délégué

Date of birth

20/08/1970

 

Place of birth

LIMOUX (11300)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. COFFINIERES PIERRE

 

Manager position

Directeur général délégué

Date of birth

25/02/1960

 

Place of birth

MARSEILLE (13013)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. KERYER PHILIPPE

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

22/02/1964

 

Place of birth

ST QUENTIN (02100)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. THOMAS RÉMI

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

14/03/1968

 

Place of birth

MEUDON (92190)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. LE GROUIEC LOÏC

 

Manager position

Directeur général délégué

Date of birth

12/04/1964

 

Place of birth

ST BRIEUC (22000)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

Mme. GAUTHEY GABRIELLE

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

28/10/1962

 

Place of birth

NANCY (54000)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

MATHIEU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. DELAHAYE MICHEL

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

22/04/1958

 

Place of birth

ST MANDE (94160)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

Mme. COQUERAN RÉGINE

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

07/03/1969

 

Place of birth

PARIS (75014)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Directors

 

 

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

 

Président du conseil d'administration

M PIERRE BARNABE

 

 

Président du conseil d'administration

M OLIVIER BAUJARD

 

 

Président du conseil d'administration

M OLIVIER CALEMARD

 

 

Président du conseil d'administration

M JEAN-CHRISTOPHE GIROUX

 

 

Président du conseil d'administration

M PASCAL HOMSY

 

 

Président du conseil d'administration

M PASCAL HOMSY

 

 

Président Directeur Général

M PASCAL HOMSY

 

 

Directeur général

M PIERRE BARNABE

 

 

Directeur général

M OLIVIER BAUJARD

 

 

Directeur général

M OLIVIER CALEMARD

 

 

Directeur général

M JEAN-CHRISTOPHE GIROUX

 

 

Directeur général

M PASCAL HOMSY

 

 

Directeur général

M PASCAL HOMSY

 

 

Directeur général délégué

M DIDIER BAICHERE

 

 

Directeur général délégué

M PIERRE BARNABE

 

 

Directeur général délégué

M NICOLAS BARRE

 

 

Directeur général délégué

M PIERRE BERETTI

 

 

Directeur général délégué

M JEHAN-ERIC CHAPUIS

 

 

Directeur général délégué

M PIERRE COFFINIERES

 

 

Directeur général délégué

M ERIC GERARDIN

 

 

Directeur général délégué

M JEAN-CHRISTOPHE GIROUX

 

 

Directeur général délégué

M ALBERT GOYET

 

 

Directeur général délégué

M ALBERT GOYET

 

 

Directeur général délégué

M ALBERT GOYET

 

 

Directeur général délégué

M LOIC LE GROUIEC

 

 

Directeur général délégué

M LOIC LE GROUIEC

 

 

Directeur général délégué

M LOÏC LE GROUIEC

 

 

Directeur général délégué

M VINCENZO NESCI

 

 

Directeur général délégué

M OLIVIER PICARD

 

 

Directeur général délégué

M FADI RAAD

 

 

Directeur général délégué

M FADI RAAD

 

 

Directeur général délégué

M FADI RAAD

 

 

Directeur général délégué

M FADI RAAD

 

 

Directeur général délégué

M GUY SIEGER

 

 

Administrateur

M JEAN-PAUL BARTH

 

 

Administrateur

M PIERRE BERETTI

 

 

Administrateur

Mme RÉGINE COQUERAN

 

 

Administrateur

M MICHEL DELAHAYE

 

 

Administrateur

M ETIENNE FOUQUES

 

 

Administrateur

M ETIENNE FOUQUES

 

 

Administrateur

MME GABRIELLE GAUTHEY

 

 

Administrateur

Mme GABRIELLE GAUTHEY

 

 

Administrateur

MME GABRIELLE GAUTHEY

 

 

Administrateur

MME CAROLINE GUILLAUMIN

 

 

Administrateur

MME CAROLINE GUILLAUMIN

 

 

Administrateur

M PHILIPPE KERYER

 

 

Administrateur

M PHILIPPE KERYER

 

 

Administrateur

M REMI THOMAS

 

 

Administrateur

M REMI THOMAS

 

 

Administrateur

M RÉMI THOMAS

 

 

 

Bottom of Form

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.51.39

UK Pound

1

Rs.80.20

Euro

1

Rs.68.92

 

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.