MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :           

09.12.2011

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Correct Name :

TAPE A L'OEIL

 

 

Registered Office :

Tao, 24 Av Du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2010

 

 

Date of Incorporation :

January 1993

 

 

Com. Reg. No.:

RCS Roubaix-Tourcoing 9 389 632 639

 

 

Legal Form :

Simplified Joint Stock Company

 

 

Line of Business :

Retail sale of clothing in specialized stores

 

 

No. of Employees :

999 Persons

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Aa

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

Large

           

Status :

Excellent

Payment Behaviour :

No Complaints

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – September 30th, 2011

 

Country Name

Previous Rating

                   (30.06.2011)                  

Current Rating

(30.09.2011)

France

a2

a2

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


Company summary

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

TAPE A L'OEIL

SIRET

389 632 639 01139

 

 

 

 

 

Acronym

TAO

 

 

Activity (APE)

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z)

 

(Retail sale of clothing in specialized stores)

Legal form

Simplified joint stock company

 

 

Phone

03 28 33 57 33

RCS Registration

RCS Roubaix-Tourcoing 9 389 632 639

 

 

Fax

 

Share capital

762,245 

 

 

Address

TAPE A L'OEIL
TAO
24 AV DU GRAND COTTIGNIES
59290 WASQUEHAL

Incorporated Date

01/1993

 

 

Nationality

France

Status

Economically active

 

 

 

 

 Last published preferential right

No social security and tax office preferential right to date

 

 

 

Ultimate Holding Company

 

Company Name

Safe Number

 

Company number

Click here to view the affiliation links

 

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VÊTEMENTS POUR ENFANTS

FR06346554

 

438295396

 

 

 

 

Current Directors

6

 

 

 

Trading to Date

12/31/2010

 

Turnover

106,917,227 €

 

Gross Operating Surplus

11,86 % Turnover

 

Net worth

31,859,488 €

 

Employees

500 to 999 employees

 

 

No trends info for the company

 

 

 

 

 

company details

 

 

 

 

Activity (APE)

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z)

)

(Retail sale of clothing in specialized stores (4771Z)

 

RCS Registration

RCS Roubaix-Tourcoing 9 389 632 639

Share capital

762,245 

 

Registration Court

Roubaix-Tourcoing (59)

Legal form

Simplified joint stock company

 

Court Registry Number

19 9 3B000

EU VAT Number

FR11389632639

 

Incorporation Date

01/1993

Formation Date

01/1993

 

Deregistration Date

 

Last account Date

31/12/2010

 

Nationality

France

 

 

 

Ultimate Parent

1 ultimate parent company for this company
>  SOC AMENAGEM DEVELOP- MAGASIN VET ENFA  - Activités des sociétés holding (6420Z)  in WASQUEHAL  (59290)

 

 

Establishment details

 

 

 

Acronym

TAO

 

Activity (APE)

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z)

Business Pages FT®

 

 

Postal Address

TAPE A L'OEIL
TAO
24 AV DU GRAND COTTIGNIES
59290 WASQUEHAL

Trading Address

24 AVENUE DU GRAND COTTIGNIES
59290 WASQUEHAL

 

Telephone

03 28 33 57 33

 

Fax

 

 

 

 

Type

Head office

Status

Economically active

 

Formation Date

07/2008

Reason for formation

Formation

 

Closure Date

 

Reason for closure

 

 

Reactivation Date

 

Production Role

 

 

Activity Nature

Other

Activity Location

Other

 

Location surface

 

Seasonality

 

 

 

 

 

Department

Nord (59)

Region

Nord-Pas-de-Calais

 

District

 

Area

 

 

City

WASQUEHAL

Size of urban area

 

 

 

 

Other establishments

 

 

 

 

Branches

109 branch entities in this company

 

 

 

Head office

 
> TAPE A L'OEIL <<<  - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z)  in WASQUEHAL  (59290)
 

 

 

Secondary establishments

>  TAPE A L'OEIL  - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z)  in ROUBAIX  (59100)
>  TAPE A L'OEIL  - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z)  in THIAIS  (94320)
>  TAPE A L'OEIL  - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z)  in OSNY  (95520)
>  TAPE A L'OEIL  - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z)  in ALBERTVILLE  (73200)
> ...

 

 

 

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas but no one grouping more than 50% of workforce

 

 

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which one activity grouping from 50 to 80% of workforce

 

 

 

Workforces

 

 

 

 

Workforce at address

100 to 199 employees

Company workforce

500 to 999 employees

 

 

 

 

 

 

accounts

 

 

Active Account |  Passive Account |  Account Results

 

Synthesized Accounts

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

Comparison mode

Average

Median

 

 

Annual Accounts

31/12/2010

 

 

 

 

 

 

Account period (month)

12

 

 

 

 

 

 

Account Type

Normal

 

 

 

 

 

 

Deposit date

15/07/2011

 

 

 

 

 

 

Activity Code

4771Z

 

 

 

 

 

 

Employees

0

 

-

 

-

 

 


Active account

Annual Accounts

31/12/2010

 

 

Sector Median 2010

 

Capital not called

0

 

 

0

0%

Total fixed assets

22 075 373

 

 

75 356

29194,8%

- Intangible assets

8 140 858

 

 

44 511

18189,5%

- Tangible assets

12 046 023

 

 

11 272

106766,8%

- Financial assets

2 072 864

 

 

1 383

149781,7%

Net current assets

39 337 926

 

 

96 568

40636,0%

- Stocks

18 661 553

 

 

45 330

41068,2%

- Advanced payments

1 635 876

 

 

0

0%

- Receivables

13 919 019

 

 

7 702

180619,5%

- Securities and cash

5 121 478

 

 

14 209

35943,9%

- Prepaid expenses

-

 

 

424

-

Accounts of regularization

0

 

 

0

0%

Total Assets

61 413 301

 

 

194 127

31535,6%


Passive Account

Annual Accounts

31/12/2010

 

 

 

 

Sector Median 2010

 

Shareholders' equity

31 859 488

 

 

 

 

42 625

74643,7%

Share capital

8 705 655

 

 

 

 

8 000

108720,7%

Other capital resources

0

 

 

 

 

0

0%

Risk Provisions

808 464

 

 

 

 

0

0%

Liabilities

28 745 348

 

 

 

 

127 993

22358,5%

- Financial liabilities

6 463 969

 

 

 

 

43 613

14721,2%

- Advanced payments received

4 000

 

 

 

 

0

0%

- Trade account payables

17 472 926

 

 

 

 

25 814

67587,8%

- Tax and social liabilities

4 043 041

 

 

 

 

19 940

20176,0%

- Other debts and fixed assets liabilities

761 412

 

 

 

 

4 074

18589,5%

Account regularization

0

 

 

 

 

0

0%

Total liabilities

61 413 301

 

 

 

 

194 198

31524,1%


Results

Annual Accounts

31/12/2010

 

 

 

 

Sector Median 2010

 

Sales of Goods

108 721 649

 

 

 

 

245 720

44146,2%

Net turnover

106 917 227

 

 

 

 

240 271

44398,6%

- of which net export turnover

10 907 598

 

 

 

 

0

0%

Operating charges

100 279 651

 

 

 

 

238 947

41867,3%

Operating profit/loss

8 441 998

 

 

 

 

6 842

123284,9%

Financial income

244 724

 

 

 

 

0

0%

Financial charges

357 186

 

 

 

 

1 684

21110,6%

Financial profit/loss

-112 462

 

 

 

 

-1 235

-9006,2%

Pretax net operating income

8 329 502

 

 

 

 

4 664

178491,4%

Extraordinary income

830 648

 

 

 

 

0

0%

Extraordinary charges

1 079 138

 

 

 

 

72

1498702,8%

Extraordinary profit/loss

-248 490

 

 

 

 

0

0%

Net result

5 265 779

 

 

 

 

4 818

109193,9%


 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

 

Normal Account

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Months

 

12

 

 

 

 


Accounts - Active
Current Assets |  Equalization accounts |  Reference

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Grand Total (I to VI)

Net

61 413 301

 

 

 

 

 

Gross

CO

74 848 852

 

 

 

 

 

Amortisation

1A

13 435 551

 

 

 

 


Non declared distributed capital (I)

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

 

 

 

 

 

Gross

AA

0

 

 

 

 


Active fixed asset (II)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Total Active fixed asset (II)

Net

22 075 373

 

 

 

 

 

Gross

BJ

34 018 858

 

 

 

 

 

Amortisation

BK

11 943 485

 

 

 

 


Intangible fixed assets

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Start-up cost

Net

0

 

 

 

 

 

Gross

AB

0

 

 

 

 

 

Amortisation

AC

0

 

 

 

 

 

R & D expenses

Net

0

 

 

 

 

 

Gross

CX

0

 

 

 

 

 

Amortisation

AE

0

 

 

 

 

 

Distributorships, patents

Net

288 393

 

 

 

 

 

Gross

AF

349 305

 

 

 

 

 

Amortisation

AG

60 912

 

 

 

 

 

Goodwill

Net

7 670 606

 

 

 

 

 

Gross

AH

7 670 606

 

 

 

 

 

Amortisation

AI

184 372

 

 

 

 

 

Other intangible fixed assets

Net

181 859

 

 

 

 

 

Gross

AJ

1 566 874

 

 

 

 

 

Amortisation

AK

1 385 015

 

 

 

 

 

Pre-payments and downpayments

Net

0

 

 

 

 

 

Gross

AL

0

 

 

 

 

 

Amortisation

AM

0

 

 

 

 

Sub Total Intangible Assets

Net

8 140 858

 

 

 

 



Tangible fixed assets

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Lands

Net

0

 

 

 

 

 

Gross

AN

0

 

 

 

 

 

Amortisation

AO

0

 

 

 

 

 

Buildings

Net

9 731 757

 

 

 

 

 

Gross

AP

17 219 561

 

 

 

 

 

Amortisation

AQ

7 487 804

 

 

 

 

 

Plant

Net

78 984

 

 

 

 

 

Gross

AR

361 908

 

 

 

 

 

Amortisation

AS

282 924

 

 

 

 

 

Other tangible fixed assets

Net

1 841 375

 

 

 

 

 

Gross

AT

4 314 868

 

 

 

 

 

Amortisation

AU

2 473 493

 

 

 

 

 

Fixed assets in construction

Net

309 769

 

 

 

 

 

Gross

AV

309 769

 

 

 

 

 

Amortisation

AW

0

 

 

 

 

 

Advances and payments on account

Net

84 138

 

 

 

 

 

Gross

AX

84 138

 

 

 

 

 

Amortisation

AY

0

 

 

 

 

 

Sub Total Tangible asset

Net

12 046 023

 

 

 

 



Financial assets

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Associates at equity

Net

0

 

 

 

 

 

Gross

CS

0

 

 

 

 

 

Amortisation

CT

0

 

 

 

 

 

Other participations

Net

380 685

 

 

 

 

 

Gross

CU

449 650

 

 

 

 

 

Amortisation

CV

68 965

 

 

 

 

 

Inter-company receivables

Net

0

 

 

 

 

 

Gross

BB

0

 

 

 

 

 

Amortisation

BC

0

 

 

 

 

 

Other investment securities

Net

0

 

 

 

 

 

Gross

BD

0

 

 

 

 

 

Amortisation

BE

0

 

 

 

 

 

Loans

Net

0

 

 

 

 

 

Gross

BF

0

 

 

 

 

 

Amortisation

BG

0

 

 

 

 

 

Other financial assets

Net

1 692 179

 

 

 

 

 

Gross

BH

1 692 179

 

 

 

 

 

Amortisation

BI

0

 

 

 

 

 

Sub Total Financial Assets

 

2 072 864

 

 

 

 

 

Current Assets (III)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Total Assets

Net

39 337 926

 

 

 

 

 

Gross

CJ

40 829 992

 

 

 

 

 

Amortisation

CK

1 492 066

 

 

 

 



Stocks

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Raw materials

Net

426 571

 

 

 

 

 

Gross

BL

426 571

 

 

 

 

 

Amortisation

BM

0

 

 

 

 

 

Work in progress (goods)

Net

0

 

 

 

 

 

Gross

BN

0

 

 

 

 

 

Amortisation

BO

0

 

 

 

 

 

Work in progress (services)

Net

0

 

 

 

 

 

Gross

BP

0

 

 

 

 

 

Amortisation

BQ

0

 

 

 

 

 

Semi-finished and finished products

Net

0

 

 

 

 

 

Gross

BR

0

 

 

 

 

 

Amortisation

BS

0

 

 

 

 

 

Goods for resale

Net

18 234 982

 

 

 

 

 

Gross

BT

19 051 932

 

 

 

 

 

Amortisation

BU

816 950

 

 

 

 

 

Sub Total Stocks

Net

18 661 553

 

 

 

 



Advance payments to suppliers

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Advance payments to suppliers

Net

1 635 876

 

 

 

 

 

Gross

BV

1 635 876

 

 

 

 

 

Amortisation

BW

0

 

 

 

 



Debtors

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Trade accounts receivable

Net

4 273 119

 

 

 

 

 

Gross

BX

4 502 263

 

 

 

 

 

Amortisation

BY

229 144

 

 

 

 

 

Other debtors

Net

6 226 370

 

 

 

 

 

Gross

BZ

6 672 342

 

 

 

 

 

Amortisation

CA

445 972

 

 

 

 

 

Capital subscribed and called up

Net

0

 

 

 

 

 

Gross

CB

0

 

 

 

 

 

Amortisation

CC

0

 

 

 

 

 

Sub Total Debtors

Net

10 499 489

 

 

 

 



Divers

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Investment securities

Net

1 890 306

 

 

 

 

 

Gross

CD

1 890 306

 

 

 

 

 

Amortisation

CE

0

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

Net

3 231 172

 

 

 

 

 

Gross

CF

3 231 172

 

 

 

 

 

Amortisation

CG

0

 

 

 

 

 

Sub Total Divers

Net

5 121 478

 

 

 

 



Prepaid expenses

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Prepaid expenses

Net

3 419 530

 

 

 

 

 

Gross

CH

3 419 530

 

 

 

 

 

Amortisation

CI

0

 

 

 

 

 

Equalization accounts (IV to VI)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Multi-period charges

CW3

0

 

 

 

 

 

Gross

 

0

 

 

 

 

 

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

 

 

 

 

 

Gross

 

0

 

 

 

 

 

Currency differential gain

CN3

0

 

 

 

 

 

Gross

 

0

 

 

 

 

 

References

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Due within one year

CP

0

 

 

 

 

 

Due after one year

CR

0

 

 

 

 

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Accounts - Passive
Other capital resources | Provisions for risks and charges | Liabilities | Translation loss | Equalization accounts | References

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Grand Total (I to V)

EE

61 413 301

 

 

 

 


Shareholder Equity (I)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Total shareholders' equity (Total I)

DL

31 859 488

 

 

 

 

 

Equity and shareholders' equity

DA

8 705 655

 

 

 

 

 

Issue and merger premiums

DB

8 847 599

 

 

 

 

 

Revaluation differentials

DC

0

 

 

 

 

 

Of which equity differential

EK

0

 

 

 

 

 

Legal reserve

DD

299 055

 

 

 

 

 

Statutory or contractual reserve

DE

0

 

 

 

 

 

Special regulated reserves

DF

126 200

 

 

 

 

 

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

 

 

 

 

 

Other reserves

DG

5 662 040

 

 

 

 

 

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

 

 

 

 

 

Profits or losses brought forward

DH

0

 

 

 

 

 

Profit or loss for the period

DI

5 265 779

 

 

 

 

 

Investment grants

DJ

0

 

 

 

 

 

Special tax-allowable reserves

DK

2 953 160

 

 

 

 

 

Other capital resources (II)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Total other capital resources (Total II)

DO

0

 

 

 

 

 

Income from participating securities

DM

0

 

 

 

 

 

Conditional loans

DN

0

 

 

 

 

 

Provisions for risks and charges (III)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

808 464

 

 

 

 

 

Risk provisions

DP

808 464

 

 

 

 

 

Reserves for charges

DQ

0

 

 

 

 

 

Liabilities (IV)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Total Liabilities (Total IV)

EC

28 745 348

 

 

 

 

 

Convertible debentures

DS

0

 

 

 

 

 

Other debentures

DT

0

 

 

 

 

 

Bank loans and liabilities

DU

4 339 315

 

 

 

 

 

Sundry loans and financial liabilities

DV

2 124 654

 

 

 

 

 

Of which participating loans

EI

0

 

 

 

 

 

Advance payments received for current orders

DW

4 000

 

 

 

 

 

Trade accounts payables

DX

17 472 926

 

 

 

 

 

Tax and social security liabilities

DY

4 043 041

 

 

 

 

 

Fixed asset liabilities

DZ

594 287

 

 

 

 

 

Other debts

EA

167 125

 

 

 

 

 

Translation loss (V)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Translation loss (Total V)

ED

0

 

 

 

 

 

Equalization accounts

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Deferred income

EB

0

 

 

 

 

 

References

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Of which tax-allowable reserve

EF

0

 

 

 

 

 

Deferred income and liabilities

EG

28 290 992

 

 

 

 

 

Of which current bank facilities

EH

3 859 447

 

 

 

 

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Result account
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges | Financial income | Financial charges | Financial charges | Extraordinary charges | Employee profit sharing | Tax on profits | References

1- Operating result (I-II)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Operating result (Total I-II)

GG

8 441 998

 

 

 

 


2 - Financial result (V - VI)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Financial result (Total V-VI)

GV

-112 462

 

 

 

 


3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

8 329 502

 

 

 

 


4 - Extraordinary result (VII-VIII)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

-248 490

 

 

 

 


Profit or loss

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Profit or loss

HN

5 265 779

 

 

 

 


Total Income (I+III+V+VII)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Total Income (I+III+V+VII)

HL

109 797 021

 

 

 

 


Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

104 531 243

 

 

 

 


Operating income (I)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Total operating income (Total I)

FR

108 721 649

 

 

 

 


Operating income (details)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Sale of goods for resale

FC

102 558 402

 

 

 

 

 

France

FA

92 218 743

 

 

 

 

 

Export

FB

10 339 659

 

 

 

 

 

Sale of goods produced

FF

0

 

 

 

 

 

France

FD

0

 

 

 

 

 

Export

FE

0

 

 

 

 

 

Sale of services

FI

4 358 825

 

 

 

 

 

France

FG

3 790 886

 

 

 

 

 

Export

FH

567 939

 

 

 

 

 

Net turnover

FL

106 917 227

 

 

 

 

 

France

FJ

96 009 629

 

 

 

 

 

Export

FK

10 907 598

 

 

 

 

 

Stocked production

FM

0

 

 

 

 

 

Self-constructed assets

FN

0

 

 

 

 

 

Operating grants

FO

139 237

 

 

 

 

 

Release of reserves and provisions

FP

1 653 912

 

 

 

 

 

Other income

FQ

11 273

 

 

 

 


Operating charges (II)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Total operating charges (Total II)

GF

100 279 651

 

 

 

 


Exploitation charges

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Purchase of goods for resale

FS

53 569 195

 

 

 

 

 

Change in stocks of goods for resale

FT

-6 250 022

 

 

 

 

 

Purchase of raw materials

FU

1 160 921

 

 

 

 

 

Change in stocks of raw materials

FV

-99 604

 

 

 

 

 

Other external purchases and charges

FW

29 144 065

 

 

 

 

 

Tax, duty and similar payments

FX

1 896 165

 

 

 

 

 

Payroll

FY

11 187 670

 

 

 

 

 

Social security costs

FZ

3 769 708

 

 

 

 


Depreciation

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Depreciation of fixed assets

GA

2 512 699

 

 

 

 

 

Amortisation of fixed assets

GB

184 372

 

 

 

 

 

Depreciation/amortisation of current assets

GC

1 131 435

 

 

 

 

 

Provisions for risks and charges

GD

808 464

 

 

 

 


Other charges

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Other charges

GE

1 264 583

 

 

 

 

 

Operating charges (III-IV)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

 

 

 

 

 

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

34

 

 

 

 

 

Financial income (V)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Total financial income (Total V)

GP

244 724

 

 

 

 

 

Share financial income

GJ

0

 

 

 

 

 

Other investment income & capitalised receivables

GK

0

 

 

 

 

 

Other interest and similar income

GL

88 115

 

 

 

 

 

Released provisions and transferred charges

GM

156 609

 

 

 

 

 

Exchange gains

GN

0

 

 

 

 

 

Net income from disposal of investment securities

GO

0

 

 

 

 

 

Financial Charge (VI)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Total financial charge (Total VI)

GU

357 186

 

 

 

 

 

Financial reserves and provisions

GQ

266 467

 

 

 

 

 

Interest and similar charges

GR

90 719

 

 

 

 

 

Exchange losses

GS

0

 

 

 

 

 

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

 

 

 

 

 

Financial Charge (VII)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Total extraordinary income (Total VII)

HD

830 648

 

 

 

 

 

Extraordinary operating income

HA

187 147

 

 

 

 

 

Extraordinary income from capital transactions

HB

0

 

 

 

 

 

Released provisions and transferred charges

HC

643 501

 

 

 

 

 

Extraordinary charges (VIII)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

1 079 138

 

 

 

 

 

Extraordinary operating charges

HE

1 263

 

 

 

 

 

Extraordinary charges from capital transactions

HF

226 859

 

 

 

 

 

Extraordinary reserves and provisions

HG

851 016

 

 

 

 

 

Employee profit sharing (IX)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

701 532

 

 

 

 

 

Tax on profits (X)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Tax on profits (Total X)

HK

2 113 702

 

 

 

 

 

References

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Of which equipment leases

HP

0

 

 

 

 

 

Of which property leases

HQ

0

 

 

 

 

 

Of which transferred charges

A1

0

 

 

 

 

 

Of which trader's own contributions

A2

0

 

 

 

 

 

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

 

 

 

 

 

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

228 263

 

 

 

 

 

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Other incomer tax return forms
Reserve for depreciation | Provisions included in balance sheet | State deadlines claims and debts at the end of period
Table allocation results and other information

Fixed Assets
Grand Total Fixed Assets (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Gross value at begin of period

OG

0

 

 

 

 

 

Increasess due to revaluation

OH

0

 

 

 

 

 

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

 

 

 

 

 

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

 

 

 

 

 

Decreasess by transfers

OK2

0

 

 

 

 

 

Gross value at the end of period

OL

0

 

 

 

 


Research and development Charge (Total I)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Gross value at begin of period

CZ

0

 

 

 

 

 

Increasess due to revaluation

KB

0

 

 

 

 

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

 

 

 

 

 

Decreasess by budget item transfer

C01

0

 

 

 

 

 

Decreasess by transfers

C02

0

 

 

 

 

 

Gross value at the end of period

D0

0

 

 

 

 


Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Gross value at begin of period

KD

0

 

 

 

 

 

Increasess due to revaluation

KE

0

 

 

 

 

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

0

 

 

 

 

 

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

 

 

 

 

 

Decreasess by transfers

LV2

0

 

 

 

 

 

Gross value at the end of period

LW

0

 

 

 

 


Tangible fixed assets (Total III)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Gross value at begin of period

LN

0

 

 

 

 

 

Increasess due to revaluation

LO

0

 

 

 

 

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

0

 

 

 

 

 

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

 

 

 

 

 

Decreasess by transfers

NG2

0

 

 

 

 

 

Gross value at the end of period

NH

0

 

 

 

 


Financial assets (Total IV)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Gross value at begin of period

LQ

0

 

 

 

 

 

Increasess due to revaluation

LR

0

 

 

 

 

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

0

 

 

 

 

 

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

 

 

 

 

 

Decreasess by transfers

NJ2

0

 

 

 

 

 

Gross value at the end of period

NK

0

 

 

 

 

 

Reserve for depreciation
Situation and movement of reserve for depreciation
Grand total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Reserve for depreciation value at begin of period

0N

0

 

 

 

 

Increases

0P

0

 

 

 

 

Decreasess

0Q

0

 

 

 

 

 

Reserve for depreciation value at the end of period

0R

0

 

 

 

 


Research and development charge (Total I)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

 

 

 

 

Increases

PB

0

 

 

 

 

Decreasess

PC

0

 

 

 

 

 

Decreasess by budget item transfer

PD

0

 

 

 

 


Other intangible assets (Total II)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

0

 

 

 

 

Increases

PF

0

 

 

 

 

Decreasess

PG

0

 

 

 

 

 

Decreasess by budget item transfer

PH

0

 

 

 

 


Total fixed assets amotisation (Total III)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

0

 

 

 

 

Increases

QV

0

 

 

 

 

Decreases

QW

0

 

 

 

 

 

Decreasess by budget item transfer

QX

0

 

 

 

 


Movements during period affecting charge allocated over several period
Charges à répartir ou frais d'émission d'emprunt

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Gross value at begin of period

Z91

0

 

 

 

 

Increases

Z92

0

 

 

 

 

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

 

 

 

 

 

Decreasess by budget item transfer

B1

0

 

 

 

 


Premium refund of obligations

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Net value at begining of period

SP1

0

 

 

 

 

Increases

SP2

0

 

 

 

 

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

 

 

 

 

 

Net value at the end of period

SR

0

 

 

 

 

 

Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Value at begining of period

7C

4 719 294

 

 

 

 

Increases

UB

3 241 755

 

 

 

 

Decreases

UC

2 454 022

 

 

 

 

 

Value at the end of period

UD

5 507 027

 

 

 

 

Includes Total allocations

 

Operating

UE

2 124 271

 

 

 

 

 

Financial

UG

266 467

 

 

 

 

 

Exceptional

UJ

851 016

 

 

 

 

Includes Total Withdrawal

 

Operating

UF

1 653 912

 

 

 

 

 

Financial

UH

156 609

 

 

 

 

 

Exceptional

UK

643 501

 

 

 

 


Total regulated provisions (Total I)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Value at begining of period

3Z

2 745 644

 

 

 

 

Increases

TS

851 016

 

 

 

 

Decreases

TT

643 501

 

 

 

 

 

Value at the end of period

TU

2 953 159

 

 

 

 


Total risk and charge provisions (Total II)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Value at begining of period

5Z

501 591

 

 

 

 

Increases

TV

808 465

 

 

 

 

Decreases

TW

501 591

 

 

 

 

 

Value at the end of period

TX

808 465

 

 

 

 


Total Provision for depreciation (Total III)

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Value at begining of period

7B

1 472 059

 

 

 

 

Increases

TY

1 582 274

 

 

 

 

Decreases

TZ

1 308 929

 

 

 

 

 

Value at the end of period

UA

1 745 404

 

 

 

 

 

State deadlines claims and debts at the end of period
State claims

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Gross value

VT

16 286 315

 

 

 

 

 

1 year at most

VU

12 474 277

 

 

 

 

 

More than one year

VV

3 812 038

 

 

 

 


State of loans

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Claims related to holdings (gross)

UL

0

 

 

 

 

 

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

 

 

 

 

 

Loans (gross)

UP

0

 

 

 

 

 

Loans (1 year at most)

UR

0

 

 

 

 

 

Other financial assets (gross)

UT

1 692 179

 

 

 

 

 

Other financial assets (1 year at most)

UV

0

 

 

 

 


Receivables statement of assets

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Customers doubtful or disputed

VA

12 025

 

 

 

 

 

Other claims customer

UX

4 490 238

 

 

 

 

 

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

 

 

 

 

 

Provision for depreciation previously established

UQ

0

 

 

 

 

 

Personnel and associated accounts

UY

45 754

 

 

 

 

 

Social Security and other social organizations

UZ

0

 

 

 

 

 

Income taxes

VM

0

 

 

 

 

 

Value added tax

VB

1 076 538

 

 

 

 

 

Other taxes and payments assimilated

VN

0

 

 

 

 

 

State and other public - Miscellaneous

VP

0

 

 

 

 

 

Group and Associates

VC

5 550 050

 

 

 

 

 

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

0

 

 

 

 


Prepaid

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Prepaid

VS

3 419 530

 

 

 

 


State Debt

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Total debt (gross)

VY

28 741 349

 

 

 

 

1 year at most

VZ2

26 406 338

 

 

 

 

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

2 335 011

 

 

 

 

More than 5 years

VZ4

0

 

 

 

 


Details

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

 

 

 

 

1 year at most

7Y2

0

 

 

 

 

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

 

 

 

 

 

Other bonds (gross)

7Z1

0

 

 

 

 

1 year at most

7Z2

0

 

 

 

 

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

 

 

 

 

 

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

479 868

 

 

 

 

1 year at most

VG2

149 511

 

 

 

 

More than 1 year and 5 years at most

VG3

330 357

 

 

 

 

 

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

3 859 447

 

 

 

 

1 year at most

VH2

3 859 447

 

 

 

 

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

 

 

 

 

 

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

2 124 654

 

 

 

 

1 year at most

8A2

120 000

 

 

 

 

More than 1 year and 5 years at most

8A3

2 004 654

 

 

 

 

 

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

17 472 926

 

 

 

 

1 year at most

8B2

17 472 926

 

 

 

 

More than 1 year and 5 years at most

8B3

17 472 926

 

 

 

 

 

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

1 910 532

 

 

 

 

1 year at most

8C2

1 910 532

 

 

 

 

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

 

 

 

 

 

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

1 158 513

 

 

 

 

1 year at most

8D2

1 158 513

 

 

 

 

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

 

 

 

 

 

Taxes on profits (gross)

8E1

0

 

 

 

 

1 year at most

8E2

0

 

 

 

 

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

 

 

 

 

 

VAT (gross)

VW1

89 330

 

 

 

 

1 year at most

VW2

89 330

 

 

 

 

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

 

 

 

 

 

Backed Obligations (gross)

VX1

0

 

 

 

 

1 year at most

VX2

0

 

 

 

 

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

 

 

 

 

 

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

884 667

 

 

 

 

1 year at most

VQ2

884 667

 

 

 

 

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

 

 

 

 

 

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

594 287

 

 

 

 

1 year at most

8J2

594 287

 

 

 

 

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

 

 

 

 

More than 5 years

8J4

0

 

 

 

 

 

Groups and associates (gross)

VI1

0

 

 

 

 

1 year at most

VI2

0

 

 

 

 

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

 

 

 

 

More 5 years

VI4

0

 

 

 

 

 

Other liabilities (gross)

8K1

167 125

 

 

 

 

1 year at most

8K2

167 125

 

 

 

 

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

 

 

 

 

 

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

 

 

 

 

1 year at most

SZ2

0

 

 

 

 

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

 

 

 

 

 

Products in advance (gross)

8L1

0

 

 

 

 

1 year at most

8L2

0

 

 

 

 

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

 

 

 

 


References

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Loans made during the period

VJ

120 000

 

 

 

 

 

Debt repaid during the period

VK

0

 

 

 

 

 

Table allocation results and other information
Dividends distributed

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Dividends

ZE

0

 

 

 

 


Commitments

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Commitments leasing furniture

YQ

0

 

 

 

 

 

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

 

 

 

 

 

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

 

 

 

 


Other charges Externes

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Subcontracting

YT

0

 

 

 

 

 

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

 

 

 

 

 

Staff outside the company

YU

0

 

 

 

 

 

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

 

 

 

 

 

Fees, commissions and brokerage

YV

0

 

 

 

 

 

Other accounts

ST

0

 

 

 

 

 

Total Other purchases and external

ZJ

0

 

 

 

 


Taxes and Fees

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Business tax

YW

0

 

 

 

 

 

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

 

 

 

 

 

Total taxes and fees

YX

0

 

 

 

 


VAT

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Amount VAT collected

YY

0

 

 

 

 

 

Total VAT on goods and services

YZ

0

 

 

 

 


Average number of employees

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Average number of employees

YP

0

 

 

 

 


Groups and Shareholders

 

 

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

Groups and Shareholders

ZR

0

 

 

 

 

 

 

 

Display parameter

Comparison mode

Average

Median


Ratios
Structure and liquidity | Management or rotation | Profitability of the business | Return on capital

Structure and Liquidity

 

31/12/2010

 

 

 

 

Sector Median 2010

 

Fixed Asset Financing

1,39

 

 

 

 

1,26

10,3%

Global Debt

97 days

 

 

 

 

177 days

-45,2%

Working Capital Fund overall net

44 days

 

 

 

 

41 days

7,3%

Financial independence

734,21%

 

 

 

 

98,68%

644,0%

More ratios

Solvability

51,88%

 

 

 

 

25,77%

101,3%

Capacity debt futures

682,26%

 

 

 

 

407,07%

67,6%

Coverage of current assets by net working capital overall

33,58%

 

 

 

 

31,52%

6,5%

General Liquidity

0,47

 

 

 

 

0,09

422,2%

Restricted Liquidity

0,67

 

 

 

 

0,32

109,4%


Management or rotation

 

31/12/2010

 

 

 

 

Sector Median 2010

 

Need background in operating working capital

29 days

 

 

 

 

2 days

1350,0%

Treasury

4 days

 

 

 

 

2 days

100%

Inventory turnover of goods

145 days

 

 

 

 

148 days

-2,0%

Average length of credit granted to customers

15 days

 

 

 

 

0 days

0%

Average length of credit obtained suppliers

81 days

 

 

 

 

49 days

65,3%

 

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

13 days

 

 

 

 

0 days

0%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

days

 

 

 

 

498 days

-

Rotation tangible assets

%

 

 

 

 

561,47%

-


Profitability of the business

 

31/12/2010

 

 

 

 

Sector Median 2010

 

Margin trading

51,67%

 

 

 

 

42,41%

21,8%

Profitability of the business

11,86

 

 

 

 

4,69%

152,9%

Net profit

4,93%

 

 

 

 

1,98%

149,0%

More ratios

Growth rate of turnover (excluding VAT)

0%

 

 

 

 

-0,87%

0%

Rates integration

27,49%

 

 

 

 

25,46%

8,0%

Rate leasing furniture

0%

 

 

 

 

0%

0%

Work Factor

50,89%

 

 

 

 

71,50%

-28,8%

Weight interests

0,33

 

 

 

 

0,67%

-50,7%


Return on capital

 

31/12/2010

 

 

 

 

Sector Median 2010

 

Cash flow from the overall profitability

6,41%

 

 

 

 

4,16%

54,1%

Rates of economic profitability

33%

 

 

 

 

11%

200%

Financial profitability

31859488%

 

 

 

 

7406%

430084,8%

Return on investment

14,67%

 

 

 

 

7,46%

96,6%

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

Comparison mode

Average

Median


Soldes Intermédiaires de Gestion

 

31/12/2010

 

 

 

 

Sector Median 2010

 

Turnover

106 917 227

 

 

 

 

240 271 € 

44398,6% 

 

Sales of goods

102 558 402

 

 

 

 

 

 

- Purchase of goods

53 569 195

 

 

 

 

 

 

+/- Stock of goods variation

-6 250 022

 

 

 

 

 

 

Trading margin

55 239 229 €

 

 

 

 

96 862 € 

56928,8% 

 

51,67 % CA

 

 

 

 

42,74 % CA 

20,9% 

 

Sale of goods produced

4 358 825

 

 

 

 

 

 

+/- Stocked production

0

 

 

 

 

 

 

+ Self-constructed assets

0

 

 

 

 

 

 

Period production

4 358 825 €

 

 

 

 

0 € 

0% 

 

4,08 % CA

 

 

 

 

0 % CA 

0% 

 

Trading margin

55 239 229

 

 

 

 

96 862 

56928,8% 

+ Period Production

4 358 825

 

 

 

 

0% 

- Purchase of raw materials

1 160 921

 

 

 

 

 

 

+/- Change in stocks of raw materiels

-99 604

 

 

 

 

 

 

- Other external purchases and charges

29 144 065

 

 

 

 

 

 

Added value

29 392 672 €

 

 

 

 

63 524 € 

46170,2% 

 

27,49 % CA

 

 

 

 

25,45 % CA 

8,0% 

 

Added value

29 392 672 €

 

 

 

 

63 524 € 

46170,2% 

+ Operating grants

139 237

 

 

 

 

 

 

- Tax, duty and similar payments

1 896 165

 

 

 

 

 

 

- Personal charges

14 957 378

 

 

 

 

 

 

Gross operating surplus

12 678 366 €

 

 

 

 

10 711 € 

118267,7% 

 

11,86 % CA

 

 

 

 

4,69 % CA 

152,9% 

 

Gross operating surplus

12 678 366 €

 

 

 

 

10 711 € 

118267,7% 

+ Release of reserves and provisions

1 653 912

 

 

 

 

 

 

+ Other operating income

11 273

 

 

 

 

 

 

- Depreciation/Amortisation

4 636 970

 

 

 

 

 

 

- Other charges

1 264 583

 

 

 

 

 

 

Operating result

8 441 998 €

 

 

 

 

6 835 € 

123411,3% 

 

11,86 % CA

 

 

 

 

4,09 % CA 

190,0% 

 

Operating result

8 441 998 €

 

 

 

 

6 835 € 

123411,3% 

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

-34

 

 

 

 

 

 

+ Financial income

244 724

 

 

 

 

 

 

- Financial charges

357 186

 

 

 

 

 

 

Pre-tax result

8 329 570 €

 

 

 

 

4 633 € 

179687,8% 

 

7,79 % CA

 

 

 

 

2,03 % CA 

283,7% 

 

Extraordinary income

830 648

 

 

 

 

0% 

- Extraordinary charges

1 079 138

 

 

 

 

 

 

Extraordinary result

-248 490 €

 

 

 

 

0 € 

0% 

 

-0,23 % CA

 

 

 

 

0 % CA 

0% 

 

Pre-tax result

8 329 570 €

 

 

 

 

4 633 € 

179687,8% 

Extraordinary result

-248 490 €

 

 

 

 

0 € 

0% 

- Employee profit sharing

701 532

 

 

 

 

 

 

- Tax on profits

2 113 702

 

 

 

 

 

 

Net result

5 265 846 €

 

 

 

 

4 784 € 

109972,0% 

 

4,93 % CA

 

 

 

 

1,98 % CA 

149,0% 

 

 

rating

 

 

Rating and Limit history

Date

Description

25/04/2011

Very Good Credit Worthiness

08/10/2010

Credit Against Collateral

19/08/2010

Credit Against Collateral

21/05/2010

Credit Against Collateral

29/12/2009

Credit Against Collateral

11/02/2009

Credit Against Collateral

31/12/2008

Credit Against Collateral

06/11/2008

Very Good Credit Worthiness

06/11/2008

Very Good Credit Worthiness

29/09/2008

Very Good Credit Worthiness

22/09/2008

Very Good Credit Worthiness

 

judgements

 

Collective procedures

 

 

 

 

No judgment information for the company

 

 

 

 

 

 

 

  Social security, pension funds preferential rights | Tax office preferential rights

 

Preferential rights details and history

Summary of preferential rights

Company monitored since

06/05/2008

Monitored stopped since

06/05/2009

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

 

 

 

Group data

 

 

Ultimate parent company

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VÊTEMENTS POUR ENFANTS

Direct parent

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VÊTEMENTS POUR ENFANTS - 99 %

Group – Number of companies

3

Linkages – Number of companies

-

Number of countries

-

Go directly to the current company

Display only where participation % > 33 %

Display all participations

This company is a part of several groups, choose the group you wish to see the structure

Display the group

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VÊTEMENTS POUR ENFANTS

loading data...

 

Raison sociale

 

Safe Number

SIREN

Parts

Score

Limite

Derniers
comptes
publiés

SOC AMENAGEM DEVELOP- MAGASIN VET ENFA

 

FR06346554

438295396

-

95

95 000 €

31/12/2010

TAPE A L'OEIL

 

FR03162918

389632639

99%

100

2 000 000 €

31/12/2010

TEEN WEB

 

FR09467705

494230592

99.90%

19

0 €

31/12/2010

Type of shareholder

Shareholders

To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Adobe Flash Player.

Please download the free Flash Player and refresh the page.

 

 

Linkages

 

Ultimate parent company

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VÊTEMENTS POUR ENFANTS

Direct parent

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VÊTEMENTS POUR ENFANTS - 99 %

Group – Number of companies

3

Linkages – Number of companies

-

Number of countries

-

 

 

Event History

 

 

Status history

 

 

Date

Description

No Status History

 

 

 

Recent publications in Gazettes

 

Publication date

Gazette Name

Description

 

16/12/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1838 - 389 632 639 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPE A L'OEIL. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : TAO. Administration : Président de la société : SDAE Directeur général : SOENEN Joanes Administrateur : SDAE Administrateur : MULLIEZ Priscilla Administrateur : KOTWIS Bénédicte Administrateur : DELANNOY Frédéric Administrateur : MULLIEZ Frédéric. Activité : commerce de détail d'habillement et d'accessoires. Adresse de l’établissement principal : 24 avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal.
Adresse du siège social : 24 avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal.
Commentaires : Nomination d'un administrateur. Date de commencement de l’activité : 01/01/1993. Date d’effet : 25/10/2010.

18/10/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

7564 - 389632639 RCS. TAPE A L'OEIL. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 24 avenue du Grand Cottignies 59290 Wasquehal. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

24/09/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

409 - 389 632 639 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPE A L'OEIL. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : TAO. Administration : Président de la société : SDAE Directeur général : SOENEN Joanes Administrateur : SDAE Administrateur : MULLIEZ Priscilla Administrateur : KOTWIS Bénédicte Administrateur : DELANNOY Frédéric. Activité : commerce de détail d'habillement et d'accessoires. Adresse de l’établissement principal : 24 avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal.
Adresse du siège social : 24 avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal.
Commentaires : Nomination d'un administrateur. Date de commencement de l’activité : 01/01/1993. Date d’effet : 27/05/2010.

04/07/2010

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

78 - YVELINES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

535 - 389 632 639 RCS Versailles. TAPE A L OEIL. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 762245.09 EUR. Adresse : 24 avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : prêt a porter féminin. Adresse : avenue GUTenberg, Centre Commercial Pariwest, 78310 Maurepas.
Précédent propriétaire : ERIKSON SARL. 382 009 405 RCS Versailles.
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : Les Annonces de la Seine du 21/06/2010. Oppositions : Au Mandataire Me. LE GO 38, Ave. De Saint Cloud 78000 VERSAILLES pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : Fonds acquis par achat au prix stipul¿ de 225000 Euros. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

14/02/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1882 - 389 632 639 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPE A L'OEIL. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : TAO. Administration : Président de la société : SDAE Directeur général : SOENEN Joanes Administrateur : SDAE Administrateur : MULLIEZ Priscilla Administrateur : KOTWIS Bénédicte. Activité : commerce de détail d'habillement et d'accessoires. Adresse de l’établissement principal : 24 avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal.
Adresse du siège social : 24 avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal.
Commentaires : Changement d'administrateur. Date de commencement de l’activité : 01/01/1993. Date d’effet : 20/10/2009.

15/01/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

LA GAZETTE DU NORD PAS DE CALAIS


Société faisant objet d'une nomination : 389632639 - TAPE A L'OEIL, TAO, 24 AV DU GRAND COTTIGNIES, 59290 WASQUEHAL
Nominé : Madame Bénédicte FREMAUX, 24 AVENUE 24 AVENUE DU GRAND COTTIGNIES, 59290 WASQUEHAL
En la fonction de : Administrateur

15/01/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

LA GAZETTE DU NORD PAS DE CALAIS


Date de décision : 20/10/2009
La société 389632639 - TAPE A L'OEIL, TAO, 24 AV DU GRAND COTTIGNIES, 59290 WASQUEHAL
Fait l'objet du départ de Monsieur Patrice HEAULME

10/12/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

4580 - 389632639 RCS. TAPE A L'OEIL. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 24 avenue du Grand Cottignies 59290 Wasquehal. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

09/09/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

488 - 389 632 639 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPE A L'OEIL. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : TAO. Administration : Président de la société : SDAE Directeur général : SOENEN Joanes Administrateur : SDAE Administrateur : MULLIEZ Priscilla Administrateur : HEAULME Patrice. Activité : commerce de détail d'habillement et d'accessoires. Adresse de l’établissement principal : 24 avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal.
Adresse du siège social : 24 avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal.
Commentaires : Augmentation du capital social effectif. Date de commencement de l’activité : 01/01/1993. Date d’effet : 15/06/2009.

05/12/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

4687 - 389632639 RCS. TAPE A L'OEIL. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 24 avenue du Grand Cottignies 59290 Wasquehal. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

29/10/2008

Bodacc B

Radiation

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE

2961 - 389 632 639 RCS Lille. TAPE A L'OEIL. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : TAO. Administration : Président de la société : AMENAGEMENT ET DEVELOP.MAGASINS VETEMENT, représenté par M MULLIEZ Patrick. Directeur général : SOENEN Joannès. Administrateur : AMENAGEMENT ET DEVELOP.MAGASINS VETEMENT, représenté par M MULLIEZ Patrick. Administrateur : MULLIEZ Priscilla. Administrateur : HEAULME Patrice. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne. Activité : Commerce articles textiles et de loisirs, la for- mation de toute personne, en rapport avec son acti vité. Adresse de l’établissement principal : 2 rue de la Cense, 59650 Villeneuve-d'Ascq.
Adresse du siège social : 2 rue de la Cense, 59650 Villeneuve-d'Ascq.

24/10/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

924 - 389 632 639 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPE A L'OEIL. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : TAO. Administration : Président de la société : SDAE. Directeur général : SOENEN Joanes. Administrateur : SDAE. Administrateur : MULLIEZ Priscilla. Administrateur : HEAULME Patrice. Activité : commerce de détail d'habillement et d'accessoires. Adresse de l’établissement principal : 24 avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal.
Adresse du siège social : 24 avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal.
Commentaires : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création. Date de commencement de l’activité : 01/01/1993. Date d’effet : 12/07/2008.

04/11/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

3124 - 389 632 639. RCS Lille TAPE A L'OEIL. Sigle: TAO Forme: Société par actions simplifiée. Adresse du siège social: 2 rue de la Cense 59650 Villeneuve-d'Ascq. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

28/10/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1726 - RCS Lille B 389 632 639. RC 96-B 1058. TAPE A L'OEIL. Sigle : TAO. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 2 rue de la Cense,, 59650 Administration : président : SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VETEMENTS POUR ENFANTS. Directeur général : DELEMAZURE (Thierry). Administrateurs : SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VETEMENTS POUR ENFANTS Mme MULLIEZ (Priscilla) HEAULME (Patrice). Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS (Etienne). Ancienne administration : anciens administrateurs : MULLIEZ (Patrick) ALCA.B-PAMU.B. Etablissement principal - Activité : commerce d'articles textiles et de loisirs formation de toutes personnes en rapport avec son activité . Adresse : 2 rue de la Cense, 59650 Date d'effet : 23 juillet 2007.

21/10/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

203 - RCS Nice B 389 632 639. RC 07-B 1773. TAPE A L'OEIL. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 2 rue de la Cense,, 59650 Commentaires : modification survenue sur la prise d'activité. Etablissement principal - Activité : commerce d'articles textiles, d'habillement et de loisirs pour enfants. Adresse : centre commercial Auchan, route de Laghet, 06340 Date de début d'activité : 15 septembre 2007.

18/10/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2092 - RCS Lille B 389 632 639. RC 96-B 1058. TAPE A L'OEIL. Sigle : TAO. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 2 rue de la Cense,, 59650 Administration : président : SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VETEMENTS POUR ENFANTS. Directeur général : DELEMAZURE (Thierry). Administrateurs : SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VETEMENTS POUR ENFANTS MULLIEZ (Patrick) ALCA.B-PAMU.B. Nouveau commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Nouveau commissaire aux comptes suppléant : BORIS (Etienne). Ancienne administration : ancien commissaire aux comptes titulaire : S.A. K.P.M.G. S.A. Ancien commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE ACEA. Etablissement principal - Activité : commerce d'articles textiles, d'habillement et d'accessoires pour enfant. Adresse : 2 rue de la Cense, 59650 Etablissement principal - nouvelle situation - Activité : commerce d'articles textiles et de loisirs formation de toutes personnes en rapport avec son activité . Date d'effet : 28 juin 2007.

05/10/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

3283 - RCS Roubaix-Tourcoing B 389 632 639. RC 93-B 6. TAPE A L'OEIL. Sigle: TAO Forme: SAS . Adresse du siège social: 2, rue de la Cense,59650 Villeneuve-D'ascq. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

20/12/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

1571 - RCS Roubaix-Tourcoing B 389 632 639. RC 93-B 6. TAPE A L'OEIL. Sigle: TAO Forme: SAS . Adresse du siège social: 2, rue de la Cense,59650 Villeneuve-D'ascq. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

21/09/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1090 - RCS Roubaix-Tourcoing B 389 632 639. RC 93-B 6. TAPE A L'OEIL. Sigle : TAO. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 2 rue de la Cense,, 59650 Administration : président : STE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VETEMENTS POUR ENFANTS. Directeur général : DELEMAZURE (Thierry). Administrateurs : MULLIEZ (Patrick, Gérard, Marie, Joseph) STE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VETEMENTS POUR ENFANTS ALCA.B-PAMU.B. Commissaire aux comptes titulaire : K.P.M.G. S.A. Commissaire aux comptes suppléant : ACEA. Ancienne administration : ancien président du conseil d'administration : MULLIEZ (Patrick, Gérard, Marie, Joseph). Etablissement principal - Activité : vente d'articles textiles, d'habillement et d'accessoires pour enfants. Adresse : 2 rue de la Cense, 59650 Date d'effet : 28 juin 2005.

10/08/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1102 - RCS Roubaix-Tourcoing B 389 632 639. RC 93-B 6. TAPE A L'OEIL. Sigle : TAO. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 2 rue de la Cense,, 59650 Administration : président : MULLIEZ (Patrick, Gérard, Marie, Joseph). Directeur général : DELEMAZURE (Thierry). Administrateurs : MULLIEZ (Patrick, Gérard, Marie, Joseph) STE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VETEMENTS POUR ENFANTS ALCA.P-PAMU.B. Commissaire aux comptes titulaire : K.P.M.G. S.A. Commissaire aux comptes suppléant : ACEA. Ancienne administration : ancien administrateur : Mme MULLIEZ, née BOULLARD (Astrid). Etablissement principal - Activité : vente d'articles textiles, d'habillement et d'accessoires pour enfants. Adresse : 2 rue de la Cense, 59650 Date d'effet : 28 juin 2005.

17/05/2005

Bodacc A

Vente et cession

 

 

1073 - RCS Castres B 444 983 654. RC 03-B 29. TOBAGO. Forme : S.A.S. Capital : 38 000 euros. Adresse du siège social : 36 rue Villegoudou, 81100 Castres. Administration : Président : MANCEAU (Patrick, François) (Nom d'usage : MANCEAU). Commissaire aux comptes titulaire : CAMBOULIVE (Olivier) (Nom d'usage : CAMBOULIVE).Commissaire aux comptes suppléant : GONZALES (Francis). A compter du : 28 février 2005. Etablissement principal - Adresse : 36 rue Villegoudou, 81100 Castres. Etablissement complémentaire : Activité : prêt-à-porter pour enfants et accessoires s'y rapportant. Adresse : centre commercial Auchan, local no 39, 81100 Castres. Etablissement complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 230 000 euros. Date d'effet : 5 mars 2005. Précédent propriétaire exploitant : S.A.S. TAPE A L'OEIL. RCS Castres B 389 632 639. RC 02-B 183. Publication légale : L'Echo du Tarn du 24 mars 2005. Oppositions : Etude de Me Deyveaux, notaire, 14 boulevard Raymond-Vittoz, 81100 Castres.

28/05/2004

Bodacc A

Vente et cession

 

 

RCS non encore inscrit. TAPE A L'OEIL. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 2 rue de la Censé, 69660 Villeneuve-d' Ascq Etablissement principal: Activité : pret-à-porter pour enfants et accessoires. Adresse : 2 rue de la Censé, 69660 Villeneuve-d'Ascq ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : pret-à-porter pour enfants et accessoires. Adresse : 18 rue de la République, 84000 Avignon Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 485 000 euros. Date d'effet : 1 e r avril 2004. Précédent propriétaire : RIKIBOUM. RCS Paris B 398562611 RC 02-B 664 Publication légale: Les Petites affiches de Vaucluse du 20 avril 2004. Oppositions : M e Lapeyre (Olivier), notaire, rue des Ciseaux-d'Or, 84000 Avignon.

31/10/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 389632639 RC 93-B 6 PH INTERNATIONAL. Sigle : TAO. Forme : S.A. S. Adresse : 2 rue de la Cense, 59650 Villeneuve-d'Ascq Nouvelle situation du siège social dénomination: TAPE A L' OEIL Etablissement principal: Activité : vente d'articles textiles, d' habillement et d'accessoires pour enfants. Adresse : 2 rue de la Cense, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Date d'effet : 27 juin 2003.

21/09/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 389632639 RC 93- B 6 S.A.S. PH INTERNATIONAL. Forme : S.A. S. Adresse du siège social : 2 rue de la Cense, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Administration : directeur général : DELEMAZURE (Thierry). Administrateurs : MULLIEZ (Patrick, Gérard, Marie, Joseph) M m e MULLIEZ, née BOULLARD (Astrid) M m e FREMAUX, née KOTWIS (Bénédicte). Commissaire aux comptes titulaire : K.P. M.G. S.A. Commissaire aux comptes suppléant : ACEA. Anciens associés en nom collectif : EISN S.A.S. SDAE. Ancien gérant associé : S.N.C D'ACTIONS MOBILIERES Etablissement principal: Activité : vente d'articles textiles, d' habillement et d'accessoires pour enfants. Adresse : 2 rue de la Cense, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Commentaires : modification survenue sur la forme juridique. Ancienne : S.N.C. Date d'effet : 9 décembre 2002.

29/08/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 389632639 RC 93- B 6 PH INTERNATIONAL. Forme : S.N.C. Adresse du siège social : 2 rue de la Cense, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Administration : gérant associé : STE D' ACTIONS MOBILIERES. Associés en nom collectif : L'EUROPEENNE D'INGENIERIE DE SERVICES ET DE NEGOCIATION-E.I.S.N. STE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VETEMENTS POUR ENFANTS. Commissaire aux comptes titulaire : K.P. M.G. S.A. Commissaire aux comptes suppléant : ACEA. Ancien commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DE FRANCE K.P.M.G. AUDIT. Ancien commissaire aux comptes suppléant : EXPERTISE CONSEIL Etablissement principal: Activité : vente d'articles textiles, d'habillement et d' accessoires pour enfants. Adresse : 2 rue de la Censé, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Date d'effet : 28 janvier 2002.

14/11/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 389632639 RC 93-B 6 P.H. INTERNATIONAL. Forme : S.N.C. Adresse : 1 rue du Transit, 59650 Villeneuve-d' Ascq Nouvelle situation du siège social. Adresse : 2 rue de la Censé, 59650 Villeneuve-d'Ascq Etablissement principal: Activité : vente d'articles textiles, d'habillement et d' accessoires pour enfants. Adresse : 1 rue du Transit, 59650 Villeneuve-d'Ascq ETABLISSEMENT PRINCIPAL nouvelle situation. Adresse : 2 rue de la Censé, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Date d'effet : 12 juillet 2002.

26/06/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 389632639 RC 93- B 6 P.H. INTERNATIONAL. Forme : S.N.C. Adresse du siège social : 1 rue du Transit, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Administration : gérant associé : STE D' ACTIONS MOBILIERES. Associés en nom collectif : L'EUROPEENNE D'INGENIERIE DE SERVICES ET DE NEGOCIATION-E.I.S.N. STE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VETEMENTS POUR ENFANTS. Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DE FRANCE K.P.M.G. AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTISE CONSEIL ET AUDIT S.A. D' EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES. Ancien associé en nom collectif : S.A. SERVIMOD Etablissement principal: Activité : vente d'articles textiles, de vetements et d'accessoires pour enfants. Adresse : 1 rue du Transit, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Date d'effet : 10 décembre 2001.

04/04/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 389632639 RC 93-B 6 PH. INTERNATIONAL. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 7 855 819,82 euros. Adresse : 1 rue du Transit, 59650 Villeneuve-d'Ascq Nouvelle situation du siège social. Capital : 7 729 620 euros Etablissement principal: Activité : vente d'articles textiles, d' habillement et d'accessoires pour enfants. Adresse : 1 rue du Transit, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Date d'effet : 10 décembre 2001.

03/04/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 389632639 RC 93-B 6 P.H. INTERNATIONAL. Forme : S.N.C. Adresse : 100 rue du Calvaire, 59510 Hem. Administration : gérant associé : STE D' ACTIONS MOBILIERES. Associés en nom collectif : L'EUROPEENNE D'INGENIERIE DE SERVICES ET DE NEGOCIATION-E.I.S.N. SERVIMOD STE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VETEMENTS POUR ENFANTS. Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DE FRANCE K.P.M. G. AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTISE CONSEIL ET AUDIT S.A. D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES Nouvelle situation du siège social dénomination: P.H. INTERNATIONAL. Forme : S.A. à conseil d'administration. Adresse : 1 rue du Transit, 59650 Villeneuve-d'Ascq Etablissement principal: Activité : commerce d'articles textiles, d' habillement et d'accessoires pour enfants. Adresse : 1 rue du Transit, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Date d'effet : 22 octobre 2001.

20/02/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 389632639 RC 93- B 6 P.H. INTERNATIONAL. Forme : S.N.C. Adresse du siège social : 100 rue du Calvaire, 59510 Hem Etablissement principal: Activité : commerce de tous articles d'habillement et d'accessoires. Adresse : 1 rue du Transit, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Commentaires : fusion- absorption de la S.N.C. P.L. INTERNATIONAL,. RCS B 389 630 674. Date d'effet : 31 décembre 1999.

20/01/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

o. RCS Roubaix-Tourcoing B 389 632 639 RC 1993-B 6 P.H. INTERNATIONAL. Forme : S. N.C. Adresse du siège social : 100, rue du Calvaire 59510 Hem. Commentaires : ancienne adresse du principal établissement : 1, boulevard de Versailles, 59650 Villeneuve-d'Ascq Etablissement principal: Activité : commerce de tous articles d'habillement et d'accessoires. Adresse : 1, rue du Transit 59650 Villeneuve-d'Ascq. Date d'effet : 1er décembre 1999 Date de début d'activité: 1er janvier 1993.

26/10/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 389 632 639 RC 93-B 6 P.H. INTERNATIONAL. Forme : S.N.C. Adresse du siège social : 100 rue du Calvaire 59510 Hem. Administration : gérant associé : STE D'ACTIONS MOBILIERES. Associé en nom collectif : SERVIMOD. Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DE FRANCE K.P.M. G. AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTISE CONSEIL ET AUDIT- S.A. D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES. Ancien commissaire aux comptes suppléant : STE ROUBAISIENNE D'EXPERTISE COMPTABLE Etablissement principal: Activité : commerce de tous articles d'habillement et d'accessoires. Adresse : 1 boulevard de Versailles 59650 Villeneuve-d'Ascq. Date d'effet : 23 juin 1997.

07/04/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 389 632 639 RC 93-B 6 P.H. INTERNATIONAL. Forme : S.N.C. Adresse du siège social : 100 rue du Calvaire 59510 Hem Etablissement principal: Activité : commerce de tous articles et d'accessoires d'habillement. Adresse : 430 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve-d'Ascq ETABLISSEMENT PRINCIPAL nouvelle situation. Adresse : 1 boulevard de Valmy et boulevard de Versailles 59650 Villeneuve-d'Ascq. Date d'effet : 1er février 1996.

07/03/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS o. RCS Roubaix-Tourcoing B 389 632 639 RC RC 93-B 6 P.H. INTERNATIONAL. Forme : S.N.C. Adresse du siège social : 100, rue du Calvaire 59510 Hem. Administration : gérant-associé : SOCIETE D'ACTIONS MOBILIERES. Associé en nom collectif : SERVIMOD. Nouveau commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DE FRANCE K.P.M.G. AUDIT. Nomination de commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE ROUBAISIENNE D' EXPERTISE COMPTABLE Etablissement principal: Activité : commerce de tous articles d'habillement et d'accessoires. Adresse : 430, rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve-d'Ascq. Date d'effet : 7 juin 1995.

21/10/1995

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS Saint-Gaudens B 310 392 394 CARUDIS. Forme : S.A.R.L. Adresse du siège social : 28, rue de la République, 31800 Saint- Gaudens ETABLISSEMENT SECONDAIRE Toulouse B RC 92-B 1948. Adresse : centre commercial Fenouillet, zone industrielle Saint-Jory, route nationale 20, 31150 Fenouillet Droit au bail du fonds complémentaire acquis par achat au prix stipulé de : 610 000 F Etablissement Complémentaire. Activité : vente de pret-à-porter pour hommes. Adresse : centre commercial E.-Leclerc, 2, allées Emile-Zola, 31700 Blagnac. Date d'effet : 15 aout 1995 Précédente propriétaire P.H. INTERNATIONAL S.N.C. RCS B 389 632 639 RC 94-B 1256 Publication légale: La Gazette des Tribunaux du Midi du 12 aout 1995. Oppositions : en l'étude de Me Dagot, notaire, 6, place Wilson, 31000 Toulouse.

08/09/1995

Bodacc A

Vente et cession

 

 

RCS non encore inscrit CARUDIS. Forme : S. A.R.L. Adresse du siège social : 28 rue de la République 31800 Saint-Gaudens Etablissement principal: Adresse : 2 allées Emile-Zola 31700 Blagnac. Activité : pret-à-porter masculin Droit au bail acquis par achat au prix stipulé de 610 000 F. Date d'effet : 15 aout 1995. Précédent propriétaire : PH INTERNATIONAL. RCS Roubaix-Tourcoing B 389 632 639 RC 94-B 1256 Publication légale: La Gazette des tribunaux du Midi du 12 aout 1995. Oppositions : Me Dagot, notaire, 6 place Wilson, 31000 Toulouse.

15/01/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 389 632 639 RC 93-B 6 P.H. INTERNATIONAL. Forme : S.N.C. Adresse : 15 avenue des Paraboles 59100 Roubaix. Administration : gérant associé : STE D'ACTIONS MOBILIERES. Associé en nom collectif : SERVIMOD. Ancien gérant LES FILS DE LOUIS MULLIEZ Nouvelle situation du siège social. Adresse : 100 rue du Calvaire 59510 Hem Etablissement principal: Activité : commerce de tous articles d'habillement et d'accessoires. Adresse : 100 rue du Calvaire 59510 Hem. Date d'effet : 28 novembre 1994.

 

Company events history

 

Date

Description

10/08/2011

Formation of Establishment

25/07/2011

Bodacc C : Deposit accounts notice

19/07/2011

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

22/06/2011

Invalid balance sheet

11/05/2011

Formation of Establishment

31/12/2010

New accounts available

16/12/2010

Bodacc B: Various editing or changing

03/12/2010

Changes to the Board of Directors

03/12/2010

Minutes of general meeting of shareholders

18/10/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

24/09/2010

Bodacc B: Various editing or changing

13/09/2010

Changes to the Board of Directors

13/09/2010

Minutes of general meeting of shareholders

13/08/2010

New shareholders detected

13/08/2010

Modification of Establishment Activity

04/07/2010

Bodacc A : Sale and transfer

28/06/2010

Closure of Establishment

14/06/2010

Appointment/resignation of company officers

14/06/2010

Private document

14/06/2010

Company formation

25/03/2010

Minutes of general meeting of shareholders

25/03/2010

Updated articles of association

14/02/2010

Bodacc B: Various editing or changing

02/02/2010

Minutes of general meeting of shareholders

02/02/2010

Changes to the Board of Directors

15/01/2010

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

31/12/2009

New accounts available

10/12/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

02/12/2009

Formation of Establishment

02/12/2009

Update of Company Workforce

20/10/2009

Legal Gazette: Appointment of the social representative

09/09/2009

Bodacc B: Various editing or changing

19/08/2009

Updated articles of association

19/08/2009

Minutes of general meeting of shareholders

19/08/2009

Capital increase

15/06/2009

Other modification of Establishment

27/02/2009

Formation of Establishment

23/01/2009

Capital increase

23/01/2009

Capital reduction

23/01/2009

Minutes of general meeting of shareholders

23/01/2009

Updated articles of association

23/01/2009

Private document

31/12/2008

New accounts available

05/12/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

29/10/2008

Bodacc B: Radiation

29/10/2008

New Bodacc B ads detected

24/10/2008

Bodacc B: Various editing or changing

24/10/2008

New Bodacc B ads detected

22/10/2008

Private document

22/10/2008

Minutes of Board meeting

22/10/2008

Minutes of general meeting of shareholders

22/10/2008

Updated articles of association

22/10/2008

Appointment/resignation of company officers

14/10/2008

Updated articles of association

14/10/2008

Statuts mis à jour

14/10/2008

Minutes of Board meeting

14/10/2008

Minutes of general meeting of shareholders

14/10/2008

PV d'Assemblée

14/10/2008

Private document

14/10/2008

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

14/10/2008

Capital increase

14/10/2008

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

07/10/2008

Formation of Establishment

12/07/2008

Transfer of Establishment

12/07/2008

Update of Company Head Office Identifier

06/05/2008

Collection of preferential rights activated for this company

03/12/2007

Private document

03/12/2007

PV du Conseil d'Administration

03/12/2007

Appointment/resignation of company officers

03/12/2007

Minutes of Board meeting

03/12/2007

Modification du Conseil d'Administration

03/12/2007

Changes to the Board of Directors

01/10/2007

PV d'Assemblée

01/10/2007

Private document

01/10/2007

Minutes of general meeting of shareholders

01/10/2007

Appointment/resignation of company officers

01/10/2007

Modification du Conseil d'Administration

01/10/2007

Changes to the Board of Directors

20/09/2007

Augmentation de Capital

20/09/2007

Capital increase

20/09/2007

Private document

20/09/2007

PV d'Assemblée

20/09/2007

Minutes of general meeting of shareholders

20/09/2007

Statuts mis à jour

20/09/2007

Updated articles of association

05/09/2007

PV d'Assemblée

05/09/2007

Change to corporate purpose

05/09/2007

Modification de l'objet social

05/09/2007

Private document

05/09/2007

Changement de Commissaire aux Comptes

05/09/2007

New auditor

05/09/2007

Statuts mis à jour

05/09/2007

Updated articles of association

05/09/2007

Minutes of general meeting of shareholders

18/04/2007

Private document

18/04/2007

Capital increase

18/04/2007

Augmentation de Capital

18/04/2007

Updated articles of association

18/04/2007

Statuts mis à jour

18/04/2007

PV d'Assemblée

18/04/2007

Minutes of general meeting of shareholders

31/12/2006

New accounts available

31/12/2005

New accounts available

07/09/2005

Changement de Président (PDG, PCA)

07/09/2005

PV du Conseil d'Administration

07/09/2005

Acte sous seing privé

07/09/2005

Nomination/démission des organes de gestion

07/09/2005

Minutes of Board meeting

07/09/2005

Appointment/resignation of company officers

07/09/2005

Private document

05/09/2005

Acte sous seing privé

05/09/2005

Appointment/resignation of company officers

05/09/2005

Statuts mis à jour

05/09/2005

Updated articles of association

05/09/2005

Modification du Conseil d'Administration

05/09/2005

Changes to the Board of Directors

05/09/2005

Minutes of general meeting of shareholders

05/09/2005

Augmentation de Capital

05/09/2005

Private document

05/09/2005

Nomination/démission des organes de gestion

05/09/2005

Capital increase

05/09/2005

PV d'Assemblée

27/07/2005

Acte sous seing privé

27/07/2005

Modification du Conseil d'Administration

27/07/2005

Changes to the Board of Directors

27/07/2005

Private document

27/07/2005

Minutes of general meeting of shareholders

27/07/2005

Appointment/resignation of company officers

27/07/2005

Nomination/démission des organes de gestion

27/07/2005

PV d'Assemblée

24/03/2005

Private document

24/03/2005

Acte sous seing privé

24/03/2005

Réduction de Capital

24/03/2005

Capital reduction

24/03/2005

Capital increase

24/03/2005

Augmentation de Capital

24/03/2005

Updated articles of association

24/03/2005

Statuts mis à jour

24/03/2005

Minutes of general meeting of shareholders

24/03/2005

PV d'Assemblée

31/12/2004

New accounts available

17/05/2004

PV d'Assemblée

17/05/2004

Augmentation de Capital

17/05/2004

Statuts mis à jour

17/05/2004

Acte sous seing privé

12/03/2004

Acte sous seing privé

12/03/2004

Statuts mis à jour

12/03/2004

PV d'Assemblée

12/03/2004

Acte modificatif

31/12/2003

New accounts available

21/10/2003

Statuts mis à jour

21/10/2003

Nomination/démission des organes de gestion

21/10/2003

Modification du Conseil d'Administration

21/10/2003

Acte sous seing privé

21/10/2003

PV d'Assemblée

21/10/2003

Changement de dénomination sociale

25/08/2003

PV du Conseil d'Administration

25/08/2003

Statuts mis à jour

25/08/2003

Acte modificatif

25/08/2003

Changement de Forme Juridique sans changement de catégorie

25/08/2003

Changement de Président (PDG, PCA)

25/08/2003

Modification du Conseil d'Administration

25/08/2003

Acte sous seing privé

25/08/2003

Nomination/démission des organes de gestion

25/08/2003

PV d'Assemblée

12/12/2002

Acte sous seing privé

12/12/2002

PV d'Assemblée

12/12/2002

Acte modificatif

19/11/2002

Rapport des Commissaires ou du Gérant

19/11/2002

Acte sous seing privé

29/10/2002

Statuts mis à jour

29/10/2002

Acte sous seing privé

29/10/2002

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

29/10/2002

PV d'Assemblée

23/07/2002

Acte sous seing privé

23/07/2002

Rapport des Commissaires ou du Gérant

22/03/2002

Conversion du Capital Social en Euros

22/03/2002

Réduction de Capital

22/03/2002

Acte sous seing privé

22/03/2002

Statuts mis à jour

22/03/2002

PV d'Assemblée

21/03/2002

Acte sous seing privé

21/03/2002

Cession de parts

21/03/2002

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

21/03/2002

Augmentation de Capital

21/03/2002

Statuts mis à jour

21/03/2002

PV d'Assemblée

04/02/2000

PV d'Assemblée

04/02/2000

Statuts mis à jour

04/02/2000

Augmentation de Capital

04/02/2000

Déclaration de conformité

04/02/2000

Acte sous seing privé

20/12/1999

Rapport des Commissaires ou du Gérant

20/12/1999

Acte sous seing privé

29/11/1999

Projet de Fusion

29/11/1999

Acte sous seing privé

19/12/1997

Statuts mis à jour

19/12/1997

PV d'Assemblée

19/12/1997

Acte sous seing privé

13/10/1997

Changement de Commissaire aux Comptes

13/10/1997

PV d'Assemblée

13/10/1997

Acte sous seing privé

20/02/1996

PV d'Assemblée

29/12/1994

Acte sous seing privé

29/12/1994

Changement de Gérant

29/12/1994

Cession de parts

29/12/1994

Statuts mis à jour

29/12/1994

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

29/12/1994

PV d'Assemblée

29/12/1994

Nomination/démission des organes de gestion

18/10/1994

PV d'Assemblée

18/10/1994

Statuts mis à jour

02/11/1993

Statuts mis à jour

02/11/1993

Déclaration de conformité

02/11/1993

PV d'Assemblée

21/06/1993

Déclaration de conformité

21/06/1993

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

21/06/1993

Statuts mis à jour

21/06/1993

PV d'Assemblée

07/01/1993

Déclaration de conformité

07/01/1993

Formation de Société

07/01/1993

Acte sous seing privé

07/01/1993

Statuts

 

Establishment events history

 

Date

Description

10/08/2011

Modification of Head office

19/07/2011

Update Limit

19/07/2011

Update Rating

11/05/2011

Update of Establishment Workforce

11/05/2011

Modification of Head office

25/04/2011

Update Rating

08/10/2010

Update Rating

19/08/2010

Update Rating

19/08/2010

Update Limit

13/08/2010

Update of Establishment Activity

13/08/2010

Modification of Head office Activity

31/07/2010

Update Limit

28/06/2010

Modification of Head office

21/05/2010

Update Limit

21/05/2010

Update Rating

29/12/2009

Update Rating

29/12/2009

Update Limit

02/12/2009

Modification of Head office

02/12/2009

Update of Establishment Workforce

13/03/2009

Update of phone numbers

27/02/2009

Modification of Head office

11/02/2009

Update Rating

11/02/2009

Update Limit

08/02/2009

Update Rating

08/02/2009

Update Limit

31/12/2008

Update Limit

31/12/2008

Update Rating

06/11/2008

Update Limit

06/11/2008

Update Rating

22/10/2008

Update of phone numbers

07/10/2008

Modification of Head office

29/09/2008

Update Rating

12/07/2008

Formation of Head office (after transfer)

 

 

 

 

directors

 

 

 

Shareholder(s)

 

 

Name

SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VETEMENTS POUR ENFANTS - SDAE

 

Name of representative

 

 

Manager position

Président, Administrateur

Date of birth

 

 

Place of birth

 

 

 

 

Type of manager

Moral person

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. SOENEN JOANNES

 

Manager position

Directeur général

Date of birth

04/03/1970

 

Place of birth

59 VILLENEUVE-D'ASCQ

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

Mme. MULLIEZ PRISCILLA

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

01/04/1971

 

Place of birth

59 CROIX

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

Mme. FREMAUX BENEDICTE

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

18/12/1961

 

Place of birth

59 ROUBAIX

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

KOTWIS

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. DELANNOY FREDERIC

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

17/01/1962

 

Place of birth

59 ROUBAIX

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. MULLIEZ FREDERIC

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

12/05/1964

 

Place of birth

59 LILLE

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Directors

 

 

 

Vous pouvez consulter ici l'historique des dirigeants de l'entreprise.
Si vous souhaitez consulter l'historique d'un dirigeant, il vous suffit de cliquer sur le lien voir le détail pour y accéder.