MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :           

20.07.2011

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

RHI AG

 

 

Registered Office :

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

31.12.2009

 

 

Date of Incorporation :

18.12.1979

 

 

Legal Form :

Joint Stock Company

 

 

Line of Business :

Manufacturer of refractory products

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Maximum Credit Limit :

EUR  10.625.000,00

 

 

Status :

Good

 

 

Payment Behaviour :

No Complaints

 

 

Litigation :

Clear

 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31st, 2011

 

Country Name

Previous Rating

                   (31.12.2010)                  

Current Rating

(31.03.2011)

Austria

a1

a1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


Basic company information

 

Company name:

RHI AG

Status:

active company

Locations:

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

Phone:

0043 (5) 0213

Fax:

0043 (5) 0213 - 6213

E-mail:

info@rhi-ag.com 

Internet:

http://www.rhi-ag.com

Activities:

Manufacture of refractory products

 

Other business support service activities n.e.c.

 

Activities of holding companies

 

General Assessment:

The Rating of this company meets industry average.

 

Recommendation

Despite the weak financial situation, the establishment of a business and credit relationship can be recommended. Risk is considered low due to positive experiences from the environment of the company.

 

Detail Assessment:

As a rule payments are made on time according to conditions, in some cases there have been delays and reminders.

 

Financial situation is average, increased use of external capital.

 

Maximum credit EUR  10.625.000,00

 

 

Additional company information

 

Year of incorporation:

1976

 

Type of company:

Manufacturing

 

Legal form:

joint stock company since 1979-11-16

 

companies' house number:

FN 103123 b Wien 1979-12-18

 

Activities:

 

 

VAT number:

ATU 14187609

 

number - Austrian National Bank:

62871

 

 

 

 

Import 

Country 

 

 

 

Import

world-wide

 

2010

 

 

Export 

Country 

 

 

 

Export

world-wide

 

2010

 

 


Financial data

 

total turnover (total sales)

2010

EUR  850.000.000,00

(estimated)

total turnover (total sales)

2009

EUR  846.518.343,55

(exact)

total turnover (total sales)

2008

EUR  1.121.483.998,91

(exact)

total turnover (total sales)

2007

EUR  976.147.670,01

(exact)

total turnover (total sales)

2006

EUR  808.904.927,07

(exact)

turnover (sales) - group

2009

EUR  1.236.900.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2008

EUR  1.596.700.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2007

EUR  1.485.800.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2006

EUR  1.335.800.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2005

EUR  1.199.400.000,00

(exact)

total employees

2011

600

(approx.)

 

 

Extraxt from the Companies' House

 

firm (style):

   22      RHI AG

legal form:

    1      Aktiengesellschaft

registered office:

    1      politischer Gemeinde Wien

business adress:

  137      Wienerbergstraße 9
           1100 Wien

capital:

  129      EUR 289.376.212,84

reference date annual accounts:

    1      31. Dezember

annual accounts:

  133      zum 31.12.2009 eingereicht am 26.05.2010

consolidated accounts:

  133      zum 31.12.2009 eingereicht am 26.05.2010

power of representation:

    1      Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder
           bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder
           durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen
           vertreten.
           Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
           selbständige Vertretungsbefugnis erteilen.

other provisions:

    3      Der Vorstand besteht aus 2, 3, 4 oder 5 Personen.

board of directors:

        CG   Dr. Giorgio Cappelli, geb. 31.01.1956
  100        Mitglied
             vertritt seit 01.01.2007 gemeinsam mit
             einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
        CH   Dr. Manfred Hödl, geb. 29.04.1955
  100        Mitglied
             vertritt seit 01.01.2007 gemeinsam mit
             einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
        DB   Henning Jensen, geb. 16.08.1960
  136        Mitglied
             vertritt seit 18.01.2010 gemeinsam mit
             einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

proxy:

        BP   Dipl.Ing. Ingo Gruber, geb. 19.04.1962
   58        vertritt seit 18.03.2002 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        BS   Mag. G. Celia Konrad, geb. 05.10.1967
   65        vertritt seit 19.12.2002 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        BT   Mag. Michael Csebits, geb. 05.01.1965
   68        vertritt seit 07.04.2003 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        BZ   Bernhard Goliasch, geb. 19.05.1964
   91        vertritt seit 01.01.2006 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        CB   Mag.Dipl.Ing.Dr. Gerald Klenner, geb. 21.04.1965
   95        vertritt seit 01.06.2006 gemeinsam mit
             einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
        CC   Mag. Rainhard Mayer, geb. 27.09.1949
   95        vertritt seit 01.06.2006 gemeinsam mit
             einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
        CN   Mag. Barbara Potisk, geb. 09.09.1968
  111        vertritt seit 13.09.2007 gemeinsam mit
             einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
        CO   Mag. Gabriele Pichler, geb. 24.05.1975
  115        vertritt seit 19.12.2007 gemeinsam mit
             einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
        CU   Mag. Bernd Buchberger, geb. 19.08.1965
  123        vertritt seit 30.03.2009 gemeinsam mit
             einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
        CW   Ulf Andersson, geb. 19.01.1966
  126        vertritt seit 25.05.2009 gemeinsam mit
             einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
        CY   Dipl.Ing. Thomas Jakowiak, geb. 08.04.1972
  126        vertritt seit 25.05.2009 gemeinsam mit
             einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
        DA   Dipl.Ing. Holger Woltron, geb. 19.12.1964
  126        vertritt seit 25.05.2009 gemeinsam mit
             einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
        DC
   DI Franz Buxbaum, geb. 22.02.1956
  130        vertritt seit 17.12.2009 gemeinsam mit
             einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied

supervisory board:

        AT   DI Leopold Miedl, geb. 07.08.1945
   30        Mitglied
        AX   Dipl.Bw. Gerd Peskes, geb. 26.12.1944
  111        Mitglied
        BJ   Stanislaus Prinz zu Sayn-Wittgenstein
             -Berleburg, geb. 15.09.1965
   47        Mitglied
        BN   Dkfm. Michael Gröller, geb. 17.04.1941
  133        Stellvertreter des Vorsitzenden
        CE   Mag. Martin Kowatsch, geb. 04.02.1972
   96        Mitglied
        CI   Dipl.-Ing.Dr. Helmut Draxler, geb. 25.04.1950
  111        Stellvertreter des Vorsitzenden
        CJ   Dr. Herbert Cordt, geb. 12.01.1947
  133        Vorsitzender
        CL   Hubert Gorbach, geb. 27.07.1956
  109        Mitglied
        CQ   Franz Reiter, geb. 25.01.1962
  116        Mitglied
        CV   Roland Rabensteiner, geb. 27.01.1971
  124        Mitglied
        DD   David Schlaff, geb. 08.10.1978
  133        Mitglied

General Table :

Handelsgericht Wien
   1 datenersterfaßt am 17.06.1994              Geschäftsfall 920 Fr  1462/94 s
       Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
   3 eingetragen am 01.07.1994                  Geschäftsfall 703 Fr  6865/94 s
       Berichtigung - Antrag  eingelangt am 29.06.1994
  12 eingetragen am 12.12.1995                  Geschäftsfall 702 Fr 12830/95 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.12.1995
  13 eingetragen am 13.12.1995                  Geschäftsfall 702 Fr 12831/95 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.12.1995
  22 eingetragen am 08.01.1998                  Geschäftsfall  72 Fr 12900/97 b
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.12.1997
  30 eingetragen am 17.03.1999                  Geschäftsfall  72 Fr  3274/99 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.03.1999
  33 eingetragen am 22.07.1999                  Geschäftsfall  72 Fr  8698/99 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.07.1999
  34 eingetragen am 06.08.1999                  Geschäftsfall  72 Fr  8701/99 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.07.1999
  35 eingetragen am 07.09.1999                  Geschäftsfall  72 Fr  9670/99 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.07.1999
  36 eingetragen am 15.10.1999                  Geschäftsfall  73 Fr  1989/99 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.10.1999
  42 eingetragen am 19.05.2001                  Geschäftsfall  73 Fr  5484/01 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.04.2001
  47 eingetragen am 06.07.2001                  Geschäftsfall  73 Fr  8859/01 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.07.2001
  57 eingetragen am 01.03.2002                  Geschäftsfall  73 Fr  2336/02 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.02.2002
  58 eingetragen am 06.04.2002                  Geschäftsfall  73 Fr  3820/02 v
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.04.2002
  65 eingetragen am 21.01.2003                  Geschäftsfall  73 Fr   693/03 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.01.2003
  68 eingetragen am 09.05.2003                  Geschäftsfall  73 Fr  4762/03 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.04.2003
  69 eingetragen am 05.08.2003                  Geschäftsfall  73 Fr  8065/03 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 15.07.2003
  70 eingetragen am 25.09.2003                  Geschäftsfall  73 Fr 10680/03 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.09.2003
  72 eingetragen am 24.12.2003                  Geschäftsfall  73 Fr 14627/03 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.12.2003
  74 eingetragen am 24.03.2004                  Geschäftsfall  73 Fr  3326/04 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.03.2004
  75 eingetragen am 24.06.2004                  Geschäftsfall  73 Fr  6931/04 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.06.2004
  78 eingetragen am 28.09.2004                  Geschäftsfall  73 Fr 11101/04 v
       Berichtigung - Antrag  eingelangt am 27.09.2004
  80 eingetragen am 18.12.2004                  Geschäftsfall  73 Fr 15541/04 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.12.2004
  83 eingetragen am 19.03.2005                  Geschäftsfall  73 Fr  3641/05 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.03.2005
  84 eingetragen am 28.06.2005                  Geschäftsfall  73 Fr  7870/05 a
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.06.2005
  87 eingetragen am 09.09.2005                  Geschäftsfall  73 Fr  9194/05 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.07.2005
  88 eingetragen am 24.09.2005                  Geschäftsfall  73 Fr 11472/05 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.09.2005
  90 eingetragen am 21.12.2005                  Geschäftsfall  73 Fr 15872/05 v
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.12.2005
  91 eingetragen am 27.01.2006                  Geschäftsfall  73 Fr   816/06 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.01.2006
  92 eingetragen am 02.02.2006                  Geschäftsfall  73 Fr  1275/06 k
       amtswegige Berichtigung
  93 eingetragen am 25.03.2006                  Geschäftsfall  71 Fr  2706/06 a
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.03.2006
  94 eingetragen am 30.06.2006                  Geschäftsfall  71 Fr  6101/06 v
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.06.2006
  95 eingetragen am 08.07.2006                  Geschäftsfall  71 Fr  6584/06 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.07.2006
  96 eingetragen am 13.07.2006                  Geschäftsfall  71 Fr  6585/06 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.07.2006
  97 eingetragen am 14.07.2006                  Geschäftsfall  71 Fr  6725/06 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.07.2006
  98 eingetragen am 22.09.2006                  Geschäftsfall  71 Fr  9393/06 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.09.2006
  99 eingetragen am 21.12.2006                  Geschäftsfall  71 Fr 13417/06 b
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.12.2006
 100 eingetragen am 04.01.2007                  Geschäftsfall  71 Fr    88/07 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.12.2006
 102 eingetragen am 07.02.2007                  Geschäftsfall  71 Fr  1466/07 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 01.02.2007
 103 eingetragen am 28.03.2007                  Geschäftsfall  71 Fr  3756/07 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.03.2007
 104 eingetragen am 30.03.2007                  Geschäftsfall  71 Fr  3911/07 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.03.2007
 106 eingetragen am 26.06.2007                  Geschäftsfall  71 Fr  7189/07 b
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.06.2007
 107 eingetragen am 27.06.2007                  Geschäftsfall  71 Fr  7379/07 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.06.2007
 109 eingetragen am 31.07.2007                  Geschäftsfall  71 Fr  7486/07 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.06.2007
 110 eingetragen am 15.09.2007                  Geschäftsfall  71 Fr 10678/07 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.09.2007
 111 eingetragen am 03.10.2007                  Geschäftsfall  71 Fr 11666/07 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.09.2007
 114 eingetragen am 22.12.2007                  Geschäftsfall  71 Fr 15179/07 b
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.12.2007
 115 eingetragen am 17.01.2008                  Geschäftsfall  71 Fr   555/08 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.01.2008
 116 eingetragen am 06.02.2008                  Geschäftsfall  71 Fr  1394/08 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.01.2008
 118 eingetragen am 17.05.2008                  Geschäftsfall  75 Fr  4804/08 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.05.2008
 119 eingetragen am 11.09.2008                  Geschäftsfall  75 Fr  9111/08 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.08.2008
 120 eingetragen am 24.09.2008                  Geschäftsfall  75 Fr 10547/08 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.09.2008
 121 eingetragen am 09.01.2009                  Geschäftsfall  75 Fr 15828/08 w
       Urkundenvorlage  eingelangt am 23.12.2008
 123 eingetragen am 07.04.2009                  Geschäftsfall  71 Fr  4335/09 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.04.2009
 124 eingetragen am 16.05.2009                  Geschäftsfall  71 Fr  6076/09 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.05.2009
 126 eingetragen am 03.07.2009                  Geschäftsfall  71 Fr  8155/09 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.06.2009
 127 eingetragen am 11.07.2009                  Geschäftsfall  71 Fr  8561/09 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.07.2009
 128 eingetragen am 22.09.2009                  Geschäftsfall  71 Fr 11849/09 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.09.2009
 129 eingetragen am 23.12.2009                  Geschäftsfall  71 Fr 16770/09 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.12.2009
 130 eingetragen am 30.01.2010                  Geschäftsfall  71 Fr   930/10 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.01.2010
 133 eingetragen am 03.06.2010                  Geschäftsfall  71 Fr  5509/10 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.05.2010
 136 eingetragen am 09.11.2010                  Geschäftsfall  71 Fr 11718/10 p
       Berichtigung - Antrag  eingelangt am 27.10.2010
 137 eingetragen am 11.11.2010                  Geschäftsfall  71 Fr 11954/10 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.11.2010

 

 

Real estate

 

Real estate text:

No real estate property registered

 

 

Private data

 

 

Surname

 

 

Date of birth

 

 

Address

 

 

Executive positions

 

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Ulf Andersson

 

1966-01-19 

 

1100 Wien Wienerbergstraße 11(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Mag.  Bernd Dieter Buchberger

1965-08-19 

 

8793 Trofaiach Neubaugasse 40

 

joint signing clerk

 

3

 

Franz Buxbaum

 

1956-02-22 

 

2540 Bad Vöslau Anzengruberstraße 10

joint signing clerk

 

1

 

Mag.  Michael Csebits

 

1960-01-05 

 

2405 Bad Deutsch Altenburg Altenburgerstraße 2A

joint signing clerk

 

1

 

Bernhard Goliasch

1964-05-19 

1100 Wien Palisagasse 20

joint signing clerk

0

Dipl-Ing.  Ingo Gruber

1962-04-19 

9300 St. Veit Glan Rainweg 18

joint signing clerk

2

Gottfried Hofreither

1959-07-25 

2440 Moosbrunn Zehentgasse 24

joint signing clerk

0

Dipl-Ing.  Thomas Jakowiak

1972-04-08 

 

1100 Wien Wienerbergstraße 11(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Dipl-Ing.Mag.Dr.  Gerald Klenner

1965-04-21 

 

1190 Wien Gugitzgasse 3/5

 

joint signing clerk

 

0

 

Mag.  Gerlinde Celia Konrad

1967-10-05 

 

1030 Wien Metternichgasse 9

 

joint signing clerk

 

4

 

Mag.  Rainhard Mayer

1949-09-27 

1230 Wien Endresstraße 110

joint signing clerk

0

Mag.  Gabriele Pichler

1975-05-24 

3240 Mank Plainachergasse 7

joint signing clerk

2

Mag.  Barbara Potisk

1968-09-09 

1030 Wien Modecenterstraße 14

joint signing clerk

1

Dipl-Ing.  Holger Woltron

1964-12-19 

 

1100 Wien Wienerbergstraße 11(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Dr.  Giorgio Cappelli

1956-01-31 

20131 Milano Via Monteverdi 5

chairman of the executive board

2

Dr.  Manfred Hödl

 

1955-04-29 

 

2620 Natschbach Loipersbach Am Steig 6

member of the executive board

 

3

 

Henning Jensen

1960-08-16 

1100 Wien Wienerbergstraße 11

member of the executive board

2

Dr.jur.  Herbert Cordt

 

1947-01-12 

 

1010 Wien Seilerstätte 11 (c/o)

chairman of the supervisory board

 

10

 

Dipl-Ing.Dr.  Helmut Draxler

1950-04-25 

 

1010 Wien Singerstraße 8

 

deputy chairman of the supervisory board

 

4

 

 

Vorsitzender des Vorstandes

Dkfm.  Michael Gröller

1941-04-17 

1010 Wien Am Hof 11

deputy chairman of the supervisory board

24

Hubert Gorbach

1956-07-27 

6820 Frastanz Obere Lände 1

member of the supervisory board

2

Mag.  Martin Kowatsch

 

1972-02-04 

 

1100 Wien Wienerbergstraße 11(c/o)

member of the supervisory board

 

0

 

Dipl-Ing.  Leopold Miedl

1945-08-07 

1100 Wien Wienerstraße 11

member of the supervisory board

0

Dipl-Betriebsw.  Gerd Peskes

1944-12-26 

 

40479 Düsseldorf Inselstraße 20

member of the supervisory board

 

1

 

Roland Rabensteiner

1971-01-27 

8663 Veitsch Köhlersiedlung 3

member of the supervisory board

0

Franz Reiter

 

1962-01-25 

 

6020 Innsbruck Universitätsstraße 15(c/o)

member of the supervisory board

 

0

 

Prinz  Stanislaus Sayn-Wittgenstein Berleburg

1965-09-15 

 

81672 München Rosenheimerstraße 146 b(c/o)

member of the supervisory board

 

0

 

David Schlaff

 

1978-10-08 

 

1100 Wien Wienerbergstraße 11(c/o)

member of the supervisory board

 

0

 

Dipl-Betriebsw.  Peter Luef

  

 

1100 Wien Wienerbergstraße 11(c/o)

head of accounting

 

0

 

Ing.  Karl Astecker

 

  

 

1100 Wien Wienerbergstraße 11(c/o)

head of EDP

 

0

 

Ines Rodax

 

  

 

1100 Wien Wienerbergstraße 11(c/o)

head of personnel

 

0

 

 

 


Balance Sheet 

(absolute) all amounts in EUR 

 

 

2009-12-31 

Franchises, patents, licences, trademarks and similar rights and advantages

10.018.961,96

Sum intangible assets

10.018.961,96

 

 

Technical plants and machines

8.452.083,00

Advanced payments and constructions in progress

1.301.902,32

Sum tangible assets

11.045.641,32

 

 

Shares on related firms

590.673.365,67

Other shareholdings

10.970.164,37

Other loans

2.100.000,00

Reimbursement claim from life insurance

13.888.645,35

Other financial assets, values and securities of fixed assets

3.901.877,74

Sum financial assets

621.534.053,13

 

 

Sum fixed assets

642.598.656,41

 

 

Raw-, auxiliary materials and supplies

474.973,63

Outstanding service claims

2.544.091,47

Stocks

30.278.944,28

Sum stock

33.298.009,38

 

 

Claims from delivered goods and performed services

77.587.095,38

Other claims and assets

3.346.350,52

Claims against companies with shareholding relationship

3.940.432,26

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

446.901.307,58

Sum claims

531.775.185,74

 

 

Cash on hand, cheques and bank deposits

101.816.257,67

Sum cash and bank

101.816.257,67

 

 

Sum current assets

666.889.452,79

 

 

Deferred charges

39.804,56

Sum deferred charges

39.804,56

Assets

1.309.527.913,76

 

 

Subscribed/declared capital

289.376.212,84

Committed capital reserves

39.142.056,75

Balance sheet profit/balance sheet loss

242.278.688,73

Thereof profit/loss carried forward

268.179.548,68

Sum equity capital

570.796.958,32

 

 

Reservesfor severance pays

13.088.240,31

Reserves for pensions

27.575.184,56

Tax reserves

1.182.500,00

Other reserves

97.653.499,22

Sum reserves

139.499.424,09

 

 

Liabilities against credit institutes

321.744.835,41

Received advanced payments for orders

7.829.269,33

Liabilities from delivered goods and performed services from the acceptance of drafts and emission of promissory notes

12.803.697,76

Liabilities against related firms

243.389.299,30

Other liabilities

13.464.429,55

Sum liabilities

599.231.531,35

 

 

Liabilities

1.309.527.913,76

 

 

Contingent liabilities

65.224.485,66

Balance sheet sum

1.309.527.913,76

 

 

P / L Account 

(absolute) all amounts in EUR 

 

 

2009-12-31 

Gross sales 

846.518.343,55

Increase or decrease in finished and unfinished goods and in service claims 

-871.849,32

Sum turnover or sum gross profit 

845.646.494,23

 

 

Profits from retirement of fixed assets, except financial assets 

1.948,00

Income from dissolution of reserves 

9.585.448,93

Other operating profits 

43.139.617,68

Other operating profits totally 

52.727.014,61

 

 

Costs for obtained services 

-34.999,56

Special account material costs 

-628.648.747,50

Costs for obtained services totally 

-628.683.747,06

 

 

Wages 

-21.864,53

Salaries 

-45.075.961,45

Costs for severance pays 

-2.619.748,97

Costs for old age pension 

-2.503.993,01

Legal fringe benefits and other payments depending on salaries 

-10.844.907,58

Other social fringe benefits 

-1.582.159,01

Personnel expenses totally 

-62.648.634,55

 

 

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation 

-11.222.739,48

Depreciation tangible assets / intangible assets totally 

-11.222.739,48

 

 

Different operating costs 

-182.814.581,67

Other taxes 

-182.834,60

Other operating costs totally 

-182.997.416,27

 

 

Operating result totally 

12.820.971,48

 

 

Profits from shareholdings 

12.860.922,62

Interest income, securties income and similar income 

15.385.642,78

Profits from the retirement of and investment in financial assets 

97.459,62

Financial profits 

108.592,00

Interest and similar disbursements 

-19.164.704,71

Financial expenses 

-46.623.965,90

Financial profits totally 

-37.336.053,59

 

 

Results from usual business activity totally 

-24.515.082,11

 

 

Taxes on income and profits 

-1.385.777,84

Taxes on income and profits totally 

-1.385.777,84

Annual surplus/annual deficit totally 

-25.900.859,95

 

 

Annual profit/annual loss totally 

-25.900.859,95

 

 

Profit and loss carried forward from previous year 

268.179.548,68

Transfer of profits totally 

268.179.548,68

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account 

242.278.688,73

 

 

Key ratios

 

 

2009  

Cash flow II

  -14.678.120,47

Debt amortisation period

  -42,85

Bank indebtedness

  24,56

Equity capital share

  43,85

Social capital share

  3,10

Fixed assets coverage

  95,15

Net profit ratio

  -2,89

Capital turnover

  0,64

Return on investment

  -0,40

Cash flow in % of operating performance

  -1,73

Cash flow I

  -13.292.342,63

Gross productivity

  13,49

Net productivity

  3,46

Operating performance

  845.646.494,23

Inventories in % of operating performance

  3,93

Gross profit

  216.962.747,17

 

 

Locations

 

Type

Locations

Description

 

 

E-mail 

operational 

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

registered office, rented premises 

 

 

 

operational 

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

registered headquarters, rented premises 

 

 

info@rhi-ag.com

operational 

P.O. Box  143, A-1011 Wien

postbox 

 

 

 

operational 

Schoberpassbundesstraße  57, A-8784 Trieben, Werk Veitsch Radex

branch office 

 

 

 

operational 

Magnesitstrasse  2, A-8700 Leoben, Technologiezentrum

branch office, rented premises 

 

 

 

former 

Wienerbergstraße  11, A-1100 Wien

registered office 

 

 

 

former 

Mommsengasse  35, A-1040 Wien

registered office 

 

 

 

former 

Wienerbergstraße  11, A-1100 Wien

registered headquarters 

 

 

 

former 

Opernring  1, A-1010 Wien

office 

 

 

 

former 

Millstätterstraße  25, A-9545 Radenthein

office 

 

 

related companies

 

Company name

 

Postal code

 

Stake in %

 

 

 

Companies House

 

 

This company holds 100% of the shares in:

"VEITSCH-RADEX" Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

100 % 2002-05-09

 

 

FN 168287 g

 

Veitsch-Radex GmbH

 

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

100 % 2002-03-13

 

 

FN 219532 t

 

Veitscher Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

100 % 2002-05-01

 

 

FN 127094 d

 

Refractory Intellectual Property GmbH

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

100 % 2002-01-31

 

 

FN 218190 v

 

 

This company holds 50% to 99% of the shares in:

RHI Refractories Raw Material GmbH

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

99.8 % 1999-04-10

 

 

FN 138973 y

 

 

This company holds less than 50% of the shares in:

Kompetenz- und Informationszentrum für Humanvermögen und interdisziplinäre Arbeits- und Unternehmensforschung GmbH

Kierlingerstraße  87, A-3400 Klosterneuburg

8.89 % 2003-10-10

 

 

 

FN 240485 f

 

 

Affiliated companies and further participations:

Refractory Intellectual Property GmbH & Co KG

Wienerbergstraße  11, A-1100 Wien

2002-03-15

 

720.797

FN 219265 z

 

Veitsch-Radex GmbH & Co OG

 

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

2002-05-08

 

 

FN 221994 m

 

 

 

Bankers

 

Banker

Bank sort code

Type of banking connection

The Royal Bank of Scotland N.V., 1011 Wien

 

19985

 

main bank connection

 

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, 1011 Wien

 

20111

 

main bank connection

 

UniCredit Bank Austria AG, 1011 Wien

 

20151

 

main bank connection

 

BKS Bank AG, 9010 Klagenfurt

 

17000

 

secondary banking connection

 

Raiffeisen Bank International AG, 1011 Wien

 

31000

 

secondary banking connection

 

 

 

Historical development

 

Year of incorporation:

1976

Date of registration:

1979-12-18

 

Change in share capital:

From

To

Capital

   

  1999-08-09

ATS  1.392.003.900,00

  1999-08-09

  1999-10-18

EUR  101.160.868,59

  1999-10-18

  2003-09-25

EUR  144.764.569,09

  2003-09-25

  2003-12-24

EUR  145.364.119,97

  2003-12-24

  2004-03-24

EUR  145.723.850,50

  2004-03-24

  2004-06-24

EUR  145.803.790,62

  2004-06-24

  2004-09-24

EUR  146.523.251,68

  2004-09-24

  2004-12-18

EUR  158.873.999,85

  2004-12-18

  2005-03-19

EUR  159.753.341,14

  2005-03-19

  2005-06-28

EUR  166.947.951,72

  2005-06-28

  2005-09-24

EUR  167.387.622,16

  2005-09-24

  2005-12-21

EUR  188.491.803,28

  2005-12-21

  2006-03-25

EUR  189.531.024,32

  2006-03-25

  2006-06-30

EUR  193.328.178,12

  2006-06-30

  2006-09-22

EUR  195.646.440,44

  2006-09-22

  2006-12-21

EUR  196.805.571,60

  2006-12-21

  2007-03-28

EUR  212.074.126,88

  2007-03-28

  2007-03-30

EUR  235.976.219,65

  2007-03-30

  2007-06-26

EUR  237.295.231,46

  2007-06-26

  2007-06-27

EUR  271.909.298,91

  2007-06-27

  2007-09-15

EUR  271.989.239,02

  2007-09-15

  2007-12-20

EUR  272.109.149,18

  2007-12-20

  2007-12-22

EUR  272.189.089,29

  2007-12-22

  2008-05-19

EUR  272.348.969,51

  2008-05-19

  2008-09-24

EUR  272.548.819,78

  2008-09-24

  2009-01-09

EUR  274.827.112,90

  2009-01-09

  2009-09-22

EUR  275.626.514,00

  2009-09-22

  2009-12-23

EUR  276.665.735,42

  2009-12-23

   

EUR  289.376.212,84

 

Former executives:

From

To

Function

Name

  2001-06-22

  2005-01-25

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Stefan Wallner 

  2005-01-21

  2006-01-27

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Björn Karlsson 

  2001-05-24

  2007-02-07

joint signing clerk 

Dr. Giorgio Cappelli 

  2001-05-24

  2007-02-07

joint signing clerk 

Dr. Manfred Hödl 

  2000-12-29

  2007-06-16

joint signing clerk 

Dkfm. Markus Richter 

  1999-02-09

  2007-07-04

joint signing clerk 

Mag. Rudolf Payer 

  1998-01-30

  2008-05-16

joint signing clerk 

Mag. Andreas Bier 

  2006-07-08

  2009-04-07

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Claus Braunhuber 

  2001-06-22

  2009-04-07

joint signing clerk 

Dipl-Ing.Dr. Stefan Pirker 

  2000-05-17

  2009-04-07

joint signing clerk 

Dr. Robin Schmidt Whitley 

  2001-05-24

  2009-07-03

joint signing clerk 

Juan Alvarez 

  2008-05-16

  2009-07-03

joint signing clerk 

Mag. Martin Bartmann 

  2001-06-22

  2009-07-03

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Klaus Dösinger 

  2001-05-24

  2009-07-03

joint signing clerk 

Mag. Josef Leitgeb 

  2006-07-08

  2009-07-03

joint signing clerk 

Dr. Dieter Siegel 

  2005-01-21

  2009-07-03

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Max Taferner 

  2008-01-17

  2009-12-23

joint signing clerk 

Mag. Johann Diwald 

  2004-01-21

  2010-04-27

joint signing clerk 

Mag. Andreas Berger 

  2009-07-03

  2010-09-08

joint signing clerk 

Dipl-Betriebsw. Robert Gregan 

  2009-07-03

  2010-09-08

joint signing clerk 

Dipl-Betriebsw. Ernst Stoelzel 

   

  1999-07-22

chairman of the executive board 

Dr. Walter Ressler 

  1999-07-22

  2002-01-16

chairman of the executive board 

Dr. Georg Obermeier 

  2002-01-14

  2007-01-20

chairman of the executive board 

Dipl-Ing.Dr. Helmut Draxler 

  2007-01-20

  2009-01-17

chairman of the executive board 

Dipl-Ing.Dr. Andreas Meier 

  2009-01-17

  2010-10-23

chairman of the executive board 

Dipl-Betriebsw. Thomas Michael Fahnemann 

  2002-01-18

  2007-01-20

deputy chairman of the executive board 

Dipl-Ing.Dr. Andreas Meier 

  2007-01-20

  2007-07-04

deputy chairman of the executive board 

Mag.Dr. Eduard Zehetner 

  2007-07-04

  2009-06-17

deputy chairman of the executive board 

Dr. Stefano Colombo 

   

  1998-01-30

member of the executive board 

Mag. Hans Jörg Kaltenbrunner 

   

  1999-02-09

member of the executive board 

Dipl-Ing.Dr. Günther Mörtl 

   

  2000-01-21

member of the executive board 

Rudolf Kanzi 

  1999-02-09

  2001-05-31

member of the executive board 

Dipl-Ing. Jakob Mosser 

  1999-02-09

  2002-01-16

member of the executive board 

Dipl-Ing.Dr. Andreas Meier 

  1997-07-04

  1997-11-05

member of the supervisory board 

Ferdinand Lacina 

   

  1998-01-30

member of the supervisory board 

Dr. Andreas Foglar Deinhardstein 

   

  1999-05-06

member of the supervisory board 

Dkfm. Gerhard Randa 

  2002-03-01

  2002-10-03

member of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Friedrich Nemec 

   

  1999-07-22

member of the supervisory board 

Andreas Huiskamp 

   

  1999-07-22

member of the supervisory board 

Hellmuth Wandschneider 

   

  2001-07-06

member of the supervisory board 

Max Deitcher 

  1999-07-22

  2001-09-12

member of the supervisory board 

Dr. Erich Hampel 

  1999-07-22

  2001-10-19

member of the supervisory board 

DDr. Erhard Schaschl 

  1998-06-25

  2001-10-26

member of the supervisory board 

Mag. Andreas Treichl 

  2002-03-01

  2004-07-03

member of the supervisory board 

Dr. Walter Ressler 

  2004-07-03

  2005-08-23

member of the supervisory board 

August Francois von Finck 

  1995-08-22

  2005-09-03

member of the supervisory board 

Dipl-Ing. Maximilian Ardelt 

  2004-12-07

  2005-10-04

member of the supervisory board 

Ing. Günther Lippitsch 

  2001-11-27

  2007-07-31

member of the supervisory board 

DDr. Erhard Schaschl 

  2006-07-14

  2007-07-31

member of the supervisory board 

Dr. Kurt Waniek 

  1999-07-22

  2002-03-01

member of the supervisory board 

Dipl-Betriebsw. Gerd Peskes 

  1993-12-01

  2008-02-06

employee's representative on the supervisory board 

Josef Horn 

  2002-01-18

  2002-04-08

member of the executive board 

Dipl-Ing.Dr. Andreas Meier 

  1999-02-16

  2003-05-06

member of the executive board 

Mag. Roland Platzer 

  2002-01-16

  2007-01-20

member of the executive board 

Mag.Dr. Eduard Zehetner 

  2007-07-04

  2010-04-01

member of the executive board 

Mag. Rudolf Payer 

  2007-01-04

  2010-10-23

member of the executive board 

Dr. Giorgio Cappelli 

   

  1997-07-04

chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing. Hellmut Friedrich Longin 

  1995-08-22

  1999-07-22

chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Friedrich Nemec 

  1999-07-22

  2002-03-01

chairman of the supervisory board 

Dr. Walter Ressler 

  2002-03-01

  2002-06-06

chairman of the supervisory board 

Dipl-Betriebsw. Gerd Peskes 

  2002-06-06

  2010-06-03

chairman of the supervisory board 

Dkfm. Michael Gröller 

   

  1997-07-04

deputy chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Friedrich Nemec 

  1998-01-30

  1999-07-22

deputy chairman of the supervisory board 

Dr. Andreas Foglar Deinhardstein 

  2001-10-19

  2001-11-27

deputy chairman of the supervisory board 

DDr. Erhard Schaschl 

  1999-07-22

  2002-03-01

deputy chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Friedrich Nemec 

  2002-03-01

  2002-06-06

deputy chairman of the supervisory board 

Dkfm. Michael Gröller 

  2002-06-06

  2007-10-03

deputy chairman of the supervisory board 

Dipl-Betriebsw. Gerd Peskes 

  2007-11-03

  2008-09-11

deputy chairman of the supervisory board 

Dr.jur. Herbert Cordt 

  2007-10-03

  2010-06-03

deputy chairman of the supervisory board 

Dr.jur. Herbert Cordt 

   

  1997-04-25

joint signing clerk 

Dr. Franz Aust 

   

  1998-08-07

joint signing clerk 

Günther Pacher 

   

  1998-11-24

joint signing clerk 

Ing.Mag. Johannes Elsner 

   

  1999-02-09

joint signing clerk 

Mag. Roland Platzer 

   

  1999-05-06

joint signing clerk 

Rosa Maria Lesacher 

  1999-02-09

  2000-01-28

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Gerd Janitschek 

  1998-01-30

  2000-12-29

joint signing clerk 

Mag. Peter Hofmann 

  1999-02-09

  2000-12-29

joint signing clerk 

Dr. Peter Podesser 

  2000-05-17

  2001-05-31

joint signing clerk 

Dr. Robin Schmidt Whitley 

  1999-02-09

  2001-06-22

joint signing clerk 

Mag. Gabriel Faimann 

  1999-02-09

  2001-06-22

joint signing clerk 

Dr. Günter Karhut 

  2001-05-24

  2001-08-01

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Edmar Allitsch 

  2001-05-24

  2001-08-01

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Viktor Fischer 

  1999-02-09

  2001-10-18

joint signing clerk 

Mag. Norbert Wittmann 

  1999-02-09

  2002-07-26

joint signing clerk 

Mag. Ronald Elgert 

  1999-02-09

  2002-07-26

joint signing clerk 

Fritz Friedrich 

  2002-07-30

  2002-11-12

joint signing clerk 

Mag. Norbert Wittmann 

  1994-12-02

  2003-02-08

joint signing clerk 

Dr. Georg Gerhardt 

  1999-02-09

  2003-11-08

joint signing clerk 

Dr. Gerhard Kantusch 

  2002-10-03

  2007-10-03

member of the supervisory board 

Dr.jur. Cornelius Alexander Grupp 

  2002-03-01

  2007-11-03

member of the supervisory board 

Ing. Gerd Klaus Gregor 

  2007-07-31

  2008-05-19

member of the supervisory board 

Dr.jur. Herbert Cordt 

  2007-07-31

  2008-05-19

member of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Helmut Draxler 

  2007-07-31

  2008-09-11

member of the supervisory board 

Mark Eckhout 

  2001-09-12

  2009-05-16

member of the supervisory board 

Karl Wetzelhütter 

  2008-09-11

  2010-06-03

member of the supervisory board 

Dr. Ulrich Glaunach 

   

  1999-03-17

employee's representative on the supervisory board 

Helga Klement 

   

  2001-09-12

employee's representative on the supervisory board 

Karl Prettner 

  1993-07-03

  2004-12-07

employee's representative on the supervisory board 

Georg Eder 

 

Former shareholdings:

From

To

Name

   

 

Refractories Consulting & Engineering Gesellschaft m.b.H. in Liqu. 

  1998-04-22

  1999-02-26

Knauf Insulation GmbH 

  1995-12-22

  2001-03-27

VIAG Telecom Connect zweite Beteiligungs-GmbH 

  1999-03-05

  2001-05-19

VRD Asia Pacific Feuerfestbeteiligungen GmbH 

  2002-04-10

  2002-05-08

Veitsch-Radex Betriebs GmbH 

  2002-02-28

  2002-12-20

MAGNIFIN Magnesiaprodukte Gesellschaft m.b.H. 

  1999-10-15

  2003-02-06

Knauf Insulation GmbH 

  2002-04-30

  2003-12-11

Radex Vertriebsgesellschaft m.b.H. 

  2002-05-03

  2005-07-30

Radex Vertriebsgesellschaft m.b.H. 

  2002-11-23

  2010-09-18

MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH 

  2002-12-20

  2010-10-19

MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH & Co KG 

   

 

Österreichische Magnesit Aktiengesellschaft in Liquidation 

   

 

RHI Refractories Raw Material GmbH 

   

 

Heraklith AG 

 

Mergers:

Date

Function

Name

  2005-03-22

merged with 

Veitsch-Radex Aktiengesellschaft für feuerfeste Erzeugnisse 

  2001-05-28

merged with 

VRD Asia Pacific Feuerfestbeteiligungen GmbH 

  2000-12-01

merged with 

Heraklith AG 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.44.59

UK Pound

1

Rs.71.62

Euro

1

Rs.62.78

 

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

 

 

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.