MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

02.03.2011

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

BOREALIS AGROLINZ MELAMINE GMBH

 

 

Registered Office :

St. Peterstraße  25, A-4021 Linz

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

31.12.2009

 

 

Date of Incorporation :

26.09.1991

 

 

Legal Form :

Limited Liability Company

 

 

Line of Business :

Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

A

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

Fairly Large

 

Maximum Credit Limit :

EUR  5.814.000,00

Status :

Good

Payment Behaviour :

Usually Correct

Litigation :

Clear

 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – December 31, 2010

 

Country Name

Previous Rating

                   (30.09.2010)                  

Current Rating

(31.12.2010)

Austria

a2

a2

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 

Basic company information

 

Last up-date:

2011-02-28

Company name:

Borealis Agrolinz Melamine GmbH

Status:

active company

Locations:

St. Peterstraße  25, A-4021 Linz

Phone:

0043 (732) 6914

Fax:

0043 (732) 6914 - 3581

E-mail:

agrolinz.melamin@agrolinz.com

Internet:

http://www.agrolinz.com

Activities:

Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds

 

Wholesale of chemical products

 

General Assessment:

 

The Rating of this company is better than industry average.

 

Recommendation

We recommends to establish a business and credit relationship, and to benefit from arising business opportunities.

 

Detail Assessment:

Group's payments are made within net agreements.

 

Company is part of a group and therefore cannot be evaluated separately. Financial situation in the group is in order.

 

Maximum credit EUR  5.814.000,00

 

 

Additional company information

 

Year of incorporation:

1939

 

Type of company:

Manufacturing

 

Legal form:

limited liability company since 1991-09-02

 

companies' house number:

FN 78587 w Linz 1991-09-26

 

Activities:

 

 

VAT number:

ATU 23057607

 

number - Austrian National Bank:

1676423

 

Import 

Country 

 

 

 

Import

Morocco

 

2011

 

Import

European Union

 

2011

 

 

 

Export 

Country 

 

 

 

Export

world-wide

 

2011

 

 


Financial data

 

total turnover (total sales)

2010

EUR  306.000.000,00

(estimated)

total turnover (total sales)

2009

EUR  305.189.893,92

(exact)

total turnover (total sales)

2008

EUR  526.373.262,78

(exact)

total turnover (total sales)

2007

EUR  328.979.291,65

(exact)

total turnover (total sales)

2006

EUR  362.885.571,03

(exact)

total employees

2011

769

(approx.)

 

 

Extraxt from the Companies' House

 

firm (style):

   71      Borealis Agrolinz Melamine GmbH

legal form:

    1      Gesellschaft mit beschränkter Haftung

registered office:

    1      politischer Gemeinde Linz

business adress:

    1      St. Peter-Str. 25
           4020 Linz

capital:

   26      EUR 70.000.000

reference date annual accounts:

    1      31. Dezember

annual accounts:

   74      zum 31.12.2009 eingereicht am 23.06.2010

consolidated accounts:

   59      zum 31.12.2006 eingereicht am 18.06.2007

power of representation:

1      Bei Geschäftsführermehrheit wird die Gesellschaft durch je
           zwei Geschäftsführer oder einem Geschäftsführer gemeinsam
           mit einem Prokuristen vertreten, soferne nicht durch Be-
           schluß der Gesellschafter eine andere Vertretungsbefugnis
           bestimmt wird.
    1   Gesellschaftsvertrag  vom 02.09.1991                                001
    1   Die Gesellschaft ist durch Umwandlung der "CHEMIE HOLDING           002
          AKTIENGESELLSCHAFT" entstanden.
    1   Verschmelzungsvertrag  vom 26.09.1991                               003
    1   Generalversammlungsbeschluss  vom 26.09.1991                        004
          Diese Gesellschaft wurde als
          übernehmende Gesellschaft mit der
          Chemie Linz Gesellschaft m.b.H.
          als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
          Sitz der übertragenden Gesellschaft in Linz.
    1   Generalversammlungsbeschluss  vom 26.09.1991                        005
          Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
    1   Verschmelzungsvertrag  vom 07.05.1992                               006
    1   Generalversammlungsbeschluss  vom 07.05.1992                        007
          Diese Gesellschaft wurde als
          übernehmende Gesellschaft mit der
          META-Chemie Gesellschaft mit be-
          schränkter Haftung
          als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
          Sitz der übertragenden Gesellschaft in Enns.
    1   Verschmelzungsvertrag  vom 27.09.1993                               008
    1   Generalversammlungsbeschluss  vom 27.09.1993                        009
          Diese Gesellschaft wurde als
          übernehmende Gesellschaft mit der
          Chemserv Industrie Service
          Gesellschaft m.b.H.
          als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
          Sitz der übertragenden Gesellschaft in Linz.
    1   Verschmelzungsvertrag  vom 28.09.1993                               010
    1   Generalversammlungsbeschluss  vom 28.09.1993                        011
          Diese Gesellschaft wurde als
          übernehmende Gesellschaft mit der
          Agrolinz Agrarchemikalien
          Gesellschaft m.b.H.
          als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
          Sitz der übertragenden Gesellschaft in Linz.
    3   Sacheinlagevertrag vom 14.03.1994                                   012
          Einbringung des Teilbetriebes "Feinchemie" als Sacheinlage
          in die Chemie Linz Chemikalien Gesellschaft m.b.H., Linz
          (FN 69745 t, LG Linz), künftig: Chemie Linz GmbH
    3   Generalversammlungsbeschluss  vom 14.03.1994                        013
          Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (1).
    3   Generalversammlungsbeschluss  vom 14.03.1994                        014
          Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (1).
    4   Sacheinlagevertrag vom 01.04.1994                                   015
          Einbringung des Teilbetriebes "Technik" in die

              Chemserv Industrie Service Gesellschaft m.b.H., Linz
          (FN 68550 i LG Linz)
   10   Einbringung des Teilbetriebes "Pflanzenschutz" in die               016
          NUFARM Pflanzenschutz GmbH & Co.KG, FN 134778 d.
   13   Verschmelzungsvertrag  vom 25.09.1996                               017
   13   Generalversammlungsbeschluss  vom 25.09.1996                        018
          Diese Gesellschaft wurde als
          übernehmende Gesellschaft mit der
          Agrarchemikalien Gesellschaft m.b.H.
          (FN 56139 h)
          als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
          Sitz der übertragenden Gesellschaft in Linz.
   13   Verschmelzungsvertrag  vom 25.09.1996                               019
   13   Generalversammlungsbeschluss  vom 25.09.1996                        020
          Diese Gesellschaft wurde als
          übernehmende Gesellschaft mit der
          Hermann Oder Geschäftsführungs-
          gesellschaft m.b.H.
          (FN 79788 k)
          als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
          Sitz der übertragenden Gesellschaft in Linz.
   26   Gesellschaftsvertrag mit Generalversammlungsbeschluss               021
          vom 07.09.2000
          gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.
   26   Generalversammlungsbeschluss  vom 07.09.2000                        022
          Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 597.443,37.
          Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
   44   Generalversammlungsbeschluss  vom 08.09.2003                        023
          Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (1).
   50   Generalversammlungsbeschluss  vom 04.08.2005                        024
          Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
   67   Gesellschafterbeschluss  vom 08.08.2008                             025
          Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Punkten 2., 7.,
          10., 11., 13., 14., 17. und 18.
   71   Generalversammlungsbeschluss  vom 19.06.2009                        026
          Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt 1.

proxy:

        AR   Mag. Dietmar Remplbauer, geb. 13.09.1962
   33        vertritt seit 01.02.2002 gemeinsam mit
             einem kollektivvertretungsbefugten Geschäftsführer oder
             einem weiteren Gesamtprokuristen
        AW   DI Dr. Gerald Papst, MBA, geb. 29.10.1964
   45        vertritt seit 01.01.2004 gemeinsam mit
             einem kollektivvertretungsbefugten Geschäftsführer oder
             einem weiteren Gesamtprokuristen
        BI   DI (FH) Rainer Höfling, geb. 15.05.1965
   63        vertritt seit 23.11.2007 gemeinsam mit
             einem weiteren Gesamtprokuristen
        BM   Herwig Ertel, geb. 26.03.1962
   65        vertritt seit 14.02.2008 gemeinsam mit
             einem weiteren Gesamtprokuristen
        BN   Wolfgang Haider, geb. 23.11.1959
   68        vertritt seit 26.08.2008 gemeinsam mit
             einem weiteren Gesamtprokuristen
        BQ   Mag. Dr. Norbert Kehrer, geb. 19.07.1966
   72        vertritt seit 01.10.2009 gemeinsam mit
             einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer oder
             einem weiteren Gesamtprokuristen
        BR   Dr. Christian Schatz, geb. 30.07.1970
   72        vertritt seit 01.10.2009 gemeinsam mit
             einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer oder
             einem weiteren Gesamtprokuristen

supervisory board:

         Y   Karl Leonhartsberger, geb. 28.07.1954
    4        Mitglied
        AG   Christian Kempinger, geb. 04.06.1961
   56        Mitglied
        BK   Herbert Willerth, geb. 22.03.1950
   69        Vorsitzender
        BS   Gerd Löbbert, geb. 17.08.1957
   73        Stellvertreter des Vorsitzenden
        BT   Katja Tautscher, geb. 02.01.1972
   75        Mitglied
        BU   Markku Korvenranta, geb. 26.01.1966
   75        Mitglied

managing director:

        BD   Hubert Puchner, geb. 22.02.1954
   69        vertritt seit 25.02.2009 selbständig

shareholder:

        BE   Borealis AG
   60        ...................  EUR 70.000.000
   60        ..............................................  EUR 70.000.000
                        -------------------------------------------------------
                 Summen:          EUR 70.000.000             EUR 70.000.000

general table:

 Landesgericht Linz
   1 Ersterfassung abgeschlossen am 10.02.1994  Geschäftsfall 913 Fr   187/94 s
       Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
   3 eingetragen am 19.03.1994                  Geschäftsfall  17 Fr   406/94 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.03.1994
   4 eingetragen am 01.06.1994                  Geschäftsfall  17 Fr  1430/94 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.05.1994
     eingetragen am 01.06.1994                  Geschäftsfall  17 Fr  1595/94 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.05.1994
   7 eingetragen am 20.12.1994                  Geschäftsfall  17 Fr  5670/94 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.12.1994
  10 eingetragen am 11.07.1995                  Geschäftsfall  12 Fr  2886/95 v
       amtswegige Nachbearbeitung
     eingetragen am 11.07.1995                  Geschäftsfall  12 Fr  2896/95 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.07.1995
  13 eingetragen am 09.11.1996                  Geschäftsfall  12 Fr  5189/96 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.09.1996
     eingetragen am 09.11.1996                  Geschäftsfall  12 Fr  5190/96 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.09.1996
  26 eingetragen am 19.10.2000                  Geschäftsfall  13 Fr  3466/00 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.09.2000
  33 eingetragen am 24.05.2002                  Geschäftsfall  13 Fr  2178/02 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 15.05.2002
  44 eingetragen am 02.10.2003                  Geschäftsfall  13 Fr  3517/03 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.09.2003
  45 eingetragen am 04.02.2004                  Geschäftsfall  13 Fr   327/04 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.01.2004
  50 eingetragen am 23.08.2005                  Geschäftsfall  13 Fr  4201/05 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.08.2005
  55 eingetragen am 19.01.2007                  Geschäftsfall  13 Fr   212/07 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.01.2007
  56 eingetragen am 08.02.2007                  Geschäftsfall  13 Fr   115/07 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.01.2007
  59 eingetragen am 07.07.2007                  Geschäftsfall  13 Fr  2537/07 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.06.2007
  60 eingetragen am 25.09.2007                  Geschäftsfall  13 Fr  3593/07 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 27.08.2007
  63 eingetragen am 28.12.2007                  Geschäftsfall  13 Fr  7153/07 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.12.2007
  64 eingetragen am 07.03.2008                  Geschäftsfall  13 Fr  1079/08 a
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 27.02.2008
  65 eingetragen am 05.04.2008                  Geschäftsfall  13 Fr  1553/08 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.04.2008
  67 eingetragen am 26.09.2008                  Geschäftsfall  13 Fr  3580/08 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.08.2008
  68 eingetragen am 03.01.2009                  Geschäftsfall  13 Fr  7424/08 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.12.2008
  69 eingetragen am 27.03.2009                  Geschäftsfall  13 Fr  1201/09 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.03.2009
  71 eingetragen am 07.07.2009                  Geschäftsfall  13 Fr  2634/09 x
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.06.2009
  72 eingetragen am 14.11.2009                  Geschäftsfall  13 Fr  6312/09 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.11.2009
  73 eingetragen am 06.02.2010                  Geschäftsfall  13 Fr   322/10 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.01.2010
  74 eingetragen am 24.06.2010                  Geschäftsfall  13 Fr  2806/10 h
       Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 23.06.2010
  75 eingetragen am 19.11.2010                  Geschäftsfall  13 Fr  6585/10 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.11.2010

 


Real estate

 

Real estate text:

No real estate property registered

 

 

Private data

 

 

Surname

 

 

Date of birth

 

 

Address

 

 

Executive positions

 

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Hubert Puchner

 

1954-02-22 

 

2323 Schwechat Mannswörth Danubiastraße 21-25 (c/o)

manager

 

0

 

Dr.  Herwig Ertel

1962-03-26 

4064 Oftering Oberndorf 3

joint signing clerk

1

Wolfgang Haider

1959-11-23 

2320 Schwechat Mailergasse 3

joint signing clerk

1

Dipl-Ing.  Rainer Höfling

1965-05-15 

 

4400 Steyr Gregor Goldbachstraße 56b

joint signing clerk

 

0

 

Mag.Dr.  Norbert Kehrer

 

1966-07-19 

 

4020 Linz St. Peterstraße 25(c/o)

joint signing clerk

 

1

 

Dipl-Ing.Dr.  Gerald Papst

1964-10-29 

 

1140 Wien Hütteldorferstraße 343

joint signing clerk

 

1

 

Mag.  Dietmar Remplbauer

1962-09-13 

 

4020 Linz St. Peterstraße 25(c/o)

joint signing clerk

 

1

 

Dr.  Christian Schatz

 

1970-07-30 

 

4030 Linz Zeppelinstraße 24(c/o)

joint signing clerk

 

1

 

KR  Herbert Willerth

 

1950-03-22 

 

2331 Vösendorf Fischerstraße 92

chairman of the supervisory board

 

2

 

Gerd Löbbert

1957-08-17 

1220 Wien Wagramerstraße 17-19

deputy chairman of the supervisory board

1

Christian Kempinger

 

1961-06-04 

 

4020 Linz St. Peterstraße 25 (c/o)

member of the supervisory board

 

0

 

Markuu Korvenranta

 

1966-01-26 

 

4021 Linz St. Peterstraße 25(c/o)

member of the supervisory board

 

0

 

Karl Leonhartsberger

 

1954-07-28 

 

1030 Wien Landstraßer Hauptstraße 26 (c/o)

member of the supervisory board

 

1

 

Mag.  Katja Tautscher

 

1972-01-02 

 

1220 Wien Wagramerstraße 17-19(c/o)

member of the supervisory board

 

2

 

Dr.  Norbert Kehrer

 

  

 

4021 Linz St. Peterstraße 25(c/o)

head of accounting

 

0

 

Dipl-Ing.  Rainer Höfling

  

 

4021 Linz St. Peterstraße 25(c/o)

head of marketing

 

0

 

 

 

Balance Sheet 

(absolute) all amounts in EUR 

 

 

2009-12-31 

 

 

 

 

Franchises, patents, licences, trademarks and similar rights and advantages

1.127.649,00

 

 

 

 

Sum intangible assets

1.127.649,00

 

 

 

 

 

Land and leasehold rights with buildings thereon including building on land owned by third parties

35.444.040,15

 

 

 

 

Technical plants and machines

89.758.862,20

 

 

 

 

Advanced payments and constructions in progress

1.364.341,14

 

 

 

 

Sum tangible assets

139.186.902,84

 

 

 

 

 

Shares on related firms

52.971.918,31

 

 

 

 

Other shareholdings

142.500,00

 

 

 

 

Other financial assets, values and securities of fixed assets

6.307.393,63

 

 

 

 

Sum financial assets

59.421.811,94

 

 

 

 

 

Sum fixed assets

199.736.363,78

 

 

 

 

 

Raw-, auxiliary materials and supplies

15.250.033,02

 

 

 

 

Unfinished products

2.165.386,88

 

 

 

 

Finished products

17.528.381,18

 

 

 

 

Merchandise

71.436,31

 

 

 

 

Outstanding service claims

296.930,70

 

 

 

 

Sum stock

35.312.168,09

 

 

 

 

 

Claims from delivered goods and performed services

12.171.737,83

 

 

 

 

Other claims and assets

15.406.701,12

 

 

 

 

Claims against companies with shareholding relationship

468.952,08

 

 

 

 

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

70.641.804,38

 

 

 

 

Sum claims

98.689.195,41

 

 

 

 

 

Cash on hand, cheques and bank deposits

511.080,63

 

 

 

 

Sum cash and bank

511.080,63

 

 

 

 

 

Sum current assets

134.512.444,13

 

 

 

 

 

Deferred charges

13.908.719,04

 

 

 

 

Sum deferred charges

13.908.719,04

 

 

 

 

Assets

348.157.526,95

 

 

 

 

 

Subscribed/declared capital

70.000.000,00

 

 

 

 

Committed capital reserves

7.006.209,06

 

 

 

 

Free reserves

5.866.702,72

 

 

 

 

Balance sheet profit/balance sheet loss

-4.150.235,87

 

 

 

 

Thereof profit/loss carried forward

20.063.248,68

 

 

 

 

Sum equity capital

78.722.675,91

 

 

 

 

 

Valuation reserves due to special depreciations and

17.738.449,36

 

 

 

 

Sum reserves before taxes

17.738.449,36

 

 

 

 

 

Reservesfor severance pays

13.885.790,00

 

 

 

 

Reserves for pensions

15.417.670,00

 

 

 

 

Other reserves

8.509.243,87

 

 

 

 

Sum reserves

37.812.703,87

 

 

 

 

 

Liabilities against credit institutes

97.093.892,76

 

 

 

 

Liabilities from delivered goods and performed services from the acceptance of drafts and emission of promissory notes

46.224.813,76

 

 

 

 

Liabilities against related firms

60.816.516,53

 

 

 

 

Other liabilities

8.240.747,12

 

 

 

 

Sum liabilities

212.375.970,17

 

 

 

 

 

Deferred income

1.507.727,64

 

 

 

 

Sum deferred income

1.507.727,64

 

 

 

 

Liabilities

348.157.526,95

 

 

 

 

 

Contingent liabilities

23.060.338,00

 

 

 

 

Balance sheet sum

348.157.526,95

 

 

 

 

 

 

P / L Account 

(Absolute) all amounts in EUR 

 

 

 

2009-12-31 

 

 

 

 

Gross sales 

305.189.893,92

 

 

 

 

Sales reductions 

-4.070.093,09

 

 

 

 

Sum turnover or sum gross profit 

301.119.800,83

 

 

 

 

 

Profits from retirement of fixed assets, except financial assets 

18.883,02

 

 

 

 

Income from dissolution of reserves 

332.765,22

 

 

 

 

Other operating profits 

14.853.931,50

 

 

 

 

Other operating profits totally 

15.205.579,74

 

 

 

 

 

Different operating costs 

-6.461.567,68

 

 

 

 

Production costs of the services performed for the sales 

-295.300.228,37

 

 

 

 

Marketing costs 

-22.185.361,81

 

 

 

 

Administration costs 

-5.357.077,79

 

 

 

 

Other operating costs totally 

-329.304.235,65

 

 

 

 

 

Operating result totally 

-12.978.855,08

 

 

 

 

 

Profits from shareholdings 

3.000.000,00

 

 

 

 

Income from other securities and loans of financial assets 

258.482,83

 

 

 

 

Interest income, securties income and similar income 

984.981,94

 

 

 

 

Income from the retirement of other financial assets 

900.000,00

 

 

 

 

Interest and similar disbursements 

-6.621.523,67

 

 

 

 

Financial expenses 

-8.051.131,73

 

 

 

 

Financial profits totally 

-9.529.190,63

 

 

 

 

 

Results from usual business activity totally 

-22.508.045,71

 

 

 

 

 

Taxes on income and profits 

-2.949.371,84

 

 

 

 

Taxes on income and profits totally 

-2.949.371,84

 

 

 

 

Annual surplus/annual deficit totally 

-25.457.417,55

 

 

 

 

 

Dissolution reserves before taxes 

1.243.933,00

 

 

 

 

Reserves movements totally 

1.243.933,00

 

 

 

 

Annual profit/annual loss totally 

-24.213.484,55

 

 

 

 

 

Profit and loss carried forward from previous year 

20.063.248,68

 

 

 

 

Transfer of profits totally 

20.063.248,68

 

 

 

 

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account 

-4.150.235,87

 

 

 

 

 

 

Key ratios

 

 

2009  

Cash flow II

  -25.457.417,55

Debt amortisation period

  -9,80

Bank indebtedness

  27,88

Equity capital share

  27,70

Social capital share

  8,41

Fixed assets coverage

  62,96

Net profit ratio

  -7,47

Capital turnover

  0,86

Return on investment

  -4,56

Cash flow in % of operating performance

  -8,45

Cash flow I

  -22.508.045,71

Gross productivity

  0,00

Net productivity

  0,00

Operating performance

  301.119.800,83

Inventories in % of operating performance

  11,72

Gross profit

  301.119.800,83

 

Locations

 

Type

Locations

Description

 

 

E-mail 

operational 

St. Peterstraße  25, A-4020 Linz

registered office 

 

 

 

operational 

St. Peterstraße  25, A-4021 Linz

registered headquarters 

 

 

agrolinz.melamin@agrolinz.com

operational 

PF  21, A-4021 Linz

postbox 

 

 

related companies

 

Company name

 

Postal code

 

Stake in %

 

 

Companies House

 

Shares in this company are held by:

Borealis AG

 

Wagramerstraße  17-19, A-1220 Wien

100 % 2007-09-25

 

 

FN 269858 a

 

 

This company holds 100% of the shares in:

LINZER AGRO TRADE GmbH

 

St. Peterstraße  25, A-4020 Linz

100 % 2005-01-25

 

 

FN 257746 p

 

 

This company holds less than 50% of the shares in:

Chemiepark Linz Betriebsfeuerwehr GmbH

St. Peterstraße  25, A-4021 Linz

47.5 % 1999-02-03

 

 

FN 178148 h

 

 

Affiliated companies and further participations:

Borealis Polyolefine GmbH

 

Danubiastraße  21-25, A-2320 Schwechat Mannswörth

 

 

 

FN 125430 g

 

 

 

Bankers

 

Banker

Bank sort code

Type of banking connection

The Royal Bank of Scotland N.V., 1011 Wien

 

19985

 

main bank connection

 

Raiffeisen Bank International AG, 1011 Wien

 

31000

 

main bank connection

 

UniCredit Bank Austria AG, 1011 Wien

 

20151

 

secondary banking connection

 

 

Historical development

 

Year of incorporation:

1939

Date of registration:

1991-09-26

 

Change of company name:

From

To

Company name

   

  2003-10-02

Agrolinz Melamin GmbH 

  2003-10-02

  2009-07-07

AMI Agrolinz Melamine International GmbH 

  2009-07-07

   

Borealis Agrolinz Melamine GmbH 

 

Change in share capital:

From

To

Capital

   

  2000-10-19

ATS  955.000.000,00

  2000-10-19

   

EUR  70.000.000,00

 

Former executives:

From

To

Function

Name

  2007-12-28

  2009-03-27

joint signing clerk 

Dr. Günther Tappeiner 

   

  2009-11-14

joint signing clerk 

Erich Obereder 

  2007-12-28

  2009-11-14

joint signing clerk 

Rainer Van Haver 

   

  1997-10-16

chairman of the supervisory board 

Mag.Dr. Wolfgang Ruttenstorfer 

  1997-10-15

  2000-06-14

chairman of the supervisory board 

Dr. Gerhard Roiss 

  2000-06-14

  2002-05-08

chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Richard Schenz 

  2002-05-08

  2007-02-08

chairman of the supervisory board 

Mag.Dr. Wolfgang Ruttenstorfer 

  2007-02-08

  2008-03-07

chairman of the supervisory board 

Dr. Gerhard Roiss 

  2008-03-07

  2009-03-27

chairman of the supervisory board 

Mark Garrett 

   

  1997-10-16

deputy chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Richard Schenz 

  2000-05-27

  2002-05-08

deputy chairman of the supervisory board 

Mag.Dr. Wolfgang Ruttenstorfer 

  2002-05-08

  2005-09-30

deputy chairman of the supervisory board 

Dr. Gerhard Roiss 

  2005-09-30

  2007-10-12

deputy chairman of the supervisory board 

Mohamed Nasser-Al Khaily 

  2007-10-12

  2008-03-07

deputy chairman of the supervisory board 

Khadem Al Qubaisi 

  2008-03-07

  2009-03-27

deputy chairman of the supervisory board 

Herbert Willerth 

  2009-03-27

  2010-02-06

deputy chairman of the supervisory board 

Dr.mont. Alfred Stern 

   

  2000-05-27

member of the supervisory board 

Dr. Walter Hatak 

   

  2000-05-27

member of the supervisory board 

Christian Kempinger 

   

  2000-05-27

member of the supervisory board 

Dr. Johann Risak 

  1999-08-12

  2007-12-28

joint signing clerk 

Mag. Gerald Kappes 

  2007-12-28

  2009-03-27

joint signing clerk 

Hubert Puchner 

  1997-04-10

  2000-05-27

member of the supervisory board 

Dr. Heinrich Georg Stahl 

  2000-05-27

  2000-06-14

member of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Richard Schenz 

  2000-06-14

  2002-05-08

member of the supervisory board 

Dr. Gerhard Roiss 

   

  2002-10-12

member of the supervisory board 

Dipl-Ing. Rudolf Strasser 

   

  2001-02-07

manager 

Dipl-Vw Günther Schwarz 

  2000-05-27

  2002-11-08

manager 

Dr. Walter Hatak 

   

  2005-02-11

manager 

Dipl-Ing. Gerhard Ketscher 

  2001-02-07

  2007-06-22

manager 

Dr. Joachim Grill 

  2004-02-18

  2007-10-27

manager 

Dr. Günther Tappeiner 

  2007-01-19

  2007-12-07

manager 

Hubert Puchner 

   

  1998-10-14

manager 

Mag.Dr. Franz Wurm 

  2007-12-07

  2009-03-27

manager 

Dr. Martin Kuzaj 

   

  1999-08-12

joint signing clerk 

Helmut Ilk 

   

  1999-08-12

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Herbert Schäffer 

   

  2000-06-01

joint signing clerk 

Ing. Karl Nitsche 

  2000-04-29

  2000-12-06

joint signing clerk 

Mag.Dr. Peter Roman Zheden 

  2000-04-29

  2001-02-07

joint signing clerk 

Dr. Joachim Grill 

   

  2001-03-29

joint signing clerk 

Edmund Wiesmayr 

   

  2001-08-02

joint signing clerk 

Dr. Roland Gahler 

   

  2002-06-07

joint signing clerk 

Dipl-Ing.Dr. Werner Czysch 

  2002-05-24

  2002-08-27

joint signing clerk 

Dipl-Ing.Dr. Werner Auer 

   

  2003-01-08

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Johann Grausam 

   

  2003-08-07

joint signing clerk 

Dr. Dietfried Geissler 

   

  2004-02-04

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Friedrich Wimmer 

  2003-09-18

  2006-06-21

joint signing clerk 

Armin Stein 

  2003-08-07

  2007-06-27

joint signing clerk 

Dipl-Betriebsw. Stefan Sommer 

  2002-05-24

  2007-07-07

joint signing clerk 

Ing.Mag.Dr. Horst König 

  2004-02-04

  2007-12-07

joint signing clerk 

Dipl-Ing.Dr. Gerald Papst 

  2002-05-08

  2005-09-30

member of the supervisory board 

Dipl-Ing.Mag. Helmut Langanger 

  2005-09-30

  2007-10-12

member of the supervisory board 

Khadem Al Qubaisi 

  2007-02-08

  2008-03-07

member of the supervisory board 

Mohamed Abdulla Al Azdi 

  2007-10-12

  2008-03-07

member of the supervisory board 

Mohamed Al Mehairi 

  2002-10-12

  2008-03-07

member of the supervisory board 

MBA. David Davies 

  1994-06-01

  2008-03-07

member of the supervisory board 

Hugo Pleckinger 

  2007-02-08

  2008-03-07

member of the supervisory board 

John Jeffrey Taylor 

  2008-03-07

  2009-03-27

member of the supervisory board 

Daniel James Shook 

  2009-03-27

  2010-11-19

member of the supervisory board 

Philippe Roodhooft 

  2010-02-06

  2010-11-19

member of the supervisory board 

Dr.mont. Alfred Stern 

 

Former shareholders:

From

To

Function

Name

  1991-09-26

  2000-04-29

partner 

Mag. Burkhard Guth 

  2000-04-29

  2002-10-12

partner 

Dr. Jürg Cabjolsky 

  2002-10-12

  2005-09-06

partner 

Mag.Dr. Wolfgang Baumann 

  2005-08-23

  2007-09-25

partner 

International Petroleum Investment Company 

  1994-02-10

  2007-09-25

partner 

OMV Aktiengesellschaft 

 

Former shareholdings:

From

To

Name

   

 

Chemie Linz Gesellschaft m.b.H. 

   

 

btF biotechnologische Forschungsgesellschaft m.b.H. in Liquidation 

   

 

Bauprodukte Gesellschaft m.b.H. in Liquidation 

   

 

"Terrakult" Grundverwertung und Liegenschafts Gesellschaft m.b.H. 

   

 

Agrarchemikalien Gesellschaft m.b.H. 

   

 

Hermann Oder Geschäftsführungsgesellschaft m.b.H. 

  1995-06-22

  1999-08-11

NUFARM GmbH 

  1994-03-08

  2004-04-27

Venture Finanzierungs- gesellschaft m.b.H. in Liqu. 

  1994-01-29

  2007-01-13

GWCL Wohnungsgesellschaft mbH 

  1994-04-12

  2008-01-25

Design Center Linz Betriebsgesellschaft m.b.H. 

   

 

Hermann Oder Gesellschaft m.b.H. & Co. Kommanditgesellschaft 

  1995-07-26

  1999-10-13

NUFARM GmbH & Co.KG 

 

Mergers:

Date

Function

Name

  2006-04-11

merged with 

Hermann Oder Gesellschaft m.b.H. & Co. Kommanditgesellschaft 

  2005-09-23

merged with 

Agrarchemikalien Gesellschaft m.b.H. 

 


FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.45.12

UK Pound

1

Rs.73.43

Euro

1

Rs.62.32

 

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

 

 

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.