MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

31.03.2011

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

SOLIANCE

 

 

Registered Office :

Rte De Bazancourt 51110 Pomacle

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

30.06.2009

 

 

Date of Incorporation :

July 1994

 

 

Com. Reg. No.:

39766289100019

 

 

Legal Form :

Public Limited Company With Board of Directors

 

 

Line of Business :

Manufacture of perfumes and toilet preparations

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

C

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

Credit not recommended

 

Status :

Poor

 

 

Payment Behaviour :

Unknown

 

 

Litigation :

--

 


NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail: infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – December 31, 2010

 

Country Name

Previous Rating

(30.09.2010)

Current Rating

(31.12.2010)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


Company Summary

 

Company Details

Company Number

39766289100019

Name

SOLIANCE

Telephone

03 26 05 42 80

Fax

03 26 05 42 89

Legal form

Public limited company with board of directors

RCS Registration

  397662891

Share Capital

1,203,125

Incorporation Date

07/1994

Address

RTE DE BAZANCOURT

Postcode

51110 POMACLE

Nationality

France

 

 

Judgements Summary

No judgements against this company.

 

Directors Summary

Directorships

9

 

Accounts Summary (last 3 years)

Accounts Date

30/06/2009

30/06/2008

30/06/2007

Turnover

12,758,198

14,945,997

14,882,946

Networth

2,687,202

3,834,570

3,667,109

Number of Employees

20 to 49 employees

-

-

 

Company Information

 

company details

Company Name

SOLIANCE

Company Number

39766289100019

Activity (APE)

Manufacture of perfumes and toilet preparations

Activity (APRM)

 

Currency

EURO (€)

Share capital

1,203,125

Registration Court

Reims (51)

Legal form

Public limited company with board of directors

Court Registry Number

19 9 4B003

EU VAT Number

FR41397662891

Incorporation Date

07/1994

Formation Date

08/1994

Deregistration Date

 

Last account Date

30/06/2009

Nationality

France

 

 

Establishment details

Postal Address

RTE DE BAZANCOURT,
51110 POMACLE,

Trading Address

RTE DE BAZANCOURT,
51110 POMACLE,

Telephone

03 26 05 42 80

Fax

03 26 05 42 89

Type

Head office

Status

Economically active

Formation Date

08/1994

Reason for formation

Formation

Closure Date

 

Reason for closure

 

Reactivation Date

 

Production Role

 

Activity Nature

Manufacture, production

Activity Location

Plant

Location Service

 

Seasonality

 

 


 

Other establishments

Branches

5 branch entities in this company

Company number

39766289100019

Company name

SOLIANCE

Type

Head office

Activity (ape)

Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

Post Code

51110

City

POMACLE

 

Company number

39766289100050

Company name

SOLIANCE

Type

Secondary establishment

Activity (ape)

Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

Post Code

22560

City

PLEUMEUR BODOU

 

Company number

39766289100043

Company name

SOLIANCE

Type

Secondary establishment

Activity (ape)

Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

Post Code

94130

City

NOGENT SUR MARNE

 

Company number

39766289100027

Company name

SOLIANCE

Type

Secondary establishment

Activity (ape)

Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

Post Code

92700

City

COLOMBES

 

Company number

39766289100035

Company name

SOLIANCE

Type

Secondary establishment

Activity (ape)

Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

Post Code

75008

City

PARIS 8

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas but no one grouping more than 50% of workforce

Mono-activity status

Legal unit having all establishments with the same main activity

 

Workforces

Workforce at address

20 to 49 employees

Company workforce

20 to 49 employees

 


Accounts & Ratios

 

Profit & Loss

Account Date

30/06/2009

%

30/06/2008

%

30/06/2007

Account period (month)

12

-

12

-

12

Account Type

Normal Account

-

Normal Account

-

Normal Account

Currency

Euro

-

Euro

-

Euro

Turnover

12,758,198

-14.6%

14,945,997

0.4%

14,882,946

Exports

5,970,760

-21.8%

7,635,956

-12.3%

8,707,017

Operating Charges

12,472,269

-19.6%

15,508,700

6.6%

14,546,829

Operating Profit

-885,826

-200.3%

882,813

66.8%

529,341

Financial Income

21,970

74.9%

12,559

13.2%

11,097

Financial Charges

265,559

-6.2%

283,054

31.4%

215,495

Pre-Tax Profit

-1,129,415

-284.4%

612,319

88.4%

324,942

Extraordinary Income

31,886

-50.4%

64,286

-68.5%

204,086

Extraordinary Charges

125,080

-1.2%

126,540

405.3%

25,045

Net Profit

-990,582

-356.1%

386,747

0.4%

385,383

 

 

Balance Sheet

Account Date

30/06/2009

%

30/06/2008

%

30/06/2007

Assets

- Tangible assets

2,426,279

-3.7%

2,519,310

-1.4%

2,555,828

Intangible assets

2,873,265

69.4%

1,695,788

10.7%

1,532,183

Financial assets

64,160

-97.1%

2,194,056

-10.9%

2,462,219

Total fixed assets

5,363,704

-16.3%

6,409,153

-2.2%

6,550,231

Stocks

3,789,417

-14.9%

4,451,407

40.5%

3,167,387

Receivables

2,987,117

-20.2%

3,743,798

-21.8%

4,789,343

- Trade Receivables

2,502,440

-20.1%

3,133,856

-13.3%

3,612,924

- Misc. Receivables

484,677

-

609,942

-

1,176,419

Cash

103,738

75.7%

59,034

-80.8%

307,027

Misc. Current Assets

8,375

-

8,900

-

8,900

Total Current Assets

6,888,647

-16.6%

8,263,139

-0.1%

8,272,657

Liabilities

Trade Accounts Payable

1,385,544

-52.9%

2,942,611

-25.8%

3,965,145

Bank Loans and Liabilities

3,357,353

-27.5%

4,634,018

36.4%

3,397,009

Sundry Loan and Liabilities

132,764

-

425,971

-

262,310

Advanced Payments Received

0

-

0

-

0

Tax and Social Liabilities

597,110

1.5%

588,445

-0.4%

590,790

Miscellaneous Liabilities

3,950,108

-

2,106,826

-

2,695,276

Provisions for Risks & Charges

30,884

8.5%

28,465

19.3%

23,861

Other Capital Resources

111,387

0.0%

111,387

-49.7%

221,387

Share Capital

1,203,125

0.0%

1,203,125

0.0%

1,203,125

Revaluation Reserve

0

-

0

-

0

Other Reserves

1,484,077

-

2,631,445

-

2,463,984

Total Shareholders Funds

2,687,202

-29.9%

3,834,570

4.6%

3,667,109

 

Total Assets

12,252,351

-16.5%

14,672,292

-1.0%

14,822,887

Net Worth

-186,063

-

2,138,782

-

2,134,926

 

 

Ratios

Account Date

30/06/2009

%

30/06/2008

%

30/06/2007

Structure

Protection

22.84%

 

26.89%

 

26.23%

Net Gearing

28.49%

 

34.49%

 

24.69%

Repayment Power

-509.33%

 

275.00%

 

187.36%

Capital Requirement

-13.00 day

 

10.00 day

 

-20.00 day

Working Capital Requirement

24.00 day

 

62.00 day

 

17.00 day

Net Cash

-37.00 day

 

-52.00 day

 

-37.00 day

 

Performance

Return on Invested Capital

-5.00%

 

30.00%

 

22.00%

Return on Equity

-36.86%

 

10.09%

 

10.51%

Gross Profit

22.32% Turnover

 

30.68% Turnover

 

26.49% Turnover

Growth v's Year Ago Qtr

-2,187,799€

 

63,051€

 

3,739,112€

Inventory Returns

-87.00 day

 

71.00 day

 

8.00 day

Receivables Days

73.00 day

 

77.00 day

 

89.00 day

Payable Days

54.00 day

 

89.00 day

 

129.00 day

 

SIG

Profit

99.41% Turnover

 

95.17% Turnover

 

84.29% Turnover

Gross Profit

22.32% Turnover

 

30.68% Turnover

 

26.49% Turnover

Wage and Salary distribution / Gross Profit

98.10% Turnover

 

51.61% Turnover

 

56.28% Turnover

Gross Operating Surplus

-2.02% Turnover

 

12.74% Turnover

 

10.02% Turnover

Pre-tax Income

-8.85% Turnover

 

4.10% Turnover

 

2.18% Turnover

Net Profit/Loss

-7.76%

 

2.59%

 

2.59%

 

Judgements

Collective Procedures

 

Courts

There are no Judgements filed against this company.

Rncs

There are no Judgements filed against this company.

Bodacc

There are no Judgements filed against this company.

 

Preferentials Rights

No social security and tax office preferential right to date.

 

Group Structure

 

Ultimate Parent

Ultimate Parent Company

SOLIANCE

Companies in Group

2

Company Name

Country

Share

Latest Annual Accounts

SOLIANCE

397662891

-

30/06/2009

SOLIANCE US CORPORATION

United States of America

100 %

N/A

Event history

 

Status history

No status history for this company.

 

Recent Publications in Gazettes

Publication Date

Gazette Name

Description

18/05/2010

B

Modification et mutation diverse

51 - MARNE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
1547 - 397 662 891 RCS Reims. SOLIANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Président du Conseil d'Administration : PREVOTEAU François-Michel, Marie Directeur général : LE HENAFF Yvon, Raoul, Jean-Marie Administrateur : VERZEAUX Jean-Pol, Edmond Administrateur : BAILLEUL Pascal, Jules, Jean Administrateur : AUBRY Philippe, Claude, René Administrateur : MILLET Daniel, Paul Administrateur : AGRO INDUSTRIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT A.R.D. Administrateur : HERMANT Didier, René, Albert Administrateur : COLLARD Daniel Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : ZEIMETT Patrick. Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

 

10/05/2010

C

Comptes annuels et rapports

51 - MARNE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
5573 - 397662891 RCS. SOLIANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : route de Bazancourt 51110 Pomacle. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 30/06/2009.

 

27/02/2009

C

Comptes annuels et rapports

51 - MARNE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
3806 - 397662891 RCS. SOLIANCE. Forme : Société Anonyme à conseil d'administration. Adresse : route de Bazancourt 51110 Pomacle. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 30/06/2008.

 

24/07/2008

A_REG

Vente et cession

51 - MARNE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
550 - 393 140 553 RCS Reims. I.D. BIO. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 6 allée Skylab Parc d'Ester, 87000 Limoges. Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 25.000,00 EUR. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : extraits végétaux. Adresse : route de Bazancourt, 51110 Pomacle. Précédent propriétaire : SOLIANCE. 397 662 891 RCS Reims. A dater du : 08/07/2008. Date de commencement de l’activité : 01/12/2007. Publication légale : PETITES AFFICHES MATOT BRAINE du 18/02/2008. Oppositions : Maître HAZARABEDIAN - Notaire 2 avenue de Rethel 51430 WITRY LES REIMS. Descriptif : achat de la branche d'activité : extraits végétaux dépendant d'un fonds de fabrication et vente de matières premières pour les industries cosmétiques. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

 

24/07/2008

A_REG

Vente et cession

51 - MARNE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
550 - 393 140 553 RCS Reims. I.D. BIO. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 6 allée Skylab Parc d'Ester, 87000 Limoges. Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 25.000,00 EUR. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : extraits végétaux. Adresse : route de Bazancourt, 51110 Pomacle. Précédent propriétaire : SOLIANCE. 397 662 891 RCS Reims. A dater du : 08/07/2008. Date de commencement de l’activité : 01/12/2007. Publication légale : PETITES AFFICHES MATOT BRAINE du 18/02/2008. Oppositions : Maître HAZARABEDIAN - Notaire 2 avenue de Rethel 51430 WITRY LES REIMS. Descriptif : achat de la branche d'activité : extraits végétaux dépendant d'un fonds de fabrication et vente de matières premières pour les industries cosmétiques. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

 

24/07/2008

C

Comptes annuels et rapports

51 - MARNE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
6531 - 397662891 RCS. SOLIANCE. Forme : Société Anonyme à conseil d'administration. Adresse : route de Bazancourt 51110 Pomacle. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 30/06/2007.

 

27/04/2007

B

Modifications et mutations diverses

1085 - RCS Reims B 397 662 891. RC 94-B 309. SOLIANCE. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 1 203 125 euros. Adresse du siège social : route de Bazancourt,, Pomacle, 51110 Administration : président du conseil d'administration : PREVOTEAU (François, Michel, Marie). Directeur général : LE HENAFF (Yvon, Raoul, Jean-Marie). Administrateurs : MAINSANT (François) VERZEAUX (Jean-Pol) BAILLEUL (Pascal, Jules, Jean) AUBRY (Philippe, Claude, René) MILLET (Daniel, Paul) AGRO INDUSTRIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT-A.R.D. HERMANT (Didier, René, Albert). Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE-S.A. Commissaire aux comptes suppléant : ZEIMETT (Patrick). Ancienne administration : ancien commissaire aux comptes suppléant : STE CHAMPAGNE ARDENNE REVISION. Ancien administrateur : ROYER (Jean-Louis). Etablissement principal - Activité : fabrication et vente de matières premières pour les industries cosmétiques. Adresse : route de Bazancourt, Pomacle, 51110 Date d'effet : 14 décembre 2006.

 

16/03/2007

C

Avis de dépôt des comptes

5460 - RCS Reims B 397 662 891. RC 94-B 309. SOLIANCE. Forme: S.A. à conseil d'administration . Adresse du siège social: route de Bazancourt,Pomacle, 51110 Bazancourt. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 30 juin 2006.

 

14/11/2006

B

Modifications et mutations diverses

1356 - RCS Reims B 397 662 891. RC 94-B 309. SOLIANCE. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 1 203 125 euros. Adresse du siège social : route de Bazancourt,, Pomacle, 51110 Administration : président du conseil d'administration : PREVOTEAU (François, Michel, Marie). Directeur général : LE HENAFF (Yvon, Raoul, Jean-Marie). Administrateurs : ROYER (Jean-Louis) MAINSANT (François) VERZEAUX (Jean-Pol) BAILLEUL (Pascal, Jules, Jean) AUBRY (Philippe, Claude, René) MILLET (Daniel, Paul) AGRO INDUSTRIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT A.R.D. Nouvel administrateur : HERMANT (Didier, René, Albert). Commissaire aux comptes titulaire : STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE S.A. Commissaire aux comptes suppléant : CHAMPAGNE ARDENNE REVISION. Ancienne administration : ancien administrateur : SWYZEN (Werner). Etablissement principal - Activité : fabrication et vente de matières premières pour les industries cosmétiques. Adresse : route de Bazancourt, Pomacle, 51110 Date d'effet : 12 décembre 2005.

 

01/09/2006

B

Modifications et mutations diverses

0786 - RCS Reims B 397 662 891. RC 94-B 309. SOLIANCE. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 1 203 125 euros. Adresse du siège social : route de Bazancourt,, Pomacle, 51110 Etablissement principal - Activité : fabrication et vente de matières premières pour les industries cosmétiques. Adresse : route de Bazancourt, Pomacle, 51110 Commentaires : cession de la branche d'activité de conditionnement et de vente d'huiles végétales à la S.A.S. ID BIO. Date d'effet : 20 juin 2006.

 

10/08/2006

A_REG

Vente et cession

1657 - RCS Limoges B 393 140 553. RC 93-B 392. I.D.BIO. Forme : S.A.S. Capital : 100 000 euros. Adresse du siège social : parc d'Ester, 6 allée Skylab, 87068 Limoges Cedex. Etablissement principal - Activité : production, fabrication et commercialisation, ainsi que la recherche et la mise au point de produits biologiques par transformation de matières animales et végétales. Conception, fabrication, commercialisation de produits, d'appareils cosmétiques et paramédicaux. Conditionnement et vente d'huiles végétales . Adresse : parc d'Ester, 6 allée Skylab, 87068 Limoges Cedex. Clientèle de la branche d'activité, dépendant du fonds, acquise par achat au prix stipulé de 30 000 euros. Commentaires : modification survenue sur l'activité (adjonction) dépendant d'un fonds exploité route de Bazancourt, 51110 Pomacle, l'exploitation de la clientèle a été transférée à l'adresse du siège social. Date d'effet : 30 juin 2006. Précédent propriétaire : S.A SOLIANCE. RCS 397 662 891. Publication légale : Les petites affiches Matot-Braine du 24 juillet 2006. Oppositions : Etude de Me Hazarabedian (Dominique), 2 avenue de Réthel, 51420 Witry-les-Reims.

 

17/03/2006

C

Avis de dépôt des comptes

1908 - RCS Reims B 397 662 891. RC 94-B 309. SOLIANCE. Forme: S.A. à conseil d'administration . Adresse du siège social: route de Bazancourt,Pomacle, 51110 Bazancourt. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 30 juin 2005.

 

15/04/2005

C

Avis de dépôt des comptes

934 - RCS Reims B 397 662 891. RC 94-B 309. SOLIANCE. Forme: S.A. à conseil d'administration . Adresse du siège social: route de Bazancourt,Pomacle, 51110 Bazancourt. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 30 juin 2004.

 

22/02/2005

A_REG

Vente et cession

1234 - RCS B 393 140 553. RC 05-B 969. S.A. I.D. BIO. Forme : S.A. Adresse du siège social : parc d'Ester, 6 allée Skylab, 87068 Limoges Cedex. Etablissement secondaire - Activité : fabrication et vente de matières premières pour les industries cosmétiques. Adresse : 101-103 rue Henri-Dunant, 92700 Colombes. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 110 000 euros. Date d'effet : 10 février 2005. Précédent propriétaire : SOLIANCE. RCS 397 662 891. Publication légale : Les Petites affiches du 3 février 2005. Oppositions : Mes Wargny, Lelong et Retel, notaires, 22 avenue Henri-Barbusse, 92700 Colombes, pour la validité et la correspondance.

 

09/03/2004

B

Modifications et mutations diverses

RCS Reims B 397662891 RC 94-B 309 SOLIANCE. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 1 203 125 euros. Adresse du siège social : route de Bazancourt, Pomacle 51110 Bazancourt. Administration : président du conseil d' administration : PREVOTEAU (François, Michel, Marie). Directeur général : LE HENAFF (Yvon, Raoul, Jean-Marie). Administrateurs : ROYER (Jean-Louis) MAINSANT (François) VERZEAUX (Jean- Pol) SWYZEN (Werner) BAILLEUL ( Pascal, Jules, Jean) AUBRY (Philippe, Claude, René) MILLET (Daniel, Paul) AGRO INDUSTRIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT-A.R.D. Commissaire aux comptes titulaire : STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE S.A. Commissaire aux comptes suppléant : CHAMPAGNE-ARDENNE REVISION. Anciens administrateurs : DE BOHAN (Jacques, Joseph, Edmond) RENARD (Jean-Claude, Albert) HUE (Roland) Etablissement principal: Activité : fabrication et vente de matières premières pour les industries cosmétiques. Adresse : route de Bazancourt, Pomacle 51110 Bazancourt. Date d'effet : 30 décembre 2002.

 

22/02/2004

B

Modifications et mutations diverses

RCS Reims B 397662891 RC 94-B 309 SOLIANCE. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 1 203 125 euros. Adresse du siège social : route de Bazancourt, Pomacle 51110 Bazancourt. Administration : président du conseil d' administration : PREVOTEAU (François, Michel, Marie). Nomination en qualité de directeur général : LE HENAFF (Yvon, Raoul, Jean-Marie). Administrateurs : ROYER (Jean-Louis) MAINSANT (François) VERZEAUX (Jean-Pol) RENARD (Jean- Claude, Albert) DE BOHAN (Jacques, Joseph, Edmond) SWYZEN (Werner) BAILLEUL (Pascal, Jules, Jean) AUBRY ( Philippe, Claude, René) HUE (Roland) MILLET (Daniel, Paul) AGRO INDUSTRIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT A.R.D. Commissaire aux comptes titulaire : STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE S.A. Commissaire aux comptes suppléant : CHAMPAGNE ARDENNE REVISION Etablissement principal: Activité : fabrication et vente de matières premières pour les industries cosmétiques. Adresse : route de Bazancourt, Pomacle 51110 Bazancourt. Date d'effet : 3 septembre 2002.

 

15/02/1998

B

Modifications et mutations diverses

RCS Reims B 397 662 891 RC 94-B 309 SOLIANCE. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 7 500 000 F. Adresse du siège social : route de Bazancourt Pomacle 51110 Bazancourt. Administration : président du conseil d' administration : MANGEART (Georges). Directeur général : DE BAYNAST (Régis). Administrateurs : LAPOINTE (Christian, Jean-Marie, André) ROYER (Jean-Louis) MAINSANT (François) PREVOTEAU ( François) MATHALY (Philippe, Lucien) RENARD (Jean-Claude, Albert) MANGIN ( Philippe). Commissaire aux comptes titulaire : STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE S.A. Commissaire aux comptes suppléant : CHAMPAGNE ARDENNE REVISION. Anciens administrateurs : PAUVERT (Jacky) HODENT (Jean-Pierre) ARNOULD (Benoit) ETIENNE (Jean-Marc) Etablissement principal: Activité : fabrication et vente de matières premières pour les industries cosmétiques. Adresse : route de Bazancourt Pomacle 51110 Bazancourt. Date d'effet : 30 juin 1997.

 

15/11/1996

B

Modifications et mutations diverses

RCS o. RCS Reims B 397 662 891 RC RC 94- B 309 SOLIANCE. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 7 500 000 F. Adresse du siège social : route de Bazancourt Pomacle 51110 Bazancourt. Administration : président du conseil d' administration : MANGEART (Georges) Directeur général : DE BAYNAST (Régis). Administrateurs : ARNOULD (Benoit, Joseph, Bernard) PREVOTEAU (François) ETIENNE (Jean, Marc) PAUVERT (Jacky) HODENT (Jean, Pierre) MATHALY ( Philippe, Lucien). Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE S.A. Commissaire aux comptes suppléant : CHAMPAGNE ARDENNE REVISION. Ancien président du conseil d'administration : PAUVERT (Jacky) Etablissement principal: Activité : fabrication et vente de matières premières pour les industries cosmétiques. Adresse : route de Bazancourt Pomacle 51110 Bazancourt Date de début d'activité: 1er aout 1994. Date d'effet : 28 juin 1996.

 

 

Company events history

 

Date

Description

12/11/2010

Disengagement of the group

26/10/2010

Collection of preferential rights activated for this company

18/05/2010

Bodacc B: Various editing or changing

10/05/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

28/04/2010

Changes to the Board of Directors

28/04/2010

Minutes of Board meeting

18/04/2010

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

18/09/2009

Legal Gazette: Appointment of the social representative

30/06/2009

New accounts available

27/02/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

20/01/2009

Merger

20/01/2009

Change to corporate purpose

20/01/2009

Private document

20/01/2009

Declaration of conformity

20/01/2009

Minutes of general meeting of shareholders

20/01/2009

Amendment

20/01/2009

Updated articles of association

14/11/2008

Amendment

14/11/2008

Private document

14/11/2008

Planned merger

 

 

Establishment events history

 

Date

Description

05/03/2011

Update Limit

04/03/2011

Update Rating

21/01/2011

Update Rating

27/04/2010

Update Limit

27/04/2010

Update Rating

06/04/2010

Update Limit

02/03/2010

Update Rating

02/03/2010

Update Limit

29/12/2009

Update Rating

04/06/2009

Update Rating

02/04/2009

Update Rating

16/03/2009

Update Rating

04/03/2009

Update Rating

09/04/2008

Update Rating

09/04/2008

Update Limit

02/04/2008

Update Limit

01/03/2008

Update Rating

16/12/2007

Update Limit

10/12/2007

Update Limit

09/12/2007

Update Limit

 

Directors

 

Director

Name

PREVOTEAU FRANÇOIS-MICHEL MARIE

Manager position

Président du conseil d'administration

Date of birth

23/12/1956

Place of birth

51 BAZANCOURT

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

Director

Name

LE HENAFF YVON RAOUL JEAN-MARIE

Manager position

Directeur général

Date of birth

06/03/1952

Place of birth

26 TAIN L HERMITAGE

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

Director

Name

VERZEAUX JEAN-POL EDMOND

Manager position

Administrateur

Date of birth

19/04/1948

Place of birth

51 BEINE-NAUROY

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

Director

Name

BAILLEUL PASCAL JULES JEAN

Manager position

Administrateur

Date of birth

20/02/1958

Place of birth

62 MAZINGARBE

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

Director

Name

AUBRY PHILIPPE CLAUDE RENÉ

Manager position

Administrateur

Date of birth

07/11/1962

Place of birth

54 LUNÉVILLE

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

Director

Name

MILLET DANIEL PAUL

Manager position

Administrateur

Date of birth

21/01/1947

Place of birth

08 AUSSONCE

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

Director

Name

AGRO INDUSTRIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT A.R.D.

Manager position

Administrateur

Date of birth

 

Place of birth

 

Type of manager

Moral person

Name at birth of manager

 

Director

Name

HERMANT DIDIER RENÉ ALBERT

Manager position

Administrateur

Date of birth

21/12/1959

Place of birth

59 ORCHIES

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

Director

Name

M COLLARD DANIEL

Manager position

Administrateur

Date of birth

30/08/1948

Place of birth

THIBIE (51)

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.44.77

UK Pound

1

Rs.71.69

Euro

1

Rs.63.02

 

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.