MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :           

12.11.2011

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Correct Name :

SOC D'IMPORTATION LECLERC

 

 

Registered Office :

26 Quai Marcel Boyer, 94200 Ivry Sur Seine

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2008

 

 

Date of Incorporation :

March 1979

 

 

Com. Reg. No.:

315281113

 

 

Legal Form :

Cooperative Public Limited Company with Board of Directors

 

 

Line of Business :

Central Fuel Purchase

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

A

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

Fairly Large

 

Maximum Credit Limit :

(€) 250,000

Status :

Good

Payment Behaviour :

No Complaints

Litigation :

Clear

 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – September 30th, 2011

 

Country Name

Previous Rating

                   (30.06.2011)                  

Current Rating

(30.09.2011)

France

a2

a2

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 Bottom of Form

 

Company Summary

 

Company Details

Company Number

31528111300052

Name

SOC D'IMPORTATION LECLERC

Telephone

08 10 00 46 90

Fax

 

Legal form

Cooperative public limited company with board of directors

RCS Registration

315281113

Share Capital

975,673

Incorporation Date

03/1979

Address

26 QUAI MARCEL BOYER

Postcode

94200 IVRY SUR SEINE

Nationality

France

 

Credit Information Summary

Company Status

Economically active

Credit Limit (€)

250,000

 

Judgements Summary

No judgements against this company.

 

Directors Summary

Directorships

13

 

Accounts Summary (last 3 years)

Accounts Date

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006

Turnover

8,457,703,304

7,258,334,527

6,502,454,296

Networth

91,526,066

96,001,200

76,146,282

Number of Employees

100 to 199 employees

-

-

 

 

Company Information

 

company details

Company Name

SOC D'IMPORTATION LECLERC

Company Number

31528111300052

Activity (APE)

Centrales d'achat de carburant

(Central fuel purchase)

Activity (APRM)

 

Currency

EURO (€)

Share capital

975,673

Registration Court

Creteil (94)

Legal form

cooperative public limited company with board of directors

Court Registry Number

20 0 6B030

EU VAT Number

FR37315281113

Incorporation Date

03/1979

Formation Date

01/1979

Deregistration Date

 

Last account Date

31/12/2008

Nationality

France

 

Establishment details

Postal Address

26 QUAI MARCEL BOYER,
94200 IVRY SUR SEINE,

Trading Address

26 QUAI MARCEL BOYER,
94200 IVRY SUR SEINE,

Telephone

08 10 00 46 90

Fax

 

Type

Head office

Status

Economically active

Formation Date

01/1979

Reason for formation

Formation

Closure Date

 

Reason for closure

 

Reactivation Date

 

Production Role

 

Activity Nature

 

Activity Location

 

Location Service

 

Seasonality

 

 

Other establishments

Branches

2 branch entities in this company

Company number

31528111300052

Company name

SOC D'IMPORTATION LECLERC

Type

Head office

Activity (ape)

Centrales d'achat de carburant

Post Code

94200

City

IVRY SUR SEINE

 

Company number

31528111300045

Company name

SOC D'IMPORTATION LECLERC

Type

Secondary establishment

Activity (ape)

Centrales d'achats non alimentaires

Post Code

75018

City

PARIS 18

 

Regionality

Legal unit with all establishments in same area

Mono-activity status

Legal unit having all establishments with the same main activity

 

Workforces

Workforce at address

Workforce unknown

Company workforce

100 to 199 employees

 

 

Accounts & Ratios

 

Profit & Loss

Account Date

31/12/2008

%

31/12/2007

%

31/12/2006

Account period (month)

12

-

12

-

12

Account Type

Normal Account

-

Normal Account

-

Normal Account

Currency

Euro

-

Euro

-

Euro

Turnover

8,457,703,304

16.5%

7,258,334,527

11.6%

6,502,454,296

Exports

0

-

0

-

0

Operating Charges

8,465,130,903

17.0%

7,237,989,063

11.3%

6,505,389,032

Operating Profit

-7,075,401

-133.2%

21,327,002

1,026.9%

-2,301,012

Financial Income

16,936,398

38.8%

12,201,341

16.6%

10,460,394

Financial Charges

8,922,555

-14.0%

10,369,480

55.4%

6,670,826

Pre-Tax Profit

1,090,489

-95.3%

23,410,532

1,283.3%

1,692,386

Extraordinary Income

8,176,458

2,374.0%

330,489

-89.0%

3,015,608

Extraordinary Charges

1,331,432

-92.8%

18,436,144

1,022.3%

1,642,654

Net Profit

3,491,381

23.9%

2,816,792

38.3%

2,036,581

 

Balance Sheet

Account Date

31/12/2008

%

31/12/2007

%

31/12/2006

Assets

- Tangible assets

13,232,596

26.0%

10,499,063

18.3%

8,875,647

Intangible assets

5,865,624

456.0%

1,055,040

-2.4%

1,081,433

Financial assets

20,977,738

4.4%

20,097,566

-5.2%

21,189,643

Total fixed assets

40,075,958

26.6%

31,651,669

1.6%

31,146,726

Stocks

160,745,675

-20.3%

201,667,567

25.5%

160,638,913

Receivables

513,545,595

9.1%

470,753,841

21.1%

388,658,748

- Trade Receivables

293,282,234

-18.7%

360,646,806

18.2%

304,995,469

- Misc. Receivables

220,263,361

-

110,107,035

-

83,663,279

Cash

149,495,607

-18.8%

184,005,719

15.9%

158,721,808

Misc. Current Assets

 

-

 

-

 

Total Current Assets

823,786,877

-3.8%

856,427,127

21.0%

708,019,469

Liabilities

Trade Accounts Payable

673,623,384

-1.4%

683,218,541

13.2%

603,699,347

Bank Loans and Liabilities

9,400,330

-71.5%

33,023,488

50.1%

21,999,631

Sundry Loan and Liabilities

645,328

-

547,578

-

775,382

Advanced Payments Received

0

-

0

-

0

Tax and Social Liabilities

30,607,647

-49.3%

60,326,975

1,244.7%

4,486,355

Miscellaneous Liabilities

40,884,811

-

5,451,282

-

24,650,153

Provisions for Risks & Charges

15,009,895

10.4%

13,597,730

75.9%

7,728,994

Other Capital Resources

0

-

0

-

0

Share Capital

1,589,051

0.6%

1,579,901

0.0%

1,579,901

Revaluation Reserve

0

-

0

-

0

Other Reserves

89,937,015

-

94,421,299

-

74,566,381

Total Shareholders Funds

91,526,066

-4.7%

96,001,200

26.1%

76,146,282

 

Total Assets

866,418,303

-2.9%

892,209,901

20.6%

739,919,348

Net Worth

85,660,442

-

94,946,160

-

75,064,849

 

Ratios

Account Date

31/12/2008

%

31/12/2007

%

31/12/2006

Structure

Protection

10.56%

 

10.76%

 

10.29%

Net Gearing

1.16%

 

3.76%

 

3.08%

Repayment Power

14.15%

 

11.97%

 

778.49%

Capital Requirement

3.00 day

 

4.00 day

 

3.00 day

Working Capital Requirement

-3.00 day

 

-4.00 day

 

-5.00 day

Net Cash

6.00 day

 

8.00 day

 

8.00 day

 

Performance

Return on Invested Capital

83.00%

 

183.00%

 

-2.00%

Return on Equity

3.81%

 

2.93%

 

2.67%

Gross Profit

0.76% Turnover

 

1.10% Turnover

 

0.45% Turnover

Growth v's Year Ago Qtr

1,199,368,777€

 

755,880,231€

 

607,369,459€

Inventory Returns

0

 

0

 

0

Receivables Days

12.00 day

 

18.00 day

 

17.00 day

Payable Days

29.00 day

 

34.00 day

 

34.00 day

 

SIG

Profit

0.96% Turnover

 

1.31% Turnover

 

0.62% Turnover

Gross Profit

0.76% Turnover

 

1.10% Turnover

 

0.45% Turnover

Wage and Salary distribution / Gross Profit

15.25% Turnover

 

10.78% Turnover

 

25.67% Turnover

Gross Operating Surplus

0.39% Turnover

 

0.80% Turnover

 

-0.01% Turnover

Pre-tax Income

0.01% Turnover

 

0.32% Turnover

 

0.02% Turnover

Net Profit/Loss

0.04%

 

0.04%

 

0.03%

Judgements

 

Collective Procedures

Courts

There are no Judgements filed against this company.

Rncs

There are no Judgements filed against this company.

Bodacc

There are no Judgements filed against this company.

 

Preferentials Rights

No social security and tax office preferential right to date.

 

 

Group Structure

 

Ultimate Parent

Ultimate Parent Company

SOCIÉTÉ D\'IMPORTATION LECLERC

Companies in Group

3

Company Name

Country

Share

Latest Annual Accounts

SOCIÉTÉ D\'IMPORTATION LECLERC

315281113

-

31/12/2008

SOCIÉTÉ DE NÉGOCE DE PRODUITS PÉTROLIERS

344059605

100 %

31/12/2009

CEDILEC

387606569

100 %

31/12/2009

 

 

Event history

 

Status history

No status history for this company.

 

Recent Publications in Gazettes

Publication Date

Gazette Name

Description

19/08/2010

C

Comptes annuels, consolidés et rapports

94 - VAL-DE-MARNE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
9564 - 315281113 RCS. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Forme : Société anonyme coopérative ŕ conseil d'administration ŕ capital variable. Adresse : 26 quai Marcel Boyer 94200 Ivry-sur-Seine. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

 

19/08/2010

C

Comptes annuels et rapports

94 - VAL-DE-MARNE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
9563 - 315281113 RCS. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Forme : Société anonyme coopérative ŕ conseil d'administration ŕ capital variable. Adresse : 26 quai Marcel Boyer 94200 Ivry-sur-Seine. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

 

16/03/2010

B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
2788 - 315 281 113 RCS Créteil. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Forme : Société anonyme coopérative ŕ capital variable. Sigle : SIPLEC. Administration : Administrateur : BELOOSSOFF Eric Fondé de pouvoir ŕ procuration générale : LECLERC Michel Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D ACHATS DES CENTRES LECLERC représenté par FEBVRE Serge modification le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : AMYOT EXCO Commissaire aux comptes suppléant : HENGOAT Gilles Directeur général délégué et administrateur : COURTOIS Régine Administrateur : EXMELIN Jean Jacques Administrateur : JAUD Hervé Administrateur : BUSSOLINI Jean Marc Directeur général délégué et administrateur : PAYRAUDEAU Marc Directeur général délégué et administrateur : LECUREUX Christophe Président du conseil d'administration et directeur général : PICARD Denis Commissaire aux comptes suppléant : JUVENTIN Chantal Commissaire aux comptes titulaire : COGEPARC Administrateur : DUCATEL Olivier en fonction le 18 Septembre 2007 Administrateur : GUITTARD Dominique en fonction le 19 Février 2009 Administrateur : TAILLANDIER Daniel en fonction le 29 Juillet 2009 Directeur général délégué et administrateur : VILLAT Thierry en fonction le 04 Mars 2010. Commentaires : Modification de représentant.

 

07/10/2009

C

Comptes annuels et rapports

94 - VAL-DE-MARNE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
10490 - 315281113 RCS. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Forme : Société anonyme coopérative ŕ capital variable. Adresse : 26 quai Marcel Boyer 94200 Ivry-sur-Seine. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

 

14/08/2009

C

Comptes annuels et rapports

94 - VAL-DE-MARNE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
8688 - 315281113 RCS. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Forme : Société anonyme coopérative ŕ capital variable. Adresse : 26 quai Marcel Boyer 94200 Ivry-sur-Seine. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

 

06/08/2009

B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
1054 - 315 281 113 RCS Créteil. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Forme : Société anonyme coopérative ŕ capital variable. Sigle : SIPLEC. Administration : Administrateur : BELOOSSOFF Eric Fondé de pouvoir ŕ procuration générale : LECLERC Michel Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D ACHATS DES CENTRES LECLERC représenté par FEBVRE Serge modification le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : AMYOT EXCO Commissaire aux comptes suppléant : HENGOAT Gilles Directeur général délégué et administrateur : COURTOIS Régine Administrateur : EXMELIN Jean Jacques Administrateur : JAUD Hervé Administrateur : BUSSOLINI Jean Marc Directeur général délégué et administrateur : PAYRAUDEAU Marc Directeur général délégué et administrateur : LECUREUX Christophe Président du conseil d'administration et directeur général : PICARD Denis Commissaire aux comptes suppléant : JUVENTIN Chantal Commissaire aux comptes titulaire : COGEPARC Administrateur : DUCATEL Olivier en fonction le 18 Septembre 2007 Administrateur : GUITTARD Dominique en fonction le 19 Février 2009 Administrateur : TAILLANDIER Daniel en fonction le 29 Juillet 2009. Commentaires : Modification de représentant.

 

19/07/2009

B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
1851 - 315 281 113 RCS Créteil. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Forme : Société anonyme coopérative ŕ capital variable. Sigle : SIPLEC. Administration : Administrateur : BELOOSSOFF Eric. Fondé de pouvoir ŕ procuration générale : LECLERC Michel. Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC représenté par FEBVRE Serge modification le 09 Juillet 2009. Commissaire aux comptes titulaire : AMYOT EXCO. Commissaire aux comptes suppléant : HENGOAT Gilles. Directeur général délégué et administrateur : COURTOIS Régine. Administrateur : MARTY Jean Paul. Administrateur : EXMELIN Jean Jacques. Administrateur : JAUD Hervé. Administrateur : BUSSOLINI Jean Marc. Directeur général délégué et administrateur : PAYRAUDEAU Marc. Directeur général délégué et administrateur : LECUREUX Christophe. Président du conseil d'administration et directeur général : PICARD Denis. Commissaire aux comptes suppléant : JUVENTIN Chantal. Commissaire aux comptes titulaire : COGEPARC. Administrateur : DUCATEL Olivier en fonction le 18 Septembre 2007. Administrateur : GUITTARD Dominique en fonction le 19 Février 2009. Commentaires : Modification de représentant.

 

03/03/2009

B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
1864 - 315 281 113 RCS Créteil. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Forme : Société anonyme coopérative ŕ capital variable. Sigle : SIPLEC. Administration : Administrateur : BELOOSSOFF Eric. Fondé de pouvoir ŕ procuration générale : LECLERC Michel. Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC représenté par GATTEPAILLE Jacques. Commissaire aux comptes titulaire : AMYOT EXCO. Commissaire aux comptes suppléant : HENGOAT Gilles. Directeur général délégué et administrateur : COURTOIS Régine. Administrateur : MARTY Jean Paul. Administrateur : EXMELIN Jean Jacques. Administrateur : JAUD Hervé. Administrateur : BUSSOLINI Jean Marc. Directeur général délégué et administrateur : PAYRAUDEAU Marc. Directeur général délégué et administrateur : LECUREUX Christophe. Président du conseil d'administration et directeur général : PICARD Denis. Commissaire aux comptes suppléant : JUVENTIN Chantal. Commissaire aux comptes titulaire : COGEPARC. Administrateur : DUCATEL Olivier en fonction le 18 Septembre 2007. Administrateur : GUITTARD Dominique en fonction le 19 Février 2009. Commentaires : Modification de représentant.

 

03/03/2009

B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
1864 - 315 281 113 RCS Créteil. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Forme : Société anonyme coopérative ŕ capital variable. Sigle : SIPLEC. Administration : Administrateur : BELOOSSOFF Eric. Fondé de pouvoir ŕ procuration générale : LECLERC Michel. Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC représenté par GATTEPAILLE Jacques. Commissaire aux comptes titulaire : AMYOT EXCO. Commissaire aux comptes suppléant : HENGOAT Gilles. Directeur général délégué et administrateur : COURTOIS Régine. Administrateur : MARTY Jean Paul. Administrateur : EXMELIN Jean Jacques. Administrateur : JAUD Hervé. Administrateur : BUSSOLINI Jean Marc. Directeur général délégué et administrateur : PAYRAUDEAU Marc. Directeur général délégué et administrateur : LECUREUX Christophe. Président du conseil d'administration et directeur général : PICARD Denis. Commissaire aux comptes suppléant : JUVENTIN Chantal. Commissaire aux comptes titulaire : COGEPARC. Administrateur : DUCATEL Olivier en fonction le 18 Septembre 2007. Administrateur : GUITTARD Dominique en fonction le 19 Février 2009. Commentaires : Modification de représentant.

 

29/07/2008

C

Comptes consolidés et rapports

94 - VAL-DE-MARNE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
8972 - 315281113 RCS. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Forme : Société anonyme coopérative ŕ capital variable. Adresse : 26 quai Marcel Boyer 94200 Ivry-sur-Seine. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

 

29/07/2008

C

Comptes annuels et rapports

94 - VAL-DE-MARNE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
8971 - 315281113 RCS. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Forme : Société anonyme coopérative ŕ capital variable. Adresse : 26 quai Marcel Boyer 94200 Ivry-sur-Seine. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

 

30/11/2007

C

Avis de dépôt des comptes

11192 - 315 281 113. RCS Créteil SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Sigle: SIPLEC Forme: Société anonyme coopérative ŕ capital variable. Adresse du sičge social: 26 quai Marcel Boyer 94200 Ivry-sur-Seine. Comptes consolidés et rapport de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

 

18/10/2007

B

Modifications et mutations diverses

4172 - RCS Créteil B 315 281 113. RC 06-B 3014. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Sigle : SIPLEC. Forme : S.A. coopérative ŕ capital variable. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : directeur général délégué et administrateur partant : LESOUDIER (Ludovic). Nomination d'un administrateur : DUCATEL (Olivier).

 

30/08/2007

C

Avis de dépôt des comptes

7650 - 315 281 113. RCS Créteil SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Sigle: SIPLEC Forme: Société anonyme coopérative ŕ capital variable. Adresse du sičge social: 26 quai Marcel Boyer 94200 Ivry-sur-Seine. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

 

31/08/2006

C

Avis de dépôt des comptes

137 - RCS Nanterre B 315 281 113. RC 93-B 1283. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Forme: COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE (SOCIETE ANONYME). Adresse du sičge social: 52, rue Camille Desmoulins,92130 Issy-les-Moulineaux. Comptes consolidés et rapport de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

 

31/08/2006

C

Avis de dépôt des comptes

136 - RCS Nanterre B 315 281 113. RC 93-B 1283. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Forme: COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE (SOCIETE ANONYME). Adresse du sičge social: 52, rue Camille Desmoulins,92130 Issy-les-Moulineaux. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

 

29/08/2006

B

Modifications et mutations diverses

4222 - RCS B 315 281 113. RC 06-B 3014. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Sigle : SIPLEC. Forme : S.A. coopérative ŕ capital variable. Capital : 975 673,71 euros. Adresse du sičge social : 26 quai Marcel-Boyer, 94200 Ivry-sur-Seine. Administration : administrateurs : GOBILLOT (Michel) BELOOSSOFF (Eric). Fondé de pouvoir ŕ procuration générale : LECLERC (Michel). Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, représentée par GATTEPAILLE (Jacques). Commissaire aux comptes titulaire : AMYOT EXCO. Commissaire aux comptes suppléant : HENGOAT (Gilles). Directeurs généraux délégués et administrateurs : COURTOIS (Régine) (Nom d'usage : CUNTZMANN) LESOUDIER (Ludovic). Administrateurs : MARTY (Jean, Paul) EXMELIN (Jean, Jacques) JAUD (Hervé) BUSSOLINI (Jean, Marc). Directeurs généraux délégués et administrateurs : PAYRAUDEAU (Marc) LECUREUX (Christophe). Président du conseil d'administration et directeur général : PICARD (Denis). Commissaire aux comptes suppléant : JUVENTIN (Chantal) (Nom d'usage : SOPENA). Commissaire aux comptes titulaire : COGEPARC. Etablissement principal - Activité : importation de produits pétroliers et de produits divers. Adresse : 26 quai Marcel-Boyer, 94200 Ivry-sur-Seine. Commentaires : cette société transfčre son sičge du 52 rue Camille-Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux. Date d'effet : 1er juillet 2006.

 

20/08/2006

B

Modifications et mutations diverses

2402 - RCS Nanterre B 315 281 113. RC 93-B 1283. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Sigle : SIPLEC. Forme : S.A. coopérative ŕ capital variable. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : commissaire aux comptes suppléant partant : HEBETTE (Michel). Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : JUVENTIN (Chantal) (Nom d'usage : SOPENA).

 

27/10/2005

B

Modifications et mutations diverses

1693 - RCS Nanterre B 315 281 113. RC 93-B 1283. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Sigle : SIPLEC. Forme : S.A. coopérative ŕ capital variable. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : P.-D.G. partant : PAYRAUDEAU (Michel, Constant, Pierre). Directeur général et administrateur partant : LE GUIL (Pierre). Administrateur partant : HUET (Jean, Maurice). Modification d'un directeur général délégué et administrateur : COURTOIS (Régine) (Nom d'usage : CUNTZMANN). Nomination de directeurs généraux délégués et administrateurs : PAYRAUDEAU (Marc) LECUREUX (Christophe). Nomination du président du conseil d'administration et directeur général : PICARD (Denis).

 

25/08/2005

C

Avis de dépôt des comptes

119 - RCS Nanterre B 315 281 113. RC 93-B 1283. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC. Forme: COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE (SOCIETE ANONYME). Adresse du sičge social: 52, rue Camille Desmoulins,92130 Issy-les-Moulineaux. Comptes consolidés et rapport de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

 

 

 

Company events history

Date

Description

12/11/2010

New shareholders detected

12/11/2010

New participations in other companies

12/11/2010

New subsidiarie(s) detected

19/08/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

09/07/2010

New participations in other companies

03/05/2010

Update of participations in other companies

16/03/2010

Bodacc B: Various editing or changing

04/03/2010

Appointment/resignation of company officers

04/03/2010

Minutes of Board meeting

31/12/2009

New accounts available

15/12/2009

Legal Gazette: Appointment of the social representative

07/10/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

14/08/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

06/08/2009

Bodacc B: Various editing or changing

29/07/2009

Minutes of general meeting of shareholders

29/07/2009

Changes to the Board of Directors

29/07/2009

Private document

29/07/2009

Appointment/resignation of company officers

19/07/2009

Bodacc B: Various editing or changing

09/07/2009

Amendment

 

 

Establishment events history

Date

Description

06/05/2011

Update Rating

15/11/2010

Update Limit

19/10/2010

Update of phone numbers

03/09/2010

Update Rating

19/08/2010

Update of phone numbers

20/10/2009

Update Rating

20/10/2009

Update Limit

02/10/2009

Update Limit

06/09/2009

Update Rating

08/12/2007

Update Limit

25/01/2007

Update Limit

25/01/2007

Update Rating

20/01/2007

Update Limit

20/01/2007

Update Rating

10/01/2007

Update Limit

10/01/2007

Update Rating

 

 

Directors

 

Director

Name

M BELOOSSOFF ERIC

Manager position

Administrateur

Date of birth

15/07/1955

Place of birth

MARMANDE

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

Director

Name

SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D ACHATS DES CENTRES LECLERC

Manager position

Administrateur

Date of birth

25/01/1963

Place of birth

LANGRES

Type of manager

Moral person

Name at birth of manager

 

Director

Name

Mme CUNTZMANN RÉGINE

Manager position

Administrateur

Date of birth

09/10/1958

Place of birth

STRASBOURG

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

COURTOIS

Director

Name

M EXMELIN JEAN JACQUES

Manager position

Administrateur

Date of birth

25/12/1947

Place of birth

HOULGATE

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

Director

Name

M JAUD HERVÉ

Manager position

Administrateur

Date of birth

05/07/1964

Place of birth

LES ESSARTS

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

Director

Name

M BUSSOLINI JEAN MARC

Manager position

Administrateur

Date of birth

17/02/1960

Place of birth

LE CANNET

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

Director

Name

M PAYRAUDEAU MARC

Manager position

Administrateur

Date of birth

14/12/1962

Place of birth

NANTES

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

Director

Name

M LECUREUX CHRISTOPHE

Manager position

Administrateur

Date of birth

19/03/1960

Place of birth

STE FOY LES LYON

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

Director

Name

M PICARD DENIS

Manager position

Directeur général

Date of birth

12/06/1955

Place of birth

CHATEAU-RENAULT

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

Director

Name

M DUCATEL OLIVIER

Manager position

Administrateur

Date of birth

21/11/1965

Place of birth

LE MANS

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

Director

Name

M GUITTARD DOMINIQUE

Manager position

Administrateur

Date of birth

08/01/1954

Place of birth

AULNAY SOUS BOIS

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

Director

Name

M TAILLANDIER DANIEL

Manager position

Administrateur

Date of birth

25/09/1956

Place of birth

BOURG DES COMPTES

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

Director

Name

M VILLAT THIERRY

Manager position

Administrateur

Date of birth

02/09/1949

Place of birth

RUFFEC

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 


FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.50.28

UK Pound

1

Rs.80.08

Euro

1

Rs.68.45

 

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

----

NB

New Business

----

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

 

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.