MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :           

16.11.2011

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

ERAMET

 

 

Registered Office :

Tour Montparnasse, 33 Av Du Maine, Paris 15, 75755 Paris Cedex 15

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2010

 

 

Date of Incorporation :

September 1963

 

 

Com. Reg. No.:

RCS Paris 6 632 045 381

 

 

Legal Form :

Public limited company with board of directors

 

 

Line of Business :

Wholesale business of ores and metals

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

A

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

Fairly Large

 

Maximum Credit Limit :

2,000,000 €

Status :

Good

Payment Behaviour :

Usually Correct

Litigation :

Clear

 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – September 30th, 2011

 

Country Name

Previous Rating

                   (30.06.2011)                  

Current Rating

(30.09.2011)

France

a2

a2

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


REGISTERED NAME & COMPANY SUMMARY

 

Name

ERAMET

 

Activity (APE)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (4672Z)

(Wholesale business of ores and metals)

Legal form

Public limited company with board of directors

 

 

Phone

01 45 38 42 42

RCS Registration

RCS Paris 6 632 045 381

 

 

Fax

 

Share capital

80,866,071 Euros

 

Address

ERAMET
TOUR MONTPARNASSE
33 AV DU MAINE
PARIS 15
75755 PARIS CEDEX 15

Incorporated Date

09/1963

 

 

Nationality

France

Status

Economically active

 

 

 

Activity (APE)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (4672Z)

(Wholesale business of ores and metals)

Business Pages FT®

 

 

 

Postal Address

ERAMET
TOUR MONTPARNASSE
33 AV DU MAINE
PARIS 15
75755 PARIS CEDEX 15

Trading Address

33 AVENUE DU MAINE
75015 PARIS 15

 

 

Telephone

01 45 38 42 42

 

 

Fax

 

 

 

CREDIT RECOMENDATION

 

Current Credit Limit: 2,000,000 €

 

DIRECTORS/MANAGEMENT

 

 

Current Directors

16

 

 

Previous directors

 

Vous pouvez consulter ici l'historique des dirigeants de l'entreprise.
Si vous souhaitez consulter l'historique d'un dirigeant, il vous suffit de cliquer sur le lien voir le détail pour y accéder.

(Here you can view the history of company executives.
If you wish to view the history of a leader, you simply click on the link to see the details for access.)

 

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

 

 

Président du conseil d'administration

M JACQUES BACARDATS

 

 

 

Président du conseil d'administration

M PATRICK BUFFET

 

 

Président du conseil d'administration

M PATRICK BUFFET

 

 

Président Directeur Général

M PATRICK BUFFET

 

 

Président Directeur Général

M PATRICK BUFFET

 

 

Directeur général

M JACQUES BACARDATS

 

 

Directeur général

M PATRICK BUFFET

 

 

Directeur général

M PATRICK BUFFET

 

 

Directeur général délégué

M PATRICK ANDRE

 

 

Directeur général délégué

M GEORGES DUVAL

 

 

Directeur général délégué

M GEORGES DUVAL

 

 

Directeur général délégué

M BERTRAND MADELIN

 

 

Directeur général délégué

M BERTRAND MADELIN

 

 

Directeur général délégué

M ALAIN ROBERT

 

 

Directeur général délégué

M PHILIPPE VECTEN

 

 

Directeur général délégué

M PHILIPPE VECTEN

 

 

Administrateur

AREVA

 

 

Administrateur

AREVA

 

 

Administrateur

AREVA

 

 

Administrateur

M REMY AUTEBERT

 

 

Administrateur

M REMY AUTEBERT

 

 

Administrateur

M JACQUES BACARDATS

 

 

Administrateur

M SÉBASTIEN BERNARD DE MONTESSUS DE BALLORE-AUGIER DE CREMIERS

 

 

Administrateur

M SÉBASTIEN BERNARD DE MONTESSUS DE BALLORE-AUGIER DE CREMIERS

 

 

Administrateur

M PATRICK BUFFET

 

 

Administrateur

M CYRILLE DUVAL

 

 

Administrateur

M CYRILLE DUVAL

 

 

Administrateur

M EDOUARD DUVAL

 

 

Administrateur

M GEORGES DUVAL

 

 

Administrateur

M GEORGES DUVAL

 

 

Administrateur

M PATRICK DUVAL

 

 

Administrateur

M PATRICK DUVAL

 

 

Administrateur

M PIERRE FROGIER

 

 

Administrateur

M PIERRE-NOEL GIRAUD

 

 

Administrateur

M PIERRE-NOEL GIRAUD

 

 

Administrateur

M PIERRE-NOEL GIRAUD

 

 

Administrateur

M FRANCOIS HENROT

 

 

Administrateur

M GILBERT LEHMANN

 

 

Administrateur

M GILBERT LEHMANN

 

 

Administrateur

M JEAN-HERVE LORENZI

 

 

Administrateur

M JEAN-HERVE LORENZI

 

 

Administrateur

M JEAN-HERVÉ LORENZI

 

 

Administrateur

M LOUIS MAPOU

 

 

Administrateur

M HAROLD MARTIN

 

 

Administrateur

M HAROLD MARTIN

 

 

Administrateur

M JACQUES ROSSIGNOL

 

 

Administrateur

M JACQUES ROSSIGNOL

 

 

Administrateur

M MICHEL SOMNOLET

 

 

Administrateur

M MICHEL SOMNOLET

 

 

Administrateur

M ANTOINE TREUILLE

 

 

Administrateur

M ANTOINE TREUILLE

 

 

 

 

NEGATIVE INFORMATION

 

 

No judgment information for the company

 

 

No social security and tax office preferential right to date

 

SHARE & SHARE CAPITAL INFORMATION

 

Shareholder(s)

 

Name

AREVA

 

 

Name of representative

M BERNARD DE MONTESSUS DE BALLORE-AUGIERS DE CREMERS SEBASTIEN

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

02/12/1974

 

 

Place of birth

PARIS 75014

 

 

 

Type of manager

Moral person

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

SORAME

 

 

Name of representative

M DUVAL CYRILLE

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

18/07/1948

 

 

Place of birth

NEUILLY-SUR-SEINE 92200

 

 

 

Type of manager

Moral person

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

CEIR

 

 

Name of representative

M DUVAL PATRICK

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

15/05/1941

 

 

Place of birth

BELLERIVE-SUR-ALLIER 03700

 

 

 

Type of manager

Moral person

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. MADELIN BERTRAND

 

 

Manager position

Directeur général délégué

Date of birth

13/09/1954

 

 

Place of birth

LA ROCHELLE (17000)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. BUFFET PATRICK

 

 

Manager position

Président du conseil d'administration, Directeur général

Date of birth

19/10/1953

 

 

Place of birth

LYON (69006)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. DUVAL GEORGES

 

 

Manager position

Directeur général délégué, Administrateur

Date of birth

03/05/1946

 

 

Place of birth

ST CLOUD (92210)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. SOMNOLET MICHEL

 

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

06/02/1940

 

 

Place of birth

CHATEAU RENAULT (37110)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. LEHMANN GILBERT

 

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

28/09/1945

 

 

Place of birth

LYON (69006)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

Name

M. LORENZI JEAN-HERVÉ

 

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

24/07/1947

 

 

Place of birth

TOULON (83000)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. VECTEN PHILIPPE

 

 

Manager position

Directeur général délégué

Date of birth

22/04/1949

 

 

Place of birth

ST SOUPPLETS (77165)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. QUINTARD MICHEL

 

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

01/08/1946

 

 

Place of birth

BONE(ALGERIE)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

Name

Mme. MILSAN ASTRID

 

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

21/11/1971

 

 

Place of birth

NEUILLY-SUR-SEINE (92200)

 

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. MAPOU LOUIS

 

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

14/11/1958

 

 

Place of birth

YATE (98834)

 

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

Mme. SAINT-M'LEUX MANOELLE

 

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

08/05/1959

 

 

Place of birth

WOONSOCKET RODE ISLAND(ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

 

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

LEPOUTRE

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. TONA FREDERIC

 

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

27/08/1947

 

 

Place of birth

PARIS (75014)

 

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

PAYMENT INFORMATION

 

Na

 

 

GROUP STRUCTURE & AFFILIATED COMPANIES

 

 

Ultimate Holding Company

 

Company Name

Safe Number

 

Company number

Click here to view the affiliation links

 

ERAMET

FR11801203

 

632045381

12 companies in 7 countries. Click here to visit linked companies

 

 

 

Ultimate Parent

1 ultimate parent company for this company
>  ERAMET  - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (4672Z)  in PARIS 15  (75015)

 

 

FINANCIAL INFORMATION

 

 

Trading to Date

12/31/2010

12/31/2009

12/31/2008

 

 

Turnover

1,067,013,000 €

751,791,000 €

1,033,393,000 €

 

 

Gross Operating Surplus

-1,86 % Turnover

-1,16 % Turnover

1,67 % Turnover

 

Net worth

1,346,789,000 €

1,211,486,000 €

1,361,449,000 €

 

Employees

250 to 499 employees

-

-

 

 

Trends

 

 

 

Profitability

 

 

Liquidity

 

Net worth

accounts

 

Active Account |  Passive Account |  Account Results

 

Synthesized Accounts

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

Comparison mode

Average

Median

 

 

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

 

Account period (month)

12

 

12

 

12

 

 

Account Type

Normal

 

Normal

 

Normal

 

 

Deposit date

06/07/2011

 

29/06/2010

 

-

 

 

Activity Code

4672Z

 

4672Z

 

4672Z

 

 

Employees

381

 

383

 

369

 

 


Active account

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

2 015 510 000

-4,6%

2 113 753 000

2,8%

2 055 207 000

60 802,50

3314747,3%

- Intangible assets

4 965 000

622,7%

687 000

-66,8%

2 071 000

0

0%

- Tangible assets

25 185 000

-3,1%

25 989 000

-5,7%

27 567 000

25 260,50

99601,1%

- Financial assets

1 985 360 000

-4,9%

2 087 077 000

3,0%

2 025 569 000

3 332

59584533,9%

Net current assets

253 105 000

33,0%

190 304 000

-12,5%

217 407 000

850 701

29652,5%

- Stocks

121 449 000

49,8%

81 087 000

-3,4%

83 928 000

154 681

78415,8%

- Advanced payments

2 688 000

33,0%

2 001 000

-21,8%

2 558 000

0

0%

- Receivables

123 658 000

17,2%

105 542 000

-19,4%

130 872 000

380 776

32375,3%

- Securities and cash

5 310 000

217,2%

1 674 000

3316,3%

49 000

120 779,50

4296,4%

- Prepaid expenses

-

-

-

-

-

115

-

Accounts of regularization

25 000

-72,8%

92 000

-70,5%

312 000

0

0%

Total Assets

2 268 640 000

-1,5%

2 304 150 000

1,4%

2 272 926 000

1 094 322

207210,1%


Passive Account

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Shareholders' equity

1 346 789 000

11,2%

1 211 486 000

-11,0%

1 361 449 000

394 686,50

341130,1%

Share capital

80 866 000

0,5%

80 428 000

0,6%

79 957 000

76 514,50

105587,2%

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

16 078 000

-1,5%

16 331 000

-40,8%

27 563 000

0

0%

Liabilities

905 772 000

-15,8%

1 076 332 000

21,8%

883 917 000

567 913,50

159391,2%

- Financial liabilities

663 127 000

-28,9%

932 957 000

20,0%

777 380 000

42 862

1547021,0%

- Advanced payments received

7 666 000

614,4%

1 073 000

423,4%

205 000

0

0%

- Trade account payables

209 220 000

76,8%

118 331 000

30,5%

90 703 000

252 010,50

82920,4%

- Tax and social liabilities

14 597 000

30,1%

11 216 000

-14,9%

13 177 000

105 241

13770,1%

- Other debts and fixed assets liabilities

11 142 000

-12,5%

12 735 000

423,6%

2 432 000

4 804

231831,7%

Account regularization

20 000

0%

20 000

0%

20 000

0

0%

Total liabilities

2 268 640 000

-1,5%

2 304 150 000

1,4%

2 272 926 000

1 094 322

207210,1%


Results

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Sales of Goods

1 090 870 000

44,0%

757 525 000

-27,1%

1 039 367 000

1 933 358,50

56323,6%

Net turnover

1 067 013 000

41,9%

751 791 000

-27,3%

1 033 393 000

1 881 776,50

56602,4%

- of which net export turnover

0

0%

0

0%

0

1 498

0%

Operating charges

1 121 552 000

44,6%

775 562 000

-24,2%

1 023 173 000

1 844 186,50

60715,5%

Operating profit/loss

-30 682 000

-70,1%

-18 037 000

-211,4%

16 194 000

67 354

-45653,3%

Financial income

96 579 000

248,8%

27 685 000

-88,1%

232 190 000

368,50

26208583,9%

Financial charges

0

0%

0

0%

100 376 000

4 692,50

0%

Financial profit/loss

96 579 000

248,8%

27 685 000

-79,0%

131 814 000

-788

12256318,3%

Pretax net operating income

65 897 000

583,0%

9 648 000

-93,5%

148 008 000

57 216

115072,3%

Extraordinary income

74 544 000

0%

0

0%

20 594 000

667,50

11167540,4%

Extraordinary charges

0

0%

45 444 000

23,1%

36 914 000

519

0%

Extraordinary profit/loss

74 544 000

421,5%

-45 444 000

-178,5%

-16 320 000

0

0%

Net result

146 112 000

588,0%

-29 943 000

-120,2%

148 159 000

52 004

280863,0%


 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

 

Normal Account

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Months

 

12

 

12

 

12


Accounts - Active
Current Assets |  Equalization accounts |  Reference

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Grand Total (I to VI)

Net

2 268 640 000

-1,5%

2 304 150 000

1,4%

2 272 926 000

 

Gross

CO

2 479 476 000

-2,1%

2 533 035 000

7,0%

2 367 916 000

 

Amortisation

1A

210 836 000

-7,9%

228 885 000

141,0%

94 990 000


Non declared distributed capital (I)

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AA

0

0%

0

-

0


Active fixed asset (II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total Active fixed asset (II)

Net

2 015 510 000

-4,6%

2 113 753 000

2,8%

2 055 207 000

 

Gross

BJ

2 210 866 000

-5,0%

2 327 691 000

8,5%

2 146 053 000

 

Amortisation

BK

195 356 000

-8,7%

213 938 000

135,5%

90 846 000


Intangilble fixed assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R & D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AE

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

258 000

5,3%

245 000

-70,9%

843 000

 

Gross

AF

8 482 000

7,4%

7 900 000

5,0%

7 527 000

 

Amortisation

AG

8 224 000

7,4%

7 655 000

14,5%

6 684 000

Goodwill

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AH

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AI

0

0%

0

0%

0

Other intangible fixed assets

Net

4 707 000

964,9%

442 000

-64,0%

1 228 000

 

Gross

AJ

6 635 000

182,9%

2 345 000

91,0%

1 228 000

 

Amortisation

AK

1 928 000

1,3%

1 903 000

0%

0

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible Assets

Net

4 965 000

622,7%

687 000

-66,8%

2 071 000



Tangilble fixed assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Lands

Net

1 131 000

0%

1 131 000

0%

1 131 000

 

Gross

AN

1 131 000

0%

1 131 000

0%

1 131 000

 

Amortisation

AO

0

0%

0

0%

0

Buildings

Net

7 442 000

-8,6%

8 143 000

-11,0%

9 145 000

 

Gross

AP

22 963 000

1,8%

22 556 000

0,4%

22 465 000

 

Amortisation

AQ

15 521 000

7,7%

14 413 000

8,2%

13 320 000

Plant

Net

12 771 000

3,4%

12 354 000

-2,5%

12 665 000

 

Gross

AR

57 074 000

4,3%

54 720 000

3,1%

53 069 000

 

Amortisation

AS

44 303 000

4,6%

42 366 000

4,9%

40 404 000

Other tangible fixed assets

Net

3 434 000

-10,7%

3 845 000

-10,5%

4 295 000

 

Gross

AT

10 769 000

3,7%

10 383 000

3,1%

10 071 000

 

Amortisation

AU

7 335 000

12,2%

6 538 000

13,2%

5 776 000

Fixed assets in construction

Net

319 000

-25,5%

428 000

76,9%

242 000

 

Gross

AV

319 000

-25,5%

428 000

76,9%

242 000

 

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

88 000

0%

88 000

-1,1%

89 000

 

Gross

AX

88 000

0%

88 000

-1,1%

89 000

 

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Tangible asset

Net

25 185 000

 

25 989 000

 

27 567 000



Financial assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

1 539 505 000

2,1%

1 508 190 000

-9,1%

1 659 383 000

 

Gross

CU

1 636 989 000

0,1%

1 635 874 000

-2,3%

1 674 367 000

 

Amortisation

CV

97 484 000

-23,7%

127 684 000

752,1%

14 984 000

Inter-company receivables

Net

424 736 000

-22,7%

549 121 000

94,8%

281 878 000

 

Gross

BB

424 736 000

-22,7%

549 121 000

94,8%

281 878 000

 

Amortisation

BC

0

0%

0

0%

0

Other investment securities

Net

6 859 000

-20,1%

8 580 000

-84,0%

53 768 000

 

Gross

BD

14 077 000

64,1%

8 580 000

-86,5%

63 446 000

 

Amortisation

BE

7 218 000

0%

0

0%

9 678 000

Loans

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BF

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BG

0

 

0

 

0

Other financial assets

Net

14 260 000

-32,7%

21 186 000

-30,6%

30 540 000

 

Gross

BH

27 603 000

-20,1%

34 565 000

13,2%

30 540 000

 

Amortisation

BI

13 343 000

-0,3%

13 379 000

0%

0

 

Sub Total Financial Assets

 

1 985 360 000

 

2 087 077 000

 

2 025 569 000

 

Current Assets (III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total Assets

Net

253 105 000

33,0%

190 304 000

-12,5%

217 407 000

 

Gross

CJ

268 586 000

30,9%

205 250 000

-7,4%

221 551 000

 

Amortisation

CK

15 481 000

3,6%

14 946 000

260,7%

4 144 000



Stocks

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Raw materials

Net

44 293 000

93,9%

22 839 000

6,2%

21 513 000

 

Gross

BL

48 132 000

80,1%

26 722 000

7,4%

24 883 000

 

Amortisation

BM

3 839 000

-1,1%

3 883 000

15,2%

3 370 000

Work in progress (goods)

Net

11 024 000

48,8%

7 410 000

0%

0

 

Gross

BN

11 024 000

48,8%

7 410 000

0%

0

 

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

6 051 000

 

Gross

BP

0

0%

0

0%

6 051 000

 

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

23 125 000

23,5%

18 729 000

-9,7%

20 749 000

 

Gross

BR

23 125 000

23,5%

18 729 000

-9,7%

20 749 000

 

Amortisation

BS

0

0%

0

0%

0

Goods for resale

Net

43 007 000

33,9%

32 109 000

-9,8%

35 615 000

 

Gross

BT

43 007 000

33,9%

32 109 000

-9,8%

35 615 000

 

Amortisation

BU

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Stocks

Net

121 449 000

49,8%

81 087 000

-3,4%

83 928 000



Advance payments to suppliers

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Advance payments to suppliers

Net

2 688 000

34,3%

2 001 000

-21,8%

2 558 000

 

Gross

BV

2 688 000

34,3%

2 001 000

-21,8%

2 558 000

 

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0



Debtors

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Trade accounts receivable

Net

103 210 000

17,1%

88 105 000

33,3%

66 088 000

 

Gross

BX

103 979 000

17,0%

88 874 000

32,9%

66 862 000

 

Amortisation

BY

769 000

0%

769 000

-0,6%

774 000

Other debtors

Net

14 003 000

-11,9%

15 894 000

-75,0%

63 620 000

 

Gross

BZ

24 876 000

-5,0%

26 188 000

-58,8%

63 620 000

 

Amortisation

CA

10 873 000

5,6%

10 294 000

0%

0

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Debtors

Net

117 213 000

12,7%

103 999 000

-19,8%

129 708 000



Divers

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CD

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

5 310 000

217,2%

1 674 000

3316,3%

49 000

 

Gross

CF

5 310 000

217,2%

1 674 000

3316,3%

49 000

 

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Divers

Net

5 310 000

217,2%

1 674 000

3316,3%

49 000



Prepaid expenses

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Prepaid expenses

Net

6 445 000

317,7%

1 543 000

32,6%

1 164 000

 

Gross

CH

6 445 000

317,7%

1 543 000

32,6%

1 164 000

 

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts (IV to VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Multi-period charges

CW3

25 000

-72,8%

92 000

-70,5%

312 000

 

Gross

 

25 000

-72,8%

92 000

-

-

 

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

-

-

 

Currency differential gain

CN3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

-

-

 

References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

 

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Accounts - Passive
Other capital resources | Provisions for risks and charges | Liabilities | Translation loss | Equalization accounts | References

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Grand Total (I to V)

EE

2 268 640 000

-1,5%

2 304 150 000

1,4%

2 272 926 000


Shareholder Equity (I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total shareholders' equity (Total I)

DL

1 346 789 000

11,2%

1 211 486 000

-11,0%

1 361 449 000

 

Equity and shareholders' equity

DA

80 866 000

0,5%

80 428 000

0,6%

79 957 000

 

Issue and merger premiums

DB

371 505 000

8,9%

341 255 000

-1,0%

344 835 000

 

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

 

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

 

Legal reserve

DD

7 996 000

0%

7 996 000

1,2%

7 901 000

 

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

 

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

 

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

 

Other reserves

DG

253 839 000

0%

253 839 000

0%

253 839 000

 

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

 

0

0%

0

 

Profits or losses brought forward

DH

406 299 000

-16,0%

483 564 000

2,6%

471 252 000

 

Profit or loss for the period

DI

146 112 000

588,0%

-29 942 000

-120,2%

148 159 000

 

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

 

Special tax-allowable reserves

DK

80 172 000

7,8%

74 346 000

33,9%

55 506 000

 

Other capital resources (II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

 

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

 

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

 

Provisions for risks and charges (III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

16 078 000

-1,5%

16 331 000

-40,8%

27 563 000

 

Risk provisions

DP

10 106 000

-10,4%

11 284 000

-49,2%

22 226 000

 

Reserves for charges

DQ

5 972 000

18,3%

5 047 000

-5,4%

5 337 000

 

Liabilities (IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total Liabilities (Total IV)

EC

905 772 000

-15,8%

1 076 332 000

21,8%

883 917 000

 

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

 

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

 

Bank loans and liabilities

DU

329 000

149,2%

132 000

-81,5%

714 000

 

Sundry loans and financial liabilities

DV

662 798 000

-28,9%

932 825 000

20,1%

776 666 000

 

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

 

Advance payments received for current orders

DW

7 666 000

614,4%

1 073 000

423,4%

205 000

 

Trade accounts payables

DX

209 220 000

76,8%

118 331 000

30,5%

90 703 000

 

Tax and social security liabilities

DY

14 597 000

30,1%

11 216 000

-14,9%

13 177 000

 

Fixed asset liabilities

DZ

1 657 000

70,3%

973 000

-8,6%

1 065 000

 

Other debts

EA

9 485 000

-19,4%

11 762 000

760,4%

1 367 000

 

Translation loss (V)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Translation loss (Total V)

ED

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Deferred income

EB

20 000

0%

20 000

0%

20 000

 

References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

 

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

 

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Result account
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges | Financial income | Financial charges | Financial charges | Extraordinary charges | Employee profit sharing | Tax on profits | References

1- Operating result (I-II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Operating result (Total I-II)

GG

-30 682 000

-70,1%

-18 037 000

-211,4%

16 194 000


2 - Financial result (V - VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Financial result (Total V-VI)

GV

96 579 000

248,8%

27 685 000

-79,0%

131 814 000


3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

65 897 000

583,0%

9 648 000

-93,5%

148 008 000


4 - Extraordinary result (VII-VIII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

74 544 000

264,0%

-45 444 000

-178,5%

-16 320 000


Profit or loss

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Profit or loss

HN

146 112 000

588,0%

-29 943 000

-120,2%

148 159 000


Total Income (I+III+V+VII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total Income (I+III+V+VII)

HL

1 261 993 000

60,7%

785 210 000

-39,2%

1 292 151 000


Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

1 115 880 000

36,9%

815 153 000

-28,7%

1 143 992 000


Operating income (I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total operating income (Total I)

FR

1 090 870 000

44,0%

757 525 000

-27,1%

1 039 367 000


Operating income (details)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sale of goods for resale

FC

1 010 587 000

46,8%

688 211 000

-29,2%

972 524 000

 

France

FA

1 010 587 000

46,8%

688 211 000

-29,2%

972 524 000

 

Export

FB

0

0%

0

0%

0

Sale of goods produced

FF

0

0%

0

0%

0

 

France

FD

0

0%

0

0%

0

 

Export

FE

0

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

56 426 000

-11,3%

63 580 000

4,5%

60 869 000

 

France

FG

56 426 000

-11,3%

63 580 000

4,5%

60 869 000

 

Export

FH

0

0%

0

0%

0

Net turnover

FL

1 067 013 000

41,9%

751 791 000

-27,3%

1 033 393 000

 

France

FJ

1 067 013 000

41,9%

751 791 000

-27,3%

1 033 393 000

 

Export

FK

0

0%

0

0%

0

 

Stocked production

FM

8 011 000

1312,0%

-661 000

89,0%

-6 021 000

 

Self-constructed assets

FN

2 877 000

4194,0%

67 000

-11,8%

76 000

 

Operating grants

FO

51 000

121,7%

23 000

-8,0%

25 000

 

Release of reserves and provisions

FP

12 918 000

108,5%

6 195 000

-47,9%

11 893 000

 

Other income

FQ

0

0%

110 000

10900%

1 000


Operating charges (II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total operating charges (Total II)

GF

1 121 552 000

44,6%

775 562 000

-24,2%

1 023 173 000


Exploitation charges

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Purchase of goods for resale

FS

755 574 000

51,5%

498 678 000

-27,9%

692 118 000

 

Change in stocks of goods for resale

FT

-10 898 000

-410,8%

3 506 000

-90,9%

38 410 000

 

Purchase of raw materials

FU

246 619 000

70,0%

145 100 000

-4,0%

151 132 000

 

Change in stocks of raw materials

FV

-21 410 000

-1064,9%

-1 838 000

-107,6%

24 073 000

 

Other external purchases and charges

FW

76 268 000

13,5%

67 170 000

1,5%

66 158 000

 

Tax, duty and similar payments

FX

2 836 000

-44,4%

5 099 000

17,4%

4 344 000

 

Payroll

FY

26 645 000

-0,5%

26 770 000

17,8%

22 726 000

 

Social security costs

FZ

22 171 000

43,2%

15 478 000

37,6%

11 250 000


Depreciation

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Depreciation of fixed assets

GA

4 732 000

-7,3%

5 104 000

-4,8%

5 360 000

 

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

0

 

Depreciation/amortisation of current assets

GC

3 839 000

-2,2%

3 925 000

16,5%

3 370 000

 

Provisions for risks and charges

GD

13 227 000

319,8%

3 151 000

526,4%

503 000


Other charges

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Other charges

GE

1 949 000

-43,0%

3 419 000

-8,3%

3 729 000

 

Operating charges (III-IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

 

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

 

Financial income (V)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total financial income (Total V)

GP

96 579 000

248,8%

27 685 000

-88,1%

232 190 000

 

Share financial income

GJ

0

0%

0

0%

210 492 000

 

Other investment income & capitalised receivables

GK

0

0%

0

0%

0

 

Other interest and similar income

GL

96 579 000

248,8%

27 685 000

1440,6%

1 797 000

 

Released provisions and transferred charges

GM

0

0%

0

0%

0

 

Exchange gains

GN

0

0%

0

0%

19 901 000

 

Net income from disposal of investment securities

GO

0

0%

0

0%

0

 

Financial Charge (VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total financial charge (Total VI)

GU

0

0%

0

0%

100 376 000

 

Financial reserves and provisions

GQ

0

0%

0

0%

31 905 000

 

Interest and similar charges

GR

0

0%

0

0%

25 340 000

 

Exchange losses

GS

0

0%

0

0%

43 131 000

 

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

 

Financial Charge (VII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total extraordinary income (Total VII)

HD

74 544 000

0%

0

0%

20 594 000

 

Extraordinary operating income

HA

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary income from capital transactions

HB

74 544 000

0%

0

0%

191 000

 

Released provisions and transferred charges

HC

0

0%

0

0%

20 403 000

 

Extraordinary charges (VIII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

0

0%

45 444 000

23,1%

36 914 000

 

Extraordinary operating charges

HE

0

0%

0

0%

21 196 000

 

Extraordinary charges from capital transactions

HF

0

0%

45 444 000

197482,6%

23 000

 

Extraordinary reserves and provisions

HG

0

0%

0

0%

15 695 000

 

Employee profit sharing (IX)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

4 228 000

629,0%

580 000

-83,9%

3 605 000

 

Tax on profits (X)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Tax on profits (Total X)

HK

-9 900 000

-53,9%

-6 433 000

68,0%

-20 076 000

 

References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

 

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

 

Of which transferred charges

A1

0

0%

0

0%

0

 

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

 

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Other incomer tax return forms
Reserve for depreciation | Provisions included in balance sheet | State deadlines claims and debts at the end of period
Table allocation results and other information

Fixed Assets
Grand Total Fixed Assets (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

1 585 647 000

 

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

626 923 000

 

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

OK2

225 728 000

-14,1%

262 741 000

294,5%

66 605 000

 

Gross value at the end of period

OL

2 210 866 000

-5,0%

2 327 604 000

8,5%

2 145 964 000


Research and development Charge (Total I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

C01

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

C02

0

0%

0

0%

0

 

Gross value at the end of period

D0

0

0%

0

0%

0


Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

KD

10 245 000

17,0%

8 755 000

39,8%

6 264 000

 

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

4 870 000

223,2%

1 507 000

-42,0%

2 599 000

 

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

LV2

-1 000

-105,9%

17 000

-84,3%

108 000

 

Gross value at the end of period

LW

15 116 000

47,5%

10 245 000

17,0%

8 755 000


Tangible fixed assets (Total III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

LN

89 306 000

2,7%

86 978 000

5,0%

82 842 000

 

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

3 269 000

33,6%

2 447 000

-46,1%

4 543 000

 

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NG2

231 000

12,1%

206 000

-49,3%

406 000

 

Gross value at the end of period

NH

92 344 000

3,5%

89 218 000

2,6%

86 979 000


Fiancial assets (Total IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

LQ

2 228 140 000

8,7%

2 050 231 000

37,0%

1 496 541 000

 

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

100 762 000

-77,1%

440 427 000

-28,9%

619 781 000

 

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NJ2

225 497 000

-14,1%

262 518 000

297,2%

66 091 000

 

Gross value at the end of period

NK

2 103 405 000

-5,6%

2 228 140 000

8,7%

2 050 231 000

 

Reserve for depreciation
Situation and movement of reserve for depreciation
Grand total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

0N

0

0%

0

0%

61 313 000

Increases

0P

0

0%

0

0%

5 361 000

Decreasess

0Q

0

0%

0

0%

490 000

 

Reserve for depreciation value at the end of period

0R

0

0%

0

0%

66 184 000


Research and development charge (Total I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0


Other intangible assets (Total II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

9 558 000

43,0%

6 684 000

22,0%

5 480 000

Increases

PF

594 000

-79,5%

2 891 000

123,1%

1 296 000

Decreasess

PG

0

0%

17 000

-81,5%

92 000

 

Decreasess by budget item transfer

PH

10 152 000

6,2%

9 558 000

43,0%

6 684 000


Total fixed assets amotisation (Total III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

63 317 000

6,4%

59 500 000

6,6%

55 833 000

Increases

QV

4 163 000

1,2%

4 115 000

1,2%

4 065 000

Decreases

QW

321 000

7,4%

299 000

-24,9%

398 000

 

Decreasess by budget item transfer

QX

67 159 000

6,1%

63 316 000

6,4%

59 500 000


Movements during period affecting charge allocated over several period
Charges à répartir ou frais d'émission d'emprunt

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0


Premium refund of obligations

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Net value at begining of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

 

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

 

Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

7C

231 740 000

115,1%

107 732 000

48,3%

72 669 000

Increases

UB

33 791 000

-78,7%

158 922 000

266,0%

43 421 000

Decreases

UC

51 236 000

44,8%

35 378 000

22,5%

28 877 000

 

Value at the end of period

UD

214 295 000

-7,3%

231 276 000

165,2%

87 213 000

Includes Total allocations

 

Operating

UE

0

0%

0

0%

0

 

Financial

UG

0

0%

0

0%

0

 

Exceptional

UJ

0

0%

0

0%

0

Includes Total Withdrawal

 

Operating

UF

0

0%

0

0%

0

 

Financial

UH

0

0%

0

0%

0

 

Exceptional

UK

0

0%

0

0%

0


Total regulated provisions (Total I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

3Z

74 346 000

33,9%

55 506 000

4,0%

53 387 000

Increases

TS

19 139 000

1,6%

18 840 000

647,0%

2 522 000

Decreases

TT

13 313 000

0%

0

0%

403 000

 

Value at the end of period

TU

80 172 000

7,8%

74 346 000

33,9%

55 506 000


Total risk and charge provisions (Total II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

5Z

16 331 000

-40,8%

27 564 000

278,7%

7 279 000

Increases

TV

14 647 000

25,2%

11 703 000

-71,2%

40 661 000

Decreases

TW

14 900 000

-36,3%

23 400 000

14,8%

20 377 000

 

Value at the end of period

TX

16 078 000

1,3%

15 867 000

-42,4%

27 563 000


Total Provision for depreciation (Total III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

7B

141 063 000

472,0%

24 662 000

105,5%

12 003 000

Increases

TY

5 000

-100,0%

128 379 000

53840,8%

238 000

Decreases

TZ

23 023 000

92,2%

11 978 000

47,9%

8 097 000

 

Value at the end of period

UA

118 045 000

-16,3%

141 063 000

3304,0%

4 144 000

 

State deadlines claims and debts at the end of period
State claims

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Gross value

VT

587 639 000

-16,1%

700 292 000

57,7%

444 064 000

 

1 year at most

VU

586 711 000

-16,1%

699 416 000

57,5%

444 064 000

 

More than one year

VV

928 000

5,9%

876 000

0%

0


State of loans

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Claims related to holdings (gross)

UL

424 736 000

-22,7%

549 121 000

94,8%

281 878 000

 

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

424 736 000

-22,7%

549 121 000

94,8%

281 878 000

 

Loans (gross)

UP

0

0%

0

0%

0

 

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

0

0%

0

 

Other financial assets (gross)

UT

27 602 000

-9,9%

30 638 000

18,8%

25 781 000

 

Other financial assets (1 year at most)

UV

27 602 000

-9,9%

30 638 000

18,8%

25 781 000


Receivables statement of assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Customers doubtful or disputed

VA

0

0%

0

0%

0

 

Other claims customer

UX

103 979 000

17,0%

88 874 000

0%

0

 

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

 

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

 

Personnel and associated accounts

UY

0

0%

0

0%

0

 

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

0

0%

0

 

Income taxes

VM

0

0%

0

0%

0

 

Value added tax

VB

0

0%

0

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

VN

0

0%

0

0%

0

 

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

0

0%

0

 

Group and Associates

VC

0

0%

0

0%

0

 

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

24 876 000

-17,4%

30 114 000

0%

0


Prepaid

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Prepaid

VS

6 445 000

317,7%

1 543 000

32,6%

1 164 000


State Debt

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total debt (gross)

VY

898 107 000

-16,5%

1 075 260 000

21,7%

883 712 000

1 year at most

VZ2

898 107 000

-16,5%

1 075 291 000

21,7%

883 712 000

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

0

0%

-31 000

0%

0

More than 5 years

VZ4

0

0%

0

0%

0


Details

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

329 000

149,2%

132 000

-81,5%

714 000

1 year at most

VG2

329 000

149,2%

132 000

-81,5%

714 000

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VH2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

662 797 000

-28,9%

932 825 000

20,1%

776 666 000

1 year at most

8A2

662 797 000

-28,9%

932 825 000

20,1%

776 666 000

More than 1 year and 5 years at most

8A3

0

0%

0

0%

0

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

209 220 000

76,8%

118 331 000

30,5%

90 703 000

1 year at most

8B2

209 220 000

76,8%

118 331 000

30,5%

90 703 000

More than 1 year and 5 years at most

8B3

209 220 000

76,8%

118 331 000

0%

0

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8C2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

14 597 000

30,1%

11 216 000

-14,9%

13 177 000

1 year at most

8D2

14 597 000

30,1%

11 216 000

-14,9%

13 177 000

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (gross)

VW1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VW2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VQ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

1 657 000

70,3%

973 000

-8,6%

1 065 000

1 year at most

8J2

1 657 000

70,3%

973 000

-8,6%

1 065 000

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VI2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More 5 years

VI4

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

9 485 000

-19,4%

11 762 000

760,4%

1 367 000

1 year at most

8K2

9 485 000

-19,4%

11 762 000

760,4%

1 367 000

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

20 000

0%

20 000

0%

20 000

1 year at most

8L2

20 000

0%

20 000

0%

20 000

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0


References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Loans made during the period

VJ

0

0%

0

0%

0

 

Debt repaid during the period

VK

0

0%

0

0%

0

 

Table allocation results and other information
Dividends distributed

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0


Commitments

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

 

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

6 259 000

 

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0


Other charges Externes

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

 

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

 

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

 

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

 

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

 

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

 

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0


Taxes and Fees

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

 

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0


VAT

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

 

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0


Average number of employees

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Average number of employees

YP

381

-0,5%

383

3,8%

369


Groups and Shareholders

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Groups and Shareholders

ZR

0

-

0

-

-

 

 

 

Display parameter

Comparison mode

Average

Median


Ratios
Structure and liquidity | Management or rotation | Profitability of the business | Return on capital

Structure and Liquidity

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Fixed Asset Financing

1

-2,0%

1,02

-2,9%

1,05

3,29

-69,6%

Global Debt

306 days

-40,6%

515 days

67,2%

308 days

101 days

203,0%

Working Capital Fund overall net

4 days

-82,6%

23 days

-41,0%

39 days

71,50 days

-94,4%

Financial independence

409358,36%

-55,4%

917792,42%

381,3%

190679,13%

1456,81%

27999,6%

More ratios

Solvability

59,37%

12,9%

52,58%

-12,2%

59,90%

42,60%

39,4%

Capacity debt futures

409358,36%

-55,4%

917792,42%

381,3%

190679,13%

4125,02%

9823,8%

Coverage of current assets by net working capital overall

4%

-82,7%

23,08%

-54,3%

50,45%

47,07%

-91,5%

General Liquidity

0,65

0%

0,65

30,0%

0,50

0,82

-20,7%

Restricted Liquidity

0,66

1,5%

0,65

30,0%

0,50

1,26

-47,6%


Management or rotation

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Need background in operating working capital

0 days

0%

21 days

-44,7%

38 days

42 days

0%

Treasury

2 days

100%

1 days

0%

0 days

19 days

-89,5%

Inventory turnover of goods

21 days

-8,7%

23 days

27,8%

18 days

56 days

-62,5%

Average length of credit granted to customers

35 days

-18,6%

43 days

87,0%

23 days

64 days

-45,3%

Average length of credit obtained suppliers

72 days

20,0%

60 days

76,5%

34 days

60 days

20,0%

More ratios

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

70 days

6,1%

66 days

11,9%

59 days

0 days

0%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

days

-

days

-

days

794 days

-

Rotation tangible assets

1155,48%

37,1%

842,64%

-29,1%

1188,09%

1322,02%

-12,6%


Profitability of the business

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Margin trading

24,92%

0,7%

24,74%

5,6%

23,42

20,07%

24,2%

Profitability of the business

-1,86

-60,3%

-1,16

-169,5%

1,67

4,29%

-143,4%

Net profit

13,69%

444,0%

-3,98%

-127,8%

14,34%

3,05%

348,9%

More ratios

Growth rate of turnover (excluding VAT)

41,93%

253,9%

-27,25%

-10,9%

-24,57%

9,08%

361,8%

Rates integration

2,98%

-41,9%

5,13%

-4,6%

5,38%

17,60%

-83,1%

Rate leasing furniture

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Work Factor

153,76%

40,4%

109,50%

79,0%

61,16%

61,63%

149,5%

Weight interests

0

0%

0%

0%

9,71%

0,20%

0%


Return on capital

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Cash flow from the overall profitability

7,15%

160,9%

2,74%

-85,9%

19,45%

3,21%

122,7%

Rates of economic profitability

-1%

0%

0%

0%

1%

15%

-106,7%

Financial profitability

1346789000%

11,2%

1211486000%

-11,0%

1361449000%

394686,50%

341130,1%

Return on investment

7,27%

619,3%

-1,40%

-112,0%

11,62%

12,53%

-42,0%

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

Comparison mode

Average

Median


Soldes Intermédiaires de Gestion

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Turnover

1 067 013 000

41,9%

751 791 000

-27,3%

1 033 393 000

1 881 776 € 

56602,4% 

 

Sales of goods

1 010 587 000

46,8%

688 211 000

-29,2%

972 524 000

 

 

- Purchase of goods

755 574 000

51,5%

498 678 000

-27,9%

692 118 000

 

 

+/- Stock of goods variation

-10 898 000

-410,8%

3 506 000

-90,9%

38 410 000

 

 

Trading margin

265 911 000 €

42,9%

186 027 000 €

-23,1%

241 996 000 €

333 525,50 € 

79627,3% 

 

24,92 % CA

0,7%

24,74 % CA

5,6%

23,42 % CA

20,39 % CA 

22,2% 

 

Sale of goods produced

56 426 000

-11,3%

63 580 000

4,5%

60 869 000

 

 

+/- Stocked production

8 011 000

1312,0%

-661 000

89,0%

-6 021 000

 

 

+ Self-constructed assets

2 877 000

4194,0%

67 000

-11,8%

76 000

 

 

Period production

67 314 000 €

6,9%

62 986 000 €

14,7%

54 924 000 €

46 334,50 € 

145178,4% 

 

6,31 % CA

-24,7%

8,38 % CA

57,8%

5,31 % CA

2,25 % CA 

180,4% 

 

Trading margin

265 911 000

42,9%

186 027 000

-23,1%

241 996 000

333 525,50 

79627,3% 

+ Period Production

67 314 000

6,9%

62 986 000

14,7%

54 924 000

46 334,50 

145178,4% 

- Purchase of raw materials

246 619 000

70,0%

145 100 000

-4,0%

151 132 000

 

 

+/- Change in stocks of raw materiels

-21 410 000

-1064,9%

-1 838 000

-107,6%

24 073 000

 

 

- Other external purchases and charges

76 268 000

13,5%

67 170 000

1,5%

66 158 000

 

 

Added value

31 748 000 €

-17,7%

38 581 000 €

-30,6%

55 557 000 €

324 153,50 € 

9694,1% 

 

2,98 % CA

-41,9%

5,13 % CA

-4,6%

5,38 % CA

17,60 % CA 

-83,1% 

 

Added value

31 748 000 €

-17,7%

38 581 000 €

-30,6%

55 557 000 €

324 153,50 € 

9694,1% 

+ Operating grants

51 000

121,7%

23 000

-8,0%

25 000

 

 

- Tax, duty and similar payments

2 836 000

-44,4%

5 099 000

17,4%

4 344 000

 

 

- Personal charges

48 816 000

15,5%

42 248 000

24,3%

33 976 000

 

 

Gross operating surplus

-19 853 000 €

-127,1%

-8 743 000 €

-150,6%

17 262 000 €

76 514,50 € 

-26046,7% 

 

-1,86 % CA

-60,3%

-1,16 % CA

-169,5%

1,67 % CA

4,29 % CA 

-143,4% 

 

Gross operating surplus

-19 853 000 €

-127,1%

-8 743 000 €

-150,6%

17 262 000 €

76 514,50 € 

-26046,7% 

+ Release of reserves and provisions

12 918 000

108,5%

6 195 000

-47,9%

11 893 000

 

 

+ Other operating income

0

0%

110 000

10900%

1 000

 

 

- Depreciation/Amortisation

21 798 000

79,0%

12 180 000

31,9%

9 233 000

 

 

- Other charges

1 949 000

-43,0%

3 419 000

-8,3%

3 729 000

 

 

Operating result

-30 682 000 €

-70,1%

-18 037 000 €

-211,4%

16 194 000 €

67 354 € 

-45653,3% 

 

-1,86 % CA

-60,3%

-1,16 % CA

-169,5%

1,67 % CA

4,29 % CA 

-143,4% 

 

Operating result

-30 682 000 €

-70,1%

-18 037 000 €

-211,4%

16 194 000 €

67 354 € 

-45653,3% 

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Financial income

96 579 000

248,8%

27 685 000

-88,1%

232 190 000

 

 

- Financial charges

0

0%

0

0%

100 376 000

 

 

Pre-tax result

65 897 000 €

583,0%

9 648 000 €

-93,5%

148 008 000 €

59 032 € 

111529,3% 

 

6,18 % CA

382,8%

1,28 % CA

-91,1%

14,32 % CA

3,54 % CA 

74,6% 

 

Extraordinary income

74 544 000

0%

0

0%

20 594 000

667,50 

11167540,4% 

- Extraordinary charges

0

0%

45 444 000

23,1%

36 914 000

 

 

Extraordinary result

74 544 000 €

264,0%

-45 444 000 €

-178,5%

-16 320 000 €

0 € 

0% 

 

6,99 % CA

215,7%

-6,04 % CA

-282,3%

-2 % CA

0 % CA 

0% 

 

Pre-tax result

65 897 000 €

583,0%

9 648 000 €

-93,5%

148 008 000 €

59 032 € 

111529,3% 

Extraordinary result

74 544 000 €

264,0%

-45 444 000 €

-178,5%

-16 320 000 €

0 € 

0% 

- Employee profit sharing

4 228 000

629,0%

580 000

-83,9%

3 605 000

 

 

- Tax on profits

-9 900 000

-53,9%

-6 433 000

68,0%

-20 076 000

 

 

Net result

146 113 000 €

588,0%

-29 943 000 €

-120,2%

148 159 000 €

52 004 € 

280864,9% 

13,69 % CA

444,0%

-3,98 % CA

-127,8%

14,34 % CA

3,05 % CA 

348,9% 

 

 

 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Na

 

 

ADDITIONAL INFORMATION

 

 

Activity (APE)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (4672Z)

 

 

RCS Registration

RCS Paris 6 632 045 381

Share capital

80,866,071 Euros

 

 

Registration Court

Paris (75)

Legal form

Public limited company with board of directors

 

Court Registry Number

19 6 3B045

EU VAT Number

FR40632045381

 

Incorporation Date

09/1963

Formation Date

01/1963

 

 

Deregistration Date

 

Last account Date

31/12/2010

 

 

Nationality

France

 

 

Type

Head office

Status

Economically active

 

 

Formation Date

02/1985

Reason for formation

Formation

 

 

Closure Date

 

Reason for closure

 

 

Reactivation Date

 

Production Role

 

 

Activity Nature

-

Activity Location

Other

 

Location surface

 

Seasonality

 

 

Department

Paris (75)

Region

Ile-de-France

 

 

District

1

Area

99

 

 

City

PARIS 15

Size of urban area

Paris conglomeration

 

 


Other establishments

 

Branches

4 branch entities in this company

 

 

 

Head office

 
> ERAMET <<<  - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (4672Z)  in PARIS 15  (75015)
 

 

 

Secondary establishments

>  ERAMET  - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (4672Z)  in TRAPPES  (78190)
>  ERAMET  - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (4672Z)  in SANDOUVILLE  (76430)
>  ERAMET  - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (4672Z)  in CLERMONT FERRAND  (63000)

 

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas having at least 50% of workforce in same area

 

 

 

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which one activity grouping from 50 to 80% of workforce

 

Workforces

 

 

 

Workforce at address

100 to 199 employees

Company workforce

250 to 499 employees

 

Company events history

Date

Description

 

28/07/2011

Bodacc B: Various editing or changing

 

11/07/2011

Changes to the Board of Directors

 

11/07/2011

Appointment/resignation of company officers

 

11/07/2011

Minutes of general meeting of shareholders

 

11/07/2011

Updated articles of association

 

08/07/2011

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

 

04/07/2011

Amendment

 

04/07/2011

Power of attorney

 

15/06/2011

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

 

11/05/2011

Legal Gazette: Appointment of the social representative

 

01/04/2011

New subsidiarie(s) detected

 

04/03/2011

Bodacc B: Various editing or changing

 

24/02/2011

Bodacc B: Various editing or changing

 

17/02/2011

Updated articles of association

 

17/02/2011

Minutes of general meeting of shareholders

 

17/02/2011

Capital increase

 

20/01/2011

Legal Gazette: Modification of the share capital

 

31/12/2010

New accounts available

 

31/12/2010

Other modification of Establishment

 

15/12/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

 

16/09/2010

Bodacc B: Various editing or changing

 

14/09/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

 

01/09/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

 

30/08/2010

Amendment

 

30/08/2010

Updated articles of association

 

30/08/2010

Changes to the Board of Directors

 

30/08/2010

Capital increase

 

13/08/2010

Update of participations in other companies

 

13/08/2010

Disengagement in other companies

 

13/08/2010

New shareholders detected

 

13/08/2010

New subsidiarie(s) detected

 

30/07/2010

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

 

28/07/2010

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

 

09/07/2010

New ultimate parent

 

21/06/2010

Other modification of Establishment

 

20/05/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

 

20/05/2010

Legal Gazette: Modification of the share capital

 

05/03/2010

Bodacc B: Various editing or changing

 

28/02/2010

Bodacc B: Various editing or changing

 

22/02/2010

New subsidiarie(s) detected

 

16/02/2010

Changes to the Board of Directors

 

10/02/2010

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

 

10/02/2010

Updated articles of association

 

10/02/2010

Amendment

 

10/02/2010

Capital increase

 

20/01/2010

Legal Gazette: Modification of the share capital

 

20/01/2010

Other modification of Establishment

 

31/12/2009

New accounts available

 

26/11/2009

Legal Gazette: Appointment of the social representative

 

30/09/2009

Bodacc B: Various editing or changing

 

14/09/2009

Updated articles of association

 

14/09/2009

Capital reduction

 

20/08/2009

Capital reduction

 

13/08/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

 

29/07/2009

Other modification of Establishment

 

30/06/2009

Bodacc B: Various editing or changing

 

15/06/2009

New auditor

 

15/06/2009

Updated articles of association

 

15/06/2009

Minutes of Board meeting

 

15/06/2009

Minutes of general meeting of shareholders

 

15/06/2009

Appointment/resignation of company officers

 

15/06/2009

Private document

 

15/06/2009

Changes to the Board of Directors

 

15/06/2009

Capital reduction

 

15/06/2009

Capital increase

 

04/05/2009

Audit or Management Report

 

04/05/2009

Private document

 

09/04/2009

Updated articles of association

 

09/04/2009

Private document

 

09/04/2009

Minutes of general meeting of shareholders

 

24/03/2009

Application and court order

 

23/03/2009

Application and court order

 

06/03/2009

Bodacc B: Various editing or changing

 

06/03/2009

New Bodacc B ads detected

 

16/02/2009

Minutes of general meeting of shareholders

 

16/02/2009

Updated articles of association

 

16/02/2009

Private document

 

16/02/2009

Capital increase

 

31/12/2008

New accounts available

 

02/09/2008

New Bodacc B ads detected

 

02/09/2008

Bodacc B: Various editing or changing

 

11/08/2008

Minutes of Board meeting

 

11/08/2008

Minutes of general meeting of shareholders

 

11/08/2008

Updated articles of association

 

11/08/2008

Private document

 

11/08/2008

Capital increase

 

11/08/2008

Amendment

 

30/07/2008

Other modification of Establishment

 

22/07/2008

Private document

 

22/07/2008

Audit or Management Report

 

08/07/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

 

10/06/2008

Application and court order

 

09/06/2008

Requête et Ordonnance

 

09/06/2008

Application and court order

 

08/06/2008

Bodacc B: Various editing or changing

 

08/06/2008

New Bodacc B ads detected

 

27/05/2008

Bodacc B: Various editing or changing

 

27/05/2008

New Bodacc B ads detected

 

25/02/2008

Amendment

 

25/02/2008

Minutes of Board meeting

 

25/02/2008

Private document

 

25/02/2008

Modification du Conseil d'Administration

 

25/02/2008

Changes to the Board of Directors

 

28/01/2008

Appointment/resignation of company officers

 

28/01/2008

Augmentation de Capital

 

28/01/2008

Capital increase

 

28/01/2008

Changes to the Board of Directors

 

28/01/2008

Modification du Conseil d'Administration

 

28/01/2008

Acte modificatif

 

28/01/2008

Updated articles of association

 

28/01/2008

Statuts mis à jour

 

28/01/2008

Private document

 

28/01/2008

Minutes of Board meeting

 

28/01/2008

Minutes of general meeting of shareholders

 

28/01/2008

Amendment

 

31/12/2007

New accounts available

 

05/06/2007

Minutes of Board meeting

 

05/06/2007

Changement de Président (PDG, PCA)

 

05/06/2007

Modification du Conseil d'Administration

 

05/06/2007

Minutes of general meeting of shareholders

 

05/06/2007

Private document

 

05/06/2007

Appointment/resignation of company officers

 

02/04/2007

Minutes of Board meeting

 

02/04/2007

PV du Conseil d'Administration

 

02/04/2007

Private document

 

02/04/2007

Changes to the Board of Directors

 

02/04/2007

Modification du Conseil d'Administration

 

02/04/2007

Appointment/resignation of company officers

 

01/02/2007

Augmentation de Capital

 

01/02/2007

Modification du Conseil d'Administration

 

01/02/2007

Changes to the Board of Directors

 

01/02/2007

Private document

 

01/02/2007

Appointment/resignation of company officers

 

01/02/2007

Minutes of general meeting of shareholders

 

01/02/2007

Minutes of Board meeting

 

01/02/2007

Statuts mis à jour

 

01/02/2007

Updated articles of association

 

01/02/2007

Acte modificatif

 

31/12/2006

New accounts available

 

22/02/2006

Augmentation de Capital

 

22/02/2006

Private document

 

22/02/2006

Acte sous seing privé

 

22/02/2006

Acte modificatif

 

22/02/2006

Updated articles of association

 

22/02/2006

Statuts mis à jour

 

27/01/2006

Appointment/resignation of company officers

 

27/01/2006

Private document

 

27/01/2006

Acte sous seing privé

 

27/01/2006

Modification du Conseil d'Administration

 

27/01/2006

Changes to the Board of Directors

 

27/01/2006

Nomination/démission des organes de gestion

 

27/01/2006

Minutes of Board meeting

 

27/01/2006

PV du Conseil d'Administration

 

31/12/2005

New accounts available

 

25/10/2005

Nomination/démission des organes de gestion

 

25/10/2005

Minutes of general meeting of shareholders

 

25/10/2005

PV d'Assemblée

 

25/10/2005

Appointment/resignation of company officers

 

25/10/2005

Private document

 

25/10/2005

Changement de Commissaire aux Comptes

 

25/10/2005

Acte sous seing privé

 

14/09/2005

Minutes of general meeting of shareholders

 

14/09/2005

PV d'Assemblée

 

14/09/2005

Nomination/démission des organes de gestion

 

14/09/2005

Appointment/resignation of company officers

 

14/09/2005

Private document

 

14/09/2005

Acte sous seing privé

 

14/09/2005

Modification du Conseil d'Administration

 

14/09/2005

Changes to the Board of Directors

 

17/02/2005

Updated articles of association

 

17/02/2005

Private document

 

17/02/2005

Acte sous seing privé

 

17/02/2005

Acte modificatif

 

17/02/2005

Statuts mis à jour

 

17/02/2005

Capital increase

 

17/02/2005

Augmentation de Capital

 

31/12/2004

New accounts available

 

02/02/2004

Acte modificatif

 

02/02/2004

Acte sous seing privé

 

02/02/2004

Augmentation de Capital

 

02/02/2004

Statuts mis à jour

 

31/12/2003

New accounts available

 

06/12/2003

Modification du Conseil d'Administration

 

06/12/2003

Acte modificatif

 

06/12/2003

Acte sous seing privé

 

06/12/2003

PV du Conseil d'Administration

 

05/11/2003

Statuts mis à jour

 

05/11/2003

PV du Conseil d'Administration

 

05/11/2003

PV d'Assemblée

 

05/11/2003

Certificat de dépôt des fonds

 

05/11/2003

Acte sous seing privé

 

05/11/2003

Augmentation de Capital

 

05/11/2003

Acte modificatif

 

03/07/2003

Acte sous seing privé

 

03/07/2003

Modification du Conseil d'Administration

 

03/07/2003

PV du Conseil d'Administration

 

03/07/2003

Nomination/démission des organes de gestion

 

03/07/2003

PV d'Assemblée

 

03/07/2003

Changement de Président (PDG, PCA)

 

21/02/2003

Statuts mis à jour

 

21/02/2003

Augmentation de Capital

 

21/02/2003

Acte modificatif

 

21/02/2003

Acte sous seing privé

 

18/11/2002

Augmentation de Capital

 

18/11/2002

Certificat de dépôt des fonds

 

18/11/2002

Statuts mis à jour

 

18/11/2002

PV d'Assemblée

 

18/11/2002

PV du Conseil d'Administration

 

18/11/2002

Acte sous seing privé

 

26/08/2002

Acte modificatif

 

26/08/2002

Statuts mis à jour

 

26/08/2002

PV du Conseil d'Administration

 

26/08/2002

Nomination/démission des organes de gestion

 

26/08/2002

PV d'Assemblée

 

26/08/2002

Acte sous seing privé

 

26/08/2002

Modification du Conseil d'Administration

 

26/08/2002

Changement de Président (PDG, PCA)

 

20/02/2002

Acte sous seing privé

 

20/02/2002

Statuts mis à jour

 

20/02/2002

PV d'Assemblée

 

20/02/2002

Augmentation de Capital

 

03/09/2001

Acte sous seing privé

 

03/09/2001

Statuts mis à jour

 

03/09/2001

Modification du Conseil d'Administration

 

03/09/2001

PV d'Assemblée

 

03/09/2001

Acte modificatif

 

03/09/2001

Nomination/démission des organes de gestion

 

03/09/2001

Augmentation de Capital

 

03/09/2001

Conversion du Capital Social en Euros

 

31/01/2001

Acte sous seing privé

 

31/01/2001

Acte modificatif

 

31/01/2001

Statuts mis à jour

 

31/01/2001

Augmentation de Capital

 

06/12/2000

PV d'Assemblée

 

06/12/2000

PV du Conseil d'Administration

 

06/12/2000

Statuts mis à jour

 

06/12/2000

Augmentation de Capital

 

06/12/2000

Modification du Conseil d'Administration

 

06/12/2000

Acte sous seing privé

 

06/12/2000

Certificat de dépôt des fonds

 

06/12/2000

Nomination/démission des organes de gestion

 

18/09/2000

PV du Conseil d'Administration

 

18/09/2000

Modification du Conseil d'Administration

 

18/09/2000

Nomination/démission des organes de gestion

 

18/09/2000

Acte sous seing privé

 

28/02/2000

Augmentation de Capital

 

28/02/2000

Acte modificatif

 

28/02/2000

Statuts mis à jour

 

28/01/2000

PV d'Assemblée

 

28/01/2000

Acte sous seing privé

 

28/01/2000

Certificat de dépôt des fonds

 

21/10/1999

Nomination/démission des organes de gestion

 

21/10/1999

Augmentation de Capital

 

21/10/1999

Modification du Conseil d'Administration

 

21/10/1999

Statuts mis à jour

 

21/10/1999

Acte sous seing privé

 

21/10/1999

Modification de l'objet social

 

21/10/1999

PV d'Assemblée

 

06/07/1999

Rapport des Commissaires ou du Gérant

 

06/07/1999

Acte sous seing privé

 

15/02/1999

Acte modificatif

 

15/02/1999

Statuts mis à jour

 

15/02/1999

PV du Conseil d'Administration

 

15/02/1999

Augmentation de Capital

 

15/02/1999

Certificat de dépôt des fonds

 

15/02/1999

Acte sous seing privé

 

01/01/1999

Requête et Ordonnance

 

01/01/1999

Nomination/démission des organes de gestion

 

28/01/1998

Nomination/démission des organes de gestion

 

28/01/1998

PV du Conseil d'Administration

 

28/01/1998

Augmentation de Capital

 

28/01/1998

Modification du Conseil d'Administration

 

28/01/1998

Acte sous seing privé

 

28/01/1998

Statuts mis à jour

 

28/01/1998

PV d'Assemblée

 

06/10/1997

PV du Conseil d'Administration

 

06/10/1997

Statuts mis à jour

 

06/10/1997

Changement de Commissaire aux Comptes

 

06/10/1997

Changement de Président (PDG, PCA)

 

06/10/1997

Modification du Conseil d'Administration

 

06/10/1997

Acte sous seing privé

 

06/10/1997

Nomination/démission des organes de gestion

 

06/10/1997

PV d'Assemblée

 

30/06/1997

Acte modificatif

 

30/06/1997

Acte sous seing privé

 

30/06/1997

Modification du Conseil d'Administration

 

30/06/1997

PV du Conseil d'Administration

 

12/06/1997

Prorogation de durée

 

12/06/1997

Requête et Ordonnance

 

31/01/1997

Acte modificatif

 

31/01/1997

PV d'Assemblée

 

31/01/1997

Augmentation de Capital

 

31/01/1997

Statuts mis à jour

 

31/01/1997

Acte sous seing privé

 

31/01/1997

PV du Conseil d'Administration

 

27/08/1996

Acte modificatif

 

27/08/1996

Acte sous seing privé

 

27/08/1996

Augmentation de Capital

 

27/08/1996

PV d'Assemblée

 

27/08/1996

Statuts mis à jour

 

27/08/1996

PV du Conseil d'Administration

 

19/02/1996

Acte modificatif

 

19/02/1996

Augmentation de Capital

 

19/02/1996

Statuts mis à jour

 

19/02/1996

PV d'Assemblée

 

19/02/1996

PV du Conseil d'Administration

 

28/12/1995

PV d'Assemblée

 

28/12/1995

Nomination/démission des organes de gestion

 

28/12/1995

PV du Conseil d'Administration

 

28/12/1995

Modification du Conseil d'Administration

 

28/12/1995

Augmentation de Capital

 

28/12/1995

Statuts mis à jour

 

28/12/1995

Acte modificatif

 

26/06/1995

PV d'Assemblée

 

26/06/1995

Nomination/démission des organes de gestion

 

26/06/1995

Modification du Conseil d'Administration

 

26/06/1995

Acte modificatif

 

23/06/1995

PV d'Assemblée

 

23/06/1995

Statuts mis à jour

 

23/06/1995

Acte modificatif

 

23/05/1995

Acte modificatif

 

23/05/1995

PV du Conseil d'Administration

 

23/05/1995

Nomination/démission des organes de gestion

 

23/05/1995

Modification du Conseil d'Administration

 

03/05/1995

Rapport des Commissaires ou du Gérant

 

03/05/1995

Apport Partiel

 

03/05/1995

Acte modificatif

 

02/05/1995

Augmentation de Capital

 

02/05/1995

Statuts mis à jour

 

02/05/1995

Acte sous seing privé

 

02/05/1995

PV d'Assemblée

 

15/03/1995

PV du Conseil d'Administration

 

15/03/1995

Acte modificatif

 

15/03/1995

Modification du Conseil d'Administration

 

15/03/1995

Nomination/démission des organes de gestion

 

06/03/1995

Acte modificatif

 

06/03/1995

Rapport des Commissaires ou du Gérant

 

06/01/1995

Requête et Ordonnance

 

19/07/1994

Acte modificatif

 

13/07/1994

Modification du Conseil d'Administration

 

13/07/1994

PV d'Assemblée

 

13/07/1994

Nomination/démission des organes de gestion

 

13/07/1994

Acte modificatif

 

01/07/1994

Acte modificatif

 

01/07/1994

Statuts mis à jour

 

01/07/1994

Modification du Conseil d'Administration

 

01/07/1994

PV d'Assemblée

 

01/07/1994

Nomination/démission des organes de gestion

 

01/01/1994

Statuts mis à jour

 

01/01/1994

Acte sous seing privé

 

10/08/1993

Acte modificatif

 

10/08/1993

Déclaration de conformité

 

10/08/1993

Changement de dénomination sociale

 

10/08/1993

PV d'Assemblée

 

10/08/1993

Statuts mis à jour

 

10/08/1993

PV du Conseil d'Administration

 

01/07/1993

Nomination/démission des organes de gestion

 

01/07/1993

Acte modificatif

 

01/07/1993

Modification du Conseil d'Administration

 

01/07/1993

PV du Conseil d'Administration

 

18/02/1993

Nomination/démission des organes de gestion

 

18/02/1993

Acte modificatif

 

18/02/1993

Modification du Conseil d'Administration

 

18/02/1993

PV du Conseil d'Administration

 

23/04/1992

PV d'Assemblée

 

23/04/1992

Acte modificatif

 

10/01/1992

Modification du Conseil d'Administration

 

10/01/1992

Nomination/démission des organes de gestion

 

10/01/1992

Acte modificatif

 

10/01/1992

PV du Conseil d'Administration

 

10/01/1992

Changement de Président (PDG, PCA)

 

Publication date

Gazette Name

Description

 

 

28/07/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1174 - 632 045 381 RCS Paris. ERAMET. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur partant : Rossignol, Jacques, Administrateur partant : Treuille, Antoine, Administrateur partant : Duval, Patrick, Administrateur partant : Duval, Cyrille, Administrateur partant : Giraud, Pierre-Noel, Administrateur partant : Bernard De Montessus De Ballore-Augier De Cremiers, Sébastien, nomination de l'Administrateur : Milsan, Astrid, nomination de l'Administrateur : Lepoutre, nom d'usage : Saint-M'Leux, Manoelle, nomination de l'Administrateur : SORAME représentée par Duval, Cyrille, nomination de l'Administrateur : CEIR représentée par Duval, Patrick, nomination de l'Administrateur : Tona, Frederic. Capital : 80866071.30 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

 

15/06/2011

JAL

Appointment of the social representative

 

 

 

 

Affiches parisiennes (Les)


Société faisant l'objet d'une nomination : 632045381 - ERAMET, 33 AV DU MAINE, TOUR MONTPARNASSE, PARIS 15, 75015 PARIS 15
Nominé : Monsieur Frédéric TONA, 3 Rue Froidevaux, 75014 PARIS 14
En la fonction de : Administrateur
Nominé :
En la fonction de : Administrateur
Nominé :
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Madame Manoelle LEPOUTRE, 17 Rue Joseph-Bertrand, 78220 VIROFLAY
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Madame Astrid MILSAN, 7 Rue Chalgrin, 75116 PARIS 16
En la fonction de : Administrateur
Date d'effet : 11/05/2011

 

15/06/2011

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

 

 

Affiches parisiennes (Les)


Date de décision : 11/05/2011
La société 632045381 - ERAMET, 33 AV DU MAINE, TOUR MONTPARNASSE, PARIS 15, 75015 PARIS 15
Fait l'objet du départ de Date d'effet : 11/05/2011

 

04/03/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1085 - 632 045 381 RCS Paris. ERAMET. Forme : Société anonyme. Capital : 80866071.30 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

 

24/02/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1128 - 632 045 381 RCS Paris. ERAMET. Forme : Société anonyme. Administration : nomination de l'Administrateur : Quintard, Michel. Capital : 80824322.90 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

 

03/02/2011

JAL

Modification of the share capital

 

 

 

 

Affiches parisiennes (Les)


Date de décision : 20/01/2011
La société : 632045381 - ERAMET, 33 AV DU MAINE, TOUR MONTPARNASSE, PARIS 15, 75015 PARIS 15 a subi une augmentation de son capital social désormais de 80 866 071 €
Date d'effet : 20/01/2011

 

31/01/2011

JAL

Appointment of the social representative

 

 

 

 

Affiches parisiennes (Les)


Société faisant l'objet d'une nomination : 632045381 - ERAMET, 33 AV DU MAINE, TOUR MONTPARNASSE, PARIS 15, 75015 PARIS 15
Nominé : Monsieur Michel QUINTARD, 5 Rue Daver Dumbea, 98845 NOUMÉA
En la fonction de : Administrateur
Date d'effet : 15/12/2010

 

16/09/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1061 - 632 045 381 RCS Paris. ERAMET. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur partant : Autebert, Remy, nomination de l'Administrateur : Bernard De Montessus De Ballore-Augier De Cremiers, Sébastien. Capital : 80427929.65 EUR.
Adresse du siège social : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

 

16/09/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1063 - 632 045 381 RCS Paris. ERAMET. Forme : Société anonyme. Capital : 80824322.90 EUR.
Adresse du siège social : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

 

16/09/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1062 - 632 045 381 RCS Paris. ERAMET. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur partant : Frogier, Pierre. Capital : 80427929.65 EUR.
Adresse du siège social : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

 

14/09/2010

Bodacc C

Comptes annuels, consolidés et rapports

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

13967 - 632045381 RCS. ERAMET. Forme : Société anonyme. Adresse : 33 AV DU MAINE TOUR MAINE MONTPARNASSE 75015 PARIS. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

 

01/09/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

11839 - 632045381 RCS. ERAMET. Forme : Société anonyme. Adresse : 33 AV DU MAINE TOUR MAINE MONTPARNASSE 75015 PARIS. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

 

30/07/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Société faisant l'objet d'une nomination : 632045381 - ERAMET, 33 AV DU MAINE, TOUR MONTPARNASSE, PARIS 15, 75015 PARIS 15
Nominé : Monsieur Sébastien BERNARD DE MONTESSUS DE BALLORE-, 9 RUE 9 RUE SALIGNAC FENELON, 92200 NEUILLY SUR SEINE
En la fonction de : Administrateur

 

30/07/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Date de décision : 20/05/2010
La société 632045381 - ERAMET, 33 AV DU MAINE, TOUR MONTPARNASSE, PARIS 15, 75015 PARIS 15
Fait l'objet du départ de Monsieur Rémy AUTEBERT

 

28/07/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Date de décision : 10/06/2010
La société 632045381 - ERAMET, 33 AV DU MAINE, TOUR MONTPARNASSE, PARIS 15, 75015 PARIS 15
Fait l'objet du départ de Monsieur Pierre FROGIER

 

28/07/2010

JAL

Modification of the share capital

 

 

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Date de décision : 20/05/2010
La société : 632045381 - ERAMET, 33 AV DU MAINE, TOUR MONTPARNASSE, PARIS 15, 75015 PARIS 15 a subi une augmentation de son capital social désormais de 80 824 320 €

 

05/03/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1799 - 632 045 381 RCS Paris. ERAMET. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur partant : Martin, Harold, nomination de l'Administrateur : Frogier, Pierre. Capital : 80427929.65 EUR.
Adresse du siège social : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

 

28/02/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2145 - 632 045 381 RCS Paris. ERAMET. Forme : Société anonyme. Capital : 80427929.65 EUR.
Adresse du siège social : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

 

10/02/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Société faisant objet d'une nomination : 632045381 - ERAMET, 33 AV DU MAINE, TOUR MONTPARNASSE, PARIS 15, 75015 PARIS 15
Nominé : Monsieur Pierre FROGIER
En la fonction de : Administrateur

 

10/02/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Date de décision : 26/11/2009
La société 632045381 - ERAMET, 33 AV DU MAINE, TOUR MONTPARNASSE, PARIS 15, 75015 PARIS 15
Fait l'objet du départ de Monsieur Harold MARTIN

 

29/01/2010

JAL

Modification of the share capital

 

 

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Date de décision : 20/01/2010
La société : 632045381 - ERAMET, 33 AV DU MAINE, TOUR MONTPARNASSE, PARIS 15, 75015 PARIS 15 a subi une augmentation de son capital social désormais de 80 427 930 €

 

30/09/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1223 - 632 045 381 RCS Paris. ERAMET. Forme : Société anonyme. Capital : 80366993.70 EUR.
Adresse du siège social : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

 

13/08/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

9770 - 632045381 RCS. ERAMET. Forme : Société anonyme. Adresse : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse 75015 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

 

13/08/2009

Bodacc C

Comptes annuels, consolidés et rapports

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

9771 - 632045381 RCS. ERAMET. Forme : Société anonyme. Adresse : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse 75015 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

 

30/06/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1524 - 632 045 381 RCS Paris. ERAMET. Forme : Société anonyme. Administration : nomination de l'Administrateur : Lorenzi, Jean-Hervé, Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Montserrat, Jean-Marc, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX. Capital : 81138292.95 EUR.
Adresse du siège social : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration.

 

06/03/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1903 - 632 045 381 RCS Paris. ERAMET. Forme : Société anonyme. Administration : modification de l'Administrateur AREVA représentée par TONA, FREDERIC, Adresse : Demeurant : 3 rue Froidevaux 75014 Paris. Capital : 79956454.55 EUR.
Adresse du siège social : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration.

 

02/09/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

370 - 632 045 381 RCS Paris. ERAMET. Forme : Société anonyme. Capital : 79748691.60 EUR.
Adresse du siège social : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

 

08/07/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

6673 - 632045381 RCS. ERAMET. Forme : Société anonyme. Adresse : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse 75015 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

 

08/07/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

6674 - 632045381 RCS. ERAMET. Forme : Société anonyme. Adresse : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse 75015 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

 

08/06/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

888 - 632 045 381 RCS Paris. ERAMET. Forme : Société anonyme. Administration : nomination du Directeur général délègué : Vecten, Philippe. Capital : 79012144.05 EUR.
Adresse du siège social : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

 

27/05/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1021 - 632 045 381 RCS Paris. ERAMET. Forme : Société anonyme. Administration : Directeur général délègué partant : Robert, Alain. Capital : 78975507.45 EUR.
Adresse du siège social : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration.

 

27/05/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1022 - 632 045 381 RCS Paris. ERAMET. Forme : Société anonyme. Administration : nomination du Directeur général délègué : Madelin, Bertrand. Capital : 79012144.05 EUR.
Adresse du siège social : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration.

 

04/12/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

 

 

10608 - 632 045 381. RCS PARIS ERAMET. Forme: Société anonyme. Adresse du siège social: 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse 75015 Paris. Comptes consolidés et rapport de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

 

04/12/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

 

 

10609 - 632 045 381. RCS PARIS ERAMET. Forme: Société anonyme. Adresse du siège social: 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse 75015 Paris. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

 

17/08/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

886 - RCS Paris B 632 045 381. RC 63-B 4538. ERAMET. Forme : S.A. Capital : 78 936 726,70 euros. Adresse du siège social : tour Maine-Montparnasse, 33 avenue du Maine,, 75015 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : BACARDATS (Jacques, Marie, Gabriel).

 

04/07/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

2145 - RCS Paris B 632 045 381. RC 63-B 4538. ERAMET. Forme : S.A. Capital : 78 936 726,70 euros. Adresse du siège social : tour Maine-Montparnasse, 33 avenue du Maine,, 75015 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification d'un administrateur : BACARDATS (Jacques, Marie, Gabriel). Modification du président du conseil d'administration et directeur général : BUFFET (Patrick).

 

08/05/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

1637 - RCS Paris B 632 045 381. RC 63-B 4538. ERAMET. Forme : S.A. Capital : 78 936 726,70 euros. Adresse du siège social : tour Maine-Montparnasse, 33 avenue du Maine,, 75015 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : HENROT (François). Nomination d'un administrateur : BUFFET (Patrick).

 

25/02/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

1072 - RCS Paris B 632 045 381. RC 63-B 4538. ERAMET. Forme : S.A. Capital : 78 659 115,70 euros. Adresse du siège social : tour Maine-Montparnasse, 33 avenue du Maine,, 75015 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : directeur général délégué partant : ANDRE (Patrick).

 

25/02/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

1073 - RCS Paris B 632 045 381. RC 63-B 4538. ERAMET. Forme : S.A. Capital : 78 936 726,70 euros. Adresse du siège social : tour Maine-Montparnasse, 33 avenue du Maine,, 75015 Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

 

19/07/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

 

 

3656 - RCS Paris B 632 045 381. RC 63-B 4538. ERAMET. Forme: S.A. Adresse du siège social: 33, avenue du Maine tour Maine Montparnasse,Paris, 75015 Paris. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

 

19/07/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

 

 

3657 - RCS Paris B 632 045 381. RC 63-B 4538. ERAMET. Forme: S.A. Adresse du siège social: 33, avenue du Maine tour Maine Montparnasse,Paris, 75015 Paris. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

 

21/06/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

0966 - RCS Paris B 632 045 381. RC 63-B 4538. ERAMET. Forme : S.A. Capital : 78 659 115,70 euros. Adresse du siège social : tour Maine-Montparnasse, 33 avenue du Maine,, 75015 Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

 

06/06/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

1937 - RCS Paris B 632 045 381. RC 63-B 4538. ERAMET. Forme : S.A. Capital : 78 522 079,20 euros. Adresse du siège social : tour Maine-Montparnasse, 33 avenue du Maine,, 75015 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : LAMY (Jean, Lucien). Nomination d'un administrateur : LEHMANN (Gilbert).

 

18/01/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

1786 - RCS Paris B 632 045 381. RC 63-B 04538. ERAMET. Forme : S.A. Adresse du siège social : tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine,, 75015 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : commissaire aux comptes suppléant partant : STE BDA. Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : BEAS.

 

25/09/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

1372 - RCS Paris B 632 045 381. RC 63-B 4538. ERAMET. Forme : S.A. Nom commercial : Eramet. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : LAFLEUR (Pascal). Nomination d'un administrateur : MARTIN (Harold).

 

10/09/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

 

 

4131 - RCS Paris B 632 045 381. RC 63-B 4538. ERAMET. Forme: S.A. Adresse du siège social: 33, avenue du Maine tour Maine Montparnasse,Paris, 75015 Paris. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

 

10/09/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

 

 

4132 - RCS Paris B 632 045 381. RC 63-B 4538. ERAMET. Forme: S.A. Adresse du siège social: 33, avenue du Maine tour Maine Montparnasse,Paris, 75015 Paris. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

 

22/03/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

2333 - RCS Paris B 632 045 381. RC 63-B 4538. ERAMET. Forme : S.A. Capital : 78 522 079,20 euros. Nom commercial : Eramet. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

 

12/02/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632045381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A. Capital : 78 011 600, 70 euros Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

 

18/12/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632045381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination de directeurs généraux délégués : ANDRE ( Patrick) ROBERT (Alain).

 

18/11/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632045381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A. Capital : 78 001 535, 70 euros Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

 

17/07/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632045381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d' administration partant : RAMBAUD (Yves). Modification du président du conseil d' administration et directeur général : BACARDATS (Jacques, Marie, Gabriel).

 

17/07/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632045381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : CASTAIGNE (Robert). Nomination d' administrateurs : AUTEBERT (Rémy) GIRAUD (Pierre-Noel) SOMNOLET (Michel).

 

09/03/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632045381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A. Capital : 76 396 531, 15 euros Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

 

01/12/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632045381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A. Capital : 76 395 463, 65 euros Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

 

06/09/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632045381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES S.A. Nomination d'un administrateur : STE DES PARTICIPATIONS DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE.

 

06/09/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632045381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification du président du conseil d'administration : RAMBAUD (Yves). Modification d'un directeur général délégué et administrateur : DUVAL (Georges). Administrateur partant : MOLINARD, née LAUVERGEON (Anne). Nomination d'un administrateur : LAMY (Jean, Lucien).

 

05/03/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632045381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A. Capital : 75 406 248 euros Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

 

16/09/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632045381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A. Capital : 75 333,04 euros Nom commercial: Eramet. Adresse du siège social : tour Maine-Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75015 Paris. Commentaires : modification survenue sur le capital (diminution) et l' administration. Administration : nomination d'administrateurs : COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES S.A. LAFLEUR (Pascal). Administrateur partant : DUTHILLEUL, née CHOPINET (Anne). Nomination d'un administrateur : MAPOU (Louis). Administrateur partant : BERNARD (Yves).

 

15/02/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632045381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A. Capital : 493 987 200 F Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur le capital ( augmentation).

 

21/12/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632045381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A. Capital : 493 078 640 F Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur le capital ( augmentation) et l'administration. Administration : nomination du directeur général non administrateur : BACARDATS ( Jacques, Marie, Gabriel). Administrateur partant : COUPIN (Yves). Nomination d'un administrateur : TONA ( Frédéric, Bernard).

 

30/09/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632045381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : CHARDON (Rémy). Nomination d'un administrateur : DUTHILLEUL, née CHOPINET (Anne).

 

12/03/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632045381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A. Capital : 488 631 920 F Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur le capital ( augmentation).

 

07/11/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632045381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A. Capital : 482 159 880 F Nom commercial: Eramet. Activité : recherche et exploitation de gisements miniers de toute nature métallurgie de tous métaux et alliages et leur négoce. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation), l'activité et l'administration. Administration : administrateur partant : ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES-E.R.A.P. Nomination d' administrateurs : BERNARD (Yves) CASTAIGNE (Robert) ROSSIGNOL (Jacques) TREUILLE (Antoine) MOLINARD, née LAUVERGEON (Anne) DUVAL (Patrick) DUVAL (Cyrille) HENROT (François) COUPIN (Yves) DUVAL (Georges) DUVAL (Edouard). Administrateurs partants : RUTMAN (Gilbert) LANGLOIS-MEURINNE ( Aimery) RAMEL (Stig) FLORES, née DEFLANDRE (Liliane) SCHNEIDER (Roland) MANDARD (Gérard) APPERT (Olivier) GIUILY (Eric) GUILLAUME (Henri) JOUVEN (François) LE BARS (Yves) LEVI (Jean, Daniel) ROUVILLOIS ( Philippe).

 

28/02/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632 045 381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A. Capital : 312 057 120 F Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur le capital ( augmentation).

 

13/02/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS *. RCS Paris B 632 045 381 RC RC 63- B 4538 ERAMET. Forme : S.A. Capital : 311 705 760 F Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

 

19/10/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632 045 381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateurs partants : COCRELLE (Gérard) HUGON ( Jean-Pierre) MOURRE (Gilbert, Olivier, Pierre) MAINGUET-SUARES (Yves) MITIEUS (René, Alfier, François) WEYMULLER (Stanislas, Bruno, Henri, Ernest) FREYCHE (Michel). Nomination d'administrateurs : FLORES, née DEFLANDRE (Liliane) SCHNEIDER (Roland) MANDARD (Gérard) APPERT (Olivier) GIUILY (Eric) GUILLAUME (Henri) JOUVEN (François) LE BARS (Yves) LEVI (Jean, Daniel) ROUVILLOIS ( Philippe). Commissaire aux comptes titulaire partant : STE BARBIER FRINAULT ET ASSOCIES. Nomination du commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU. Commissaire aux comptes suppléant partant : PEUCH- LESTRADE (Philippe). Nomination du commissaire aux comptes suppléant : STE D.B.A.

 

13/07/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS *. RCS Paris B 632 045 381 RC RC 63- B 4538 ERAMET. Forme : S.A Nom commercial: Eramet. Administration : démission : administrateur : PONTET (Philippe). Nomination en qualité d'administrateur : CHARDON (Rémy). Commentaires : modification survenue sur l' administration.

 

12/09/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS *. RCS Paris B 632 045 381 RC RC 63- B 4538 ERAMET. Forme : S.A. Capital : 308 833 980 F Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur le capital.

 

03/03/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS Paris B 632 045 381 RC 63-B 4538 ERAMET. Forme : S.A. Capital : 304 766 200 F Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur le capital.

 

18/01/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS *. RCS Paris B 632 045 381 RC RC 63- B 4538 ERAMET. Forme : S.A. Capital : 304 756 760 F Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur le capital.

 

14/07/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS *. RCS Paris B 632 045 381 RC RC 63- B 4538 ERAMET. Forme : S.A Nom commercial: Eramet. Administration : président- directeur général : RAMBAUD (Yves) Administrateurs : COCRELLE (Gérard) ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES - ERAP HUGON (Jean- Pierre) RUTMAN (Gilbert) MOURRE ( Gilbert, Olivier, Pierre) MAINGUET- SUARES (Yves) LANGLOIS-MEURINNE ( Aimery) MITIEUS (René, Alfier, François) WEYMULLER (Stanislas, Bruno, Henri, Ernest) PONTET ( Philippe) FREYCHE (Michel) LOWY ( George, T.) RAMEL (Stig) SCHEIDER (Wilhelm). Commissaires aux comptes titulaires : ERNST ET YOUNG AUDIT SOCIETE BARBIER FRINAULT ET ASSOCIES. Commissaires aux comptes suppléants : MONTSERRAT (Jean-Marc) PEUCH- LESTRADE (Philippe). Commentaires : modification survenue sur l' administration.

 

09/06/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS *. RCS Paris B 632 045 381 RC RC 63- B 4538 ERAMET. Forme : S.A Nom commercial: Eramet. Administration : président- directeur général : RAMBAUD (Yves) Administrateurs : COCRELLE (Gérard) ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES - E.R.A.P. HUGON (Jean- Pierre) RUTMAN (Gilbert) MOURRE ( Gilbert, Olivier, Pierre) MAINGUET- SUARES (Yves) LANGLOIS-MEURINNE ( Aimery) MITIEUS (René, Alfier, François) WEYMULLER (Stanislas, Bruno, Henri, Ernest) PONTET ( Philippe). Commissaires aux comptes titulaires : ERNST ET YOUNG AUDIT SOCIETE BARBIER FRINAULT ET ASSOCIES. Commissaires aux comptes suppléants : MONTSERRAT (Jean-Marc) PEUCH- LESTRADE (Philippe). Commentaires : modification survenue sur l' administration.

 

18/05/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS *. RCS Paris B 632 045 381 RC RC 63- B 4538 ERAMET. Forme : S.A. Capital : 300 267 520 F Nom commercial: Eramet. Commentaires : modification survenue sur le capital.

 

15/04/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

 

 

RCS *. RCS Paris B 632 045 381 RC RC 63- B 4538 ERAMET. Forme : S.A Nom commercial: Eramet. Administration : président- directeur général : RAMBAUD (Yves) Administrateurs : BOISSON (Pierre) COCRELLE (Gérard) ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES ERAP HUGON (Jean-Pierre) RUTMAN ( Gilbert) MOURRE (Gilbert, Olivier, Pierre) MAINGUET-SUARES (Yves) LANGLOIS-MEURINNE (Aimery) MITIEUS ( René, Alfier, François) WEYMULLER ( Stanislas, Bruno, Henri, Ernest). Commissaires aux comptes titulaires : H.S.D. CASTEL JACQUET SOCIETE BARBIER FRINAULT ET ASSOCIES. Commissaires aux comptes suppléants : MONTSERRAT (Jean-Marc) PEUCH- LESTRADE (Philippe). Commentaires : modification survenue sur l' administration.

 

 

 

NOTES & COMMENTS

 

Na

 

 


FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.50.56

UK Pound

1

Rs.80.30

Euro

1

Rs.68.79

 

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

----

NB

New Business

----

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

 

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.