MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :           

29.10.2011

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

ARKEMA FRANCE

 

 

Registered Office :

8, 420 Rue Estienne D Orves, 92700 Colombes

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2010

 

 

Date of Incorporation :

February 1957

 

 

Com. Reg. No.:

RCS Nanterre 8 319 632 790

 

 

Legal Form :

Public limited company with board of directors

 

 

Line of Business :

Manufacture of other organic basic chemicals

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Maximum Credit Limit :

2,000,000 €

 

 

Status :

Good

 

 

Payment Behaviour :

No Complaints

 

 

Litigation :

Clear


NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – September 30th, 2011

 

Country Name

Previous Rating

                   (30.06.2011)                  

Current Rating

(30.09.2011)

France

a2

a2

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 

REGISTERED NAME & COMPANY SUMMARY

 

 Name ARKEMA FRANCE        SIRET   319 632 790 00857          

 

Activity (APE)

Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

(2014Z)

(Manufacture of other organic basic chemicals (2014Z))

Legal form

Public limited company with board of directors

 

 

 

Phone

01 49 00 70 09

RCS Registration

RCS Nanterre 8 319 632 790

 

 

 

Fax

 

Share capital

274,845,346 Euros

 

 

 

Address

ARKEMA FRANCE
/8
420 RUE ESTIENNE D ORVES
92700 COLOMBES

Incorporated Date

02/1957

 

 

 

Nationality

France

Status

Economically active

 

 

 

Company details

 

 

Activity (APE)

Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (2014Z)

(Manufacture of other organic basic chemicals (2014Z)))

 

RCS Registration

RCS Nanterre 8 319 632 790

Share capital

274,845,346 Euros

 

Registration Court

Nanterre (92)

Legal form

Public limited company with board of directors

 

Court Registry Number

19 8 1B003

EU VAT Number

FR32319632790

 

Incorporation Date

02/1957

Formation Date

01/1980

 

Deregistration Date

 

Last account Date

31/12/2010

 

Nationality

France

 

 

CREDIT RECOMENDATION

 

Credit Limit: 2,000,000 €

 

 

DIRECTORS/MANAGEMENT

 

 

Current Directors

6

 

 


 

directors

 

 

 

 

 

Name

M. LE HENAFF THIERRY

 

Manager position

Administrateur, Président du conseil d'administration

Date of birth

04/05/1963

 

Place of birth

SAVIGNY SUR ORGE

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. DELABORDE MICHEL

 

Manager position

Directeur général, Administrateur

Date of birth

14/08/1956

 

Place of birth

SENLIS

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. LEMONNIER THIERRY

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

06/11/1953

 

Place of birth

MONTREUIL

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. SCHULLER MARC

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

11/12/1960

 

Place of birth

METZ

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. TAKKEN OTTO

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

30/04/1951

 

Place of birth

VEENENDAAL(PAYS-BAS)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. CHANOINE PIERRE

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

10/05/1949

 

Place of birth

WORMS(ALLEMAGNE)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Directors

 

 

 

 

Vous pouvez consulter ici l'historique des dirigeants de l'entreprise.
Si vous souhaitez consulter l'historique d'un dirigeant, il vous suffit de cliquer sur le lien voir le détail pour y accéder.

 

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

 

Président du conseil d'administration

M THIERRY LE HENAFF

 

 

Directeur général

M MICHEL DELABORDE

 

 

Administrateur

M PIERRE CHANOINE

 

 

Administrateur

M PIERRE CHANOINE

 

 

Administrateur

M MICHEL DELABORDE

 

 

Administrateur

M THIERRY LE HENAFF

 

 

Administrateur

M THIERRY LEMONNIER

 

 

Administrateur

M MARC SCHULLER

 

 

Administrateur

M OTTO TAKKEN

 

 

Administrateur

M OTTO TAKKEN

 

 

Administrateur

M OTTO TAKKEN

 

 

 

 

NEGATIVE INFORMATION

 

Collective procedures

 

 

No judgment information for the company

 

 

SHARE & SHARE CAPITAL INFORMATION

 

 

Ultimate Holding Company

 

 

Company Name

Safe Number

 

Company number

Click here to view the affiliation links

 

 

ARKEMA

FR07050899

 

445074685

7 companies in 4 countries. Click here to visit linked companies

 

 

 

Ultimate Parent

1 ultimate parent company for this company
>  ARKEMA  - Activités des sociétés holding (6420Z)  in COLOMBES  (92700)

 

 

 


PAYMENT INFORMATION

 

Na

 

GROUP STRUCTURE & AFFILIATED COMPANIES

 

Group data

 

 

Ultimate parent company

ARKEMA

Direct parent

ARKEMA - 99.99 %

Group – Number of companies

123

Linkages – Number of companies

7

Number of countries

4

Go directly to the current company

Display only where participation % > 33 %

Display all participations

This company is a part of several groups, choose the group you wish to see the structure

Display the group

ARKEMA

loading data...

Raison sociale

 

Safe Number

SIREN

Parts

Score

Limite

Derniers
comptes
publiés

ARKEMA

 

FR07050899

445074685

-

98

580 000 €

31/12/2010

ARKEMA EUROPE HOLDINGS B.V.

 

NL01245331

24326561

100%

No Rating

-

31/12/2007

ARKEMA AMERIQUES SAS

 

FR07554175

451658470

99.46%

100

250 000 €

31/12/2010

ARKEMA CANADA INC.

 

-

-

40.80%

-

-

-

ARKEMA DELAWARE INC.

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA INC.

 

-

-

100%

-

-

-

AMERICAN ACRYL LP

 

-

-

50%

-

-

-

ARKEMA ASIE SAS

 

FR04912713

418681029

59.40%

99

250 000 €

31/12/2010

ARKEMA K.K.

 

-

-

100%

-

-

-

AKISHIMA CHEMICAL INDUSTRIES CO LTD

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA YOSHITOMI LTD

 

-

-

49%

-

-

-

SARTOMER JAPAN INC

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA CHINA INVESTMENT CO LTD

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA HYDROGEN PEROXIDE CO., LTD. SHANG...

 

-

-

66.67%

-

-

-

ARKEMA CHANGSHU FLUOROCHEMICAL CO., LTD

 

-

-

54.64%

-

-

-

ARKEMA BEIJING CHEMICALS CO LTD

 

-

-

100%

-

-

-

CHANGSHU HAIKE CHEMICALS CO LTD

 

-

-

49%

-

-

-

ARKEMA CHANGSHU CHEMICALS CO LTD

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA SHANGHAI DISTRIBUTION CO. LTD

 

-

-

100%

-

-

-

SHANGHAI ARKEMA GAOYUAN CHEMICALS CO LTD

 

-

-

93.40%

-

-

-

CHANGSHU RESICHINA ENGINEERING POLYMERS ...

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA CHANGSHU FLUOROCHEMICAL CO., LTD

 

-

-

45.36%

-

-

-

DAIKIN ARKEMA REFRIGERANTS ASIA LLD

 

-

-

40%

-

-

-

ARKEMA DAIKIN ADVANCED FLUOROCHEMICALS C...

 

-

-

50%

-

-

-

ARKEMA EUROPE

 

FR05715207

429608342

34.32%

93

250 000 €

31/12/2010

ARKEMA NORTH EUROPE B.V.

 

NL01214284

24270059

100%

No Rating

-

31/12/2007

ARKEMA HOLLAND HOLDING B.V.

 

NL01970645

33220762

100%

No Rating

-

31/12/2007

ARKEMA GMBH

 

DE01798026

HRB 29373

80%

93

1 550 000 €

31/12/2009

ARKEMA LTD (UK)

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA QUIMICA SA

 

-

-

99.92%

-

-

-

PLASGOM SAU

 

-

-

99.92%

-

-

-

ARKEMA SRL

 

-

-

100%

-

-

-

ALPHACAN DOO

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA FINANCE NEDERLAND B.V.

 

NL01421604

27157026

100%

No Rating

-

31/12/2007

ARKEMA FRANCE

 

FR00950253

319632790

99.99%

100

2 000 000 €

31/12/2010

ARKEMA VLISSINGEN B.V.

 

NL01117698

22016916

100%

No Rating

-

-

DORLYL SNC

 

FR11805107

642014559

100%

19

0 €

31/12/2009

ARKEMA CANADA INC.

 

-

-

59.20%

-

-

-

ALTUMAX DEUTSCHLAND GMBH

 

DE01072374

HRB 7404

100%

No Rating

-

-

MAQUILADORA GENERAL DE MATAMOROS SA DE C...

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA ROTTERDAM B.V.

 

NL01190580

24183071

100%

No Rating

-

-

ARKEMA PEROXIDES INDIA PRIVATE LTD

 

-

-

100%

-

-

-

VETEK SA

 

-

-

60%

-

-

-

ARKEMA RE

 

FR04918819

418755096

100%

100

4 000 €

31/12/2010

SOCIETE COATEX

 

FR12169404

971509070

100%

100

2 000 000 €

31/12/2010

COATEX NETHERLANDS BV

 

-

-

100%

-

-

-

COATEX INC

 

-

-

100%

-

-

-

COATEX KOREA

 

-

-

100%

-

-

-

COATEX CENTRAL EASTERN EUROPE SRO

 

-

-

100%

-

-

-

COATEX ASIA PACIFIC INC

 

-

-

100%

-

-

-

COATEX LATIN AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...

 

-

-

100%

-

-

-

CHANGSHU COATEX ADDITIVES CO. LTD

 

-

-

100%

-

-

-

ALTUGLAS INTERNATIONAL LIMITED

 

-

-

100%

-

-

-

ALTUGLAS INTERNATIONAL SPA

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA ASIE SAS

 

FR04912713

418681029

40.60%

99

250 000 €

31/12/2010

ARKEMA K.K.

 

-

-

100%

-

-

-

AKISHIMA CHEMICAL INDUSTRIES CO LTD

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA YOSHITOMI LTD

 

-

-

49%

-

-

-

SARTOMER JAPAN INC

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA CHINA INVESTMENT CO LTD

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA HYDROGEN PEROXIDE CO., LTD. SHANG...

 

-

-

66.67%

-

-

-

ARKEMA CHANGSHU FLUOROCHEMICAL CO., LTD

 

-

-

54.64%

-

-

-

ARKEMA BEIJING CHEMICALS CO LTD

 

-

-

100%

-

-

-

CHANGSHU HAIKE CHEMICALS CO LTD

 

-

-

49%

-

-

-

ARKEMA CHANGSHU CHEMICALS CO LTD

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA SHANGHAI DISTRIBUTION CO. LTD

 

-

-

100%

-

-

-

SHANGHAI ARKEMA GAOYUAN CHEMICALS CO LTD

 

-

-

93.40%

-

-

-

CHANGSHU RESICHINA ENGINEERING POLYMERS ...

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA CHANGSHU FLUOROCHEMICAL CO., LTD

 

-

-

45.36%

-

-

-

DAIKIN ARKEMA REFRIGERANTS ASIA LLD

 

-

-

40%

-

-

-

ARKEMA DAIKIN ADVANCED FLUOROCHEMICALS C...

 

-

-

50%

-

-

-

MLPC INTERNATIONAL

 

FR12173026

986120186

100%

19

0 €

31/12/2010

ARKEMA QUIMICA LDA

 

-

-

100%

-

-

-

ALTUGLAS INTERNATIONAL SAS

 

FR03078795

388432171

100%

98

2 000 000 €

31/12/2010

ARKEMA INICIADORES SA DE CV

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA EUROPE

 

FR05715207

429608342

65.68%

93

250 000 €

31/12/2010

ARKEMA NORTH EUROPE B.V.

 

NL01214284

24270059

100%

No Rating

-

31/12/2007

ARKEMA HOLLAND HOLDING B.V.

 

NL01970645

33220762

100%

No Rating

-

31/12/2007

ARKEMA GMBH

 

DE01798026

HRB 29373

80%

93

1 550 000 €

31/12/2009

ARKEMA LTD (UK)

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA QUIMICA SA

 

-

-

99.92%

-

-

-

PLASGOM SAU

 

-

-

99.92%

-

-

-

ARKEMA SRL

 

-

-

100%

-

-

-

ALPHACAN DOO

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA LTD

 

-

-

100%

-

-

-

VINYLFOS

 

FR00701856

311867857

100%

100

1 080 000 €

31/12/2010

SCI AGRICOLE PARAPON

 

FR05596815

428343826

100%

95

-

-

ARKEMA

 

-

-

100%

-

-

-

RESINOPLAST

 

FR11820378

662037704

100%

100

1 620 000 €

31/12/2010

OXOCHIMIE

 

FR11823684

662048883

50%

100

250 000 €

31/12/2009

ALPHACAN

 

FR00643789

309745891

100%

97

2 000 000 €

31/12/2010

ALPHACAN S.P.A.

 

-

-

100%

-

-

-

ALPHACAN B.V.

 

NL00740628

16028740

100%

No Rating

-

31/12/2006

ALPHACAN ESPANA TRANSFORMADOS SAU

 

-

-

99.92%

-

-

-

SOC ETUDE REALISAT FINANCIERES

 

FR11855749

712057165

100%

19

0 €

31/12/2010

SOCIETE DES FLUIDES DIELECTRIQUES

 

FR11742458

552149353

50%

55

1 800 €

31/12/2010

ARKEMA QUIMICA LTDA

 

-

-

100%

-

-

-

CECA SA

 

FR11931513

775728025

100%

100

2 000 000 €

31/12/2010

FEBEX S.A.

 

-

-

96.77%

-

-

-

IRISH CECA LIMITED

 

IE00015767

IE021629

100%

No Rating

-

31/12/2005

CECA ITALIANA SRL

 

-

-

100%

-

-

-

WINKELMANN MINERARIA

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA PTY LTD

 

-

-

100%

-

-

-

SUNCLEAR

 

FR01388217

330338013

100%

100

2 000 000 €

31/12/2010

ARKEMA COMPANY LTD

 

-

-

100%

-

-

-

SEKI ARKEMA

 

-

-

51%

-

-

-

ARKEMA CATALYST INDIA LTD

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA ENERGIE

 

FR09374080

493446603

100%

100

1 650 €

31/12/2010

ARKEMA AFRIQUE

 

FR09374086

493446645

100%

100

1 650 €

31/12/2010

PIEZOTECH S.A.

 

FR03281963

391321122

99%

65

13 000 €

31/12/2010

ALTUGLAS INTERNATIONAL MEXICO INC

 

-

-

100%

-

-

-

AMERICAN ACRYL NA LLC

 

-

-

50%

-

-

-

ARKEMA GUANGZHOU CHEMICALS LTD

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA HOLDINGS LTD.

 

UK01138952

01470171

100%

No Rating

-

31/12/2009

ARKEMA PTE LTD

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA RE LTD

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA SP ZOO

 

-

-

100%

-

-

-

DELAWARE CHEMICALS CORPORATION

 

-

-

100%

-

-

-

LUPEROX INICIADORES SA DE CV

 

-

-

100%

-

-

-

MICHELET FINANCE INC

 

-

-

100%

-

-

-

OZARK MAHONING COMPANY

 

-

-

100%

-

-

-

PLASTICOS ALTUMAX SA

 

-

-

99.92%

-

-

-

RESIL BELGIUM NV

 

BE01204046

877366285

100%

51

0 €

31/12/2010

RESILIA SRL

 

-

-

100%

-

-

-

STANNICA LLC

 

-

-

40%

-

-

-

TURKISH PRODUCTS INC

 

-

-

100%

-

-

-

VIKING CHEMICAL COMPANY

 

-

-

100%

-

-

-

FOSFANIL SA

 

-

-

96.58%

-

-

-

ALTUGLAS POLIVAR SPA

 

-

-

100%

-

-

-

ALTUGLAS INTERNATIONAL SRL

 

-

-

100%

-

-

-

ALTUGLAS INTERNATIONAL DENMARK AS

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA MAGYARORSZAG KFT

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA PENSION FUND TRUSTEE COMPANY ...

 

UK02084786

02422536

100%

No Rating

-

31/12/2007

ARKEMA SDN BHD

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA A/S

 

-

-

100%

-

-

-

OXFORD PERFORMANCE MATERIALS INC

 

-

-

84.50%

-

-

-

ARKEMA GAS ODORANTS LLC

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA MEXICO S.A DE C.V

 

-

-

100%

-

-

-

RESINOPLAST NORTH AMERICA SRL DE CV

 

-

-

100%

-

-

-

ODOR-TECH LLC

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA SRO

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA VE KIMYA SANAYI VE TICARET

 

-

-

100%

-

-

-

ATOFINA ARGENTINA S.A.

 

-

-

100%

-

-

-

SUNCLEAR SA

 

-

-

100%

-

-

-

SUNCLEAR SRL

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA INTERNATIONAL

 

-

-

100%

-

-

-

ARKEMA COATINGS RESINS SRL

 

-

-

100%

-

-

-

Type of shareholder

Shareholders

 

 

Linkages

 

 

Ultimate parent company

ARKEMA

Direct parent

ARKEMA - 99.99 %

Group – Number of companies

123

Linkages – Number of companies

7

Number of countries

4

 

 

Safe Number

SIREN

Dernier bilan

Score

Limite

CA

ARKEMA RE LIMITED

 

IE00411739

IE420011

31/12/2009

92

900 000 €

8 178 922 €

ARKEMA LTD.

 

UK00542388

00868680

31/12/2010

84

140 000 £

4 163 000 £

ALPHACAN OMNIPLAST GMBH

 

DE00179775

HRB 1182

-

No Rating

-

-

ARKEMA GMBH, NIEDERLASSUNG KIRCHHEIMBOLA...

 

DE00936681

HRB 11862

-

No Rating

-

-

ARKEMA EUROPE SA

 

-

-

-

No Rating

-

-

ARKEMA SA

 

-

-

-

No Rating

-

-

MIMOSA SAS

 

-

-

-

No Rating

-

-

 

 

FINANCIAL INFORMATION

 

 

Trading to Date

12/31/2010

12/31/2009

12/31/2008

 

Turnover

3,112,000,000 €

2,493,800,000 €

3,316,000,000 €

 

Gross Operating Surplus

0,62 % Turnover

-10,07 % Turnover

-0,69 % Turnover

 

Net worth

370,700,000 €

171,100,000 €

417,000,000 €

 

Employees

5 000+ employees

-

-

 

Synthesized Accounts

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

Comparison mode

Average

Median

 

 

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

 

Account period (month)

12

 

12

 

12

 

 

Account Type

Normal

 

Normal

 

Normal

 

 

Deposit date

06/07/2011

 

22/07/2010

 

-

 

 

Activity Code

2014Z

 

2014Z

 

2014Z

 

 

Employees

0

 

6357

 

6515

 

 

Active account

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

2 140 700 000

24,1%

1 725 100 000

-31,2%

2 509 000 000

657 745

325360,5%

- Intangible assets

31 500 000

14,1%

27 600 000

-25,4%

37 000 000

3 846

818932,8%

- Tangible assets

672 100 000

4,1%

645 700 000

-2,6%

663 000 000

328 776

204324,9%

- Financial assets

1 437 100 000

36,6%

1 051 800 000

-41,8%

1 807 000 000

6 597

21784044,3%

Net current assets

1 599 100 000

30,3%

1 227 000 000

-25,4%

1 644 000 000

1 815 333

87988,5%

- Stocks

352 200 000

9,0%

323 200 000

-27,4%

445 000 000

342 367

102772,1%

- Advanced payments

67 600 000

30,3%

73 700 000

-10,1%

82 000 000

0

0%

- Receivables

711 600 000

-13,0%

818 200 000

-25,9%

1 104 000 000

707 158

100528,1%

- Securities and cash

467 800 000

3831,1%

11 900 000

19,0%

10 000 000

147 065

317990,6%

- Prepaid expenses

-

-

-

-

-

606,50

-

Accounts of regularization

42 400 000

223,7%

13 100 000

-73,3%

49 000 000

0

0%

Total Assets

3 782 300 000

27,6%

2 964 900 000

-29,4%

4 202 000 000

3 111 624

121453,9%

 

Passive Account

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Shareholders' equity

370 700 000

116,7%

171 100 000

-59,0%

417 000 000

1 026 599

36009,5%

Share capital

274 800 000

300%

68 700 000

1,0%

68 000 000

200 000

137300%

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

514 400 000

11,0%

463 400 000

-15,7%

550 000 000

6 531

7876182,3%

Liabilities

2 893 100 000

24,6%

2 321 100 000

-27,5%

3 201 000 000

1 120 000

258212,5%

- Financial liabilities

2 113 800 000

31,0%

1 613 900 000

-33,1%

2 412 000 000

156 281

1352463,7%

- Advanced payments received

4 300 000

-8,5%

4 700 000

135,0%

2 000 000

0

0%

- Trade account payables

449 500 000

15,7%

388 500 000

-8,4%

424 000 000

353 614

127016,0%

- Tax and social liabilities

205 400 000

-17,8%

249 900 000

-2,0%

255 000 000

116 659

175968,7%

- Other debts and fixed assets liabilities

120 300 000

68,3%

71 500 000

-43,7%

127 000 000

49 016

245330,1%

Account regularization

3 800 000

90,0%

2 000 000

-80,0%

10 000 000

0

0%

Total liabilities

3 782 300 000

27,6%

2 964 900 000

-29,4%

4 202 000 000

3 111 624

121453,9%

 

Results

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Sales of Goods

3 347 600 000

26,7%

2 642 700 000

-25,4%

3 543 000 000

2 874 842

116344,7%

Net turnover

3 112 000 000

24,8%

2 493 800 000

-24,8%

3 316 000 000

2 603 997

119408,6%

- of which net export turnover

0

0%

0

0%

0

0

0%

Operating charges

3 408 300 000

17,3%

2 904 400 000

-19,3%

3 600 000 000

2 896 360

117575,3%

Operating profit/loss

-60 700 000

76,8%

-261 700 000

-336,2%

-60 000 000

40 152

-151275,5%

Financial income

123 700 000

-28,3%

172 500 000

-10,6%

193 000 000

6 775

1825730,3%

Financial charges

88 600 000

-34,8%

135 900 000

-17,6%

165 000 000

18 557

477347,9%

Financial profit/loss

35 100 000

-4,1%

36 600 000

30,7%

28 000 000

-1 934

1814991,4%

Pretax net operating income

-25 600 000

88,6%

-225 100 000

-650,3%

-30 000 000

29 405

-87160,0%

Extraordinary income

90 400 000

-87,6%

729 200 000

428,4%

138 000 000

10 000

903900%

Extraordinary charges

82 300 000

-89,3%

767 500 000

472,8%

134 000 000

12 665

649722,3%

Extraordinary profit/loss

8 100 000

98,2%

-38 300 000

-1376,7%

3 000 000

0

0%

Net result

-700 000

99,7%

-244 500 000

-3392,9%

-7 000 000

38 685

-1909,5%

 

 Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

 

Normal Account

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Months

 

12

 

12

 

12


Accounts - Active
Current Assets |  Equalization accounts |  Reference

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Grand Total (I to VI)

Net

3 782 300 000

27,6%

2 964 900 000

-29,4%

4 202 000 000

 

Gross

CO

6 954 600 000

15,0%

6 047 300 000

-14,9%

7 103 000 000

 

Amortisation

1A

3 172 300 000

2,9%

3 082 400 000

6,3%

2 901 000 000


Non declared distributed capital (I)

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

 

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

 

 

Gross

AA

0

0%

0

-

0

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

 

Normal Account

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Months

 

12

 

12

 

12


Accounts - Active
Current Assets |  Equalization accounts |  Reference

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Grand Total (I to VI)

Net

3 782 300 000

27,6%

2 964 900 000

-29,4%

4 202 000 000

 

Gross

CO

6 954 600 000

15,0%

6 047 300 000

-14,9%

7 103 000 000

 

Amortisation

1A

3 172 300 000

2,9%

3 082 400 000

6,3%

2 901 000 000


Non declared distributed capital (I)

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AA

0

0%

0

-

0


Active fixed asset (II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total Active fixed asset (II)

Net

2 140 700 000

24,1%

1 725 100 000

-31,2%

2 509 000 000

 

Gross

BJ

5 266 800 000

10,7%

4 758 000 000

-11,1%

5 354 000 000

 

Amortisation

BK

3 126 100 000

3,1%

3 032 900 000

6,6%

2 845 000 000


Intangible fixed assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R & D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AE

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AF

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AG

0

0%

0

0%

0

Goodwill

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AH

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AI

0

0%

0

0%

0

Other intangible fixed assets

Net

31 500 000

14,1%

27 600 000

-25,4%

37 000 000

 

Gross

AJ

263 100 000

4,3%

252 300 000

-0,3%

253 000 000

 

Amortisation

AK

231 600 000

3,1%

224 700 000

4,0%

216 000 000

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible Assets

Net

31 500 000

14,1%

27 600 000

-25,4%

37 000 000



Tangilble fixed assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Lands

Net

30 100 000

-3,2%

31 100 000

0,3%

31 000 000

 

Gross

AN

45 100 000

-0,4%

45 300 000

3,0%

44 000 000

 

Amortisation

AO

15 000 000

5,6%

14 200 000

9,2%

13 000 000

Buildings

Net

89 900 000

-2,4%

92 100 000

7,1%

86 000 000

 

Gross

AP

623 700 000

1,7%

613 100 000

2,9%

596 000 000

 

Amortisation

AQ

533 800 000

2,5%

521 000 000

2,2%

510 000 000

Plant

Net

451 600 000

-1,7%

459 400 000

13,4%

405 000 000

 

Gross

AR

2 497 900 000

2,6%

2 435 300 000

6,9%

2 278 000 000

 

Amortisation

AS

2 046 300 000

3,6%

1 975 900 000

5,5%

1 873 000 000

Other tangible fixed assets

Net

7 100 000

-20,2%

8 900 000

-1,1%

9 000 000

 

Gross

AT

54 400 000

0,6%

54 100 000

8,2%

50 000 000

 

Amortisation

AU

47 300 000

4,6%

45 200 000

10,2%

41 000 000

Fixed assets in construction

Net

93 400 000

72,3%

54 200 000

-58,9%

132 000 000

 

Gross

AV

93 700 000

72,6%

54 300 000

-58,9%

132 000 000

 

Amortisation

AW

300 000

200%

100 000

0%

0

Advances and payments on account

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AX

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Tangible asset

Net

672 100 000

 

645 700 000

 

663 000 000



Financial assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

890 000 000

1,8%

874 500 000

-42,2%

1 513 000 000

 

Gross

CU

1 141 400 000

1,8%

1 121 700 000

-33,9%

1 697 000 000

 

Amortisation

CV

251 400 000

1,7%

247 200 000

34,3%

184 000 000

Inter-company receivables

Net

307 600 000

85,7%

165 600 000

-40,9%

280 000 000

 

Gross

BB

307 600 000

85,7%

165 600 000

-40,9%

280 000 000

 

Amortisation

BC

0

0%

0

0%

0

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

Loans

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BF

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BG

0

 

0

 

0

Other financial assets

Net

239 500 000

1947,0%

11 700 000

-16,4%

14 000 000

 

Gross

BH

239 900 000

1371,8%

16 300 000

-14,2%

19 000 000

 

Amortisation

BI

400 000

-91,3%

4 600 000

-8,0%

5 000 000

 

Sub Total Financial Assets

 

1 437 100 000

 

1 051 800 000

 

1 807 000 000

 

Current Assets (III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total Assets

Net

1 599 100 000

30,3%

1 227 000 000

-25,4%

1 644 000 000

 

Gross

CJ

1 645 400 000

28,9%

1 276 400 000

-24,9%

1 700 000 000

 

Amortisation

CK

46 300 000

-6,3%

49 400 000

-11,8%

56 000 000



Stocks

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Raw materials

Net

114 200 000

-3,5%

118 400 000

-24,6%

157 000 000

 

Gross

BL

138 600 000

-3,8%

144 100 000

-21,3%

183 000 000

 

Amortisation

BM

24 500 000

-4,7%

25 700 000

-1,2%

26 000 000

Work in progress (goods)

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BN

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

238 000 000

16,2%

204 800 000

-28,9%

288 000 000

 

Gross

BR

252 600 000

15,7%

218 300 000

-29,8%

311 000 000

 

Amortisation

BS

14 600 000

8,1%

13 500 000

-41,3%

23 000 000

Goods for resale

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BT

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BU

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Stocks

Net

352 200 000

9,0%

323 200 000

-27,4%

445 000 000



Advance payments to suppliers

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Advance payments to suppliers

Net

67 600 000

-8,3%

73 700 000

-10,1%

82 000 000

 

Gross

BV

67 600 000

-8,3%

73 700 000

-10,1%

82 000 000

 

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0



Debtors

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Trade accounts receivable

Net

465 400 000

-0,4%

467 200 000

-12,3%

533 000 000

 

Gross

BX

471 700 000

-1,0%

476 500 000

-11,8%

540 000 000

 

Amortisation

BY

6 300 000

-32,3%

9 300 000

32,9%

7 000 000

Other debtors

Net

244 500 000

-30,0%

349 400 000

-38,7%

570 000 000

 

Gross

BZ

245 400 000

-29,9%

350 300 000

-38,5%

570 000 000

 

Amortisation

CA

900 000

0%

900 000

0%

0

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Debtors

Net

709 900 000

-13,1%

816 600 000

-26,0%

1 103 000 000



Divers

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Investment securities

Net

464 000 000

0%

0

0%

0

 

Gross

CD

464 000 000

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

3 800 000

-68,1%

11 900 000

19,0%

10 000 000

 

Gross

CF

3 800 000

-68,1%

11 900 000

19,0%

10 000 000

 

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Divers

Net

467 800 000

3831,1%

11 900 000

19,0%

10 000 000



Prepaid expenses

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Prepaid expenses

Net

1 700 000

6,2%

1 600 000

60,0%

1 000 000

 

Gross

CH

1 700 000

6,2%

1 600 000

60,0%

1 000 000

 

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts (IV to VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Multi-period charges

CW3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

-

-

 

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

-

-

 

Currency differential gain

CN3

42 400 000

223,7%

13 100 000

-73,3%

49 000 000

 

Gross

 

42 400 000

223,7%

13 100 000

-

-

 

References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

 

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Accounts - Passive
Other capital resources | Provisions for risks and charges | Liabilities | Translation loss | Equalization accounts | References

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Grand Total (I to V)

EE

3 782 300 000

27,6%

2 964 900 000

-29,4%

4 202 000 000


Shareholder Equity (I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total shareholders' equity (Total I)

DL

370 700 000

116,7%

171 100 000

-59,0%

417 000 000

 

Equity and shareholders' equity

DA

274 800 000

300%

68 700 000

1,0%

68 000 000

 

Issue and merger premiums

DB

0

0%

0

0%

0

 

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

 

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

 

Legal reserve

DD

6 900 000

0%

6 900 000

15,0%

6 000 000

 

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

 

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

 

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

 

Other reserves

DG

0

0%

0

0%

0

 

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

 

0

0%

0

 

Profits or losses brought forward

DH

-84 900 000

-153,2%

159 600 000

-4,4%

167 000 000

 

Profit or loss for the period

DI

-700 000

99,7%

-244 500 000

-3392,9%

-7 000 000

 

Investment grants

DJ

500 000

-28,6%

700 000

-30,0%

1 000 000

 

Special tax-allowable reserves

DK

174 100 000

-3,1%

179 700 000

-0,2%

180 000 000

 
Other capital resources (II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

 

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

 

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

 



Provisions for risks and charges (III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

514 400 000

11,0%

463 400 000

-15,7%

550 000 000

 

Risk provisions

DP

314 700 000

15,2%

273 200 000

-42,5%

475 000 000

 

Reserves for charges

DQ

199 700 000

5,0%

190 100 000

153,5%

75 000 000

 

Liabilities (IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total Liabilities (Total IV)

EC

2 893 100 000

24,6%

2 321 100 000

-27,5%

3 201 000 000

 

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

 

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

 

Bank loans and liabilities

DU

137 300 000

-56,8%

317 600 000

-23,5%

415 000 000

 

Sundry loans and financial liabilities

DV

1 976 500 000

52,5%

1 296 300 000

-35,1%

1 997 000 000

 

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

 

Advance payments received for current orders

DW

4 300 000

-8,5%

4 700 000

135,0%

2 000 000

 

Trade accounts payables

DX

449 500 000

15,7%

388 500 000

-8,4%

424 000 000

 

Tax and social security liabilities

DY

205 400 000

-17,8%

249 900 000

-2,0%

255 000 000

 

Fixed asset liabilities

DZ

61 800 000

124,7%

27 500 000

-55,6%

62 000 000

 

Other debts

EA

54 500 000

57,5%

34 600 000

-3,9%

36 000 000

 
Translation loss (V)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Translation loss (Total V)

ED

4 000 000

-57,4%

9 400 000

-67,6%

29 000 000

 

Equalization accounts

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Deferred income

EB

3 800 000

90,0%

2 000 000

-80,0%

10 000 000

 

References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

 

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

 

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

 Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Result account
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges | Financial income | Financial charges | Financial charges | Extraordinary charges | Employee profit sharing | Tax on profits | References

1- Operating result (I-II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Operating result (Total I-II)

GG

-60 700 000

76,8%

-261 700 000

-336,2%

-60 000 000


2 - Financial result (V - VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Financial result (Total V-VI)

GV

35 100 000

-4,1%

36 600 000

30,7%

28 000 000


3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

-25 600 000

88,6%

-225 100 000

-650,3%

-30 000 000


4 - Extraordinary result (VII-VIII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

8 100 000

121,1%

-38 300 000

-1376,7%

3 000 000


Profit or loss

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Profit or loss

HN

-700 000

99,7%

-244 500 000

-3392,9%

-7 000 000


Total Income (I+III+V+VII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total Income (I+III+V+VII)

HL

3 561 700 000

0,5%

3 544 300 000

-8,5%

3 873 000 000


Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

3 562 400 000

-6,0%

3 788 800 000

-2,4%

3 880 000 000


Operating income (I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total operating income (Total I)

FR

3 347 600 000

26,7%

2 642 700 000

-25,4%

3 543 000 000


Operating income (details)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sale of goods for resale

FC

0

0%

0

0%

0

 

France

FA

0

0%

0

0%

0

 

Export

FB

0

0%

0

0%

0

Sale of goods produced

FF

2 855 700 000

26,4%

2 259 100 000

-25,5%

3 034 000 000

 

France

FD

2 855 700 000

26,4%

2 259 100 000

-25,5%

3 034 000 000

 

Export

FE

0

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

256 300 000

9,2%

234 700 000

-16,8%

282 000 000

 

France

FG

256 300 000

9,2%

234 700 000

-16,8%

282 000 000

 

Export

FH

0

0%

0

0%

0

Net turnover

FL

3 112 000 000

24,8%

2 493 800 000

-24,8%

3 316 000 000

 

France

FJ

3 112 000 000

24,8%

2 493 800 000

-24,8%

3 316 000 000

 

Export

FK

0

0%

0

0%

0

 

Stocked production

FM

34 300 000

136,8%

-93 200 000

-1764,0%

-5 000 000

 

Self-constructed assets

FN

10 600 000

2,9%

10 300 000

3,0%

10 000 000

 

Operating grants

FO

5 700 000

-8,1%

6 200 000

24,0%

5 000 000

 

Release of reserves and provisions

FP

164 300 000

-21,1%

208 200 000

6,2%

196 000 000

 

Other income

FQ

20 700 000

20,3%

17 200 000

-14,0%

20 000 000


Operating charges (II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total operating charges (Total II)

GF

3 408 300 000

17,3%

2 904 400 000

-19,3%

3 600 000 000


Exploitation charges

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Purchase of goods for resale

FS

0

0%

0

0%

0

 

Change in stocks of goods for resale

FT

0

0%

0

0%

0

 

Purchase of raw materials

FU

1 845 900 000

33,9%

1 379 000 000

-31,4%

2 011 000 000

 

Change in stocks of raw materials

FV

5 400 000

-86,2%

39 000 000

454,5%

-11 000 000

 

Other external purchases and charges

FW

786 600 000

5,2%

747 500 000

-11,2%

842 000 000

 

Tax, duty and similar payments

FX

52 400 000

-2,4%

53 700 000

-0,6%

54 000 000

 

Payroll

FY

297 200 000

-0,4%

298 400 000

-0,2%

299 000 000

 

Social security costs

FZ

155 800 000

3,5%

150 600 000

-2,2%

154 000 000


Depreciation

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

 

Depreciation of fixed assets

GA

137 400 000

3,2%

133 100 000

2,4%

130 000 000

 

 

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

0

 

 

Depreciation/amortisation of current assets

GC

43 500 000

-17,5%

52 700 000

3,3%

51 000 000

 

 

Provisions for risks and charges

GD

73 900 000

86,1%

39 700 000

-27,8%

55 000 000

 

 

 Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Result account
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges | Financial income | Financial charges | Financial charges | Extraordinary charges | Employee profit sharing | Tax on profits | References

1- Operating result (I-II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Operating result (Total I-II)

GG

-60 700 000

76,8%

-261 700 000

-336,2%

-60 000 000


2 - Financial result (V - VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Financial result (Total V-VI)

GV

35 100 000

-4,1%

36 600 000

30,7%

28 000 000


3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

-25 600 000

88,6%

-225 100 000

-650,3%

-30 000 000


4 - Extraordinary result (VII-VIII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

8 100 000

121,1%

-38 300 000

-1376,7%

3 000 000


Profit or loss

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Profit or loss

HN

-700 000

99,7%

-244 500 000

-3392,9%

-7 000 000


Total Income (I+III+V+VII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total Income (I+III+V+VII)

HL

3 561 700 000

0,5%

3 544 300 000

-8,5%

3 873 000 000


Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

3 562 400 000

-6,0%

3 788 800 000

-2,4%

3 880 000 000


Operating income (I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total operating income (Total I)

FR

3 347 600 000

26,7%

2 642 700 000

-25,4%

3 543 000 000


Operating income (details)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sale of goods for resale

FC

0

0%

0

0%

0

 

France

FA

0

0%

0

0%

0

 

Export

FB

0

0%

0

0%

0

Sale of goods produced

FF

2 855 700 000

26,4%

2 259 100 000

-25,5%

3 034 000 000

 

France

FD

2 855 700 000

26,4%

2 259 100 000

-25,5%

3 034 000 000

 

Export

FE

0

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

256 300 000

9,2%

234 700 000

-16,8%

282 000 000

 

France

FG

256 300 000

9,2%

234 700 000

-16,8%

282 000 000

 

Export

FH

0

0%

0

0%

0

Net turnover

FL

3 112 000 000

24,8%

2 493 800 000

-24,8%

3 316 000 000

 

France

FJ

3 112 000 000

24,8%

2 493 800 000

-24,8%

3 316 000 000

 

Export

FK

0

0%

0

0%

0

 

Stocked production

FM

34 300 000

136,8%

-93 200 000

-1764,0%

-5 000 000

 

Self-constructed assets

FN

10 600 000

2,9%

10 300 000

3,0%

10 000 000

 

Operating grants

FO

5 700 000

-8,1%

6 200 000

24,0%

5 000 000

 

Release of reserves and provisions

FP

164 300 000

-21,1%

208 200 000

6,2%

196 000 000

 

Other income

FQ

20 700 000

20,3%

17 200 000

-14,0%

20 000 000


Operating charges (II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total operating charges (Total II)

GF

3 408 300 000

17,3%

2 904 400 000

-19,3%

3 600 000 000


Exploitation charges

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Purchase of goods for resale

FS

0

0%

0

0%

0

 

Change in stocks of goods for resale

FT

0

0%

0

0%

0

 

Purchase of raw materials

FU

1 845 900 000

33,9%

1 379 000 000

-31,4%

2 011 000 000

 

Change in stocks of raw materials

FV

5 400 000

-86,2%

39 000 000

454,5%

-11 000 000

 

Other external purchases and charges

FW

786 600 000

5,2%

747 500 000

-11,2%

842 000 000

 

Tax, duty and similar payments

FX

52 400 000

-2,4%

53 700 000

-0,6%

54 000 000

 

Payroll

FY

297 200 000

-0,4%

298 400 000

-0,2%

299 000 000

 

Social security costs

FZ

155 800 000

3,5%

150 600 000

-2,2%

154 000 000


Depreciation

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Depreciation of fixed assets

GA

137 400 000

3,2%

133 100 000

2,4%

130 000 000

 

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

0

 

Depreciation/amortisation of current assets

GC

43 500 000

-17,5%

52 700 000

3,3%

51 000 000

 

Provisions for risks and charges

GD

73 900 000

86,1%

39 700 000

-27,8%

55 000 000


Other charges

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Other charges

GE

10 200 000

-5,6%

10 800 000

-28,0%

15 000 000

 

Operating charges (III-IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

 

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

 

Financial income (V)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total financial income (Total V)

GP

123 700 000

-28,3%

172 500 000

-10,6%

193 000 000

 

Share financial income

GJ

56 600 000

-53,8%

122 400 000

-11,3%

138 000 000

 

Other investment income & capitalised receivables

GK

0

0%

0

0%

8 000 000

 

Other interest and similar income

GL

1 600 000

-44,8%

2 900 000

-75,8%

12 000 000

 

Released provisions and transferred charges

GM

16 200 000

-63,6%

44 500 000

27,1%

35 000 000

 

Exchange gains

GN

49 000 000

1714,8%

2 700 000

0%

0

 

Net income from disposal of investment securities

GO

300 000

0%

0

0%

0

 

Financial Charge (VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total financial charge (Total VI)

GU

88 600 000

-34,8%

135 900 000

-17,6%

165 000 000

 

Financial reserves and provisions

GQ

55 200 000

-17,6%

67 000 000

19,6%

56 000 000

 

Interest and similar charges

GR

21 100 000

-22,7%

27 300 000

-71,0%

94 000 000

 

Exchange losses

GS

12 300 000

0%

0

0%

0

 

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

41 500 000

176,7%

15 000 000

 

Financial Charge (VII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total extraordinary income (Total VII)

HD

90 400 000

-87,6%

729 200 000

428,4%

138 000 000

 

Extraordinary operating income

HA

6 700 000

235,0%

2 000 000

-90,5%

21 000 000

 

Extraordinary income from capital transactions

HB

17 000 000

-97,3%

624 200 000

1200,4%

48 000 000

 

Released provisions and transferred charges

HC

66 700 000

-35,2%

103 000 000

51,5%

68 000 000

 

Extraordinary charges (VIII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

82 300 000

-89,3%

767 500 000

472,8%

134 000 000

 

Extraordinary operating charges

HE

12 300 000

-65,1%

35 200 000

30,4%

27 000 000

 

Extraordinary charges from capital transactions

HF

9 200 000

-98,5%

605 600 000

3462,4%

17 000 000

 

Extraordinary reserves and provisions

HG

60 800 000

-52,0%

126 700 000

40,8%

90 000 000

 

Employee profit sharing (IX)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

0

0%

0

0%

0

 

Tax on profits (X)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Tax on profits (Total X)

HK

-16 800 000

11,6%

-19 000 000

0%

-19 000 000

 

References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

 

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

 

Of which transferred charges

A1

0

0%

0

0%

0

 

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Other incomer tax return forms
Reserve for depreciation | Provisions included in balance sheet | State deadlines claims and debts at the end of period
Table allocation results and other information

Fixed Assets
Grand Total Fixed Assets (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

5 221 000 000

 

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

531 000 000

 

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

OK2

280 600 000

-65,0%

802 200 000

101,1%

399 000 000

 

Gross value at the end of period

OL

5 266 900 000

10,7%

4 758 000 000

-11,1%

5 354 000 000


Research and development Charge (Total I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

C01

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

C02

0

0%

0

0%

0

 

Gross value at the end of period

D0

0

0%

0

0%

0


Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

KD

252 300 000

-0,6%

253 700 000

8,9%

233 000 000

 

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

19 300 000

46,2%

13 200 000

-45,0%

24 000 000

 

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

LV2

8 500 000

-41,8%

14 600 000

265,0%

4 000 000

 

Gross value at the end of period

LW

263 100 000

4,3%

252 300 000

-0,3%

253 000 000


Tangible fixed assets (Total III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

LN

3 202 100 000

3,2%

3 103 800 000

3,2%

3 007 000 000

 

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

216 800 000

86,3%

116 400 000

-16,3%

139 000 000

 

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NG2

104 000 000

474,6%

18 100 000

-56,9%

42 000 000

 

Gross value at the end of period

NH

3 314 900 000

3,5%

3 202 100 000

3,2%

3 104 000 000


Fiancial assets (Total IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

LQ

1 303 600 000

-34,7%

1 997 200 000

0,8%

1 981 000 000

 

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

553 400 000

629,1%

75 900 000

-79,4%

368 000 000

 

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NJ2

168 100 000

-78,2%

769 500 000

118,0%

353 000 000

 

Gross value at the end of period

NK

1 688 900 000

29,6%

1 303 600 000

-34,7%

1 996 000 000

 

Reserve for depreciation
Situation and movement of reserve for depreciation
Grand total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

0N

0

0%

0

0%

2 419 000 000

Increases

0P

0

0%

0

0%

133 000 000

Decreasess

0Q

0

0%

0

0%

40 000 000

 

Reserve for depreciation value at the end of period

0R

0

0%

0

0%

2 512 000 000


Research and development charge (Total I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0


Other intangible assets (Total II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

199 800 000

4,2%

191 700 000

4,8%

183 000 000

Increases

PF

7 000 000

-13,6%

8 100 000

1,2%

8 000 000

Decreasess

PG

100 000

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PH

206 700 000

3,5%

199 800 000

4,6%

191 000 000


Total fixed assets amotisation (Total III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

2 455 800 000

5,8%

2 321 500 000

3,8%

2 236 000 000

Increases

QV

144 400 000

-3,7%

149 900 000

19,9%

125 000 000

Decreases

QW

20 600 000

32,9%

15 500 000

-61,2%

40 000 000

 

Decreasess by budget item transfer

QX

2 579 600 000

5,0%

2 455 800 000

5,8%

2 321 000 000


Movements during period affecting charge allocated over several period
Charges à répartir ou frais d'émission d'emprunt

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0


Premium refund of obligations

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Net value at begining of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

 

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

 

Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

7C

1 070 000 000

-4,6%

1 121 600 000

-1,6%

1 140 000 000

Increases

UB

229 200 000

-12,3%

261 200 000

4,5%

250 000 000

Decreases

UC

224 400 000

-28,3%

312 800 000

14,2%

274 000 000

 

Value at the end of period

UD

1 074 800 000

0,4%

1 070 000 000

-4,1%

1 116 000 000

Includes Total allocations

 

Operating

UE

117 400 000

27,1%

92 400 000

-13,6%

107 000 000

 

Financial

UG

55 200 000

-17,6%

67 000 000

19,6%

56 000 000

 

Exceptional

UJ

54 000 000

-47,0%

101 800 000

17,0%

87 000 000

Includes Total Withdrawal

 

Operating

UF

138 900 000

-22,4%

178 900 000

-7,8%

194 000 000

 

Financial

UH

16 200 000

-63,6%

44 500 000

270,8%

12 000 000

 

Exceptional

UK

66 700 000

-25,4%

89 400 000

31,5%

68 000 000


Total regulated provisions (Total I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

3Z

179 700 000

-0,5%

180 600 000

1,5%

178 000 000

Increases

TS

28 700 000

-21,4%

36 500 000

7,4%

34 000 000

Decreases

TT

34 300 000

-8,3%

37 400 000

16,9%

32 000 000

 

Value at the end of period

TU

174 100 000

-3,1%

179 700 000

-0,2%

180 000 000


Total risk and charge provisions (Total II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

5Z

463 400 000

-16,0%

551 700 000

-5,5%

584 000 000

Increases

TV

136 300 000

47,0%

92 700 000

-29,2%

131 000 000

Decreases

TW

85 300 000

-52,9%

181 000 000

7,7%

168 000 000

 

Value at the end of period

TX

514 400 000

11,0%

463 400 000

-15,3%

547 000 000


Total Provision for depreciation (Total III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

7B

426 900 000

9,7%

389 300 000

3,0%

378 000 000

Increases

TY

64 200 000

-51,4%

132 000 000

55,3%

85 000 000

Decreases

TZ

104 800 000

11,0%

94 400 000

27,6%

74 000 000

 

Value at the end of period

UA

386 300 000

-9,5%

426 900 000

9,7%

389 000 000

 
State deadlines claims and debts at the end of period
State claims

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Gross value

VT

1 266 300 000

25,1%

1 011 900 000

-32,3%

1 495 000 000

 

1 year at most

VU

956 500 000

12,5%

850 200 000

-22,7%

1 100 000 000

 

More than one year

VV

309 800 000

91,6%

161 700 000

-59,1%

395 000 000


State of loans

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Claims related to holdings (gross)

UL

307 600 000

85,7%

165 600 000

-40,9%

280 000 000

 

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

15 700 000

-20,3%

19 700 000

0%

0

 

Loans (gross)

UP

0

0%

0

0%

0

 

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

0

0%

0

 

Other financial assets (gross)

UT

239 900 000

1371,8%

16 300 000

-14,2%

19 000 000

 

Other financial assets (1 year at most)

UV

222 000 000

44300%

500 000

0%

0


Receivables statement of assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Customers doubtful or disputed

VA

0

0%

0

0%

0

 

Other claims customer

UX

471 700 000

-1,0%

476 500 000

-11,8%

540 000 000

 

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

 

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

 

Personnel and associated accounts

UY

0

0%

0

0%

0

 

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

0

0%

0

 

Income taxes

VM

0

0%

0

0%

0

 

Value added tax

VB

0

0%

0

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

VN

0

0%

0

0%

0

 

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

0

0%

0

 

Group and Associates

VC

0

0%

0

0%

0

 

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

247 100 000

-29,8%

351 900 000

0%

0


Prepaid

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Prepaid

VS

0

0%

1 600 000

0%

0


State Debt

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total debt (gross)

VY

779 300 000

10,2%

707 200 000

-77,9%

3 200 000 000

1 year at most

VZ2

779 300 000

10,2%

707 200 000

-71,2%

2 458 000 000

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

0

0%

0

0%

24 000 000

More than 5 years

VZ4

0

0%

0

0%

718 000 000


Details

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VG2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

0

0%

0

0%

413 000 000

1 year at most

VH2

0

0%

0

0%

413 000 000

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

0

0%

0

0%

1 998 000 000

1 year at most

8A2

0

0%

0

0%

1 256 000 000

More than 1 year and 5 years at most

8A3

0

0%

0

0%

24 000 000

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

449 500 000

15,7%

388 500 000

-8,4%

424 000 000

1 year at most

8B2

449 500 000

15,7%

388 500 000

-8,4%

424 000 000

More than 1 year and 5 years at most

8B3

449 500 000

15,7%

388 500 000

0%

0

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8C2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

205 400 000

-17,8%

249 900 000

-2,0%

255 000 000

1 year at most

8D2

205 400 000

-17,8%

249 900 000

-2,0%

255 000 000

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (gross)

VW1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VW2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VQ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

61 800 000

124,7%

27 500 000

-55,6%

62 000 000

1 year at most

8J2

61 800 000

124,7%

27 500 000

-55,6%

62 000 000

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VI2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More 5 years

VI4

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

58 800 000

42,4%

41 300 000

8,7%

38 000 000

1 year at most

8K2

58 800 000

42,4%

41 300 000

8,7%

38 000 000

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

3 800 000

0%

0

0%

10 000 000

1 year at most

8L2

3 800 000

0%

0

0%

10 000 000

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0


References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Loans made during the period

VJ

0

0%

0

0%

0

 

Debt repaid during the period

VK

0

0%

0

0%

0

 

Table allocation results and other information
Dividends distributed

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0


Commitments

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

 

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

 

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0


Other charges Externes

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

 

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

 

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

 

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

 

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

 

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

 

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0


Taxes and Fees

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

 

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0


VAT

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

 

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0


Average number of employees

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Average number of employees

YP

0

0%

6 357

-2,4%

6 515


Groups and Shareholders

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Groups and Shareholders

ZR

0

-

0

-

-

 

 

 

Display parameter

Comparison mode

Average

Median


Ratios
Structure and liquidity | Management or rotation | Profitability of the business | Return on capital

Structure and Liquidity

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Fixed Asset Financing

1,16

4,5%

1,11

-4,3%

1,16

1,27

-8,7%

Global Debt

335 days

0%

335 days

-3,7%

348 days

140,50 days

138,4%

Working Capital Fund overall net

99 days

30,3%

76 days

-19,1%

94 days

101 days

-2,0%

Financial independence

269,99%

401,2%

53,87%

-46,4%

100,48%

756,73%

-64,3%

More ratios

Solvability

9,80%

69,8%

5,77%

-41,8%

9,92%

50,66%

-80,7%

Capacity debt futures

%

-

%

-

100,97%

2688,56%

-

Coverage of current assets by net working capital overall

40,72%

-0,8%

41,05%

-20,0%

51,30%

49,67%

-18,0%

General Liquidity

1,23

2,5%

1,20

166,7%

0,45

0,69

78,3%

Restricted Liquidity

1,83

50,0%

1,22

171,1%

0,45

1,14

60,5%


Management or rotation

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Need background in operating working capital

41 days

-43,8%

73 days

-20,7%

92 days

45 days

-8,9%

Treasury

54 days

2600%

2 days

100%

1 days

12,50 days

332,0%

Inventory turnover of goods

days

-

days

-

days

4 days

-

Average length of credit granted to customers

55 days

-20,3%

69 days

16,9%

59 days

59 days

-6,8%

Average length of credit obtained suppliers

61 days

-6,2%

65 days

20,4%

54 days

63 days

-3,2%

More ratios

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

27 days

-28,9%

38 days

15,2%

33 days

42 days

-35,7%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

94 days

20,5%

78 days

-27,1%

107 days

129 days

-27,1%

Rotation tangible assets

93,88%

20,5%

77,88%

-27,1%

106,83%

117,17%

-19,9%


Profitability of the business

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Margin trading

0%

0%

0%

0%

0

0%

0%

Profitability of the business

0,62

106,2%

-10,07

-1359,4%

-0,69

6,83%

-90,9%

Net profit

-0,02%

99,8%

-9,80%

-4566,7%

-0,21%

2,35%

-100,9%

More ratios

Growth rate of turnover (excluding VAT)

24,79%

200%

-24,79%

-1397,9%

1,91%

5,11%

385,1%

Rates integration

16,68%

69,5%

9,84%

-31,9%

14,45%

24,80%

-32,7%

Rate leasing furniture

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Work Factor

87,28%

-52,3%

182,97%

93,5%

94,57%

48%

81,8%

Weight interests

2,85

-47,7%

5,45%

9,4%

4,98%

0,65%

338,5%


Return on capital

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Cash flow from the overall profitability

0,74%

107,4%

-9,99%

-816,5%

-1,09%

6,46%

-88,5%

Rates of economic profitability

1%

107,1%

-14%

-1300%

-1%

11%

-90,9%

Financial profitability

370700000%

116,7%

171100000%

-59,0%

417000000%

1026599%

36009,5%

Return on investment

3,54%

158,2%

-6,08%

-208,8%

5,59%

5,68%

-37,7%

 

 Display parameter

 

Currency

Euro

Kilo Euro

 

Comparison mode

Average

Median

 


Soldes Intermédiaires de Gestion

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Turnover

3 112 000 000

24,8%

2 493 800 000

-24,8%

3 316 000 000

2 603 997 € 

119408,6% 

 

Sales of goods

0

0%

0

0%

0

 

 

- Purchase of goods

0

0%

0

0%

0

 

 

+/- Stock of goods variation

0

0%

0

0%

0

 

 

Trading margin

0 €

0%

0 €

0%

0 €

0 € 

0% 

 

0,00 % CA

0%

0,00 % CA

0%

0,00 % CA

0 % CA 

0% 

 

Sale of goods produced

3 112 000 000

24,8%

2 493 800 000

-24,8%

3 316 000 000

 

 

+/- Stocked production

34 300 000

136,8%

-93 200 000

-1764,0%

-5 000 000

 

 

+ Self-constructed assets

10 600 000

2,9%

10 300 000

3,0%

10 000 000

 

 

Period production

3 156 900 000 €

30,9%

2 410 900 000 €

-27,4%

3 321 000 000 €

2 352 303 € 

134104,6% 

 

101,44 % CA

4,9%

96,68 % CA

-3,5%

100,15 % CA

99,92 % CA 

1,5% 

 

Trading margin

0

0%

0

0%

0

0% 

+ Period Production

3 156 900 000

30,9%

2 410 900 000

-27,4%

3 321 000 000

2 352 303 

134104,6% 

- Purchase of raw materials

1 845 900 000

33,9%

1 379 000 000

-31,4%

2 011 000 000

 

 

+/- Change in stocks of raw materiels

5 400 000

-86,2%

39 000 000

454,5%

-11 000 000

 

 

- Other external purchases and charges

786 600 000

5,2%

747 500 000

-11,2%

842 000 000

 

 

Added value

519 000 000 €

111,5%

245 400 000 €

-48,8%

479 000 000 €

352 323 € 

147208,0% 

 

16,68 % CA

69,5%

9,84 % CA

-31,9%

14,45 % CA

24,80 % CA 

-32,7% 

 

Added value

519 000 000 €

111,5%

245 400 000 €

-48,8%

479 000 000 €

352 323 € 

147208,0% 

+ Operating grants

5 700 000

-8,1%

6 200 000

24,0%

5 000 000

 

 

- Tax, duty and similar payments

52 400 000

-2,4%

53 700 000

-0,6%

54 000 000

 

 

- Personal charges

453 000 000

0,9%

449 000 000

-0,9%

453 000 000

 

 

Gross operating surplus

19 300 000 €

107,7%

-251 100 000 €

-991,7%

-23 000 000 €

77 552 € 

24786,5% 

 

0,62 % CA

106,2%

-10,07 % CA

-1359,4%

-0,69 % CA

6,83 % CA 

-90,9% 

 

Gross operating surplus

19 300 000 €

107,7%

-251 100 000 €

-991,7%

-23 000 000 €

77 552 € 

24786,5% 

+ Release of reserves and provisions

164 300 000

-21,1%

208 200 000

6,2%

196 000 000

 

 

+ Other operating income

20 700 000

20,3%

17 200 000

-14,0%

20 000 000

 

 

- Depreciation/Amortisation

254 800 000

13,0%

225 500 000

-4,4%

236 000 000

 

 

- Other charges

10 200 000

-5,6%

10 800 000

-28,0%

15 000 000

 

 

Operating result

-60 700 000 €

76,8%

-262 000 000 €

-351,7%

-58 000 000 €

40 152 € 

-151275,5% 

 

0,62 % CA

106,2%

-10,07 % CA

-1359,4%

-0,69 % CA

6,35 % CA 

-90,2% 

 

Operating result

-60 700 000 €

76,8%

-262 000 000 €

-351,7%

-58 000 000 €

40 152 € 

-151275,5% 

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Financial income

123 700 000

-28,3%

172 500 000

-10,6%

193 000 000

 

 

- Financial charges

88 600 000

-34,8%

135 900 000

-17,6%

165 000 000

 

 

Pre-tax result

-25 600 000 €

88,6%

-225 400 000 €

-651,3%

-30 000 000 €

36 775 € 

-69712,5% 

 

-0,82 % CA

90,9%

-9,04 % CA

-904,4%

-0,90 % CA

2,75 % CA 

-129,8% 

 

Extraordinary income

90 400 000

-87,6%

729 200 000

428,4%

138 000 000

10 000 

903900% 

- Extraordinary charges

82 300 000

-89,3%

767 500 000

472,8%

134 000 000

 

 

Extraordinary result

8 100 000 €

121,1%

-38 300 000 €

-1057,5%

4 000 000 €

0 € 

0% 

 

0,26 % CA

116,9%

-1,54 % CA

-1383,3%

0 % CA

0 % CA 

0% 

 

Pre-tax result

-25 600 000 €

88,6%

-225 400 000 €

-651,3%

-30 000 000 €

36 775 € 

-69712,5% 

Extraordinary result

8 100 000 €

121,1%

-38 300 000 €

-1057,5%

4 000 000 €

0 € 

0% 

- Employee profit sharing

0

0%

0

0%

0

 

 

- Tax on profits

-16 800 000

11,6%

-19 000 000

0%

-19 000 000

 

 

Net result

-700 000 €

99,7%

-244 700 000 €

-3395,7%

-7 000 000 €

45 118 € 

-1651,5% 

-0,02 % CA

99,8%

-9,81 % CA

-4571,4%

-0,21 % CA

2,89 % CA 

-100,7% 

 


FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Na

 

 

ADDITIONAL INFORMATION

 

 

 

 

No social security and tax office preferential right to date

Establishment details

 

 

 

Activity (APE)

Activités des sièges sociaux (7010Z)

Business Pages FT®

 

 

Postal Address

ARKEMA FRANCE
/8
420 RUE ESTIENNE D ORVES
92700 COLOMBES

Trading Address

420 RUE ESTIENNE D ORVES
92700 COLOMBES

 

Telephone

01 49 00 70 09

 

Fax

 

 

 

 

Type

Head office

Status

Economically active

 

Formation Date

06/2007

Reason for formation

Formation

 

Closure Date

 

Reason for closure

 

 

Reactivation Date

 

Production Role

 

 

Activity Nature

 

Activity Location

 

 

Location surface

 

Seasonality

 

 

 

 

Department

Hauts-de-Seine (92)

Region

Ile-de-France

 

 

District

2

Area

92

 

 

City

COLOMBES

Size of urban area

Paris conglomeration

 

Other establishments

 

 

 

Branches

40 branch entities in this company

 

 

 

Head office

 
> ARKEMA FRANCE <<<  - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (2014Z)  in COLOMBES  (92700)
 

 

 

Secondary establishments

>  ATOFINA  - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (241G)  in MARSEILLE 8  (13008)
>  ARKEMA FRANCE  - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (2014Z)  in VERNEUIL EN HALATTE  (60550)
>  ARKEMA FRANCE  - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (2014Z)  in VILLERS SAINT PAUL  (60870)
>  ARKEMA FRANCE  - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (2014Z)  in PIERRE BENITE  (69310)
> ...

 

 

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas but no one grouping more than 50% of workforce

 

 

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which one activity grouping from 80 to 99% of workforce

 

Workforces

 

 

 

Workforce at address

500 to 999 employees

Company workforce

5 000+ employees

 

judgements

 

 

Collective procedures

 

 

 

 

No judgment information for the company

 

 

 

 

 

 

 

   Social security, pension funds preferential rights | Tax office preferential rights

Preferential rights details and history

Summary of preferential rights

Company monitored since

14/09/2007

 

 

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

Tax office preferential rights

Number of active preferential rights

0

Total amount

-

Due remaining amount

-

Date of last preferential right

-

 

Historical Data

Registration number

Registration date

Date of the planned end

Creditor

Amount of the debt

Due remaining amount

41100541

25/05/2011

19/07/2011

DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

432 238 EUR

-

Reason for closure

Crossed Off

Court

Nanterre

Creditor

DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
8 RUE COURTOIS 93505, PANTIN CEDEX

Debtor

ARKEMA FRANCE
420 RUE Estienne d Orves 92700 COLOMBES, FR

   

 

event history

 

 

Status history

 

 

 

Date

Description

No Status History

 

 

 

Recent publications in Gazettes

 

 

 

Publication date

Gazette Name

Description

 

07/10/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

62 - PAS-DE-CALAIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS

524 - Réctificatif.
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : . Date de parution : 14 septembre 2011. Numéro d’annonce : 543. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant.
319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 76386269 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Fabrication et distillation de goudrons, développement, production et commercialistion des résines de revêtemetns. Adresse : 121 route de Lille, 62218 Loison-sous-Lens.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : la voix du nord du 16/07/2011. Oppositions : au siège de la société CRAY VALLEY SA 16-32 rue Henry Régnault la défense 6 92400 COURBEVOIE et pour la validité au lieu d exploitation à ROUVROY Route d'Arras Drocourt MERCI DE COMPLETER LE CAPITAL SOCIAL DE LA STE ARKEMA FRANCE SOIT / 274 845 346.04 EUROS. Descriptif : Modification survenue sur l'activit¿. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

14/09/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

62 - PAS-DE-CALAIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS

543 - Réctificatif.
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : . Date de parution : 2 août 2011. Numéro d’annonce : 720. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant.
319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 76386269 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Fabrication et distillation de goudrons, développement, production et commercialistion des résines de revêtemetns. Adresse : 121 route de Lille, 62218 Loison-sous-Lens.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : la voix du nord du 16/07/2011. Oppositions : au siège de la société CRAY VALLEY SA 16-32 rue Henry Régnault la défense 6 92400 COURBEVOIE et pour la validité au lieu d exploitation à ROUVROY Route d'Arras Drocourt. Descriptif : Modification survenue sur l'activit¿. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

02/08/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

62 - PAS-DE-CALAIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS

720 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Etablissement secondaire précédemment exploité en location-gérance acquis par apport au montant évalué à 7279029677 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Fabrication et distillation de goudrons . Développement production et commercialisation des résines de revêtements. Adresse : 121 route de Lille, 62218 Loison-sous-Lens. Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 76386269 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Fabrication et distillation de goudrons, développement, production et commercialistion des résines de revêtemetns. Adresse : 121 route de Lille, 62218 Loison-sous-Lens.
Précédent propriétaire : NORSOLOR. 301 459 525 RCS Arras. Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 31/07/1990. Publication légale : Publicateur légal du 03/08/1990. Oppositions : pas d'oppositions. Descriptif : Modification survenue sur l'activit¿. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

27/07/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

60 - OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE

844 - 319 632 790 RCS Compiegne. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 76386469 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : recherche et développement dans le domaine des résines Photoréticulables et des résines de revêtement. Adresse : rue Jacques Taffanel, 60550 Verneuil-en-Halatte.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : Le Parisien du 16/07/2011. Oppositions : ARKEMA FRANCE ZA de Villers St Paul BP 13 60870 VILLERS ST PAUL pour la validité et pour la correspondance CRAY VALLEY SA La Défense 6 16-32 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

27/07/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1635 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 274845346.04 EUR. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 76386469 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : le fonds de commerce relatif a l'activité de développement, production et commercialisation de résines Photoreticulables et des résines de revêtement. Adresse : 16-32 rue Henri Regbault, la Défense 6, 92400 Courbevoie.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : La Loi du 15/07/2011. Oppositions : STE CRAY VALLEY SA A L ATTENTION DU DIRECTEUR GENERAL SITUE 16-32 RUE HENRI REGNAULT LA DEFENSE 6 - 92400 COURBEVOIE pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

27/07/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

60 - OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE

845 - 319 632 790 RCS Compiegne. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 76386469 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : développement, production et commercialisation des résines Photoréticulables et des résines de revêtement. Adresse : Zone Artisanale de Villers Saint-Paul, Bp 13, 60870 Villers Saint-Paul.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : Le Parisien du 16/07/2011. Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance CRAY VALLEY La Défense 6 16-32 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

16/07/2011

JAL

Activity or goodwill cession

 

 

Voix du Nord (La)/édition CALAIS


Date de décision : 01/07/2011
Cédant : 340869353 - CRAY VALLEY SA, 16 RUE HENRI REGNAULT, LA DEFENSE 6 - 16 A 32, 92400 COURBEVOIE
Cessionnaire : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Prix de vente : 76386469 €
trDate d’effet : 01/07/2011

16/07/2011

JAL

Activity or goodwill cession

 

 

Parisien (Le)/Edition de l'Oise


Date de décision : 01/07/2011
Cédant : 340869353 - CRAY VALLEY SA, 16 RUE HENRI REGNAULT, LA DEFENSE 6 - 16 A 32, 92400 COURBEVOIE
Cessionnaire : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Prix de vente : 34090200 €
trDate d’effet : 01/07/2011

15/07/2011

JAL

Activity or goodwill cession

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 01/07/2011
Cédant : 340869353 - CRAY VALLEY SA, 16 RUE HENRI REGNAULT, LA DEFENSE 6 - 16 A 32, 92400 COURBEVOIE
Cessionnaire : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Prix de vente : 76386469 €
trDate d’effet : 01/07/2011

31/07/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1196 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 274845346.04 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

16/07/2010

JAL

Modification of the share capital

 

 

LES PETITES AFFICHES


Date de décision : 28/06/2010
La société : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES a subi une augmentation de son capital social désormais de 274 845 300 €

13/07/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2801 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 06 Septembre 2001 Président du conseil d'administration et administrateur : LE HENAFF Thierry modification le 26 Août 2008 Directeur général et administrateur : DELABORDE Michel modification le 14 Juin 2006 Administrateur : LEMONNIER Thierry en fonction le 28 Mars 2006 Administrateur : SCHULLER Marc en fonction le 28 Mars 2006 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 14 Juin 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 14 Juin 2006 Administrateur : TAKKEN Otto en fonction le 12 Décembre 2006 Administrateur : CHANOINE Pierre en fonction le 25 Mars 2008 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 02 Juillet 2010.
Commentaires : Modification de représentant.

09/07/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

8816 - 319632790 RCS. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves 92700 Colombes. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

23/06/2010

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1463 - . BASF SE (SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DROIT ALLEMAND À CAPITAL VARIABLE). Forme : Société de droit étranger. Capital : 1175652728.32 EUR. Adresse : Carl - Bosch - Strasse 38, 99999 .
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : commercialisation d'acide méthacrylique. Adresse : 420 rue Estienne d' Orves, 92700 Colombes.
Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. 319 632 790 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : La Loi du 04/02/2010. Oppositions : Au fonds vendu et au siège du cessionnaire pour la correspondance pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 100000 Euros. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

26/03/2010

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1527 - . EVONIK RÖHM GMBH. Forme : Société de droit étranger. Capital : 52300000 EUR. Adresse : Kirschenallée 00000 64293 Darmstadt
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : commercialisation de Monomères d'Esthers Métacryliques de spécialités. Adresse : 420 rue d'Estienne d Orves, 92700 Colombes.
Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. 319 632 790 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : Le Parisien du 08/02/2010. Oppositions : ARKEMA FRANCE AU 420 RUE D ESTIENNE D ORVES 92700 COLOMBES pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 1700000 Euros. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

08/02/2010

JAL

Activity or goodwill cession

 

 

92


Date de décision : 04/02/2010
Cédant : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Cessionnaire : EVONIK ROHM GMBH,
Prix de vente : 1700000 €

04/02/2010

JAL

Activity or goodwill cession

 

 

LES PETITES AFFICHES


Date de décision : 02/02/2010
Cédant : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Cessionnaire : BASF SE, CARL BOSCH STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN
Prix de vente : 100000 €

02/08/2009

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

865 - . EW LIMITED PRIVATE LIMITED COMPANY. Forme : Société de droit étranger. Adresse : C/o Internationals Management Édith Cavell Street Limited - les Cascades Building - 00000 Port Louis
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : commercialisation de chlorure d'aluminium. Adresse : 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. 319 632 790 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : Gazette du palais du 23/07/2009. Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 200000 Euros. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

19/07/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

9398 - 319632790 RCS. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves 92700 Colombes. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

30/06/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

7881 - 319632790 RCS. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves 92700 Colombes. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

29/05/2008

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2119 - . SUMITOMO SEIKA EUROPE S. A. N. V. Forme : Société de droit étranger. Capital : 4000000 EUR. Adresse : 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : un élément de fonds de commerce relatif à l'activité de production et de commercialisation de différents super-absorbants acryliques. Adresse : 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. 319 632 790 RCS Nanterre.
Publication légale : Journal spécial des sociétés françaises du 15/05/2008. Oppositions : Au Mandataire FIDAL - ME JOSSET ET HARIRI - 14 BD DU GENERAL LECLERC - 92527 NEUILLY SUR SEINE CEDEX pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 5000000 Euros. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

23/03/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

3704 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 06 Septembre 2001. Commissaire aux comptes suppléant : BOUCHET Alain en fonction le 06 Septembre 2001. Président du conseil d'administration et administrateur : LE HENAFF Thierry modification le 14 Juin 2006. Directeur général et administrateur : DELABORDE Michel modification le 14 Juin 2006. Administrateur : LEMONNIER Thierry en fonction le 28 Mars 2006. Administrateur : SCHULLER Marc en fonction le 28 Mars 2006. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 14 Juin 2006. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 14 Juin 2006. Administrateur : TAKKEN Otto en fonction le 12 Décembre 2006. Administrateur : CHANOINE Pierre en fonction le 25 Mars 2008.
Commentaires : Modification de représentant.

29/11/2007

Bodacc A

Vente et cession

 

 

507 - RCS Lyon B 349 305 318. RC 07-B 5775. KEMIRA CHIMIE. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : route de Mothern Port du Rhin, 67630 Lauterbourg. Etablissement secondaire - Activité : fabrication de co-agulant pour le traitement de l'eau. Adresse : rue Henri Moisan, 69491 Pierre-Benite. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 496 000 euros . Date de début d'activité : 31 octobre 2007. Précédent propriétaire : RCS 319 632 790. ARKEMA FRANCE. Publication légale : Petites Affiches Lyonnaises du 19 novembre 2007 . Oppositions : à l'attention de Monsieur Denis Fromage, Directeur d'Usine Arkema France rue Henri Moisan 69491 Pierre-Benite.

25/11/2007

Bodacc A

Vente et cession

 

 

966 - RCS B 349 305 318. RC AP-B 42109. KEMIRA CHIMIE S.A.S. Forme : S.A.S. Capital : 5 700 000 euros. Adresse du siège social : route de Mothern, 67630 Lauterbourg. Etablissement principal - Activité : conception, fabrication, vente et livraisons d'appareils de traitement de l'eau. Adresse : 420 rue d'Estienne-d'Orves, 92700 Colombes. Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 496 000 euros. Date d'effet : 31 octobre 2007. Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. RCS 319 632 790. Publication légale : Le Publicateur légal du 12 novembre 2007. Oppositions : Arkema France, 420 rue d'Estienne-d'Orves, 92700 Colombes, pour la validité et Cabinet Carreras, Barsikian, Robertson et Associés, 32 avenue Raymond-Poincaré, 75116 Paris, pour la correspondance.

18/09/2007

Bodacc A

Vente et cession

 

 

2047 - RCS non encore inscrit. RC AP-B 42014. CAFFARO CHIMICA. Forme : société de droit étranger. Capital : 20 010 000 euros. Etablissement principal - Activité : activité de chlorite de sodium. Adresse : 420 rue d'Estiennes-d'Orves, 92700 Colombes. Cession de la propriété et de l'ensemble des droits et des intérêts, dépendant de l'établissement principal, acquis par achat au prix stipulé de 2 500 000 euros, à l'exclusion du bail commercial. Date d'effet : 7 août 2007. Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. RCS 319 632 790. Publication légale : La Gazette du Palais du 1er septembre 2007. Oppositions : au fonds, pour la validité et la correspondance.

25/07/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2306 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA FRANCE. Forme : S.A. Adresse du siège social : 420 rue Estienne-d'Orves,, 92700 Commentaires : modification survenue sur l'adresse du siège social et l'adresse de l'établissement principal. Etablissement principal - Adresse : 420 rue Estienne-d'Orves, 92700

10/07/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

8117 - 319 632 790. RCS Nanterre ARKEMA FRANCE. Forme: Société anonyme. Adresse du siège social: 4/8 Cours Michelet 92800 Puteaux. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

26/12/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2895 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA FRANCE. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : PERNOT (Philippe). Nomination d'un administrateur : TAKKEN (Otto).

11/08/2006

Bodacc A

Vente et cession

 

 

1717 - RCS non encore inscrit. RC AP-B 41427. FACT-FUTURE ADVANCED COMPOSITES & TECHNOLOGY. Forme : société de droit étranger. Capital : 82 200 euros. Etablissement principal - Activité : fabrication et commercialisation de produits de base thermoplastiques renforcés de fibres longues distribués tant en France, qu'en Allemagne ou qu'au Portugal sous la marque > Pryltex < . Adresse : La Défense 10, 4-8 cours Michelet, 92800 Puteaux. Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 600 000 euros. Date d'effet : 6 juillet 2006. Précédent propriétaire : ARKEMA (France). RCS 319 632 790. Publication légale : Les Petites affiches du 26 juillet 2006. Oppositions : au fonds vendu pour la validité et la correspondance.

11/07/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1569 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA FRANCE. Forme : S.A. Capital : 68 685 704,12 euros. Commentaires : modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation) et l'administration. Administration : modification du président du conseil d'administration et administrateur : LE HENAFF (Thierry). Modification d'un directeur général et administrateur : DELABORDE (Michel). Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT. Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.

20/06/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

2002 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA. Forme: S.A. Adresse du siège social: 4/8, cours Michelet,92800 Puteaux. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

23/04/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2776 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateurs partants : CASTAIGNE (Robert) LAFONT (Françoise) (Nom d'usage : LEROY) HOWAT (Ian). Nomination d'administrateurs : PERNOT (Philippe) GOEBEL (Philippe) LEMONNIER (Thierry) SCHULLER (Marc).

16/12/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1679 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA. Forme : S.A. Capital : 27 125 346,60 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (diminution).

24/08/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

5185 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA. Forme: S.A. Adresse du siège social: 4/8, cours Michelet,92800 Puteaux. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

06/01/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1776 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'administrateurs : HOWAT (Ian) DELABORDE (Michel).

01/12/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 319632790 RC 81-B 332 ARKEMA. Forme : S.A. Capital : 520 868 934, 51 euros. Activité : fabrication et vente de produits chimiques ou plastiques. Adresse du siège social : 48 cours Michelet, 92800 Puteaux. Commentaires : modification survenue sur le capital ( augmentation). Apport des sociétés BOSTIK HOLDINGS S.A. (ex-DAJA 33),. RCS Nanterre 445 074 461 et TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE S.A.,. RCS Nanterre 428 891 113. Date d'effet : 22 octobre 2004.

25/01/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 319632790 RC 81-B 332 ATOFINA. Forme : S.A. Capital : 501 240 321 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration. Administration : nomination du commissaire aux comptes titulaire : CABINET BARBIER FRINAULT ET AUTRES. Nomination du commissaire aux comptes suppléant : LEGER (Michel).

18/05/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

*. RCS Nanterre B 319 632 790 RC 81-B 332 ATOFINA. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur la dénomination.

29/08/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 319632790 RC 81-B 332 ELF ATOCHEM S.A. Forme : S.A. Capital : 494 868 500 euros. Adresse du siège social : 4-8 cours Michelet, 92800 Puteaux. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation). Fusion- absorption de la CIE FINANCIERE ATOCHEM, de la STE FINIRIS , de la STE MEDITERRANEENNE DU BROME et de la STE OXYSYNTHESE. Date d'effet : 30 juin 1999.

06/09/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 319 632 790 RC 81-B 332 ELF ATOCHEM S.A. Forme : S.A. Capital : 3 246 123 500 F. Adresse du siège social : 4-8 cours Michelet 92800 Puteaux. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation). Apport pur et simple par la STE ELF AQUITAINE EXPLORATION PRODUCTION FRANCE (LACTAME ET THIOCHIMIE),. RCS Nanterre B 409 160 132. Date d'effet : 31 juillet 1998.

02/10/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Nanterre B 319 632 790 RC RC 81-B 332 ELF ATOCHEM S.A. Forme : S.A. Capital : 3 156 750 500 F. Administration : président du conseil d'administration : PUECHAL (Jacques) Administrateurs : DIDIER (François) RUTMAN (Gilbert) ISOARD (Frédéric) CASTILLON (Pierre) DE WISSOCQ (François) POLGE DE COMBERT (Bernard) WEYMULLER ( Stanislas) DESBIENDRAS (Daniel) ARTHAUD (Jean-Pierre). Commissaire aux comptes titulaire : ERNST AND YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : BAHON (Yves). Commentaires : modification survenue sur le capital et l'administration.

 

Company events history

 

Date

Description

07/10/2011

Bodacc A : Sale and transfer

14/09/2011

Bodacc A : Sale and transfer

02/09/2011

Update of participations in other companies

02/09/2011

Disengagement in other companies

02/09/2011

New subsidiarie(s) detected

02/08/2011

Bodacc A : Sale and transfer

27/07/2011

Bodacc A : Sale and transfer

18/07/2011

Bodacc C : Deposit accounts notice

08/07/2011

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

01/07/2011

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

25/05/2011

Unfiling of a Tax Office preferential right

25/05/2011

New Filling of Tax Office preferential right

31/12/2010

New accounts available

29/11/2010

Payment incident closed

23/08/2010

Payment incident closed

13/08/2010

Update of participations in other companies

13/08/2010

Disengagement in other companies

13/08/2010

New participations in other companies

13/08/2010

New subsidiarie(s) detected

02/08/2010

Payment incident closed

31/07/2010

Bodacc B: Various editing or changing

21/07/2010

Updated articles of association

21/07/2010

Fund deposit certificate

21/07/2010

Capital increase

21/07/2010

Payment incident detected

13/07/2010

Bodacc B: Various editing or changing

09/07/2010

Update of participations in other companies

09/07/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

01/07/2010

New auditor

28/06/2010

Legal Gazette: Modification of the share capital

28/06/2010

Other modification of Establishment

23/06/2010

Bodacc A : Sale and transfer

21/06/2010

Payment incident detected

01/06/2010

Payment incident closed

26/03/2010

Bodacc A : Sale and transfer

08/02/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

04/02/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

26/01/2010

Payment incident detected

13/01/2010

Payment incident closed

08/01/2010

Payment incident closed

31/12/2009

New accounts available

16/10/2009

Payment incident closed

02/10/2009

Payment incident detected

31/08/2009

Payment incident detected

02/08/2009

Bodacc A : Sale and transfer

28/07/2009

Updated articles of association

28/07/2009

Minutes of general meeting of shareholders

28/07/2009

Private document

19/07/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

17/07/2009

Payment incident closed

26/06/2009

Payment incident closed

09/06/2009

Payment incident detected

19/03/2009

Payment incident detected

31/12/2008

New accounts available

15/10/2008

Payment incident closed

29/07/2008

Payment incident detected

30/06/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

29/05/2008

New Bodacc A ads detected

29/05/2008

Bodacc A : Sale and transfer

25/03/2008

Minutes of Board meeting

25/03/2008

PV du Conseil d'Administration

25/03/2008

Appointment/resignation of company officers

25/03/2008

Private document

25/03/2008

Changes to the Board of Directors

25/03/2008

Modification du Conseil d'Administration

23/03/2008

New Bodacc B ads detected

23/03/2008

Bodacc B: Various editing or changing

31/12/2007

New accounts available

14/09/2007

Collection of preferential rights activated for this company

04/07/2007

Updated articles of association

04/07/2007

Statuts mis à jour

04/07/2007

Minutes of general meeting of shareholders

04/07/2007

PV d'Assemblée

04/07/2007

Private document

04/07/2007

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

04/07/2007

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

25/06/2007

PV d'Assemblée

25/06/2007

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

25/06/2007

Statuts mis à jour

31/12/2006

New accounts available

12/12/2006

Changes to the Board of Directors

12/12/2006

Private document

12/12/2006

PV du Conseil d'Administration

12/12/2006

Minutes of Board meeting

12/12/2006

Modification du Conseil d'Administration

12/12/2006

Appointment/resignation of company officers

14/06/2006

Augmentation de Capital

14/06/2006

Capital increase

14/06/2006

Réduction de Capital

14/06/2006

Changement de dénomination sociale

14/06/2006

New company name

14/06/2006

Changement de Président (PDG, PCA)

14/06/2006

Changes to the Board of Directors

14/06/2006

Modification du Conseil d'Administration

14/06/2006

Acte sous seing privé

14/06/2006

Private document

14/06/2006

Appointment/resignation of company officers

14/06/2006

Nomination/démission des organes de gestion

14/06/2006

Minutes of general meeting of shareholders

14/06/2006

PV d'Assemblée

14/06/2006

Minutes of Board meeting

14/06/2006

PV du Conseil d'Administration

14/06/2006

Statuts mis à jour

14/06/2006

Updated articles of association

14/06/2006

Changement de Commissaire aux Comptes

14/06/2006

New auditor

14/06/2006

Audit or Management Report

14/06/2006

Rapport des Commissaires ou du Gérant

18/05/2006

Expédition acte notarié

18/05/2006

Office copy

18/05/2006

Acte modificatif

18/05/2006

Amendment

18/04/2006

Modification to Establishment Address or Identifier

28/03/2006

Changes to the Board of Directors

28/03/2006

Private document

28/03/2006

Modification du Conseil d'Administration

28/03/2006

Minutes of general meeting of shareholders

28/03/2006

PV d'Assemblée

28/03/2006

Acte sous seing privé

28/03/2006

Updated articles of association

28/03/2006

Statuts mis à jour

28/03/2006

Appointment/resignation of company officers

28/03/2006

Nomination/démission des organes de gestion

31/12/2005

New accounts available

01/12/2005

Minutes of general meeting of shareholders

01/12/2005

Rapport des Commissaires ou du Gérant

01/12/2005

Audit or Management Report

01/12/2005

PV d'Assemblée

01/12/2005

Private document

01/12/2005

Acte sous seing privé

01/12/2005

Réduction de Capital

01/12/2005

Capital reduction

01/12/2005

Updated articles of association

01/12/2005

Statuts mis à jour

22/11/2005

Rapport des Commissaires ou du Gérant

22/11/2005

Private document

22/11/2005

Acte sous seing privé

22/11/2005

Audit or Management Report

31/12/2004

New accounts available

17/12/2004

Appointment/resignation of company officers

17/12/2004

Nomination/démission des organes de gestion

17/12/2004

Rapport des Commissaires ou du Gérant

17/12/2004

Minutes of general meeting of shareholders

17/12/2004

Audit or Management Report

17/12/2004

Private document

17/12/2004

Acte sous seing privé

17/12/2004

Modification du Conseil d'Administration

17/12/2004

PV d'Assemblée

17/12/2004

Changes to the Board of Directors

15/11/2004

Audit or Management Report

15/11/2004

Rapport des Commissaires ou du Gérant

15/11/2004

Minutes of Board meeting

15/11/2004

PV du Conseil d'Administration

15/11/2004

Statuts mis à jour

15/11/2004

Updated articles of association

15/11/2004

Acte sous seing privé

15/11/2004

Private document

15/11/2004

Declaration of conformity

15/11/2004

Déclaration de conformité

15/11/2004

Certificat de dépôt des fonds

15/11/2004

Fund deposit certificate

22/10/2004

Nomination/démission des organes de gestion

22/10/2004

Statuts mis à jour

22/10/2004

PV d'Assemblée

22/10/2004

PV du Conseil d'Administration

22/10/2004

Changement de dénomination sociale

21/10/2004

PV d'Assemblée

21/10/2004

Minutes of general meeting of shareholders

21/10/2004

Nomination/démission des organes de gestion

21/10/2004

Appointment/resignation of company officers

21/10/2004

Acte sous seing privé

21/10/2004

Modification du Conseil d'Administration

21/10/2004

New company name

21/10/2004

Changement de dénomination sociale

21/10/2004

Changement de Président (PDG, PCA)

21/10/2004

New chairman (CEO, CoB)

21/10/2004

Private document

21/10/2004

Changes to the Board of Directors

21/10/2004

Updated articles of association

21/10/2004

Minutes of Board meeting

21/10/2004

PV du Conseil d'Administration

21/10/2004

Statuts mis à jour

01/10/2004

Private document

01/10/2004

Réduction de Capital

01/10/2004

Capital reduction

01/10/2004

Acte sous seing privé

01/10/2004

Minutes of general meeting of shareholders

01/10/2004

Capital increase

01/10/2004

Augmentation de Capital

01/10/2004

PV d'Assemblée

21/09/2004

Rapport des Commissaires ou du Gérant

25/08/2004

Apport Partiel

25/08/2004

Acte sous seing privé

25/08/2004

Acte modificatif

25/08/2004

Amendment

25/08/2004

Private document

25/08/2004

Scission

16/04/2004

PV d'Assemblée

16/04/2004

Acte sous seing privé

16/04/2004

Statuts mis à jour

16/04/2004

Rapport des Commissaires ou du Gérant

31/12/2003

New accounts available

12/12/2003

Acte sous seing privé

12/12/2003

Modification du Conseil d'Administration

12/12/2003

Nomination/démission des organes de gestion

28/08/2003

Acte sous seing privé

28/08/2003

Modification du Conseil d'Administration

28/08/2003

Rapport des Commissaires ou du Gérant

28/08/2003

PV du Conseil d'Administration

28/08/2003

PV d'Assemblée

28/08/2003

Statuts mis à jour

14/09/2002

PV du Conseil d'Administration

14/09/2002

Modification du Conseil d'Administration

14/09/2002

Statuts mis à jour

14/09/2002

Acte sous seing privé

14/09/2002

Nomination/démission des organes de gestion

14/09/2002

PV d'Assemblée

04/06/2002

PV du Conseil d'Administration

04/06/2002

Acte sous seing privé

04/06/2002

Modification du Conseil d'Administration

04/06/2002

Nomination/démission des organes de gestion

29/11/2001

Acte modificatif

29/11/2001

Acte sous seing privé

29/11/2001

Statuts mis à jour

06/09/2001

Nomination/démission des organes de gestion

06/09/2001

Acte sous seing privé

06/09/2001

Changement de Commissaire aux Comptes

06/09/2001

PV d'Assemblée

04/07/2001

Changement de Président (PDG, PCA)

04/07/2001

Acte sous seing privé

04/07/2001

PV du Conseil d'Administration

04/07/2001

Modification du Conseil d'Administration

04/07/2001

Nomination/démission des organes de gestion

11/01/2001

PV d'Assemblée

11/01/2001

Augmentation de Capital

11/01/2001

Rapport des Commissaires ou du Gérant

11/01/2001

Nomination/démission des organes de gestion

11/01/2001

Acte sous seing privé

11/01/2001

Statuts mis à jour

05/12/2000

Acte sous seing privé

05/12/2000

Rapport des Commissaires ou du Gérant

17/08/2000

Nomination/démission des organes de gestion

17/08/2000

Requête et Ordonnance

02/05/2000

Rapport des Commissaires ou du Gérant

02/05/2000

Statuts mis à jour

02/05/2000

PV d'Assemblée

02/05/2000

Acte sous seing privé

02/05/2000

Modification du Conseil d'Administration

02/05/2000

Changement de dénomination sociale

14/04/2000

Modification du Conseil d'Administration

14/04/2000

Nomination/démission des organes de gestion

14/04/2000

Changement de Président (PDG, PCA)

14/04/2000

Acte sous seing privé

14/04/2000

PV du Conseil d'Administration

11/10/1999

PV du Conseil d'Administration

11/10/1999

Modification du Conseil d'Administration

11/10/1999

Nomination/démission des organes de gestion

11/10/1999

Acte sous seing privé

16/08/1999

Déclaration de conformité

16/08/1999

Conversion du Capital Social en Euros

16/08/1999

Acte sous seing privé

16/08/1999

Statuts mis à jour

16/08/1999

Augmentation de Capital

16/08/1999

PV d'Assemblée

16/08/1999

Fusion

22/06/1999

Acte sous seing privé

22/06/1999

Rapport des Commissaires ou du Gérant

28/05/1999

Acte sous seing privé

28/05/1999

Projet de Fusion

10/03/1999

Requête et Ordonnance

10/03/1999

Nomination/démission des organes de gestion

09/12/1998

Rapport des Commissaires ou du Gérant

09/12/1998

Acte sous seing privé

02/12/1998

Acte sous seing privé

02/12/1998

Projet de Fusion

18/11/1998

Nomination/démission des organes de gestion

18/11/1998

Requête et Ordonnance

17/11/1998

Projet de Fusion

17/11/1998

Acte sous seing privé

20/10/1998

Acte sous seing privé

20/10/1998

Modification du Conseil d'Administration

20/10/1998

PV du Conseil d'Administration

20/10/1998

Nomination/démission des organes de gestion

24/08/1998

Statuts mis à jour

24/08/1998

Projet de Fusion

24/08/1998

PV d'Assemblée

24/08/1998

Acte sous seing privé

24/08/1998

Augmentation de Capital

23/07/1998

Rapport des Commissaires ou du Gérant

23/07/1998

Acte sous seing privé

19/05/1998

Requête et Ordonnance

19/05/1998

Nomination/démission des organes de gestion

29/07/1997

PV d'Assemblée

29/07/1997

Nomination/démission des organes de gestion

29/07/1997

Changement de Commissaire aux Comptes

29/07/1997

Acte sous seing privé

18/09/1996

Certificat de dépôt des fonds

18/09/1996

Statuts mis à jour

18/09/1996

PV du Conseil d'Administration

18/09/1996

PV d'Assemblée

18/09/1996

Acte sous seing privé

18/09/1996

Augmentation de Capital

18/09/1996

Acte modificatif

04/08/1995

PV d'Assemblée

04/08/1995

Acte modificatif

14/09/1994

Nomination/démission des organes de gestion

14/09/1994

PV d'Assemblée

14/09/1994

Acte modificatif

14/09/1994

Modification du Conseil d'Administration

14/09/1994

PV du Conseil d'Administration

22/03/1994

Acte modificatif

22/03/1994

Statuts mis à jour

22/03/1994

PV d'Assemblée

22/03/1994

Déclaration de conformité

16/09/1993

Acte modificatif

16/09/1993

Certificat de dépôt des fonds

16/09/1993

Déclaration de conformité

16/09/1993

PV d'Assemblée

16/09/1993

Augmentation de Capital

16/09/1993

PV du Conseil d'Administration

16/09/1993

Statuts mis à jour

16/04/1993

Acte modificatif

16/04/1993

Nomination/démission des organes de gestion

16/04/1993

PV du Conseil d'Administration

16/04/1993

Modification du Conseil d'Administration

10/02/1992

Acte sous seing privé

10/02/1992

Statuts mis à jour

10/02/1992

PV d'Assemblée

10/02/1992

Fusion

10/02/1992

Acte modificatif

10/02/1992

Changement de dénomination sociale

 

Establishment events history

 

 

Date

Description

25/04/2011

Update Rating

06/08/2010

Update Rating

23/07/2010

Update Rating

21/01/2010

Update of phone numbers

20/11/2009

Update of phone numbers

10/07/2009

Update Rating

22/10/2008

Update of phone numbers

08/07/2008

Update Rating

03/07/2008

Update Rating

12/06/2008

Update of phone numbers

09/12/2007

Update Limit

08/12/2007

Update Rating

06/12/2007

Update Rating

25/07/2007

Update of phone numbers

18/04/2006

Update of Establishment Workforce

18/04/2006

Update of Establishment Address

18/04/2006

Modification of Head office Identification

 

 

 

 

NOTES & COMMENTS

 

Na

 

 


FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.48.82

UK Pound

1

Rs.78.57

Euro

1

Rs.69.29

 

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

----

NB

New Business

----

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

 

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.