MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

18.04.2012

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

peugeot citroen automobile sa

 

 

Registered Office :

Rte De Gizy 78140 Velizy Villacoublay

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2010

 

 

Date of Incorporation :

May 1973

 

 

Com. Reg. No.:

RCS Versailles 9 542 065 479

 

 

Legal Form :

Public limited company with board of directors

 

 

Line of Business :

Manufacture of motor vehicles (2910Z)

 

 

No. of Employees :

Not Available

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ca

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

Limited with full security

 

Status :

Moderate

Payment Behaviour :

No Complaints

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail: infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31st, 2012

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2011)

Current Rating

(31.03.2012)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


Company name

Top of Form

 

 

 

 

Name    PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA  SIRET   542 065 479 00991        

 

company summary

 

 

 

 

 

Activity

 (APE)

Manufacture of motor vehicles (2910Z)

Legal form

Public limited company with board of directors

 

 

Phone

01 57 59 30 00

RCS Registration

RCS Versailles 9 542 065 479

 

 

Fax

 

Share capital

294,816,500 Euros

 

 

Address

PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA
RTE DE GIZY
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Incorporated Date

05/1973

 

 

Nationality

France

Status

Economically active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last published preferential right

This company is not under monitoring

 

 

 

Ultimate Holding Company

 

Company Name

 

Company number

Click here to view the affiliation links

 

PEUGEOT S.A.

 

552100554

435 companies in 50 countries. Click here to visit linked companies

 

 

 

Current Directors

5

 

 

 

Trading to Date

12/31/2010

12/31/2009

12/31/2008

 

Turnover

58,426,756,000 €

51,098,319,000 €

59,851,572,000 €

 

Gross Operating Surplus

1,30 % Turnover

-0,68 % Turnover

0,89 % Turnover

 

Net worth

-723,336,000 €

182,299,000 €

2,998,493,000 €

 

Employees

-

-

-

 

 

 

Trends

 

 

Profitability

arrow_up

 

Liquidity

arrow_up

 

Net worth

arrow_down

 

 

 

 

company details

 

 

 

 

 

 

 

Activity (APE)

Construction de véhicules automobiles (2910Z)

 

RCS Registration

RCS Versailles 9 542 065 479

Share capital

294,816,500 Euros

 

Registration Court

Versailles (78)

Legal form

Public limited company with board of directors

 

Court Registry Number

19 9 9B003

EU VAT Number

FR82542065479

 

Incorporation Date

05/1973

Formation Date

01/1954

 

Deregistration Date

 

Last account Date

31/12/2010

 

Nationality

France

 

 

 

 

Ultimate Parent

1 ultimate parent company for this company
> PEUGEOT SA - Activités des sièges sociaux (7010Z) in PARIS 16 (75116)

 

 

 

 

 

 

 

Activity (APE)

Activités des sièges sociaux (7010Z)

Business Pages FT®

 

 

Postal Address

PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA
RTE DE GIZY
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Trading Address

ROUTE DE GIZY
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

 

Telephone

01 57 59 30 00

 

Fax

 

 

 

 

 

Type

Head office

Status

Economically active

 

Formation Date

12/2002

Reason for formation

Other

 

Closure Date

 

Reason for closure

 

 

Reactivation Date

 

Production Role

 

 

Activity Nature

-

Activity Location

Other

 

Location surface

 

Seasonality

 

 

 

 

 

Department

Yvelines (78)

Region

Ile-de-France

 

District

4

Area

37

 

City

VELIZY VILLACOUBLAY

Size of urban area

Paris conglomeration

 

 

 

 

 

 

 

Branches

53 branch entities in this company

 

 

 

Head office


> PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA <<< - Construction de véhicules automobiles (2910Z) in VELIZY VILLACOUBLAY (78140)

 

 

Secondary establishments

> PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA - Construction de véhicules automobiles (2910Z) in CARRIERES SOUS POISSY (78955)
> PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA - Construction de véhicules automobiles (2910Z) in THENAY (41400)
> PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA - Construction de véhicules automobiles (2910Z) in BAIE MAHAULT (97122)
> PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA - Construction de véhicules automobiles (2910Z) in BAIE MAHAULT (97122)
> ...

 

 

 

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas but no one grouping more than 50% of workforce

 

 

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which one activity grouping from 80 to 99% of workforce

 

 

 

 

 

 

 

Workforce at address

0 employee

Company workforce

 

 

 

 


 

accounts

 

Active Account | Passive Account | Account Results

 

Synthesized Accounts

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

Comparison mode

Average

Median

 

 

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

 

Account period (month)

12

 

12

 

12

 

 

Account Type

Normal

 

Normal

 

Normal

 

 

Deposit date

20/07/2011

 

26/08/2010

 

-

 

 

Activity Code

2910Z

 

2910Z

 

2910Z

 

 

Employees

67184

 

71205

 

75757

 

 


Active account

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

8 258 227 000

-0,7%

8 316 912 000

-4,2%

8 685 700 000

643 826

1282579,9%

- Intangible assets

188 852 000

27,0%

148 646 000

5,0%

141 525 000

27 441

688111,1%

- Tangible assets

5 775 702 000

-2,3%

5 911 943 000

-0,1%

5 916 624 000

150 014

3850008,7%

- Financial assets

2 293 673 000

1,7%

2 256 323 000

-14,1%

2 627 551 000

4 050

56633801,2%

Net current assets

10 416 635 000

5,3%

9 895 353 000

29,3%

7 651 358 000

1 656 042

628907,9%

- Stocks

1 174 306 000

-9,1%

1 291 247 000

-20,6%

1 625 256 000

357 699

328194,5%

- Advanced payments

8 368 000

5,3%

14 955 000

-68,7%

47 720 000

0

0%

- Receivables

9 226 553 000

7,5%

8 581 906 000

43,8%

5 966 399 000

741 626

1243997,8%

- Securities and cash

7 408 000

2,2%

7 245 000

-39,5%

11 983 000

43 983

16742,9%

- Prepaid expenses

-

-

-

-

-

782,50

-

Accounts of regularization

506 000

25,6%

403 000

0%

0

0

0%

Total Assets

18 675 368 000

2,5%

18 212 668 000

11,5%

16 337 058 000

2 652 830

703879,1%


Passive Account

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Shareholders' equity

-723 336 000

-496,8%

182 299 000

-93,9%

2 998 493 000

455 690

-158834,2%

Share capital

294 816 000

0%

294 816 000

0%

294 816 000

255 204

115421,7%

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

1 567 913 000

-0,1%

1 569 499 000

52,2%

1 031 012 000

0

0%

Liabilities

17 829 515 000

8,3%

16 458 786 000

33,8%

12 299 051 000

1 738 698

1025352,1%

- Financial liabilities

5 993 628 000

12,3%

5 337 961 000

132,3%

2 297 881 000

320 057

1872575,2%

- Advanced payments received

9 802 000

39,4%

7 030 000

0%

0

0

0%

- Trade account payables

9 023 832 000

7,7%

8 377 953 000

15,3%

7 263 319 000

352 492

2559910,4%

- Tax and social liabilities

1 043 820 000

0,3%

1 041 128 000

-18,1%

1 271 566 000

330 306

315916,1%

- Other debts and fixed assets liabilities

1 667 048 000

3,6%

1 609 061 000

21,7%

1 321 911 000

37 489

4446665,7%

Account regularization

92 661 000

5,6%

87 737 000

-42,6%

152 876 000

0

0%

Total liabilities

18 675 368 000

2,5%

18 212 668 000

11,5%

16 337 058 000

2 652 830

703879,1%


Results

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Sales of Goods

59 567 605 000

14,5%

52 011 809 000

-15,8%

61 784 553 000

2 243 249

2655316,5%

Net turnover

58 426 756 000

14,3%

51 098 319 000

-14,6%

59 851 572 000

2 179 620

2680493,7%

- of which net export turnover

0

0%

0

0%

0

0

0%

Operating charges

60 107 081 000

11,6%

53 876 751 000

-13,9%

62 586 166 000

2 355 747

2551408,3%

Operating profit/loss

-539 476 000

71,1%

-1 864 942 000

-132,6%

-801 613 000

5 594

-9643932,7%

Financial income

226 556 000

-23,5%

296 142 000

-34,9%

454 837 000

539

42032553,1%

Financial charges

533 692 000

-37,5%

853 414 000

164,5%

322 618 000

12 677

4209823,5%

Financial profit/loss

-307 136 000

44,9%

-557 272 000

-521,5%

132 219 000

-2 853

-10765269,8%

Pretax net operating income

-846 612 000

65,0%

-2 422 214 000

-261,9%

-669 394 000

3 196

-26489837,2%

Extraordinary income

1 022 017 000

35,9%

752 118 000

32,7%

566 720 000

19 483

5245586,0%

Extraordinary charges

1 249 271 000

-9,4%

1 379 467 000

1,0%

1 365 729 000

22 803

5478437,9%

Extraordinary profit/loss

-227 254 000

-62,5%

-627 349 000

21,5%

-799 009 000

-90

-252504344,4%

Net result

-1 019 218 000

66,0%

-2 995 803 000

-111,6%

-1 415 662 000

8 210

-12414448,4%



 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

 

Normal Account

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Months

 

12

 

12

 

12


Accounts - Active
Current Assets | Equalization accounts | Reference

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Grand Total (I to VI)

Net

18 675 368 000

2,5%

18 212 668 000

11,5%

16 337 058 000

 

Gross

CO

33 409 214 000

1,3%

32 973 483 000

9,3%

30 157 946 000

 

Amortisation

1A

14 733 846 000

-0,2%

14 760 815 000

6,8%

13 820 888 000


Non declared distributed capital (I)

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AA

0

0%

0

-

0


Active fixed asset (II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Total Active fixed asset (II)

Net

8 258 227 000

-0,7%

8 316 912 000

-4,2%

8 685 700 000

 

Gross

BJ

22 917 403 000

-0,3%

22 993 464 000

2,6%

22 421 343 000

 

Amortisation

BK

14 659 176 000

-0,1%

14 676 552 000

6,9%

13 735 643 000


Intangilble fixed assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

R & D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AE

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Distributorships, patents

Net

184 405 000

24,1%

148 549 000

5,0%

141 428 000

 

Gross

AF

340 430 000

21,7%

279 787 000

11,5%

251 031 000

 

Amortisation

AG

156 025 000

18,9%

131 238 000

19,7%

109 603 000

button_minusbutton_plus

Goodwill

Net

76 000

0%

76 000

0%

76 000

 

Gross

AH

76 000

0%

76 000

0%

76 000

 

Amortisation

AI

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Other intangible fixed assets

Net

4 371 000

20714,3%

21 000

0%

21 000

 

Gross

AJ

4 371 000

20714,3%

21 000

0%

21 000

 

Amortisation

AK

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible Assets

Net

188 852 000

27,0%

148 646 000

5,0%

141 525 000



Tangilble fixed assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Lands

Net

224 736 000

-3,8%

233 559 000

-1,2%

236 405 000

 

Gross

AN

330 199 000

-1,2%

334 085 000

-1,9%

340 616 000

 

Amortisation

AO

105 463 000

4,9%

100 526 000

-3,5%

104 211 000

button_minusbutton_plus

Buildings

Net

1 250 731 000

-7,0%

1 345 281 000

-3,2%

1 389 804 000

 

Gross

AP

3 763 108 000

0,3%

3 750 867 000

1,3%

3 703 403 000

 

Amortisation

AQ

2 512 377 000

4,4%

2 405 586 000

4,0%

2 313 599 000

button_minusbutton_plus

Plant

Net

3 953 800 000

1,0%

3 914 665 000

5,9%

3 694 861 000

 

Gross

AR

14 763 016 000

-0,5%

14 834 324 000

5,0%

14 128 835 000

 

Amortisation

AS

10 809 216 000

-1,0%

10 919 659 000

4,7%

10 433 974 000

button_minusbutton_plus

Other tangible fixed assets

Net

70 005 000

-28,7%

98 133 000

-22,7%

126 942 000

 

Gross

AT

535 276 000

-14,8%

628 404 000

-6,2%

669 871 000

 

Amortisation

AU

465 271 000

-12,3%

530 271 000

-2,3%

542 929 000

button_minusbutton_plus

Fixed assets in construction

Net

114 687 000

-22,5%

147 937 000

-46,0%

274 019 000

 

Gross

AV

118 742 000

-22,1%

152 370 000

-45,5%

279 743 000

 

Amortisation

AW

4 055 000

-8,5%

4 433 000

-22,6%

5 724 000

button_minusbutton_plus

Advances and payments on account

Net

161 743 000

-6,2%

172 368 000

-11,4%

194 593 000

 

Gross

AX

161 743 000

-6,2%

172 368 000

-11,4%

194 593 000

 

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Tangible asset

Net

5 775 702 000

 

5 911 943 000

 

5 916 624 000



Financial assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Other participations

Net

2 189 569 000

0,9%

2 169 753 000

-12,7%

2 485 275 000

 

Gross

CU

2 709 309 000

1,4%

2 670 807 000

1,5%

2 631 492 000

 

Amortisation

CV

519 740 000

3,7%

501 054 000

242,7%

146 217 000

button_minusbutton_plus

Inter-company receivables

Net

15 923 000

80,1%

8 842 000

-87,7%

71 856 000

 

Gross

BB

15 923 000

80,1%

8 842 000

-87,7%

71 856 000

 

Amortisation

BC

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Loans

Net

31 000

0%

31 000

0%

31 000

 

Gross

BF

24 364 000

0%

24 364 000

0%

24 364 000

 

Amortisation

BG

24 333 000

 

24 333 000

 

24 333 000

button_minusbutton_plus

Other financial assets

Net

88 150 000

13,5%

77 697 000

10,4%

70 389 000

 

Gross

BH

150 846 000

10,0%

137 149 000

9,3%

125 442 000

 

Amortisation

BI

62 696 000

5,5%

59 452 000

8,0%

55 053 000

 

Sub Total Financial Assets

 

2 293 673 000

 

2 256 323 000

 

2 627 551 000



Current Assets (III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Total Assets

Net

10 416 635 000

5,3%

9 895 353 000

29,3%

7 651 358 000

 

Gross

CJ

10 491 305 000

5,1%

9 979 616 000

29,0%

7 736 603 000

 

Amortisation

CK

74 670 000

-11,4%

84 263 000

-1,2%

85 245 000



Stocks

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Raw materials

Net

10 300 000

-8,4%

11 244 000

394,0%

2 276 000

 

Gross

BL

19 647 000

-5,1%

20 694 000

74,6%

11 850 000

 

Amortisation

BM

9 347 000

-1,1%

9 450 000

-1,3%

9 574 000

button_minusbutton_plus

Work in progress (goods)

Net

38 376 000

432,0%

7 214 000

-64,3%

20 209 000

 

Gross

BN

38 376 000

432,0%

7 214 000

-66,5%

21 544 000

 

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

1 335 000

button_minusbutton_plus

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Semi-finished and finished products

Net

1 086 483 000

-13,4%

1 254 411 000

-20,6%

1 579 213 000

 

Gross

BR

1 122 222 000

-13,7%

1 300 205 000

-20,2%

1 628 799 000

 

Amortisation

BS

35 739 000

-22,0%

45 794 000

-7,6%

49 586 000

button_minusbutton_plus

Goods for resale

Net

39 147 000

113,0%

18 378 000

-22,0%

23 558 000

 

Gross

BT

40 029 000

105,6%

19 467 000

-23,3%

25 371 000

 

Amortisation

BU

882 000

-19,0%

1 089 000

-39,9%

1 813 000

 

Sub Total Stocks

Net

1 174 306 000

-9,1%

1 291 247 000

-20,6%

1 625 256 000



Advance payments to suppliers

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Advance payments to suppliers

Net

8 368 000

-44,0%

14 955 000

-68,7%

47 720 000

 

Gross

BV

8 368 000

-44,0%

14 955 000

-68,7%

47 720 000

 

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0



Debtors

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Trade accounts receivable

Net

8 350 124 000

6,5%

7 842 403 000

54,2%

5 087 362 000

 

Gross

BX

8 368 526 000

6,4%

7 865 923 000

54,0%

5 107 963 000

 

Amortisation

BY

18 402 000

-21,8%

23 520 000

14,2%

20 601 000

button_minusbutton_plus

Other debtors

Net

772 272 000

11,8%

690 931 000

-18,9%

851 984 000

 

Gross

BZ

782 572 000

12,5%

695 341 000

-18,6%

854 320 000

 

Amortisation

CA

10 300 000

133,6%

4 410 000

88,8%

2 336 000

button_minusbutton_plus

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Debtors

Net

9 122 396 000

6,9%

8 533 334 000

43,7%

5 939 346 000



Divers

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Investment securities

Net

7 172 000

0%

7 172 000

-39,7%

11 897 000

 

Gross

CD

7 172 000

0%

7 172 000

-39,7%

11 897 000

 

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Cash and cash equivalents

Net

236 000

223,3%

73 000

-15,1%

86 000

 

Gross

CF

236 000

223,3%

73 000

-15,1%

86 000

 

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Divers

Net

7 408 000

2,2%

7 245 000

-39,5%

11 983 000



Prepaid expenses

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Prepaid expenses

Net

104 157 000

114,4%

48 572 000

79,5%

27 053 000

 

Gross

CH

104 157 000

114,4%

48 572 000

79,5%

27 053 000

 

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0



Equalization accounts (IV to VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Multi-period charges

CW3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

-

-

 

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

-

-

 

Currency differential gain

CN3

506 000

25,6%

403 000

0%

0

 

Gross

 

506 000

25,6%

403 000

-

-



References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

 

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Accounts - Passive
Other capital resources | Provisions for risks and charges | Liabilities | Translation loss | Equalization accounts | References

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Grand Total (I to V)

EE

18 675 368 000

2,5%

18 212 668 000

11,5%

16 337 058 000


Shareholder Equity (I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Total shareholders' equity (Total I)

DL

-723 336 000

-496,8%

182 299 000

-93,9%

2 998 493 000

 

Equity and shareholders' equity

DA

294 816 000

0%

294 816 000

0%

294 816 000

 

Issue and merger premiums

DB

0

0%

0

0%

1 225 626 000

 

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

 

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

 

Legal reserve

DD

29 330 000

0%

29 330 000

0%

29 330 000

 

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

 

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

 

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

 

Other reserves

DG

0

0%

0

0%

0

 

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

 

0

0%

0

 

Profits or losses brought forward

DH

-3 185 840 000

-1576,4%

-190 037 000

0%

0

 

Profit or loss for the period

DI

-1 019 218 000

66,0%

-2 995 803 000

-111,6%

-1 415 662 000

 

Investment grants

DJ

2 554 000

-26,7%

3 482 000

50,3%

2 317 000

 

Special tax-allowable reserves

DK

3 155 022 000

3,8%

3 040 511 000

6,2%

2 862 066 000



Other capital resources (II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

 

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

 

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0



Provisions for risks and charges (III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

1 567 913 000

-0,1%

1 569 499 000

52,2%

1 031 012 000

 

Risk provisions

DP

1 434 217 000

8,4%

1 322 719 000

69,1%

782 298 000

 

Reserves for charges

DQ

133 696 000

-45,8%

246 780 000

-0,8%

248 714 000



Liabilities (IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Total Liabilities (Total IV)

EC

17 829 515 000

8,3%

16 458 786 000

33,8%

12 299 051 000

 

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

 

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

 

Bank loans and liabilities

DU

5 980 905 000

12,3%

5 326 085 000

134,3%

2 272 949 000

 

Sundry loans and financial liabilities

DV

12 723 000

7,1%

11 876 000

-52,4%

24 932 000

 

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

 

Advance payments received for current orders

DW

9 802 000

39,4%

7 030 000

0%

0

 

Trade accounts payables

DX

9 023 832 000

7,7%

8 377 953 000

15,3%

7 263 319 000

 

Tax and social security liabilities

DY

1 043 820 000

0,3%

1 041 128 000

-18,1%

1 271 566 000

 

Fixed asset liabilities

DZ

174 689 000

29,6%

134 768 000

-33,8%

203 529 000

 

Other debts

EA

1 491 083 000

1,3%

1 472 209 000

32,6%

1 109 880 000



Translation loss (V)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Translation loss (Total V)

ED

1 276 000

-38,8%

2 084 000

-75,5%

8 502 000



Equalization accounts

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Deferred income

EB

92 661 000

5,6%

87 737 000

-42,6%

152 876 000



References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

 

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

 

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Result account
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges | Financial income | Financial charges | Financial charges | Extraordinary charges | Employee profit sharing | Tax on profits | References

1- Operating result (I-II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Operating result (Total I-II)

GG

-539 476 000

71,1%

-1 864 942 000

-132,6%

-801 613 000


2 - Financial result (V - VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Financial result (Total V-VI)

GV

-307 136 000

44,9%

-557 272 000

-521,5%

132 219 000


3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

-846 612 000

65,0%

-2 422 214 000

-261,9%

-669 394 000


4 - Extraordinary result (VII-VIII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

-227 254 000

63,8%

-627 349 000

21,5%

-799 009 000


Profit or loss

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Profit or loss

HN

-1 019 218 000

66,0%

-2 995 803 000

-111,6%

-1 415 662 000


Total Income (I+III+V+VII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total Income (I+III+V+VII)

HL

60 816 178 000

14,6%

53 060 069 000

-15,5%

62 806 110 000


Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

61 835 396 000

10,3%

56 055 872 000

-12,7%

64 221 772 000


Operating income (I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total operating income (Total I)

FR

59 567 605 000

14,5%

52 011 809 000

-15,8%

61 784 553 000


Operating income (details)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Sale of goods for resale

FC

1 729 652 000

14,9%

1 505 656 000

-21,2%

1 909 573 000

 

France

FA

1 729 652 000

14,9%

1 505 656 000

-21,2%

1 909 573 000

 

Export

FB

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Sale of goods produced

FF

50 487 215 000

15,3%

43 794 808 000

-15,3%

51 704 259 000

 

France

FD

50 487 215 000

15,3%

43 794 808 000

-15,3%

51 704 259 000

 

Export

FE

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Sale of services

FI

6 209 889 000

7,1%

5 797 855 000

-7,1%

6 237 740 000

 

France

FG

6 209 889 000

7,1%

5 797 855 000

-7,1%

6 237 740 000

 

Export

FH

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Net turnover

FL

58 426 756 000

14,3%

51 098 319 000

-14,6%

59 851 572 000

 

France

FJ

58 426 756 000

14,3%

51 098 319 000

-14,6%

59 851 572 000

 

Export

FK

0

0%

0

0%

0

 

Stocked production

FM

-146 821 000

57,2%

-342 919 000

-149,5%

692 476 000

 

Self-constructed assets

FN

181 436 000

4,1%

174 274 000

-5,9%

185 192 000

 

Operating grants

FO

23 284 000

-3,4%

24 103 000

-6,8%

25 854 000

 

Release of reserves and provisions

FP

652 686 000

-2,4%

668 908 000

5,3%

635 052 000

 

Other income

FQ

430 264 000

10,6%

389 124 000

-1,3%

394 407 000


Operating charges (II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total operating charges (Total II)

GF

60 107 081 000

11,6%

53 876 751 000

-13,9%

62 586 166 000


Exploitation charges

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Purchase of goods for resale

FS

701 595 000

16,0%

604 978 000

-38,4%

981 788 000

 

Change in stocks of goods for resale

FT

-20 983 000

-459,1%

5 844 000

73,0%

3 378 000

 

Purchase of raw materials

FU

46 782 505 000

15,1%

40 636 739 000

-16,7%

48 770 070 000

 

Change in stocks of raw materials

FV

1 043 000

111,7%

-8 879 000

-389,7%

-1 813 000

 

Other external purchases and charges

FW

6 155 484 000

3,8%

5 928 021 000

-3,9%

6 171 200 000

 

Tax, duty and similar payments

FX

294 295 000

8,2%

271 926 000

-7,9%

295 137 000

 

Payroll

FY

2 666 578 000

-3,7%

2 768 572 000

-2,9%

2 851 789 000

 

Social security costs

FZ

1 144 807 000

4,7%

1 093 902 000

-5,0%

1 151 958 000


Depreciation

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Depreciation of fixed assets

GA

1 079 204 000

-5,6%

1 143 312 000

1,0%

1 132 146 000

 

Amortisation of fixed assets

GB

54 227 000

205,9%

17 725 000

-76,4%

75 197 000

 

Depreciation/amortisation of current assets

GC

31 706 000

-26,3%

43 036 000

-23,3%

56 138 000

 

Provisions for risks and charges

GD

251 587 000

-32,1%

370 452 000

169,1%

137 654 000


Other charges

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Other charges

GE

965 033 000

-3,6%

1 001 123 000

4,1%

961 524 000



Operating charges (III-IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

 

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0



Financial income (V)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Total financial income (Total V)

GP

226 556 000

-23,5%

296 142 000

-34,9%

454 837 000

 

Share financial income

GJ

107 073 000

-41,5%

182 970 000

-6,6%

195 804 000

 

Other investment income & capitalised receivables

GK

0

0%

0

0%

0

 

Other interest and similar income

GL

763 000

-69,0%

2 465 000

-92,8%

34 134 000

 

Released provisions and transferred charges

GM

15 357 000

13,0%

13 593 000

242,3%

3 971 000

 

Exchange gains

GN

103 363 000

6,4%

97 114 000

-56,0%

220 928 000

 

Net income from disposal of investment securities

GO

0

0%

0

0%

0



Financial Charge (VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Total financial charge (Total VI)

GU

533 692 000

-37,5%

853 414 000

164,5%

322 618 000

 

Financial reserves and provisions

GQ

139 368 000

-76,5%

591 959 000

5543,6%

10 489 000

 

Interest and similar charges

GR

243 403 000

75,1%

139 001 000

97,7%

70 318 000

 

Exchange losses

GS

150 921 000

23,2%

122 454 000

-49,4%

241 811 000

 

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0



Financial Charge (VII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Total extraordinary income (Total VII)

HD

1 022 017 000

35,9%

752 118 000

32,7%

566 720 000

 

Extraordinary operating income

HA

18 986 000

617,5%

2 646 000

-45,4%

4 845 000

 

Extraordinary income from capital transactions

HB

47 077 000

55,2%

30 326 000

61,5%

18 780 000

 

Released provisions and transferred charges

HC

955 954 000

32,9%

719 146 000

32,4%

543 095 000



Extraordinary charges (VIII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

1 249 271 000

-9,4%

1 379 467 000

1,0%

1 365 729 000

 

Extraordinary operating charges

HE

178 908 000

-23,0%

232 233 000

4,0%

223 375 000

 

Extraordinary charges from capital transactions

HF

41 774 000

-33,8%

63 084 000

67,2%

37 738 000

 

Extraordinary reserves and provisions

HG

1 028 589 000

-5,1%

1 084 150 000

-1,9%

1 104 616 000



Employee profit sharing (IX)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

0

0%

0

0%

-513 000



Tax on profits (X)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Tax on profits (Total X)

HK

-54 648 000

-1,7%

-53 760 000

-2,9%

-52 228 000



References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

 

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

 

Of which transferred charges

A1

0

0%

0

0%

0

 

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Other incomer tax return forms
Reserve for depreciation | Provisions included in balance sheet | State deadlines claims and debts at the end of period
Table allocation results and other information

Fixed Assets
Grand Total Fixed Assets (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

22 934 922 000

 

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

1 285 665 000

 

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

OK2

1 171 749 000

100,2%

585 294 000

-67,5%

1 799 244 000

 

Gross value at the end of period

OL

22 917 403 000

-0,3%

22 993 463 000

2,6%

22 421 343 000


Research and development Charge (Total I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

C01

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

C02

0

0%

0

0%

0

 

Gross value at the end of period

D0

0

0%

0

0%

0


Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Gross value at begin of period

KD

279 883 000

11,5%

251 128 000

10,5%

227 234 000

 

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

67 560 000

131,9%

29 132 000

18,5%

24 580 000

 

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

LV2

2 566 000

580,6%

377 000

-45,0%

686 000

 

Gross value at the end of period

LW

344 877 000

23,2%

279 883 000

11,5%

251 128 000


Tangible fixed assets (Total III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Gross value at begin of period

LN

19 872 418 000

2,9%

19 317 061 000

-2,7%

19 858 778 000

 

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

967 240 000

-9,6%

1 070 251 000

-9,8%

1 186 638 000

 

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NG2

1 167 574 000

126,8%

514 894 000

-70,2%

1 728 355 000

 

Gross value at the end of period

NH

19 672 084 000

-1,0%

19 872 418 000

2,9%

19 317 061 000


Fiancial assets (Total IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Gross value at begin of period

LQ

2 841 162 000

-0,4%

2 853 154 000

0,1%

2 848 910 000

 

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

60 889 000

4,9%

58 031 000

-22,1%

74 447 000

 

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NJ2

1 609 000

-97,7%

70 023 000

-0,3%

70 203 000

 

Gross value at the end of period

NK

2 900 442 000

2,1%

2 841 162 000

-0,4%

2 853 154 000



Reserve for depreciation
Situation and movement of reserve for depreciation
Grand total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Reserve for depreciation value at begin of period

0N

0

0%

0

0%

13 872 213 000

Increases

0P

0

0%

0

0%

1 132 144 000

Decreasess

0Q

0

0%

0

0%

1 691 140 000

 

Reserve for depreciation value at the end of period

0R

0

0%

0

0%

13 313 217 000


Research and development charge (Total I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0


Other intangible assets (Total II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

131 184 000

19,9%

109 428 000

23,2%

88 812 000

Increases

PF

25 358 000

15,8%

21 897 000

4,1%

21 044 000

Decreasess

PG

547 000

287,9%

141 000

-67,1%

428 000

 

Decreasess by budget item transfer

PH

155 995 000

18,9%

131 184 000

19,9%

109 428 000


Total fixed assets amotisation (Total III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

13 869 924 000

5,0%

13 203 789 000

-4,2%

13 783 401 000

Increases

QV

1 054 182 000

-6,0%

1 121 416 000

0,9%

1 111 100 000

Decreases

QW

1 128 043 000

147,8%

455 281 000

-73,1%

1 690 712 000

 

Decreasess by budget item transfer

QX

13 796 063 000

-0,5%

13 869 924 000

5,0%

13 203 789 000


Movements during period affecting charge allocated over several period
Charges à répartir ou frais d'émission d'emprunt

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0


Premium refund of obligations

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Net value at begining of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

 

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0



Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Value at begining of period

7C

5 369 717 000

22,0%

4 400 748 000

11,9%

3 931 088 000

Increases

UB

1 505 477 000

-28,6%

2 107 322 000

52,3%

1 384 093 000

Decreases

UC

1 370 472 000

20,4%

1 138 353 000

24,5%

914 433 000

 

Value at the end of period

UD

5 504 722 000

2,5%

5 369 717 000

22,0%

4 400 748 000

Includes Total allocations

 

Operating

UE

337 520 000

-21,7%

431 213 000

0%

0

 

Financial

UG

139 368 000

-76,5%

591 959 000

0%

0

 

Exceptional

UJ

1 028 589 000

-5,1%

1 084 150 000

0%

0

Includes Total Withdrawal

 

Operating

UF

460 651 000

13,4%

406 397 000

0%

0

 

Financial

UH

13 508 000

5,4%

12 810 000

0%

0

 

Exceptional

UK

896 313 000

24,6%

719 146 000

0%

0


Total regulated provisions (Total I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Value at begining of period

3Z

3 040 511 000

6,2%

2 862 066 000

14,6%

2 496 906 000

Increases

TS

713 173 000

-1,3%

722 459 000

-2,8%

743 090 000

Decreases

TT

598 662 000

10,0%

544 014 000

43,9%

377 930 000

 

Value at the end of period

TU

3 155 022 000

3,8%

3 040 511 000

6,2%

2 862 066 000


Total risk and charge provisions (Total II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Value at begining of period

5Z

1 569 499 000

52,2%

1 031 012 000

10,3%

934 720 000

Increases

TV

678 506 000

-29,2%

958 713 000

91,7%

500 240 000

Decreases

TW

680 092 000

61,8%

420 226 000

4,0%

403 948 000

 

Value at the end of period

TX

1 567 913 000

-0,1%

1 569 499 000

52,2%

1 031 012 000


Total Provision for depreciation (Total III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Value at begining of period

7B

759 707 000

49,6%

507 670 000

1,6%

499 462 000

Increases

TY

113 798 000

-73,3%

426 150 000

202,7%

140 763 000

Decreases

TZ

91 718 000

-47,3%

174 113 000

31,4%

132 555 000

 

Value at the end of period

UA

781 787 000

2,9%

759 707 000

49,6%

507 670 000



State deadlines claims and debts at the end of period
State claims

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Gross value

VT

9 342 231 000

7,0%

8 731 619 000

39,8%

6 243 647 000

 

1 year at most

VU

9 162 296 000

7,0%

8 561 443 000

40,7%

6 085 136 000

 

More than one year

VV

179 935 000

5,7%

170 176 000

7,4%

158 511 000


State of loans

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Claims related to holdings (gross)

UL

15 923 000

80,1%

8 842 000

-87,7%

71 856 000

 

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

7 081 000

0%

0

0%

63 014 000

 

Loans (gross)

UP

24 364 000

0%

24 364 000

0%

24 364 000

 

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

0

0%

0

 

Other financial assets (gross)

UT

150 846 000

10,0%

137 149 000

9,3%

125 442 000

 

Other financial assets (1 year at most)

UV

4 117 000

2200%

179 000

30,7%

137 000


Receivables statement of assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Customers doubtful or disputed

VA

19 539 000

-24,7%

25 942 000

7,9%

24 048 000

 

Other claims customer

UX

8 348 987 000

6,5%

7 839 980 000

54,2%

5 083 915 000

 

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

 

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

 

Personnel and associated accounts

UY

9 750 000

-46,4%

18 186 000

-27,8%

25 198 000

 

Social Security and other social organizations

UZ

3 175 000

-33,3%

4 763 000

-26,1%

6 446 000

 

Income taxes

VM

0

0%

0

0%

0

 

Value added tax

VB

533 488 000

41,0%

378 291 000

-33,7%

570 563 000

 

Other taxes and payments assimilated

VN

7 650 000

-8,2%

8 329 000

-67,4%

25 531 000

 

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

0

0%

0

 

Group and Associates

VC

113 293 000

6,0%

106 862 000

-13,3%

123 287 000

 

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

115 216 000

-35,6%

178 911 000

613,3%

25 081 000


Prepaid

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Prepaid

VS

0

0%

0

0%

0


State Debt

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Total debt (gross)

VY

17 736 854 000

3,3%

17 172 716 000

41,4%

12 146 175 000

1 year at most

VZ2

16 842 013 000

3,0%

16 344 141 000

39,6%

11 712 013 000

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

790 233 000

-1,7%

803 703 000

407,5%

158 365 000

More than 5 years

VZ4

104 608 000

320,6%

24 872 000

-91,0%

275 797 000


Details

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

button_minusbutton_plus

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

0

0%

6 127 753 000

1072,6%

522 565 000

1 year at most

VG2

0

0%

5 328 293 000

4228,3%

123 105 000

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

775 000 000

520,0%

125 000 000

button_minusbutton_plus

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

5 980 905 000

0%

0

0%

1 750 384 000

1 year at most

VH2

5 106 445 000

0%

0

0%

1 750 384 000

More than 1 year and 5 years at most

VH3

770 000 000

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

12 723 000

7,1%

11 877 000

-52,4%

24 932 000

1 year at most

8A2

9 334 000

27,3%

7 335 000

-61,9%

19 233 000

More than 1 year and 5 years at most

8A3

3 241 000

-21,5%

4 130 000

-5,3%

4 362 000

button_minusbutton_plus

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

9 023 832 000

7,7%

8 377 953 000

15,3%

7 263 319 000

1 year at most

8B2

9 023 832 000

7,7%

8 377 953 000

15,3%

7 263 319 000

More than 1 year and 5 years at most

8B3

9 023 832 000

7,7%

8 377 953 000

0%

0

button_minusbutton_plus

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

474 477 000

13,5%

418 021 000

-4,9%

439 569 000

1 year at most

8C2

474 477 000

13,5%

418 021 000

-4,9%

439 569 000

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

363 985 000

0,2%

363 242 000

-8,3%

396 102 000

1 year at most

8D2

363 985 000

0,2%

363 242 000

-8,3%

396 102 000

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

VAT (gross)

VW1

82 338 000

-47,3%

156 180 000

-50,2%

313 922 000

1 year at most

VW2

82 338 000

-47,3%

156 180 000

-50,2%

313 922 000

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

123 020 000

18,6%

103 685 000

-15,0%

121 973 000

1 year at most

VQ2

123 020 000

18,6%

103 685 000

-15,0%

121 973 000

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

174 689 000

29,6%

134 768 000

-33,8%

203 529 000

1 year at most

8J2

174 689 000

29,6%

134 768 000

-33,8%

203 529 000

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

0

0%

1 067 187 000

1 year at most

VI2

0

0%

0

0%

1 067 187 000

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More 5 years

VI4

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Other liabilities (gross)

8K1

1 500 885 000

1,5%

1 479 237 000

3364,8%

42 693 000

1 year at most

8K2

1 483 893 000

2,0%

1 454 664 000

10525,7%

13 690 000

More than 1 year and 5 years at most

8K3

16 992 000

-30,9%

24 573 000

-15,3%

29 003 000

button_minusbutton_plus

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Products in advance (gross)

8L1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8L2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0


References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Loans made during the period

VJ

0

0%

0

0%

0

 

Debt repaid during the period

VK

0

0%

0

0%

0



Table allocation results and other information
Dividends distributed

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0


Commitments

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

 

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

 

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0


Other charges Externes

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

 

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

 

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

 

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

 

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

 

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

 

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0


Taxes and Fees

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

 

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0


VAT

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

 

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0


Average number of employees

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Average number of employees

YP

67 184

-5,6%

71 205

-6,0%

75 757


Groups and Shareholders

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Groups and Shareholders

ZR

0

-

0

-

-

 

 

Display parameter

Comparison mode

Average

Median


Ratios
Structure and liquidity | Management or rotation | Profitability of the business | Return on capital

Structure and Liquidity

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Fixed Asset Financing

help1

0,94

-1,1%

0,95

6,7%

0,89

1,54

-39,0%

Global Debt

help1

110 days

-5,2%

116 days

56,8%

74 days

180,50 days

-39,1%

Working Capital Fund overall net

help1

-9 days

0%

-9 days

35,7%

-14 days

58,50 days

-115,4%

Financial independence

help1

-12,09%

-453,5%

3,42%

-97,4%

131,92%

203,09%

-106,0%

button_plusbutton_minusMore ratios

Solvability

help1

-3,87%

-487,0%

1%

-94,6%

18,35%

27,13%

-114,3%

Capacity debt futures

help1

-14,17%

-634,7%

2,65%

-98,1%

141,21%

674,64%

-102,1%

Coverage of current assets by net working capital overall

help1

-13,66%

-10,6%

-12,35%

59,6%

-30,54%

32,08%

-142,6%

General Liquidity

help1

0,54

3,8%

0,52

0%

0,52

0,54

0%

Restricted Liquidity

help1

0,54

3,8%

0,52

0%

0,52

0,79

-31,6%


Management or rotation

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Need background in operating working capital

help1

-9 days

-12,5%

-8 days

38,5%

-13 days

41,50 days

-121,7%

Treasury

help1

0 days

0%

0 days

0%

0 days

2 days

0%

Inventory turnover of goods

help1

21 days

90,9%

11 days

22,2%

9 days

99 days

-78,8%

Average length of credit granted to customers

help1

52 days

-5,5%

55 days

77,4%

31 days

48 days

8,3%

Average length of credit obtained suppliers

help1

61 days

-4,7%

64 days

36,2%

47 days

69 days

-11,6%

button_plusbutton_minusMore ratios

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

help1

0 days

0%

0 days

0%

0 days

41,50 days

0%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

help1

297 days

15,6%

257 days

-17,1%

310 days

419 days

-29,1%

Rotation tangible assets

help1

297%

15,5%

257,13%

-17,0%

309,84%

363,89%

-18,4%


Profitability of the business

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Margin trading

help1

1,80%

2,9%

1,75%

13,6%

1,54

0,05%

3500%

Profitability of the business

help1

1,30

291,2%

-0,68

-176,4%

0,89

3,52%

-63,1%

Net profit

help1

-1,74%

70,3%

-5,86%

-147,3%

-2,37%

1,09%

-259,6%

button_plusbutton_minusMore ratios

Growth rate of turnover (excluding VAT)

help1

14,34%

198,1%

-14,62%

-78,3%

-8,20%

0%

0%

Rates integration

help1

8,29%

12,6%

7,36%

-8,3%

8,03%

22,51%

-63,2%

Rate leasing furniture

help1

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Work Factor

help1

78,72%

-23,3%

102,64%

23,2%

83,33%

69,94%

12,6%

Weight interests

help1

0,91

-45,5%

1,67%

209,3%

0,54%

0,46%

97,8%


Return on capital

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Cash flow from the overall profitability

help1

-0,16%

93,5%

-2,47%

-259,4%

1,55%

3,74%

-104,3%

Rates of economic profitability

help1

14%

333,3%

-6%

-160,0%

10%

10%

40,0%

Financial profitability

help1

-723336000%

-496,8%

182299000%

-93,9%

2998493000%

455690%

-158834,2%

Return on investment

help1

-9,21%

76,3%

-38,81%

-88,0%

-20,64%

4,52%

-303,8%

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

Comparison mode

Average

Median


Soldes Intermédiaires de Gestion

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Turnover

58 426 756 000

14,3%

51 098 319 000

-14,6%

59 851 572 000

2 179 620 €

2680493,7%

 

Sales of goods

1 729 652 000

14,9%

1 505 656 000

-21,2%

1 909 573 000

 

 

- Purchase of goods

701 595 000

16,0%

604 978 000

-38,4%

981 788 000

 

 

+/- Stock of goods variation

-20 983 000

-459,1%

5 844 000

73,0%

3 378 000

 

 

Trading margin

1 049 040 000 €

17,2%

894 834 000 €

-3,2%

924 407 000 €

1 530 €

68564605,9%

 

1,80 % CA

2,9%

1,75 % CA

13,6%

1,54 % CA

0,11 % CA

1536,4%

 

Sale of goods produced

56 697 104 000

14,3%

49 592 663 000

-14,4%

57 941 999 000

 

 

+/- Stocked production

-146 821 000

57,2%

-342 919 000

-149,5%

692 476 000

 

 

+ Self-constructed assets

181 436 000

4,1%

174 274 000

-5,9%

185 192 000

 

 

Period production

56 731 719 000 €

14,8%

49 424 018 000 €

-16,0%

58 819 667 000 €

2 005 524 €

2828672,9%

 

97,10 % CA

0,4%

96,72 % CA

-1,6%

98,28 % CA

97,72 % CA

-0,6%

 

Trading margin

1 049 040 000

17,2%

894 834 000

-3,2%

924 407 000

1 530

68564605,9%

+ Period Production

56 731 719 000

14,8%

49 424 018 000

-16,0%

58 819 667 000

2 005 524

2828672,9%

- Purchase of raw materials

46 782 505 000

15,1%

40 636 739 000

-16,7%

48 770 070 000

 

 

+/- Change in stocks of raw materiels

1 043 000

111,7%

-8 879 000

-389,7%

-1 813 000

 

 

- Other external purchases and charges

6 155 484 000

3,8%

5 928 021 000

-3,9%

6 171 200 000

 

 

Added value

4 841 727 000 €

28,7%

3 762 971 000 €

-21,7%

4 804 617 000 €

394 732 €

1226485,9%

 

8,29 % CA

12,6%

7,36 % CA

-8,3%

8,03 % CA

22,51 % CA

-63,2%

 

Added value

4 841 727 000 €

28,7%

3 762 971 000 €

-21,7%

4 804 617 000 €

394 732 €

1226485,9%

+ Operating grants

23 284 000

-3,4%

24 103 000

-6,8%

25 854 000

 

 

- Tax, duty and similar payments

294 295 000

8,2%

271 926 000

-7,9%

295 137 000

 

 

- Personal charges

3 811 385 000

-1,3%

3 862 474 000

-3,5%

4 003 747 000

 

 

Gross operating surplus

759 331 000 €

318,6%

-347 326 000 €

-165,3%

531 587 000 €

32 775 €

2316699,4%

 

1,30 % CA

291,2%

-0,68 % CA

-176,4%

0,89 % CA

3,52 % CA

-63,1%

 

Gross operating surplus

759 331 000 €

318,6%

-347 326 000 €

-165,3%

531 587 000 €

32 775 €

2316699,4%

+ Release of reserves and provisions

652 686 000

-2,4%

668 908 000

5,3%

635 052 000

 

 

+ Other operating income

430 264 000

10,6%

389 124 000

-1,3%

394 407 000

 

 

- Depreciation/Amortisation

1 416 724 000

-10,0%

1 574 525 000

12,4%

1 401 135 000

 

 

- Other charges

965 033 000

-3,6%

1 001 123 000

4,1%

961 524 000

 

 

Operating result

-539 476 000 €

71,1%

-1 864 942 000 €

-132,6%

-801 613 000 €

5 594 €

-9643932,7%

 

-0,92 % CA

74,8%

-3,65 % CA

-172,4%

-1,34 % CA

1,23 % CA

-174,8%

 

Operating result

-539 476 000 €

71,1%

-1 864 942 000 €

-132,6%

-801 613 000 €

5 594 €

-9643932,7%

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Financial income

226 556 000

-23,5%

296 142 000

-34,9%

454 837 000

 

 

- Financial charges

533 692 000

-37,5%

853 414 000

164,5%

322 618 000

 

 

Pre-tax result

-846 612 000 €

65,0%

-2 422 214 000 €

-261,9%

-669 394 000 €

3 196 €

-26489837,2%

 

-1,45 % CA

69,4%

-4,74 % CA

-323,2%

-1,12 % CA

0,91 % CA

-259,3%

 

Extraordinary income

1 022 017 000

35,9%

752 118 000

32,7%

566 720 000

19 483

5245586,0%

- Extraordinary charges

1 249 271 000

-9,4%

1 379 467 000

1,0%

1 365 729 000

 

 

Extraordinary result

-227 254 000 €

63,8%

-627 349 000 €

21,5%

-799 009 000 €

-90 €

-252504344,4%

 

-0,39 % CA

68,3%

-1,23 % CA

7,5%

-1 % CA

-00,02 % CA

-1850,0%

 

Pre-tax result

-846 612 000 €

65,0%

-2 422 214 000 €

-261,9%

-669 394 000 €

3 196 €

-26489837,2%

Extraordinary result

-227 254 000 €

63,8%

-627 349 000 €

21,5%

-799 009 000 €

-90 €

-252504344,4%

- Employee profit sharing

0

0%

0

0%

-513 000

 

 

- Tax on profits

-54 648 000

-1,7%

-53 760 000

-2,9%

-52 228 000

 

 

Net result

-1 019 218 000 €

66,0%

-2 995 803 000 €

-111,6%

-1 415 662 000 €

8 210 €

-12414448,4%

help1

-1,74 % CA

70,3%

-5,86 % CA

-147,3%

-2,37 % CA

1,09 % CA

-259,6%

 

judgements

Collective procedures

 

 

No judgment information for the company

 

 

 

 

 

 

Social security, pension funds preferential rights | Tax office preferential rights

Preferential rights details and history

Status of collection

This company is not under monitoring

Group data

This company is a part of several groups, choose the group you wish to see the structure

preloader1loading data...

 

 

Linkages

Ultimate parent company

PEUGEOT S.A.

Direct parent

PEUGEOT S.A. - 99.99 %

Group – Number of companies

498

Linkages – Number of companies

435

Number of countries

50

 

 

SIREN

Dernier bilan

CA

CONTINENTAL DEKK NORGE AS

 

960678680

31/12/2010

675 647 550 €

CONTINENTAL U.K. GROUP HOLDINGS LIMITED

 

00566118

31/12/2010

0 £

CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE

 

314722026

31/12/2010

706 930 375 €

ROBINS & DAY LIMITED

 

00129806

31/12/2010

448 144 000 £

CITROEN U.K. LIMITED

 

00191579

31/12/2010

974 416 000 £

CONTINENTAL TYRES LIMITED

 

01759120

31/12/2010

0 £

CONTINENTAL HOLDING FRANCE SAS

 

655780088

31/12/2009

1 136 831 €

CONTINENTAL FRANCE

 

380110304

31/12/2010

684 281 558 €

CONTITECH ANOFLEX SNC

 

410279533

31/12/2010

61 698 777 €

CONTINENTAL GLOBAL HOLDING NETHERLANDS B...

 

34298284

31/12/2010

-

PHOENIX OIL & MARINE LIMITED

 

04012370

31/12/2010

0 £

CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET

 

409709607

31/12/2010

186 235 064 €

CONTINENTAL DÄCK SVERIGE AB

 

5562837137

31/12/2010

632 042 KSEK

CONTINENTAL TEVES UK LIMITED

 

00700225

31/12/2010

22 671 000 £

CAS UK HOLDING LIMITED

 

04684092

31/12/2010

1 041 759 £

CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE

 

732055413

31/12/2010

120 536 109 €

SAS AUTOMOTIVE LIMITED

 

04208364

31/12/2010

291 730 641 £

SAS AUTOSYSTEMTECHNIK VERWALTUNGS GMBH

 

HRB 108641

31/12/2010

1 462 504 €

CONTINENTAL SAFETY ENGINEERING INTERNATI...

 

HRB 4756

30/09/2007

-

SAS AUTOMOTIVE FRANCE

 

418768727

31/12/2008

9 868 284 €

PHOENIX VIBRACOUSTIC LIMITED

 

04012419

31/12/2005

0 £

HOLDING CONTITECH SAS

 

958505794

31/12/2009

0 €

CONTINENTAL TYRE GROUP LTD.

 

00296602

31/12/2010

305 250 000 £

SIMEX (EUROPE) LIMITED

 

02143139

31/12/2006

0 £

CONTITECH UNITED KINGDOM LIMITED

 

01076936

31/12/2010

21 099 000 £

CONTINENTAL AUTOMOTIVE HAMBACH FRANCE

 

500173943

31/12/2010

0 €

TIKKA SPIKES OY

 

20181718

31/12/2010

6 240 000 €

DEKKMANN AS

 

966242825

31/12/2010

76 520 782 €

IMMOLEASE LEASING GMBH

 

HRB 100594

31/12/2009

-

VOGTLÄNDISCHE REIFENWERKE SITZ BAD NAUHE...

 

HRB 1444

31/12/2008

-

CONTINENTAL RENGAS OY

 

02011950

31/12/2010

41 092 000 €

MATADOR DEUTSCHLAND GMBH

 

HRB 204246

31/12/2010

-

REIFEN-KAUFFMANN GESELLSCHAFT MIT BESCHR...

 

HRB 130140

31/12/2010

-

CONTINENTAL TEVES FRANCE SNC

 

389616202

31/12/2010

2 974 705 €

MCSYNCRO FRANCE

 

428297857

31/12/2010

16 866 526 €

CARGOCONCEPT GMBH

 

HRB 691

31/12/2010

-

COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS DOUAI SNC

 

438552366

31/12/2008

176 650 795 €

CONTITECH FRANCE

 

410253967

31/12/2010

5 702 879 €

S - Y SYSTEMS TECHNOLOGIES EUROPE GMBH

 

HRB 8246

31/03/2010

197 505 000 €

CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING NEDERLAND...

 

33061567

31/12/2009

-

IDM GMBH INDUSTRIESENSOREN

 

HRB 8052

31/12/2008

4 645 026 €

BALANCE GMBH, HANDEL UND BERATUNGSSERVIC...

 

HRB 60352

31/12/2009

37 688 €

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE

 

412005001

31/12/2010

0 €

RADSYSTEM HAMBACH

 

493945232

31/12/2009

6 115 207 €

ESTOP GMBH

 

HRB 7438

30/09/2007

-

NOVAFERRA-EISEN-GMBH & CO. ABGASTECHNOLO...

 

HRA 12776

31/12/2009

1 353 579 €

UNTERSTÜTZUNGSKASSE PEUGEOT DEUTSCHLAND ...

 

HRB 8870

31/12/2010

-

PHOENIX CONVEYOR BELT SYSTEMS ASIA GMBH

 

HRB 71165

31/12/2006

10 236 €

INTECH THÜRINGEN GMBH

 

HRB 110675

31/12/2010

0 €

REIFEN APEL GMBH

 

HRB 214

31/12/2010

-

PEUGEOT COMMERCIAL PAPER GMBH

 

HRB 35150

31/12/2007

-

STEINEBRONN BETEILIGUNGS-GMBH

 

HRB 270295

31/12/2006

3 835 €

CONTINENTAL AUTOMOTIVE GRUNDSTÜCKSGESELL...

 

HRB 78121

31/12/2006

-

UNTERSTÜTZUNGSKASSE MIT BESCHRÄNKTER HAF...

 

HRB 530035

31/12/2010

-

CORREX HANDELSGESELLSCHAFT FÜR KAUTSCHUK...

 

HRB 56481

31/12/2007

0 €

PEUGEOT COMMERCE GMBH

 

HRB 16839

31/12/2010

-

CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH

 

HRB 59424

31/12/2006

-

CONTINENTAL AFTERMARKET GMBH

 

HRB 89870

30/09/2006

2 500 €

SAS AUTOSYSTEMTECHNIK ZWICKAU VERWALTUNG...

 

HRB 23812

31/12/2010

-

FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES ...

 

12067345

31/12/2009

120 260 000 €

CONTI-GUMMI FINANCE B.V.

 

33157039

31/12/2010

-

AKTIEBOLAGET SVENSK BILDISKONTERING

 

5560407297

31/12/2010

0 KSEK

DEKKMANN SVERIGE AB

 

5566540216

31/12/2010

8 490 KSEK

FAMA BIL AKTIEBOLAG

 

5560954660

31/12/2010

0 KSEK

DUNLOP OIL & MARINE LIMITED

 

03471656

31/12/2010

42 721 000 £

PHOENIX INDUSTRIAL PLASTICS HOLDING (UK)...

 

03437132

31/12/2006

0 £

MATADOR (UK) LTD

 

05143561

05/07/2009

-

PHOENIX INDUSTRIEANLAGEN VERWALTUNGS GMB...

 

HRB 77591

31/12/2006

-

THERMOPOL (1990) LIMITED

 

00725930

31/12/2008

-

VIKING TYRES (UK) LIMITED

 

00864474

31/12/2010

-

CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING UK LIMITE...

 

00965702

31/12/2010

26 570 000 £

CONTINENTAL AUTOMOTIVE UK LIMITED

 

00976731

31/12/2010

-

ASHTON-LYNE MOTORS LIMITED

 

01029957

31/12/2010

-

PHOENIX INDUSTRIAL PLASTICS UK LIMITED

 

01124357

31/12/2006

-

CONTINENTAL AUTOMOTIVE TELFORD UK LIMITE...

 

02375012

31/12/2010

-

PSA FINANCE PLC

 

02590471

31/12/2010

-

THERMOPOL INTERNATIONAL LIMITED

 

03048337

31/12/2008

-

PHOENIX FLUID HANDLING LIMITED

 

03932750

31/12/2010

0 £

CONTINENTAL AUTOMOTIVE HOLDINGS UK LIMIT...

 

04114756

31/12/2010

0 £

CONTINENTAL TYRE INVESTMENT UK LIMITED

 

04914878

31/12/2010

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS UK LIMITE...

 

05830432

31/12/2010

-

 

SAS AUTOSYSTEMTECHNIK ZWICKAU GMBH & CO....

 

HRA 6140

31/12/2009

237 392 107 €

 

THERMOPOL EXPORT LIMITED

 

00877718

-

-

 

SOC BELGE AUTOMOBILES CITROËN SA

 

403430819

31/12/2003

1 748 000 €

 

CONTINENTAL BENELUX SPRL

 

404411707

31/12/2010

456 464 645 €

 

U.T.I. NV

 

407673776

31/12/2010

10 662 462 €

 

CONTITECH BELGIUM BVBA

 

417570449

31/12/2010

939 825 €

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE BELGIUM NV

 

430659115

31/12/2010

7 881 908 €

 

COMPANIA HULERA EUZKADI

 

5778

-

-

 

UNTERSTÜTZUNGSKASSE DER FIRMA BALADECOR ...

 

HRB 200286

31/12/2010

-

 

CONTITECH SCHLAUCH GMBH

 

HRB 52032

-

-

 

REG REIFEN-ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT MBH

 

HRB 53378

-

-

 

CONTITECH ANTRIEBSSYSTEME GMBH

 

HRB 52030

-

-

 

CONTINENTAL MECHANICAL COMPONENTS GERMAN...

 

HRB 9067

-

-

 

CONTITECH KÜHNER GMBH & CIE. KG.

 

HRA 270662

-

-

 

CONTITECH VERWALTUNGS- GMBH

 

HRB 60897

-

-

 

EDDELBÜTTEL + SCHNEIDER GMBH

 

HRB 63789

-

-

 

CAS MÜNCHEN GMBH

 

HRB 61672

-

-

 

ADC AUTOMOTIVE DISTANCE CONTROL SYSTEMS ...

 

HRB 6408

-

-

 

CONTITECH VIBRATION CONTROL GMBH

 

HRB 52029

-

-

 

-

 

 

-

-

 

CAS-ONE HOLDINGGESELLSCHAFT MBH

 

HRB 59425

-

-

 

CONTITECH TRANSPORTBANDSYSTEME GMBH

 

HRB 52025

-

-

 

SAI AUTOMOTIVE AKTIENGESELLSCHAFT

 

HRB 11630

-

-

 

VERGÖLST GMBH

 

HRB 64

-

-

 

PHOENIX FLUID HANDLING INDUSTRY GMBH

 

HRB 71166

-

-

 

PHOENIX CONVEYOR BELT SYSTEMS GMBH

 

HRB 71164

-

-

 

CONTITECH ELASTOMER-BESCHICHTUNGEN GMBH

 

HRB 50972

-

-

 

UMG BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH

 

HRB 3669

-

-

 

CONSEO GMBH

 

HRB 69379

-

-

 

PHOENIX COMPOUNDING TECHNOLOGY GMBH

 

HRB 79107

-

-

 

BESMER GMBH

 

HRB 100068

-

-

 

TEMIC AUTOMOTIVE ELECTRIC MOTORS GMBH

 

HRB 74454 B

-

-

 

PHOENIX BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH

 

HRB 13690

-

-

 

CONTITECH LUFTFEDERSYSTEME GMBH

 

HRB 52028

-

-

 

MAX KAMMERER GMBH

 

HRB 45347

-

-

 

PHOENIX SERVICE GMBH & CO. KG

 

HRA 92475

-

-

 

UNION-MITTELLAND-GUMMI-GMBH & CO. GRUNDB...

 

HRA 25297

-

-

 

PHOENIX VERMÖGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT...

 

HRB 50614

-

-

 

CONTINENTAL ENGINEERING SERVICES GMBH

 

HRB 76752

-

-

 

DLC DUISBURG LOGISTIK GMBH

 

HRB 19426

-

-

 

CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG

 

HRA 27047

-

-

 

CONTINENTAL CAOUTCHOUC-EXPORT-GMBH

 

HRB 204411

-

-

 

IPM GMBH

 

HRB 702480

-

-

 

FAURECIA AUTOSITZE GMBH

 

HRB 200125

-

-

 

GÖPPINGER KALIKO GMBH

 

HRB 530019

-

-

 

CONTI TEMIC MICROELECTRONIC GMBH

 

HRB 16084

-

-

 

P. A. RENTROP GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNK...

 

HRB 122

-

-

 

SIEMENS VDO AUTOMOTIVE AG

 

HRB 132637

-

-

 

FIRST CONTINENTAL TRADING GMBH

 

HRB 33499

-

-

 

CONTITECH-UNIVERSE VERWALTUNGS-GMBH

 

HRB 60899

-

-

 

FORMPOLSTER GMBH

 

HRB 61882

-

-

 

CONTITECH AG

 

HRB 62105

-

-

 

CONTI TECH TECHNO-CHEMIE GMBH

 

HRB 71427

-

-

 

ABC FITMENT CENTRE PTY. LTD

 

-

-

-

 

ADAM TOURING GMBH

 

-

-

-

 

ADVANCE TYRE COMPANY LTD

 

-

-

-

 

AGICOM SA

 

-

-

-

 

AGRYPO SA

 

-

-

-

 

ALFRED TEVES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MB...

 

-

-

-

 

ALPHAPEAK LTD

 

-

-

-

 

ANDUJAR SA

 

-

-

-

 

AUTOMOBILES CITROEN

 

-

-

-

 

AUTOMOBILES CITROEN SA ...

 

-

-

-

 

AUTOMOBILES PEUGEOT S.A.

 

-

-

-

 

AUTOMOTIVE PRODUCTS ITALIA SV SRL

 

-

-

-

 

BABEL GRUNDSTÜCKSVERWALTUNGS GMBH

 

-

-

-

 

BANQUE PSA FINANCE HOLDING ...

 

-

-

-

 

BARUM CENTRUM PRAHA SRO

 

-

-

-

 

BARUM CONTINENTAL SLOVAKIA SRO

 

-

-

-

 

BARUM CONTINENTAL SPOL. SRO

 

-

-

-

 

BARUM KAFKA SRO

 

-

-

-

 

BAWE SPOL. SRO

 

-

-

-

 

BC TIRES SRO

 

-

-

-

 

BEATTIE INDUSTRIAL LTD

 

-

-

-

 

BENECKE CHANGSHUN AUTO TRIM ZHANGJIAGANG...

 

-

-

-

 

BENECKE-KALIKO AG

 

-

-

-

 

BENOAC FERTIGTEILE GMBH

 

-

-

-

 

CAPWELL TYRE CENTER LTD

 

-

-

-

 

CAR ELECTRONIC ARCHITECTURE & NETWORKS S...

 

-

-

-

 

CAS SLOVAKIA SRO

 

-

-

-

 

CAUCHO TÉCNICA SA

 

-

-

-

 

CG TIRE INC

 

-

-

-

 

CG TRADING DEL PERU SA

 

-

-

-

 

CGT REFERRAL RESOURCES INC

 

-

-

-

 

CLEMENS & HEGEL GMBH

 

-

-

-

 

COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO SA

 

-

-

-

 

CONTI AUTOMOTIVE SERVICIOS SA DE CV

 

-

-

-

 

CONTI VERSICHERUNGSDIENST VERSICHERUNGSV...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AG

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE AUSTRIA GMBH

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE CANADA INC

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE CHANGCHUN CO. LTD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE COMPONENTS INDIA ...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE COMPONENTS MALAYS...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE CORPORATION JAPAN...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC SR...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE ELECTRONICS LTD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE FUNDING CORPORATI...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE GRUNDSTÜCKS-VERMI...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE GUADALAJARA MÉXIC...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE HOLDING SPAIN SL

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE INC

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LTD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE INSTRUMENTS MALAY...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE ITALY SPA

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE JAPAN KK

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE KOREA LTD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE LICENSING CORP

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE MALAYSIA SDN. BHD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE MEXICANA SA DE CV

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE NOGALES SA DE CV

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SINGAPORE PTE. LT...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN SA

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SWITZERLAND AG

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEM MANAGEMENT...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS CHANGSHU ...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS CORPORATI...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS COSTA RIC...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS CZECH REP...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS HOLDING U...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS JAPAN LTD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS KOREA CO....

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SHANGHAI ...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS TIANJIN C...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS US INC

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE THAILAND CO. LTD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA SR...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ÖSTERREIC...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE WUHU CO. LTD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL BRASIL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA ...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL CORPORATE TEAM BUILDING PTY....

 

-

-

-

 

CONTINENTAL DAEK DÄNEMARK A/S

 

-

-

-

 

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIV...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL ENGINEERING SERVICES & PRODU...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL GENERAL TIRE CANADA INC

 

-

-

-

 

CONTINENTAL GUADALAJARA SERVICES MÉXICO ...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL HT TYRES SRO

 

-

-

-

 

CONTINENTAL HUNGÁRIA KFT

 

-

-

-

 

CONTINENTAL INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA

 

-

-

-

 

CONTINENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO AUTOMOT...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PECA...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL INVESTMENT LTD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL ITALIA SPA

 

-

-

-

 

CONTINENTAL LEMMERZ COMPONENTES PARA AUT...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL LLANTERA POTOSINA SA DE CV

 

-

-

-

 

CONTINENTAL MABOR INDÚSTRIA DE PNEUS SA

 

-

-

-

 

CONTINENTAL MATADOR RUBBER SRO

 

-

-

-

 

CONTINENTAL MATADOR TRUCK TIRES SRO

 

-

-

-

 

CONTINENTAL OFF-ROAD ACADEMY PTY. LTD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL OPONY POLSKA SPOL. ZOO

 

-

-

-

 

CONTINENTAL PNEUS PORTUGAL SA

 

-

-

-

 

CONTINENTAL PRODUCTS CORPORATION

 

-

-

-

 

CONTINENTAL PROPERTIES MÉXICO SA DE CV

 

-

-

-

 

CONTINENTAL PTY. LTD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL RICO HYDRAULIC BRAKES INDIA ...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL RUBBER OF AMERICA CORP.

 

-

-

-

 

CONTINENTAL SIME TYRE AS SDN. BHD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL SIME TYRE MARKETING SDN. BHD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL SIME TYRE PJ SDN. BHD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL SIME TYRE SDN. BHD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL SIME TYRE TECHNOLOGY CENTRE ...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL SUISSE SA

 

-

-

-

 

CONTINENTAL TAIWAN CO. LTD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL TEMIC ELECTRONICS PHILS. INC

 

-

-

-

 

CONTINENTAL TEVES CORP. LIAN YUN GANG CO...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL TEVES CZECH REPUBLIC SRO

 

-

-

-

 

CONTINENTAL TEVES HUNGÁRIA KFT

 

-

-

-

 

CONTINENTAL TEVES INC

 

-

-

-

 

CONTINENTAL TEVES KOREA CO. LTD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL TEVES PORTUGAL - SISTEMAS DE...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL TEVES TAIWAN CO. LTD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL TIRE NORTH AMERICA INC

 

-

-

-

 

CONTINENTAL TIRE SERVICIOS SA DE CV

 

-

-

-

 

CONTINENTAL TIRES ESPANA SL

 

-

-

-

 

CONTINENTAL TIRES RUS OOO

 

-

-

-

 

CONTINENTAL TIRES SHANGHAI CO. LTD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL TYRE AND RUBBER SINGAPORE PT...

 

-

-

-

 

CONTINENTAL TYRE NAMIBIA PTY. LTD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL TYRE SOUTH AFRICA PTY. LTD

 

-

-

-

 

CONTINENTAL VÝROBA PNEUMATIK SRO

 

-

-

-

 

CONTITECH AIRSPRING SYSTEMS NINGHAI CO. ...

 

-

-

-

 

CONTITECH CONSULTING MEXICANA, SA DE CV

 

-

-

-

 

CONTITECH DAE WON AIRSPRING SYSTEMS CO. ...

 

-

-

-

 

CONTITECH DIS TICARET LTD

 

-

-

-

 

CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA KFT

 

-

-

-

 

CONTITECH FLUID MEXICANA, SA DE CV

 

-

-

-

 

CONTITECH FLUID SHANGHAI CO. LTD

 

-

-

-

 

CONTITECH FORMPOLSTER GMBH

 

-

-

-

 

CONTITECH GRAND OCEAN FLUID CHANGCHUN CO...

 

-

-

-

 

CONTITECH HYCOP AB

 

-

-

-

 

CONTITECH INA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M...

 

-

-

-

 

CONTITECH INA GMBH & CO. KG

 

-

-

-

 

CONTITECH INDIA LTD

 

-

-

-

 

CONTITECH JAPAN CO. LTD

 

-

-

-

 

CONTITECH JIEBAO POWER TRANSMISSION SYST...

 

-

-

-

 

CONTITECH KAUTSCHUK UND KUNSTSTOFFVERTRI...

 

-

-

-

 

CONTITECH KÜHNER BETEILIGUNGSGES. MBH

 

-

-

-

 

CONTITECH LASTIK SANAYI VE TICARET AS

 

-

-

-

 

CONTITECH MEXICANA SA DE CV

 

-

-

-

 

CONTITECH NORTH AMERICA INC

 

-

-

-

 

CONTITECH PRINTING BLANKET SHANGHAI CO. ...

 

-

-

-

 

CONTITECH ROMANIA SRL

 

-

-

-

 

CONTITECH RUBBER INDUSTRIAL KFT

 

-

-

-

 

CONTITECH SCANDINAVIA AB

 

-

-

-

 

CONTITECH THERMOPOL INCORPORATED

 

-

-

-

 

CONTITECH VIBRATION CONTROL SLOVAKIA SRO

 

-

-

-

 

CONTITECH VIBRATION CONTROL SRO

 

-

-

-

 

CT FLUID AUTOMOTIVE GMBH

 

-

-

-

 

CT-CHARLOTTE LLC

 

-

-

-

 

CTNA HOLDING CORP

 

-

-

-

 

CTNA LLC

 

-

-

-

 

CTNA MANUFACTURING LIMITED PARTNERSHIP

 

-

-

-

 

D. M. SERVICES SARL

 

-

-

-

 

DAN-BELT SA

 

-

-

-

 

DEGETRINUM GRUNDSTÜCKSVERWALTUNGSGESELLS...

 

-

-

-

 

DEUTSCHE GASRUßWERKE GMBH

 

-

-

-

 

DRAHTCORD SAAR GESCHAEFTSFUEHRUNGS GMBH

 

-

-

-

 

DRAHTCORD SAAR GMBH & CO. KG

 

-

-

-

 

DUPONT BVBA

 

-

-

-

 

DYNAGEN INC

 

-

-

-

 

EMCON TECHNOLGIES HOLDING LIMITED

 

-

-

-

 

EMITEC GESELLSCHAFT FÜR EMISSIONSTECHNOL...

 

-

-

-

 

ENGLEWOOD SERVICES INC

 

-

-

-

 

ENLOG ENSAMBLAJE LOGÍSTICA DE CONJUNTOS ...

 

-

-

-

 

ET DUTCH HOLDINGS BV

 

-

-

-

 

EUCO SA

 

-

-

-

 

EURO FITTING INVOICING NV

 

-

-

-

 

EURO-FITTING MANAGEMENT NV

 

-

-

-

 

EVERGOMMA SRL

 

-

-

-

 

FAURECIA EXHAUST SYSTEMS BV ...

 

-

-

-

 

FAURECIA EXHAUST SYSTEMS, INC.

 

-

-

-

 

FAURECIA INVESTMENTS

 

-

-

-

 

FAURECIA NETHERLANDS HOLDING BV

 

-

-

-

 

FAURECIA SA

 

-

-

-

 

FAURECIA SA ...

 

-

-

-

 

FIT AUTOMOCION SA

 

-

-

-

 

FSC FRANCHISING SERVICE COMPANY SPA

 

-

-

-

 

FSC SERVICIOS DE FRANQUICIA SA

 

-

-

-

 

FSG HUNGÁRIA KFT

 

-

-

-

 

GENERAL TIRE DE MEXICO SA DE CV

 

-

-

-

 

GENERAL TIRE INTERNATIONAL COMPANY

 

-

-

-

 

GERAP GRUNDBESITZ- UND VERWALTUNGSGES GM...

 

-

-

-

 

GRUNDSTÜCKSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT BUTAN...

 

-

-

-

 

GTY TIRE COMPANY PARTNERSHIP

 

-

-

-

 

HIGHWAY TWO LLC

 

-

-

-

 

HJULSYSTEM MCP AB

 

-

-

-

 

I.T.U. SARL

 

-

-

-

 

IMAS AE

 

-

-

-

 

IRISH TYRE CENTRES LTD

 

-

-

-

 

ITA INDÚSTRIA TEXTIL DO AVE SA

 

-

-

-

 

KOMMANDITGESELLSCHAFT DEUTSCHE GASRUßWER...

 

-

-

-

 

KOREA EMS CO. LTD

 

-

-

-

 

KORSO INDUSTRIEBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT ...

 

-

-

-

 

LEUKOS HANDELSGESELLSCHAFT FÜR KAUTSCHUK...

 

-

-

-

 

MANUFACTURA DE CAUCHO Y FIBRA SA

 

-

-

-

 

MATADOR A AK

 

-

-

-

 

MATADOR CESKA REPUBLIKA AS

 

-

-

-

 

MATADOR HUNGÁRIA KFT

 

-

-

-

 

MATADOR RU

 

-

-

-

 

MATADOR SLOVENSKO SRO

 

-

-

-

 

MC PROJECTS B.V.

 

-

-

-

 

MC SYNCRO BRATISLAVA SRO

 

-

-

-

 

MC SYNCRO KOLIN SRO

 

-

-

-

 

MC SYNCRO NV

 

-

-

-

 

MC SYNCRO SUPPLY GMBH

 

-

-

-

 

MC SYNCRO VIGO SA

 

-

-

-

 

METALLGUMMI GMBH

 

-

-

-

 

MÜNDENER GUMMIWERK GMBH

 

-

-

-

 

NOGALES SERVICIOS SA DE CV

 

-

-

-

 

OBNOVA KOP SPOL. SRO

 

-

-

-

 

OKTOPRINT SERVICE LLC

 

-

-

-

 

ONLINE TECHNOLOGY POLAND SP. ZOO

 

-

-

-

 

OOO CONTINENTAL AUTOMOTIVE ENGINEERING R...

 

-

-

-

 

OOO CONTINENTAL AUTOMOTIVE RUS

 

-

-

-

 

OOO NAUCHNOPROIZVODSTVENNOE PREDPRIJATIE...

 

-

-

-

 

OOO TIKKA

 

-

-

-

 

OTA GRUNDSTÜCKS UND BETEILIGUNGSVERW GMB...

 

-

-

-

 

OTOMOTIVE LASTIKLERI TEVZI AS

 

-

-

-

 

PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A.

 

-

-

-

 

PEUGEOT MOTOCYCLES S.A.

 

-

-

-

 

PHOENIX AIRSPRING TECHNOLOGY KFT

 

-

-

-

 

PHOENIX BEATTIE CORP

 

-

-

-

 

PHOENIX BEATTIE CORP

 

-

-

-

 

PHOENIX BV

 

-

-

-

 

PHOENIX ELASTOMERPRODUKTE VERTRIEBSGESEL...

 

-

-

-

 

PHOENIX GB LTD

 

-

-

-

 

PHOENIX NORDEN AB

 

-

-

-

 

PHOENIX RUBBER PRODUCTS SDN BHD

 

-

-

-

 

PHOENIX RUBBER S.A. PTY LTD

 

-

-

-

 

PHOENIX SHANXI CONVEYOR BELT CO. LTD

 

-

-

-

 

PHOENIX VIBRATION CONTROL BV

 

-

-

-

 

PHOENIX YULE LTD

 

-

-

-

 

PNEU SETTE SRL

 

-

-

-

 

PNEU SLUZBY SRO

 

-

-

-

 

PNEUS EXPERT POLSKA SPOL. ZOO

 

-

-

-

 

PROFI REIFEN UND AUTOSERVICE GESELLSCHAF...

 

-

-

-

 

PT CONTINENTAL SIME TYRE MARKETING

 

-

-

-

 

PT INDO VDO INSTRUMENTS CO. LTD

 

-

-

-

 

RADSYSTEM GMBH

 

-

-

-

 

ROSEA GRUNDSTÜCKS-VERMIETUNGSGESELLSCHAF...

 

-

-

-

 

ROULUNDS RUBBER A/S

 

-

-

-

 

ROULUNDS RUBBER KOREA LTD

 

-

-

-

 

RUNDPNEU BETEILIGUNGSGES MBH

 

-

-

-

 

S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL

 

-

-

-

 

S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL

 

-

-

-

 

S.C. PHOENIX UNIO SRL

 

-

-

-

 

S.C. THERMOPOL SRL

 

-

-

-

 

SANSUY BENECKE LTDA

 

-

-

-

 

SAS (WUHU) AUTOMOTIVE SYSTEMS CO.LTD

 

-

-

-

 

SAS AUTOMOTIVE DE PORTUGAL UNIPESSOAL LD...

 

-

-

-

 

SAS AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA

 

-

-

-

 

SAS AUTOMOTIVE NV

 

-

-

-

 

SAS AUTOMOTIVE RSA PTY LTD

 

-

-

-

 

SAS AUTOMOTIVE SRO

 

-

-

-

 

SAS AUTOMOTIVE SYSTEMS & SERVICES SA DE ...

 

-

-

-

 

SAS AUTOMOTIVE SYSTEMS SA DE CV

 

-

-

-

 

SAS AUTOMOTIVE USA INC

 

-

-

-

 

SAS AUTOMOTRIZ ARGENTINA SA

 

-

-

-

 

SAS AUTOSYSTEMTECHNIK SA

 

-

-

-

 

SAS AUTOSYSTEMTECHNIK SRO

 

-

-

-

 

SAS AUTOSYSTEMTECHNIK VALENCIA SLU

 

-

-

-

 

SC CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE SRL

 

-

-

-

 

SECHSTE PHOENIX VERWALTUNGS GMBH

 

-

-

-

 

SEMPERIT IRELAND LTD

 

-

-

-

 

SEMPERIT REIFEN GESELLSCHAFT MBH

 

-

-

-

 

SEMPERIT UK LTD

 

-

-

-

 

SHANGHAI AUTOMOTIVE BRAKE SYSTEMS CO. LT...

 

-

-

-

 

SHANGHAI ROULUNDS RUBBER PRODUCTIONS LTD

 

-

-

-

 

SIEBTE PHOENIX VERWALTUNGS GMBH

 

-

-

-

 

SIEMENS VDO ASIA PACIFIC CO. LTD

 

-

-

-

 

SIEMENS VDO AUTOMOTIVE HUIZHOU CO. LTD

 

-

-

-

 

SIEMENS VDO AUTOMOTIVE LTD

 

-

-

-

 

SIEMENS VDO TRADING A/S

 

-

-

-

 

SIME KITARAN BUMI SDN. BHD

 

-

-

-

 

SIME RUBBER INDUSTRIES SDN. BHD

 

-

-

-

 

SIME TYRES MARKETING SDN. BHD

 

-

-

-

 

SYNERJECT LLC

 

-

-

-

 

SYRMA AE

 

-

-

-

 

TEMIC AUTOMOTIVE OF NORTH AMERICA INC

 

-

-

-

 

TEMIC AUTOMOTIVE PHILS. INC

 

-

-

-

 

TEMIC SERVICIOS SA DE CV

 

-

-

-

 

TEMIC TELEFUNKEN MICROELECTRONIC HUNGARY...

 

-

-

-

 

TEVES SERVICIOS SA DE CV

 

-

-

-

 

TGB TRANSPORTGUMMI BLANKENBURG GMBH IL

 

-

-

-

 

THERMOPOL HK LIMITED

 

-

-

-

 

THERMOPOL KOREA LIMITED

 

-

-

-

 

THUNDER RACING PTY LTD

 

-

-

-

 

TIC ROULUNDS ITALIA SPA

 

-

-

-

 

TW FITTING NA LLC

 

-

-

-

 

TYRE REINSURANCE IRELAND LTD

 

-

-

-

 

VIPOTEST SRO

 

-

-

-

 

WOHLFAHRTSEINRICHTUNG FÜR DIE ARBEITER U...

 

-

-

-

 

YOKOHAMA CONTINENTAL TIRE COMPANY LTD

 

-

-

-

 

 

event history

 

 

 

 

 

 

Date

Description

01/01/2010

Economically active

 

 

 

 

 

 

Publication date

Gazette Name

Description

 

12/01/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

78 - YVELINES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

1482 - 542 065 479 RCS Versailles. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA. Forme : Société anonyme. Capital : 294816500 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

03/01/2012

JAL

Modification of the share capital

 

 

Semaine de l'Ile-de-France (La)


Date de décision : 19/12/2011
La société : 542065479 - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA, RTE DE GIZY, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY a subi une diminution de son capital social désormais de 294 816 500 €
Date d'effet : 19/12/2011

23/12/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

78 - YVELINES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

1956 - 542 065 479 RCS Versailles. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA. Forme : Société anonyme. Capital : 2358532000 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

20/12/2011

JAL

Modification of the share capital

 

 

Semaine de l'Ile-de-France (La)


Date de décision : 15/11/2011
La société : 542065479 - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA, RTE DE GIZY, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 358 532 000 €
Date d'effet : 15/11/2011

02/10/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

78 - YVELINES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

1399 - 542 065 479 RCS Versailles. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes suppléant : de CAMBOURG Patrick en fonction le 23 Septembre 2005 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA modification le 23 Septembre 2011 Administrateur : MARTIN Denis modification le 21 Avril 2010 Directeur général et administrateur : FAURY Guillaume modification le 21 Avril 2010 Administrateur : SAINT-GEOURS Frédéric en fonction le 21 Septembre 2009 Président du conseil d'administration et administrateur : VARIN Philippe modification le 21 Avril 2010 Administrateur : BRUNET Claude en fonction le 13 Décembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 23 Septembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 23 Septembre 2011. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant.

21/12/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

78 - YVELINES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

2373 - 542 065 479 RCS Versailles. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Octobre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : de CAMBOURG Patrick en fonction le 23 Septembre 2005 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD en fonction le 23 Septembre 2005 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 16 Juin 2008 Administrateur : MARTIN Denis modification le 21 Avril 2010 Directeur général et administrateur : FAURY Guillaume modification le 21 Avril 2010 Administrateur : SAINT-GEOURS Frédéric en fonction le 21 Septembre 2009 Président du conseil d'administration et administrateur : VARIN Philippe modification le 21 Avril 2010 Administrateur : BRUNET Claude en fonction le 13 Décembre 2010. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant.

14/12/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

Semaine de l'Ile-de-France (La)


Société faisant l'objet d'une nomination : 542065479 - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA, RTE DE GIZY, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Nominé : Monsieur Claude BRUNET, 14B Villa Madrid, 92200 NEUILLY SUR SEINE
En la fonction de : Administrateur
Date d'effet : 05/10/2010

14/12/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

Semaine de l'Ile-de-France (La)


Date de décision : 05/10/2010
La société 542065479 - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA, RTE DE GIZY, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Fait l'objet du départ de Date d'effet : 05/10/2010

25/08/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

78 - YVELINES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

5580 - 542065479 RCS. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA. Forme : Société anonyme. Adresse : route de Gisy 78140 Vélizy-Villacoublay. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

02/05/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

78 - YVELINES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

1160 - 542 065 479 RCS Versailles. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Octobre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : de CAMBOURG Patrick en fonction le 23 Septembre 2005 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD en fonction le 23 Septembre 2005 Administrateur : OLIVIER Gregoire en fonction le 14 Mai 2007 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 16 Juin 2008 Administrateur : MARTIN Denis modification le 21 Avril 2010 Directeur général et administrateur : FAURY Guillaume modification le 21 Avril 2010 Administrateur : SAINT-GEOURS Frédéric en fonction le 21 Septembre 2009 Président du conseil d'administration et administrateur : VARIN Philippe modification le 21 Avril 2010.
Commentaires : Modification de représentant.

20/04/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

LA SEMAINE DE L’ILE DE FRANCE


Société faisant objet d'une nomination : 542065479 - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA, CHE DE GIZY, CHEMIN VICINAL 2, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Nominé : Monsieur Guillaume FAURY
En la fonction de : DG - Directeur Général

20/04/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

LA SEMAINE DE L’ILE DE FRANCE


Société faisant objet d'une nomination : 542065479 - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA, CHE DE GIZY, CHEMIN VICINAL 2, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Nominé : Monsieur Philippe VARIN
En la fonction de : Président du Conseil d'Administration

20/04/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

LA SEMAINE DE L’ILE DE FRANCE


Date de décision : 23/03/2010
La société 542065479 - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA, CHE DE GIZY, CHEMIN VICINAL 2, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Fait l'objet du départ de Monsieur Denis MARTIN

08/01/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Société faisant objet d'une nomination : 382373116 - SOLENDI EXPANSION, 122 BD VICTOR HUGO, 93400 SAINT OUEN
Nominé :
En la fonction de : Administrateur

01/10/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

78 - YVELINES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

2120 - 542 065 479 RCS Versailles. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Octobre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : de CAMBOURG Patrick en fonction le 23 Septembre 2005 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS& GUERARD en fonction le 23 Septembre 2005 Administrateur : OLIVIER Gregoire en fonction le 14 Mai 2007 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 16 Juin 2008 Président du conseil d'administration et directeur général : MARTIN Denis en fonction le 10 Mars 2009 Administrateur : FAURY Guillaume en fonction le 21 Septembre 2009 Administrateur : SAINT-GEOURS Frédéric en fonction le 21 Septembre 2009.
Commentaires : Modification de représentant.

01/10/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

78 - YVELINES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

2121 - 542 065 479 RCS Versailles. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Octobre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : de CAMBOURG Patrick en fonction le 23 Septembre 2005 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS& GUERARD en fonction le 23 Septembre 2005 Administrateur : OLIVIER Gregoire en fonction le 14 Mai 2007 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 16 Juin 2008 Président du conseil d'administration et directeur général : MARTIN Denis en fonction le 10 Mars 2009 Administrateur : FAURY Guillaume en fonction le 21 Septembre 2009 Administrateur : SAINT-GEOURS Frédéric en fonction le 21 Septembre 2009 Administrateur : VARIN Philippe en fonction le 21 Septembre 2009.
Commentaires : Modification de représentant.

31/07/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

78 - YVELINES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

5564 - 542065479 RCS. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA. Forme : Société anonyme. Adresse : route de Gisy 78140 Vélizy-Villacoublay. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

20/03/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

78 - YVELINES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

1653 - 542 065 479 RCS Versailles. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur : VARDANEGA Roland en fonction le 07 Mars 2003. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Octobre 2003. Commissaire aux comptes suppléant : de CAMBOURG Patrick en fonction le 23 Septembre 2005. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS& GUERARD en fonction le 23 Septembre 2005. Administrateur : OLIVIER Gregoire en fonction le 14 Mai 2007. Administrateur : STREIFF Christian en fonction le 14 Mai 2007. Administrateur : MAREY-SEMPER Isabel en fonction le 22 Novembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 16 Juin 2008. Président du conseil d'administration et directeur général : MARTIN Denis en fonction le 10 Mars 2009.
Commentaires : Modification de représentant.

07/09/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

78 - YVELINES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

4401 - 542065479 RCS. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA. Forme : Société anonyme. Adresse : route de Gisy 78140 Vélizy-Villacoublay. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

25/06/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

78 - YVELINES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

3389 - 542 065 479 RCS Versailles. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur : VARDANEGA Roland en fonction le 07 Mars 2003Président du conseil d'administration et directeur général : VERGNE Jean-Luc modification le 27 Octobre 2003. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Octobre 2003. Commissaire aux comptes suppléant : de CAMBOURG Patrick en fonction le 23 Septembre 2005. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD en fonction le 23 Septembre 2005. Administrateur : OLIVIER Gregoire en fonction le 14 Mai 2007. Administrateur : STREIFF Christian en fonction le 14 Mai 2007. Administrateur : MAREY-SEMPER Isabel en fonction le 22 Novembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 16 Juin 2008.
Commentaires : Modification de représentant.

21/12/2007

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

78 - YVELINES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

495 - 542 065 479 RCS Versailles. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur : GUERY Sylvie radiation le 22 Novembre 2007. Administrateur : MAREY-SEMPER Isabel en fonction le 22 Novembre 2007.
Commentaires : Modification de représentant.

30/08/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

3341 - 542 065 479. RCS Versailles PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA. Forme: Société anonyme. Adresse du siège social: route de Gisy 78140 Vélizy-Villacoublay. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

13/06/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2328 - RCS Versailles B 542 065 479. RC 99-B 360. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateurs partants : FOLZ (Jean-Martin) MICHEL (Gilles). Nomination d'administrateurs : OLIVIER (Grégoire) STREIFF (Christian).

24/09/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1867 - RCS Versailles B 542 065 479. RC 99-B 360. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Capital : 294 816 500 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

30/08/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

2781 - RCS Versailles B 542 065 479. RC 99-B 360. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA. Forme: S.A. Adresse du siège social: route de Gisy,78140 Vélizy-Villacoublay. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

09/10/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2288 - RCS Versailles B 542 065 479. RC 99-B 360. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : commissaire aux comptes suppléant partant : AMEYE (François-Xavier). Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET CONSTANTIN ASSOCIES. Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : DE CAMBOURG (Patrick). Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD.

24/08/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

2992 - RCS Versailles B 542 065 479. RC 99-B 360. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA. Forme: S.A. Adresse du siège social: route de Gisy,78140 Vélizy-Villacoublay. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

10/12/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

Rectificatif: Annonce numéro: 1998 Date de parution: 19 mars 2003 Page: 101 Numéro de parution: 54 B Au lieu de : nomination du président du conseil d' administration : VERGNE (Jean-Luc) lire. RCS Versailles B 542065479 RC 99-B 360 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Administration : nomination d' un président du conseil d' administration et directeur général : VERGNE (Jean-Luc).

21/10/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Versailles B 542065479 RC 99-B 360 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : directeur général délégué et administrateur partant : SILVANT (Jean- Louis).

21/10/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Versailles B 542065479 RC 99-B 360 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : commissaire aux comptes titulaire partant : COOPERS ET LYBRAND AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant partant : NICOLAS (Yves). Nomination d' un commissaire aux comptes suppléant : SCHNEIDER (Louis, Pierre). Nomination d' un commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT.

21/10/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Versailles B 542065479 RC 99-B 360 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un administrateur : MICHEL (Gilles).

19/03/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Versailles B 542065479 RC 99-B 360 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Capital : 293 304 000 euros. Adresse du siège social : route de Gisy, 78140 Vélizy-Villacoublay. Administration : nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : AMEYE (François-Xavier). Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : CABINET CONSTANTIN ASSOCIES. Nomination d'administrateurs : VARDANEGA (Roland) FOLZ (Jean-Martin). Nomination d'un directeur général délégué et administrateur : SILVANT ( Jean-Louis). Nomination d'un administrateur : DELABRIERE (Yann). Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : COOPERS ET LYBRAND AUDIT. Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS (Yves). Nomination du président du conseil d' administration : VERGNE (Jean-Luc). Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation). Cette société transfère son siège social des 65-71 boulevard du Chateau, 92200 Neuilly-sur-Seine. Date d'effet : 7 mars 2003.

06/11/2002

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS B 433974300 A dater du: 21 octobre 2002 RC 02-B 133 D.J. 34. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 40 040 000 euros. Adresse du siège social : 75 avenue de la Grande-Armée, 75116 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : participer, directement ou indirectement, par tous moyens à toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à la réparation, l' achat, la vente des prestations de services. Adresse : Z.I. des Trembles, 54920 Villers-la-Montagne Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 40 000 000 d'euros Date de début d'activité: 1 e r octobre 2002. Précédent propriétaire : PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. RCS B 542065479 Publication légale: Les Petites affiches du 1 e r octobre 2002. Oppositions : au siège de la société D.J. 34.

09/08/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 542065479 RC 80-B 23720 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification d'un administrateur : FOLZ (Jean-Martin). Modification d'un directeur général délégué et administrateur : SILVANT (Jean-Louis). Modification du P.-D.G. : VERGNE (Jean- Luc).

14/06/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 542065479 RC 80-B 23720 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : PEUGEOT S.A., représentée par VERGNE (Jean-Luc). Nomination d'un administrateur : VERGNE (Jean-Luc).

02/06/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS B 542065479 RC 99-B 1168 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : 65-71 boulevard du Chateau, 92200 Neuilly-sur- Seine. Commentaires : apport sous le régime des scissions par les sociétés AUTOMOBILES CITROEN S.A.,. RCS Paris 642 050 199 et AUTOMOBILES PEUGEOT S.A.,. RCS Paris 552 144 503. Date d'effet : 18 décembre 2001.

27/03/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 542065479 RC 80-B 23720 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Capital : 293 304 000 euros. Adresse du siège social : 65-71 boulevard du Chateau, 92200 Neuilly-sur-Seine. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation), l'adresse du siège social et l'adresse de l' établissement principal Etablissement principal: Activité : industrie, commerce automobiles, conception, développement, construction, achat, vente, entretien et réparation. Adresse : 65-71 boulevard du Chateau, 92200 Neuilly-sur-Seine.

30/06/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 542065479 RC 80-B 23720 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : WOLFF (Jean). Nomination d'un administrateur : VARDANEGA (Roland).

12/11/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 542065479 RC 80-B 23720 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : commissaire aux comptes suppléant partant : GUFFLET (Gilles). Nomination du commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS (Yves).

27/06/2000

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

428 709 786. RCS Nanterre. A dater du: 29 mai 2000 KOYO STEERING DIJON SAINT- ETIENNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse du siège social : 62 boulevard Victor-Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine Fonds secondaire acquis par apport- fusion, au montant global net évalué à 237 255 000 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Dijon 2000-B 1051. Activité : fabrication, construction, réparation, entretien, achat, vente de toutes pièces, composants mécaniques ou autres, ensembles et moteurs, notamment organe de direction automobiles, machines de toutes natures et travail de tous métaux et matières. Adresse : 38 boulevard Voltaire, 21000 Dijon Date de début d'activité: 31 mars 2000 Précédente propriétaire-exploitante PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES 542 065 479. RCS Dijon. Publication légale: Journal du Palais du 15 avril 2000.

10/03/2000

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS B 302475041 RC 75-B 02715 SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE. Forme : S.A. Capital : 23 852 000 F. Adresse du siège social : 75 avenue de la Grande-Armée, 75016 Paris Etablissement principal: Activité : toutes opérations commerciales et industrielles concernant l'automobile. Adresse : 75 avenue de la Grande-Armée, 75016 Paris Etablissement Complémentaire. Activité : achat, vente de véhicules automobiles, neufs ou d'occasion, vente de pièces de rechange, d'accessoires automobiles et de carburants entretien, fonctionnement de véhicules automobiles et location de véhicules. Adresse : 98 avenue du Général-Leclerc, 75014 Paris Etablissement complémentaire acquis par apport au montant évalué à 4 407 592 F. Commentaires : augmentation du capital. Date d'effet : 30 juin 1999. Précédent propriétaire : PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. RCS B 542065479 Publication légale: Les Annonces de la Seine du 29 novembre 1999 déclaration de créances: au tribunal de commerce de Paris.

07/12/1999

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS B 354 051 203 RC 90-B 05943 PARISUD. Forme : S.A. Capital : 3 900 000 F. Adresse du siège social : 105 avenue Gabriel-Péri, 92240 Malakoff Fonds principal acquis par apport, au montant évalué à 2 609 816 F Etablissement principal: Activité : concession automobile Peugeot, achats et ventes de voitures neuves et d'occasion, foire et exposition, réparation de véhicules, ventes de pièces de rechanges. Adresse : 105 avenue Gabriel-Péri, 92240 Malakoff Date de début d'activité: 30 juin 1999 Précédente propriétaire PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. RCS B 542 065 479 Publication légale: Les Annonces de la Seine du 24 juin 1999 déclaration de créances: au greffe du tribunal de commerce de Nanterre.

24/10/1999

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS B 354051203 RC 99-B 97 PARISUD. Forme : S.A. Adresse du siège social : 105 avenue Gabriel-Péri, 92240 Malakoff Etablissement principal: Activité : garage automobile, station-service, commercialisation de tous produits, d' accessoires, d'articles divers destinés à tous véhicules et aux automobilistes vente de carburants et de lubrifiants. Adresse : 54-56 rue de la Convention, 94270 Le Kremlin-Bicetre Etablissement principal acquis par apport au montant évalué à 855 909 F Date de début d' activité: 1 e r novembre 1998. Précédent propriétaire : PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. RCS B 542065479 Publication légale: Les Annonces de la Seine du 24 juin 1999.

07/10/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

*. RCS Nanterre B 542 065 479 RC 80-B 23720 PEUGEOT-CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Capital : 249 999 970 euros. Commentaires : modification survenue sur l'administration et le capital ( augmentation). Administration : suppression : commissaire aux comptes titulaire : BARBIER FRINAULT ET AUTRES. Nomination en qualité de commissaire aux comptes titulaire : CABINET CONSTANTIN ASSOCIES. Suppression : commissaire aux comptes suppléant : MACIOCE (Pascal). Nomination en qualité de commissaire aux comptes suppléant : AMEYE (François-Xavier).

07/10/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

*. RCS Nanterre B 542 065 479 RC 80-B 23720 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification : commissaire aux comptes titulaire : BARBIER FRINAULT ET AUTRES.

29/06/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Montbéliard B 414668194 A dater du: 15 mars 1999 RC 99-B 46 PEUGEOT CITROEN SOCHAUX SOCIETE EN NOM COLLECTIF. Forme : S.N.C. Capital : 250 000 F. Adresse du siège social : 57 avenue du Général- Leclerc, 25600 Sochaux. Administration : associé en nom : STE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES PEUGEOT CITROEN, représentant permanent : KIRSZENBERG ( Marc). Associé gérant : PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A., représentant permanent : FOLZ (Jean, Martin). Commissaire aux comptes titulaire : COOPERS ET LYBRAND AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : GUFFLET (Gilles) Etablissement principal: Activité : fabrication, construction, achat, vente, montage, réparation et entretien de tous véhicules automobiles, de moteurs, de carrosseries, d'ensembles et de pièces mécaniques ou autres. Adresse : 57 avenue du Général-Leclerc, 25600 Sochaux Etablissement principal reçu en location-gérance. Commentaires : transfert du 75 avenue de la Grande- Armée, 75016 Paris. Date d'effet : 31 décembre 1998 Propriétaire PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES. RCS B 542065479 RC 99-B 27.

26/06/1999

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS B 542065479 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES. Forme : S.A. Adresse du siège social : 62 boulevard Victor-Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC 99-B 00592. Activité : industrie, commerce automobile, conception, développement, construction, achat, vente, entretien et réparation. Adresse : boulevard André-Citroen, 93600 Aulnay-sous-Bois Etablissement secondaire acquis par apport au montant évalué à 1 499 999 820 F Date de début d'activité: 31 décembre 1998. Précédent propriétaire : AUTOMOBILES CITROEN. RCS B 642050199 Publication légale: Les Annonces de la Seine du 28 décembre 1998 déclaration de créances: au tribunal de commerce de Bobigny.

17/06/1999

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS Nanterre B 542 065 479 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : 62 boulevard Victor-Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine Fonds complémentaire acquis par achat, au prix stipulé de 4 800 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Montbéliard 99-B 27. Adresse : 57 avenue du Général- Leclerc, 25600 Sochaux Etablissement Complémentaire. Activité : industrie, commerce automobiles , conception, développement, construction, achat, vente, entretien, réparation. Adresse : 25420 Bart. Date d'effet : 31 décembre 1998 Précédente propriétaire S.A. PEUGEOT AUTOMOBILES 552 144 503 Publication légale: Les Annonces de la Seine du 28 décembre 1998 déclaration de créances: au greffe du tribunal de commerce de Nanterre.

15/05/1999

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS Nanterre B 542 065 476 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : 62 boulevard Victor-Hugo 92200 Neuilly-sur-Seine ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Montbéliard 99-B 27. A dater du : 9 février 1999. Activité : industrie, commerce, conception, développement, construction, achat, vente, entretien et réparation d' automobiles. Adresse : 57 avenue du Général-Leclerc 25600 Sochaux Etablissement secondaire acquis par apport au montant évalué à 1 439 538 581 F Date de début d'activité: 31 décembre 1998. Précédent propriétaire : AUTOMOBILES PEUGEOT. RCS B 552 144 503 Publication légale: Les Annonces de la Seine du 28 décembre 1998 déclaration de créances: au tribunal de commerce de Nanterre.

11/05/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Mulhouse B 414 713 503 A dater du: 23 mars 1999 RC 99-B 199 PEUGEOT CITROEN MULHOUSE SOCIETE EN NOM COLLECTIF. Forme : S.N.C. Capital : 250 000 F (fixe). Adresse du siège social : route de Chalampe, Ile-Napoléon, 68390 Sausheim. Commentaires : transfert du siège du 75 avenue de la Grande Armée, 75016 Paris. Administration : gérant associé : PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S. A. associée : SOCIETE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES PEUGEOT CITROEN S.A. commissaire aux comptes titulaire : CABINET BARBIER FRINAULT ET AUTRES commissaire aux comptes suppléant : MACIOCE (Pascal) Etablissement principal: Activité : fabrication, construction, achat et vente, montage, réparation et entretien de tous véhicules automobiles , moteurs, carrosseries. Adresse : route de Chalampe, Ile-Napoléon, 68390 Sausheim Fonds principal reçu en location- gérance. Date d'effet : 31 décembre 1998 Propriétaire PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A.

27/04/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

414 713 594. RCS Nanterre. PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DE L'EST SOCIETE EN NOM COLLECTIF. Forme : S.N.C. Adresse du siège social : 62 boulevard Victor-Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Dijon 99-B 160. Activité : fabrication, construction, réparation, entretion, achat, vente de toutes pièces mécaniques ou autres, ensembles et moteurs, machines de toutes natures et travail de tous métaux et matières. Adresse : 38 boulevard Voltaire, 21000 Dijon Fonds secondaire reçu en location- gérance Date de début d'activité: 31 décembre 1998 Propriétaire PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES. RCS B 542 065 479.

25/04/1999

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS B 542 065 479 A dater du: 15 février 1999 RC 99-B 00015 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. à conseil d'administration. Adresse du siège social : 62 boulevard Victor-Hugo 92200 Neuilly-sur-Seine ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : industrie, commerce automobile, conception, développement, construction, achat, vente, entretien et réparation. Adresse : Z.I. des Trembles 54 - Villers-la- Montagne Etablissement secondaire acquis par apport au montant évalué à 16 051 288 180 F. Date d'effet : 31 décembre 1998. Précédent propriétaire : AUTOMOBILES PEUGEOT. RCS B 552 144 503 Publication légale: Les Annonces de la Seine du 28 décembre 1998 déclaration de créances: au tribunal de commerce de Nanterre.

23/04/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS. RCS B 414 713 495 A dater du: 18 mars 1999 RC RC 99-B 277 PEUGEOT CITROEN RENNES S.N.C. Forme : S.N.C. Capital : 250 000 F. Adresse du siège social : route de Nantes 35131 Chartres- de-Bretagne. Administration : gérant- associé : PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S. A. Associé en nom collectif : SOCIETE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES PEUGEOT CITROEN. Commissaire aux comptes titulaire : BARBIER FRINAULT ET AUTRES. Commissaire aux comptes suppléant : MACIOCE (Pascal) Etablissement principal: Activité : fabrication, construction, achat, vente, montage, réparation et entretien de tous véhicules automobiles , moteurs, carrosseries, ensembles et pièces mécaniques ou autres destinés à tous usages. Adresse : route de Nantes 35131 Chartres-de-Bretagne Etablissement principal reçu en location-gérance. Commentaires : transfert du siège social du 75, avenue de la Grande-Armée, 75016 Paris. Date d'effet : 31 décembre 1998 Propriétaire : PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. RCS RCS B 542 035 479.

11/04/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

Propriétaire. RCS Briey B 542 065 479 RC 99-B 15 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. à conseil d'administration. Adresse du siège social : 62 boulevard Victor-Hugo 92200 Neuilly-sur-Seine ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Adresse : Z.I. des Trembles 54920 Villers-la-Montagne Fonds acquit par achat Mise en location- gérance de l'établissement secondaire sis Z.I. des Trembles, Villers-la- Montagne. Activité : industrie et commerce d'automobiles Bénéficiaire: S. N.C.PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DE L'EST. Date d'effet : 31 décembre 1998.

26/02/1999

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS *. RCS Bobigny B 542 065 479 RC RC 99-B 592 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES. Forme : S.A. Adresse du siège social : 62, boulevard Victor-Hugo 92200 Neuilly-sur- Seine Etablissement principal: Activité : industrie de commerce automobiles, conception, développement, construction, achat, vente, entretien, réparation. Adresse : boulevard André-Citroen 93600 Aulnay-sous-Bois Etablissement secondaire acquis par apport au montant évalué à 1 486 239 820 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE immatriculé au. RCS : Bobigny. Adresse : 23, avenue du Capitaine-Glarner 93400 Saint-Ouen. Activité : industrie de commerce automobiles, conception, développement, achat, vente, entretien, réparation, construction Date de début d'activité: 31 décembre 1998. Précédent propriétaire : AUTOMOBILES CITROEN. RCS RCS B 642 050 199 Publication légale: Les Annonces de la Seine du 28 décembre 1998 déclaration de créances: au greffe du tribunal de commerce de Bobigny.

26/02/1999

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS *. RCS Bobigny B 542 065 479 RC RC 99-B 592 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES. Forme : S.A. Adresse du siège social : 62, boulevard Victor-Hugo 92200 Neuilly-sur- Seine Etablissement principal: Activité : industrie de commerce automobiles, conception, développement, construction, achat, vente, entretien, réparation. Adresse : boulevard André-Citroen 93600 Aulnay-sous-Bois Etablissement secondaire acquis par apport au montant évalué à 1 476 239 820 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE immatriculé au. RCS : Bobigny. Adresse : 61, rue Arago 93400 Saint-Ouen. Activité : centre de formation Date de début d'activité: 31 décembre 1998. Précédent propriétaire : : AUTOMOBILES CITROEN. RCS RCS B 642 050 199 Publication légale: Les Annonces de la Seine du 28 décembre 1998 déclaration de créances: au greffe du tribunal de commerce de Bobigny.

19/02/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Nanterre B 542 065 479 RC RC 80-B 23720 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Capital : 1 499 999 820 F. Administration : nomination en qualité de commissaire aux comptes titulaire : BARBIER FRINAULT ET ASSOCIES. Nomination en qualité de commissaire aux comptes suppléant : MACIOCE ( Pascal). Commentaires : modification survenue sur l'administration et le capital (augmentation).

11/12/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Nanterre B 542 065 479 RC RC 80-B 23720 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Capital : 23 760 000 F. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

11/12/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Nanterre B 542 065 479 RC RC 80-B 23720 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : 62, boulevard Victor-Hugo 92200 Neuilly- sur-Seine. Activité : industrie, commerce automobiles, conception, développement, construction, achat, vente, entretien, réparation Etablissement principal: Adresse : 62, boulevard Victor-Hugo 92200 Neuilly-sur-Seine. Administration : nomination en qualité d'administrateur : PEUGEOT S.A. Commentaires : modification survenue sur la dénomination, l' activité, l'adresse du siège social, l' adresse de l'établissement principal et l'administration.

27/11/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Nanterre B 542 065 479 RC RC 80-B 23720 PARISUD. Forme : S.A. Administration : nomination en qualité de président du conseil d' administration : FOLZ (Jean-Martin). Suppression : président du conseil d' administration : VARDANEGA (Roland) Nomination en qualité de directeur général et administrateur : SILVANT ( Jean-Louis). Nomination en qualité d' administrateurs : WOLFF (Jean) DELABRIERE (Yann) PEUGEOT (Christian) IMMEUBLES ET PARTICIPATIONS DE L'EST S. A. Suppression : administrateur : AUTOMOBILES PEUGEOT S.A. Commentaires : modification survenue sur l' administration.

23/09/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Nanterre B 542 065 479 RC RC 80-B 23720 PARISUD. Forme : S.A. Administration : modification : administrateur : PEUGEOT (Christian). Nomination en qualité de commissaire aux comptes titulaire : COOPERS ET LYBRAND AUDIT. Suppression : commissaire aux comptes suppléant : LEGER (Michel). Nomination en qualité de commissaire aux comptes suppléant : GUFFLET (Gilles). Commentaires : modification survenue sur l' administration.

14/03/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Nanterre B 542 065 479 RC RC 80-B 23720 PARISUD. Forme : S.A. Administration : modification : administrateur : AUTOMOBILES PEUGEOT S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration.

 

 

 

 

Date

Description

06/04/2012

New subsidiarie(s) detected

12/01/2012

Bodacc B: Various editing or changing

04/01/2012

Minutes of general meeting of shareholders

04/01/2012

Capital reduction

04/01/2012

Updated articles of association

23/12/2011

Bodacc B: Various editing or changing

19/12/2011

Other modification of Establishment

19/12/2011

Legal Gazette: Modification of the share capital

15/12/2011

Capital increase

15/12/2011

Fund deposit certificate

15/12/2011

Minutes of general meeting of shareholders

15/12/2011

Updated articles of association

13/12/2011

Payment incident detected

30/11/2011

Other modification of Establishment

15/11/2011

Legal Gazette: Modification of the share capital

07/10/2011

Disengagement in other companies

02/10/2011

Bodacc B: Various editing or changing

23/09/2011

New auditor

23/09/2011

Minutes of general meeting of shareholders

26/07/2011

Bodacc C : Deposit accounts notice

21/07/2011

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

31/12/2010

New accounts available

21/12/2010

Bodacc B: Various editing or changing

14/12/2010

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

13/12/2010

Changes to the Board of Directors

13/12/2010

Minutes of Board meeting

05/10/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

25/08/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

13/08/2010

Update of participations in other companies

13/08/2010

New subsidiarie(s) detected

02/05/2010

Bodacc B: Various editing or changing

21/04/2010

Changes to the Board of Directors

21/04/2010

Minutes of Board meeting

20/04/2010

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

23/03/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

19/03/2010

Payment incident closed

14/01/2010

Payment incident closed

01/01/2010

Transfer of Establishment

31/12/2009

New accounts available

10/12/2009

Payment incident detected

10/12/2009

Legal Gazette: Appointment of the social representative

13/11/2009

Payment incident detected

01/10/2009

Bodacc B: Various editing or changing

21/09/2009

Appointment/resignation of company officers

21/09/2009

Changes to the Board of Directors

21/09/2009

Minutes of general meeting of shareholders

21/09/2009

Minutes of Board meeting

15/09/2009

Payment incident closed

31/07/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

02/07/2009

Payment incident closed

11/05/2009

Payment incident detected

20/03/2009

Bodacc B: Various editing or changing

10/03/2009

New chairman (CEO, CoB)

10/03/2009

Minutes of Board meeting

10/03/2009

Changes to the Board of Directors

23/02/2009

Changes to the Board of Directors

23/02/2009

Payment incident closed

23/02/2009

Private document

23/02/2009

Appointment/resignation of company officers

23/02/2009

Minutes of Board meeting

23/02/2009

New chairman (CEO, CoB)

19/02/2009

Payment incident closed

16/02/2009

Payment incident closed

31/12/2008

New accounts available

24/12/2008

Payment incident detected

04/12/2008

Payment incident closed

24/11/2008

Payment incident closed

06/11/2008

Payment incident detected

29/10/2008

Payment incident detected

06/10/2008

Payment incident closed

29/09/2008

Payment incident detected

07/09/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

04/09/2008

Payment incident closed

25/06/2008

Bodacc B: Various editing or changing

25/06/2008

New Bodacc B ads detected

16/06/2008

Amendment

16/06/2008

New auditor

16/06/2008

Changement de Commissaire aux Comptes

16/06/2008

Minutes of general meeting of shareholders

16/06/2008

Private document

16/06/2008

PV d'Assemblée

01/03/2008

Formation of Establishment

31/12/2007

New accounts available

21/12/2007

New Bodacc B ads detected

21/12/2007

Bodacc B: Various editing or changing

21/11/2007

PV du Conseil d'Administration

21/11/2007

Appointment/resignation of company officers

21/11/2007

Private document

21/11/2007

Modification du Conseil d'Administration

21/11/2007

Changes to the Board of Directors

21/11/2007

Minutes of Board meeting

12/10/2007

Payment incident detected

27/06/2007

Payment incident detected

14/05/2007

Modification du Conseil d'Administration

14/05/2007

Changes to the Board of Directors

14/05/2007

Private document

14/05/2007

Appointment/resignation of company officers

14/05/2007

PV du Conseil d'Administration

14/05/2007

Minutes of Board meeting

01/03/2007

Formation of Establishment

01/01/2007

Other modification of Establishment

12/09/2006

Statuts mis à jour

12/09/2006

Updated articles of association

12/09/2006

PV du Conseil d'Administration

12/09/2006

Minutes of Board meeting

12/09/2006

Déclaration de conformité

12/09/2006

Minutes of general meeting of shareholders

12/09/2006

PV d'Assemblée

12/09/2006

Declaration of conformity

12/09/2006

Private document

12/09/2006

Acte sous seing privé

12/09/2006

Capital increase

12/09/2006

Augmentation de Capital

12/09/2006

Fusion

09/06/2006

Audit or Management Report

09/06/2006

Acte sous seing privé

09/06/2006

Rapport des Commissaires ou du Gérant

09/06/2006

Private document

11/05/2006

Planned merger

11/05/2006

Private document

11/05/2006

Acte sous seing privé

11/05/2006

Projet de Fusion

11/05/2006

Acte modificatif

31/12/2005

New accounts available

23/09/2005

Minutes of general meeting of shareholders

23/09/2005

PV d'Assemblée

23/09/2005

Changement de Commissaire aux Comptes

23/09/2005

New auditor

23/09/2005

Acte sous seing privé

23/09/2005

Private document

23/09/2005

Appointment/resignation of company officers

23/09/2005

Nomination/démission des organes de gestion

09/06/2005

Requête et Ordonnance

09/06/2005

Application and court order

31/12/2004

New accounts available

31/12/2003

New accounts available

09/10/2003

PV d'Assemblée

09/10/2003

Nomination/démission des organes de gestion

09/10/2003

PV du Conseil d'Administration

09/10/2003

Acte sous seing privé

09/10/2003

Changement de Commissaire aux Comptes

09/10/2003

Modification du Conseil d'Administration

07/03/2003

Déclaration de conformité

07/03/2003

PV d'Assemblée

07/03/2003

Acte sous seing privé

07/03/2003

Immatriculation secondaire devient principale

07/03/2003

Transfert du Siège hors du ressort du Tribunal de Commerce

07/03/2003

Fusion

07/03/2003

Rapport des Commissaires ou du Gérant

07/03/2003

Statuts mis à jour

07/03/2003

PV du Conseil d'Administration

07/03/2003

Immatriculation suite à transfert

15/11/2002

Projet de Fusion

15/11/2002

Acte sous seing privé

10/10/2002

Déclaration de conformité

10/10/2002

PV du Conseil d'Administration

10/10/2002

Acte sous seing privé

10/10/2002

Apport Partiel

10/10/2002

Rapport des Commissaires ou du Gérant

10/10/2002

PV d'Assemblée

02/08/2002

Apport Partiel

02/08/2002

Acte sous seing privé

02/08/2002

Projet de Fusion

29/07/2002

Statuts mis à jour

29/07/2002

PV du Conseil d'Administration

29/07/2002

Changement de Président (PDG, PCA)

29/07/2002

PV d'Assemblée

29/07/2002

Nomination/démission des organes de gestion

29/07/2002

Acte sous seing privé

29/07/2002

Modification du Conseil d'Administration

03/06/2002

PV du Conseil d'Administration

03/06/2002

Acte sous seing privé

03/06/2002

Modification du Conseil d'Administration

03/06/2002

Nomination/démission des organes de gestion

14/03/2002

Augmentation de Capital

14/03/2002

PV du Conseil d'Administration

14/03/2002

Apport Partiel

14/03/2002

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

14/03/2002

Statuts mis à jour

14/03/2002

Acte modificatif

14/03/2002

PV d'Assemblée

14/03/2002

Acte sous seing privé

14/03/2002

Déclaration de conformité

06/12/2001

Acte sous seing privé

06/12/2001

Rapport des Commissaires ou du Gérant

08/11/2001

Acte sous seing privé

08/11/2001

Apport Partiel

26/09/2001

Requête et Ordonnance

14/06/2001

Acte sous seing privé

14/06/2001

Nomination/démission des organes de gestion

14/06/2001

PV du Conseil d'Administration

14/06/2001

Modification du Conseil d'Administration

26/10/2000

Acte sous seing privé

26/10/2000

PV d'Assemblée

26/10/2000

Changement de Commissaire aux Comptes

26/10/2000

Nomination/démission des organes de gestion

24/03/2000

Apport Partiel

24/03/2000

Acte modificatif

24/03/2000

Acte sous seing privé

10/03/2000

Acte sous seing privé

10/03/2000

Nomination/démission des organes de gestion

30/11/1999

Acte sous seing privé

30/11/1999

Apport Partiel

30/11/1999

Projet de Fusion

21/09/1999

Changement de Commissaire aux Comptes

21/09/1999

Conversion du Capital Social en Euros

21/09/1999

Statuts mis à jour

21/09/1999

Acte sous seing privé

21/09/1999

Nomination/démission des organes de gestion

21/09/1999

Augmentation de Capital

21/09/1999

PV d'Assemblée

19/07/1999

Déclaration de conformité

19/07/1999

Conversion du Capital Social en Euros

19/07/1999

Changement de Commissaire aux Comptes

19/07/1999

Fusion

19/07/1999

Statuts mis à jour

19/07/1999

Nomination/démission des organes de gestion

19/07/1999

PV d'Assemblée

07/06/1999

Rapport des Commissaires ou du Gérant

07/06/1999

Acte sous seing privé

10/05/1999

PV du Conseil d'Administration

10/05/1999

Acte sous seing privé

10/05/1999

Projet de Fusion

01/04/1999

Requête et Ordonnance

01/04/1999

Nomination/démission des organes de gestion

04/02/1999

Augmentation de Capital

04/02/1999

Rapport des Commissaires ou du Gérant

04/02/1999

Changement de Commissaire aux Comptes

04/02/1999

Statuts mis à jour

04/02/1999

PV d'Assemblée

04/02/1999

Nomination/démission des organes de gestion

04/02/1999

Acte sous seing privé

27/01/1999

Reconstitution de l'Actif Net

27/01/1999

Modification du Conseil d'Administration

27/01/1999

Changement de dénomination sociale

27/01/1999

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

27/01/1999

Nomination/démission des organes de gestion

27/01/1999

Modification de l'objet social

27/01/1999

Acte sous seing privé

27/01/1999

PV d'Assemblée

27/01/1999

Augmentation de Capital

12/12/1998

Rapport des Commissaires ou du Gérant

12/12/1998

Acte sous seing privé

11/12/1998

Acte sous seing privé

11/12/1998

Rapport des Commissaires ou du Gérant

23/11/1998

Statuts mis à jour

23/11/1998

Augmentation de Capital

23/11/1998

Modification de l'objet social

23/11/1998

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

23/11/1998

Changement de dénomination sociale

23/11/1998

Modification du Conseil d'Administration

23/11/1998

Acte sous seing privé

23/11/1998

Certificat de dépôt des fonds

23/11/1998

Nomination/démission des organes de gestion

23/11/1998

PV d'Assemblée

20/11/1998

Acte sous seing privé

20/11/1998

Modifications concernant le fonds de commerce

20/11/1998

Projet de Fusion

20/11/1998

Apport Partiel

09/11/1998

Acte sous seing privé

09/11/1998

PV du Conseil d'Administration

09/11/1998

Modification du Conseil d'Administration

09/11/1998

Changement de Président (PDG, PCA)

09/11/1998

Nomination/démission des organes de gestion

07/10/1998

Continuation malgré perte supérieure à la moitié du capital

07/10/1998

PV d'Assemblée

07/10/1998

Acte sous seing privé

05/09/1997

Réduction de Capital

05/09/1997

Augmentation de Capital

05/09/1997

Changement de Commissaire aux Comptes

05/09/1997

Statuts mis à jour

05/09/1997

PV d'Assemblée

05/09/1997

Nomination/démission des organes de gestion

05/09/1997

Acte sous seing privé

05/09/1997

Reconstitution de l'Actif Net

25/02/1997

Nomination/démission des organes de gestion

25/02/1997

Acte sous seing privé

22/09/1994

Acte modificatif

22/09/1994

PV d'Assemblée

22/09/1994

Continuation malgré perte supérieure à la moitié du capital

27/12/1993

Immatriculation secondaire devient principale

27/12/1993

Statuts mis à jour

27/12/1993

Acte modificatif

27/12/1993

PV du Conseil d'Administration

27/12/1993

Déclaration de conformité

01/12/1993

Acte modificatif

01/12/1993

Transfert du Siège hors du ressort du Tribunal de Commerce

01/12/1993

PV du Conseil d'Administration

 

 

 

 

 

 

directors

 

 

 

 

Name

M. VARIN PHILIPPE

 

Manager position

Président du conseil d'administration, Administrateur

Date of birth

08/08/1952

 

Place of birth

REIMS

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. MARTIN DENIS

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

19/11/1956

 

Place of birth

CHOLET

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. FAURY GUILLAUME

 

Manager position

Directeur général, Administrateur

Date of birth

22/02/1968

 

Place of birth

CHERBOURG

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. SAINT-GEOURS FRÉDÉRIC

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

20/04/1950

 

Place of birth

CLAMART

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. BRUNET CLAUDE

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

05/11/1957

 

Place of birth

MULHOUSE

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Directors

 

 

Vous pouvez consulter ici l'historique des dirigeants de l'entreprise.
Si vous souhaitez consulter l'historique d'un dirigeant, il vous suffit de cliquer sur le lien voir le détail pour y accéder.

 

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

 

Président du conseil d'administration

M DENIS MARTIN

 

 

Président du conseil d'administration

M DENIS MARTIN

 

 

Président du conseil d'administration

M PHILIPPE VARIN

 

 

Président du conseil d'administration

M JEAN-LUC VERGNE

 

 

Directeur général

M GUILLAUME FAURY

 

 

Directeur général

M DENIS MARTIN

 

 

Directeur général

M DENIS MARTIN

 

 

Directeur général

M JEAN-LUC VERGNE

 

 

Administrateur

M CLAUDE BRUNET

 

 

Administrateur

M YANN DELABRIERE

 

 

Administrateur

M GUILLAUME FAURY

 

 

Administrateur

M JEAN-MARTIN FOLZ

 

 

Administrateur

MME ISABEL MAREY SEMPER

 

 

Administrateur

M DENIS MARTIN

 

 

Administrateur

M GILLES MICHEL

 

 

Administrateur

M GREGOIRE OLIVIER

 

 

Administrateur

M GREGOIRE OLIVIER

 

 

Administrateur

MME ISABEL RAPPAPORT

 

 

Administrateur

MME SYLVIE RUCAR

 

 

Administrateur

M FRÉDÉRIC SAINT-GEOURS

 

 

Administrateur

M CHRISTIAN STREIFF

 

 

Administrateur

M ROLAND VARDANEGA

 

 

Administrateur

M PHILIPPE VARIN

 

 

 

Bottom of Form

 

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.51.62

UK Pound

1

Rs.81.94

Euro

1

Rs.67.65

 

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.