MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

10.12.2012

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

SANDOZ GMBH

 

 

Registered Office :

Biochemiestraße  10, A-6250 Kundl

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

31.12.2010

 

 

Date of Incorporation :

26.11.1965

 

 

Legal Form :

Limited Liability Company

 

 

Line of Business :

Manufacturer of pharmaceutical preparations

 

 

No. of Employees :

3117 Approximately

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

With Financials

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory

Payment Behaviour :

No Complaints

Litigation :

Clear

 

 

NOTES:

Any query related to this report can be made on e-mail: infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – June 30th, 2012

 

Country Name

Previous Rating

(31.03.2012)

Current Rating

(30.06.2012)

Austria

A2

A2

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 

 

austria - ECONOMIC OVERVIEW

 

Austria, with its well-developed market economy, skilled labor force, and high standard of living, is closely tied to other EU economies, especially Germany's. Its economy features a large service sector, a sound industrial sector, and a small, but highly developed agricultural sector. Following several years of solid foreign demand for Austrian exports and record employment growth, the international financial crisis of 2008 and subsequent global economic downturn led to a sharp but brief recession. Austrian GDP contracted 3.9% in 2009 but saw positive growth of about 2% in 2010 and 3% in 2011. Unemployment did not rise as steeply in Austria as elsewhere in Europe, partly because the government subsidized reduced working hour schemes to allow companies to retain employees. Stabilization measures, stimulus spending, and an income tax reform pushed the budget deficit to 4.7% in 2010 and 3.6% in 2011, from only about 1.3% in 2008. The international financial crisis of 2008 caused difficulties for Austria''s largest banks whose extensive operations in central, eastern, and southeastern Europe faced large losses. The government provided bank support - including in some instances, nationalization - to support aggregate demand and stabilize the banking system. Austria''s fiscal position compares favorably with other euro-zone countries, but it faces considerable external risks, such as Austrian banks'' continued high exposure to central and eastern Europe as well as political and economic uncertainties caused by the European sovereign debt crisis. In 2011 the government attempted to pass a constitutional amendment limiting public debt to 60% of GDP by 2020, but it was unable to obtain sufficient support in parliament and instead passed the measure as a simple law. In March 2012, the Austrian parliament approved an austerity budget that will bring public finances into balance by 2016.

 

Source : CIA

 

 


Basic company information

 

Company name:

Sandoz GmbH

Status:

active company

Locations:

Biochemiestraße  10, A-6250 Kundl

Phone:

0043 (5338) 200

Fax:

0043 (5338) 200 - 415

E-mail:

kundl.austria@sandoz.com

Internet:

http://www.sandoz.com

Internet:

http://www.sandoz.at

Activities:

Önace 21200 100% Manufacture of pharmaceutical preparations

 

Probability of Default (Basel II):

0,06%

Very low risk

comparison:

The Rating of this company is better than industry average.

Recommendation:

In respect to solvency reasons, there is nothing to say against an establishment of a business relationship.

 

Detail Assessment:

Payment

Payments are sometimes made using cash discounts or according to conditions.

 

Assessment

Financial situation is good.

 

Additional company information

 

Year of incorporation:

1965

 

Type of company:

Manufacturing

 

Legal form:

limited liability company since 1965-11-18

 

companies' house number:

FN 50587 v Innsbruck 1965-11-26

 

Activities:

 

 

VAT number:

ATU 32425809

 

ARA-number:

3462

 

number - Austrian National Bank:

4812

 

 

 

 

Export 

Country 

 

 

 

Export

world-wide

 

2012

 

 


Financial data

 

total turnover (total sales)

2011

EUR  1.480.566.195,12

(exact)

total turnover (total sales)

2010

EUR  1.428.954.760,56

(exact)

total turnover (total sales)

2009

EUR  1.315.733.905,62

(exact)

total turnover (total sales)

2008

EUR  1.263.133.197,81

(exact)

total turnover (total sales)

2007

EUR  1.300.456.268,63

(exact)

total employees

2012

3117

(approx.)

total investments

2010

EUR  55.920.042,80

(exact)

 

Extraxt from the Companies' House

 

firm (style):

   63      Sandoz GmbH

legal form:

    1      Gesellschaft mit beschränkter Haftung

registered office:

    1      politischer Gemeinde Kundl

business adress:

   15      Biochemiestraße 10
           6250 Kundl

capital:

   52      EUR 32.703.000

reference date annual accounts:

    1      31. Dezember

annual accounts:

  119      zum 31.12.2010 eingereicht am 24.09.2011

 

power of representation:

    1      Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer
           bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
           durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen
           vertreten.

other provisions:

proxy:

        CS   Dr. Elmar Dolejsi, geb. 12.10.1960
   26        vertritt seit 01.01.1998 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        CT   Sibylla Härtel, geb. 21.10.1962
   26        vertritt seit 01.01.1998 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        CW   Mag. Ingrid Schwarzenberger, geb. 20.03.1958
   26        vertritt seit 01.01.1998 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        EC   Mag. Hans-Peter Amon, geb. 19.01.1975
  100        vertritt seit 01.02.2009 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        EH   Drs. Gerhard Jan van der Meij, geb. 19.08.1968
  111        vertritt seit 01.06.2010 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        EK   Dipl.-Chem. Michael Kocher, geb. 12.04.1967
  122        vertritt seit 23.02.2012 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        EL   Dr. Nikolaus Kofler, geb. 05.12.1968
  124        vertritt seit 10.04.2012 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        EM   Dkfm. Michael Friedhofen, geb. 27.08.1967
  125        vertritt seit 12.06.2012 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen

supervisory board:

        CX   Helmut Pancheri, geb. 05.07.1961
   25        Mitglied
        DB   Mag. Christian Seiwald, geb. 25.09.1955
  112        Vorsitzender
        DF   Dr. Josef Egerbacher, geb. 20.11.1958
  123        Mitglied
        EA   Barbara Nerad, geb. 30.12.1962
   96        Mitglied
        EG   Christina Ackermann-Swistara, geb. 13.01.1965
  112        Stellvertreter des Vorsitzenden
        EJ   Hans-Helmut Michael Fabry, geb. 18.09.1956
  118        Mitglied

managing director:

        AU   Mag. Richard Kronbichler, geb. 05.11.1952
  115        vertritt seit 01.10.2010 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
        BD   Mag. Hubert Hirzinger, geb. 10.05.1957
   90        vertritt seit 01.06.2007 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
        DU   Ernst Meijnders, geb. 14.12.1956
   82        vertritt seit 01.06.2006 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen
        EE   Dr. Günter Stempfer, geb. 09.12.1965
  107        vertritt seit 01.01.2010 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
        EF   Dr. Peter Gasteiger, geb. 30.06.1972
  108        vertritt seit 12.02.2010 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen

shareholder:

        CM   Novartis Holding AG
   85        ......................    EUR 3.000
   85        .................................................    EUR 3.000
        DW   Novartis Austria GmbH
   85        .................    EUR 32.700.000
   85        ............................................    EUR 32.700.000
                          ------------------------------------------------------
                   Summen:        EUR 32.703.000             EUR 32.703.000

general table:

 Landesgericht Innsbruck
   1 datenersterfaßt am 23.09.1993              Geschäftsfall 915 Fr  3046/93 i
       Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
   8 eingetragen am 04.08.1994                  Geschäftsfall  19 Fr  3050/94 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.07.1994
  15 eingetragen am 31.07.1996                  Geschäftsfall  50 Fr  3421/96 b
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 10.07.1996
  18 eingetragen am 22.02.1997                  Geschäftsfall  50 Fr   480/97 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.01.1997
  22 eingetragen am 14.06.1997                  Geschäftsfall  50 Fr  3183/97 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.06.1997
  25 eingetragen am 24.01.1998                  Geschäftsfall  50 Fr   503/98 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.01.1998
  26 eingetragen am 27.01.1998                  Geschäftsfall  50 Fr   356/98 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.01.1998
  32 eingetragen am 24.11.1998                  Geschäftsfall  50 Fr  7458/98 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.09.1998
  40 eingetragen am 12.01.2000                  Geschäftsfall  50 Fr 15588/99 x
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.12.1999
  52 eingetragen am 05.10.2001                  Geschäftsfall  62 Fr  1934/01 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.09.2001
  59 eingetragen am 10.09.2002                  Geschäftsfall  62 Fr  1740/02 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 06.08.2002
  63 eingetragen am 01.05.2003                  Geschäftsfall  62 Fr   914/03 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.04.2003
  66 eingetragen am 01.10.2003                  Geschäftsfall  62 Fr  1753/03 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.09.2003
  79 eingetragen am 06.10.2005                  Geschäftsfall  62 Fr  1652/05 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.09.2005
  80 eingetragen am 11.02.2006                  Geschäftsfall  62 Fr  2534/05 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.12.2005
  82 eingetragen am 03.06.2006                  Geschäftsfall  62 Fr   809/06 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.05.2006
  85 eingetragen am 27.07.2006                  Geschäftsfall  62 Fr  1055/06 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.07.2006
  86 eingetragen am 31.08.2006                  Geschäftsfall  62 Fr  1258/06 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.08.2006
  87 eingetragen am 10.10.2006                  Geschäftsfall  62 Fr  1543/06 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.09.2006
  88 eingetragen am 09.02.2007                  Geschäftsfall  62 Fr   236/07 x
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.02.2007
  90 eingetragen am 06.06.2007                  Geschäftsfall  62 Fr   777/07 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.05.2007
  96 eingetragen am 01.08.2008                  Geschäftsfall  62 Fr  1428/08 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.07.2008
  98 eingetragen am 19.12.2008                  Geschäftsfall  62 Fr  3130/08 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.12.2008
 100 eingetragen am 19.02.2009                  Geschäftsfall  62 Fr   265/09 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.02.2009
 102 eingetragen am 29.10.2009                  Geschäftsfall  62 Fr  2202/09 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.09.2009
 103 eingetragen am 30.10.2009                  Geschäftsfall  62 Fr  2201/09 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.09.2009
 107 eingetragen am 09.01.2010                  Geschäftsfall  62 Fr  3962/09 v
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.12.2009
 108 eingetragen am 20.02.2010                  Geschäftsfall  62 Fr   342/10 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.02.2010
 110 eingetragen am 20.04.2010                  Geschäftsfall  62 Fr   782/10 a
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.04.2010
 111 eingetragen am 18.06.2010                  Geschäftsfall  62 Fr  1235/10 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.06.2010
 112 eingetragen am 29.07.2010                  Geschäftsfall  62 Fr  1543/10 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.07.2010
 114 eingetragen am 12.10.2010                  Geschäftsfall  62 Fr  2478/10 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.10.2010
 115 eingetragen am 13.11.2010                  Geschäftsfall  62 Fr  2741/10 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.10.2010
 118 eingetragen am 30.06.2011                  Geschäftsfall  62 Fr  2433/11 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.06.2011
 119 eingetragen am 08.10.2011                  Geschäftsfall  62 Fr  3711/11 t
       Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 24.09.2011
 122 eingetragen am 16.03.2012                  Geschäftsfall  60 Fr   618/12 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.03.2012
 123 eingetragen am 26.04.2012                  Geschäftsfall  60 Fr   963/12 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.04.2012
 124 eingetragen am 01.05.2012                  Geschäftsfall  60 Fr  1009/12 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.04.2012
 125 eingetragen am 11.07.2012                  Geschäftsfall  60 Fr  1826/12 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.07.2012

Real estate

 

Registration number of real estate  100  Cadastral register  83108  Kundl T  Number and date of entry  2460/2011  Status of  2012-06-12 

 

Part A - type of real estate  :

 

    GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
     32/1     GST-Fläche               877
              Bauf.(Gebäude)           240
              Gärten                   637  Biochemiestraße 4
     43/2     GST-Fläche              3405
              Bauf.(Gebäude)          1498
              Sonst(Betriebsf.)       1907  Biochemiestraße 11
                                            Biochemiestraße 5
                                            Biochemiestraße 9
    478/2   G Gärten            *     5848
    478/3   G Sonst(Straßen)    *      152
    481/1     Landw(Feld/Wiese)        344
    484     G GST-Fläche        *   108797
              Bauf.(Gebäude)         45898
              Sonst(Betriebsf.)      62899  Biochemiestraße 10
                                            Biochemiestraße 6
    GESAMTFLAECHE                   119423
    1  a Stand 1923 Miteigentumsrecht zu 1/3 Anteil an EZ 57
    2  a 354/1951 Miteigentumsrecht zu 1/2 Anteil an EZ 56
   11  a 2346/1989 2463/2009 Recht der Führung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen auf gst 478/1 478/4 29 in EZ 90030
   16  a 3065/1990 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von 2
           Leitungen auf Gst 1449 in EZ 90040
   17  a 3117/1990 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von 2
           Leitungen auf Gst 1428/1 in EZ 186
   18  a 3122/1990 2862/2000 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und
           Erhaltung von 2 Leitungen auf Gst 1448 in EZ 333
   19  a 676/1991 Recht der Fürhung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1459 in EZ 979
   20  a 790/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 462 in EZ 710
   21  a 791/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1430 in EZ 90023
   22  a 792/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1425 in EZ 90011
   23  a 793/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1431 in EZ 25
   24  a 794/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 466/2 1424 in EZ 90025
   25  a 795/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1426 in EZ 90027
   26  a 796/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1423 in EZ 90033
   27  a 797/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1428/1 in EZ 186
   28  a 798/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 452/2 in EZ 90031
   29  a 799/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1433 in EZ 90003
   30  a 800/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 463 in EZ 90028
   31  a 801/1991 2307/2003 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und
           Erhaltung von Leitungen und Bauwerken auf Gst 1427 in EZ 90066
   32  a 802/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1429 in EZ 982
   33  a 803/1991 2460/2011 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und
           Erhaltung von Leitungen und Bauwerken auf
           Gst 1458/1 in EZ 166
           Gst 1458/2 in EZ 996
   34  a 1088/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1432 in EZ 204
   36  a 2325/1996 Wasserschutzgebiet auf Gst 489 gem § 34 Abs 5 WRG
   40  a 528/2004 Kaufvertrag 2003-11-25 Zuschreibung Gst 481/1 aus EZ
           90043
   42  a 2463/2009 Kaufvertrag und Urkunde 2009-10-29 Zuschreibung Gst 478/2
           478/3 aus EZ 90030
   43  a 2463/2009 RECHT des Gehens und Fahrens auf Gst 478/4 in EZ
           90030
           für Gst 478/2 478/3 484
   44  a 2463/2009 RECHT der Unterlassung der Errichtung eines Mistlagers, einer
           Bioabfall-Anlage oder einer Fäulnisanlage sowie der Ausbringung von
           Gülle, Mist oder anderen geruchsintensiven Düngemitteln auf Gst
           477/1 478/1 1293 in EZ 90030 für Gst 478/2
   45  a 2463/2009 Kaufvertrag und Urkunde 2009-10-29 Zuschreibung Teilfläche(n)
           Gst 1294/1 aus EZ 56, Einbeziehung in Gst 478/2 484
   46  a 1053/2011 RECHT der unterirdischen Führung, Verlegung, Benützung und
           Erhaltung von Leitungen in Gst 1428/1 in EZ 186 für Gst 484
   47  a 1053/2011 RECHT der unterirdischen Führung, Verlegung, Benützung und
           Erhaltung von Leitungen in Gst 1428/1 in EZ 186 für Gst 484
   48  a gelöscht
 

Part B - ownership details  :

    1 ANTEIL: 1/1
      Sandoz GmbH
      ADR: Biochemiestraße 10, Kundl   6250
       a 561/1956 Urkunde und Übergabsvertrag 1956-08-13
           Eigentumsrecht
       b 1660/2003 Namensänderung
 

Part C - registered charges  :

    3  a 1589/1993
           DIENSTBARKEIT der Verlegung, des Betriebes, der Erhaltund
           und Erneuerung einer Leitung auf Gst 481/1 gem
           Dienstbarkeitsvertrag 1993-04-30 für
           Tiroler Ferngas Gesellschaft mbH
       b 528/2004 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ
           90043
    4  a 2463/2009
           DIENSTBARKEIT des Gehens und Fahrens auf Gst 478/2 478/3
           484 gemäß Punkt VI. Ziffer 1. Kauf- und
           Dienstbarkeitsvertrag 2009-10-29
           für Gst 477/1 478/1 478/4 1293 in EZ 90030
    5  a 672/2011
           DIENSTBARKEIT zur Führung, Benützung und Erhaltung von
           sechs unterirdischen Niederspannungsleitungen nach Maßgabe
           des Punktes II. des Dienstbarkeitsvertrages vom 15.03.2011
           in Gst 484 für Gst 59/1 in EZ 275
            Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS

 

Private data

 

 

Surname

 

 

Date of birth

 

 

Address

 

 

Executive positions

 

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Dr.  Peter Gasteiger

1972-06-30 

6250 Kundl Biochemiestraße 10

manager,

head of personnel

0

Mag.  Hubert Hirzinger

 

1957-05-10 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10 (p/A Sandoz GmbH)

manager

 

4

 

Mag.  Richard Kronbichler

1952-11-05 

 

6341 Ebbs Oberndorf 50 d

 

manager

 

0

 

Dipl-Ing.  Ernst Meijinders

1956-12-14 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10

 

manager

 

0

 

Dr.  Günter Stempfer

1965-12-09 

6250 Kundl Biochemiestraße 10

manager

0

Mag.  Hans Peter Amon

 

1975-01-19 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

joint signing clerk,

head of accounting

 

6

 

Dr.  Elmar Dolejsi

 

1960-10-12 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

joint signing clerk

 

2

 

Dkfm.  Michael Friedhofen

1967-08-27 

 

1235 Wien Carlbergergasse 44

 

joint signing clerk

 

1

 

Sibylla Härtel

 

1962-10-21 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Michael Kocher

 

1967-04-12 

 

6250 Kundl c/o Sandoz GmbH Biochemiestraß 10

joint signing clerk

 

0

 

Dr.  Nikolaus Kofler

 

1968-12-05 

 

6250 Kundl c/o Sandoz GmbH Biochemiestraß 10

joint signing clerk

 

0

 

Mag.  Ingrid Schwarzenberger

1958-03-20 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Dr.  Gerhard van-der-Meij

1968-08-19 

 

1020 Wien Stella Klein Löwweg 17

joint signing clerk

 

1

 

Mag.  Christian Seiwald

 

1952-10-02 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

chairman of the supervisory board

 

0

 

Christina Ackermann-Swistara

 

1965-01-13 

 

83607 Holzkirchen Industriestraße 25

deputy chairman of the supervisory board

 

0

 

Dr.  Josef Egerbacher

 

1958-11-20 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

member of the supervisory board

 

0

 

Hans Helmut Michael Fabry

 

1956-09-18 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

member of the supervisory board

 

0

 

Barbara Nerad

1962-12-30 

6250 Kundl Biochemiestraße 10

member of the supervisory board

0

Helmut Pancheri

 

1961-07-05 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

member of the supervisory board

 

0

 

Mag.  Max Leitinger

 

  

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

head of EDP

 

0

 

Josef Postl

 

  

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

technical director

 

0

 

 

Balance Sheet  (absolute) 

all amounts in EUR 

 

 

2010-12-31 

 

 

 

 

Franchises, patents, licences, trademarks and similar rights and advantages

11.161.597,64

 

 

 

 

Sum intangible assets

11.161.597,64

 

 

 

 

 

Land and leasehold rights with buildings thereon including building on land owned by third parties

231.878.775,51

 

 

 

 

Other operating and business equipment

11.540.618,76

 

 

 

 

Technical plants and machines

144.977.005,50

 

 

 

 

Advanced payments and constructions in progress

11.136.092,60

 

 

 

 

Sum tangible assets

399.532.492,37

 

 

 

 

 

Shares on related firms

35.906.602,18

 

 

 

 

Other shareholdings

1.751.901,77

 

 

 

 

Other financial assets, values and securities of fixed assets

15.801.791,72

 

 

 

 

Sum financial assets

53.460.295,67

 

 

 

 

 

Sum fixed assets

464.154.385,68

 

 

 

 

 

Raw-, auxiliary materials and supplies

47.031.295,59

 

 

 

 

Unfinished products

142.212.835,68

 

 

 

 

Finished products

35.055.293,35

 

 

 

 

Sum stock

224.299.424,62

 

 

 

 

 

Claims from delivered goods and performed services

139.876.504,41

 

 

 

 

Claims against companies with shareholding relationship

2.697,49

 

 

 

 

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

118.549.445,90

 

 

 

 

Other claims and assets

50.080.447,62

 

 

 

 

Sum claims

308.509.095,42

 

 

 

 

 

Cash on hand, cheques and bank deposits

2.830.952,99

 

 

 

 

Sum cash and bank

2.830.952,99

 

 

 

 

 

Sum current assets

535.639.473,03

 

 

 

 

 

Deferred charges

679.514,55

 

 

 

 

Sum deferred charges

679.514,55

 

 

 

 

Assets

1.000.473.373,26

 

 

 

 

 

Subscribed/declared capital

32.703.000,00

 

 

 

 

Legal reserves

3.270.300,00

 

 

 

 

Free reserves

59.656.425,77

 

 

 

 

Balance sheet profit/balance sheet loss

0,00

 

 

 

 

Sum equity capital

95.629.725,77

 

 

 

 

 

Valuation reserves and other reserves before taxes

26.285.782,64

 

 

 

 

Sum reserves before taxes

26.285.782,64

 

 

 

 

 

Investment contributions

974.649,08

 

 

 

 

Sum floor capital

974.649,08

 

 

 

 

 

Reservesfor severance pays

36.579.590,00

 

 

 

 

Reserves for pensions

49.921.495,00

 

 

 

 

Other reserves

60.617.485,09

 

 

 

 

Sum reserves

147.118.570,09

 

 

 

 

 

Liabilities against credit institutes

163.241.793,48

 

 

 

 

Received advanced payments for orders

1.550.741,67

 

 

 

 

Liabilities from delivered goods and performed services from the acceptance of drafts and emission of promissory notes

96.633.068,56

 

 

 

 

Liabilities against related firms

458.297.320,42

 

 

 

 

Liabilities against firm with shareholding relationship

544.405,62

 

 

 

 

Other liabilities

6.332.147,61

 

 

 

 

Other loans

3.198.800,00

 

 

 

 

Sum liabilities

729.798.277,36

 

 

 

 

 

Deferred income

666.368,32

 

 

 

 

Sum deferred income

666.368,32

 

 

 

 

Liabilities

1.000.473.373,26

 

 

 

 

 

Contingent liabilities

7.300.000,00

 

 

 

 

Balance sheet sum

1.000.473.373,26

 

 

 

 

 

P / L Account  (absolute) 

all amounts in EUR 

 

 

2010-12-31 

 

 

 

 

Gross sales 

1.428.954.760,56

 

 

 

 

Increase or decrease in finished and unfinished goods and in service claims 

-17.550.642,10

 

 

 

 

Other manufacturing costs capitalized 

3.437.239,77

 

 

 

 

Sum turnover or sum gross profit 

1.414.841.358,23

 

 

 

 

 

Profits from retirement of fixed assets, except financial assets 

18.381,47

 

 

 

 

Income from dissolution of reserves 

991.957,71

 

 

 

 

Other operating profits 

26.244.172,34

 

 

 

 

Other operating profits totally 

27.254.511,52

 

 

 

 

 

Costs for obtained services 

-27.070.927,98

 

 

 

 

Special account material costs 

-815.771.988,94

 

 

 

 

Costs for obtained services totally 

-842.842.916,92

 

 

 

 

 

Wages 

-23.973.590,68

 

 

 

 

Salaries 

-121.383.673,54

 

 

 

 

Costs for severance pays 

-4.596.841,86

 

 

 

 

Costs for old age pension 

-5.659.842,09

 

 

 

 

Legal fringe benefits and other payments depending on salaries 

-38.576.922,78

 

 

 

 

Other social fringe benefits 

-4.705.661,62

 

 

 

 

Personnel expenses totally 

-198.896.532,57

 

 

 

 

 

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation 

-72.317.631,47

 

 

 

 

Depreciation tangible assets / intangible assets totally 

-72.317.631,47

 

 

 

 

 

Different operating costs 

-212.876.409,41

 

 

 

 

Other taxes 

-342.380,43

 

 

 

 

Other operating costs totally 

-213.218.789,84

 

 

 

 

 

Operating result totally 

114.819.998,95

 

 

 

 

 

Profits from shareholdings 

15.327.530,15

 

 

 

 

Income from other securities and loans of financial assets 

19.542.959,85

 

 

 

 

Interest income, securties income and similar income 

256.956,10

 

 

 

 

Interest and similar disbursements 

-9.102.030,97

 

 

 

 

Financial expenses 

-1.172.937,40

 

 

 

 

Financial profits totally 

24.852.477,73

 

 

 

 

 

Results from usual business activity totally 

139.672.476,68

 

 

 

 

 

Taxes on income and profits 

-226.071,59

 

 

 

 

Taxes on income and profits totally 

-226.071,59

 

 

 

 

Annual surplus/annual deficit totally 

139.446.405,09

 

 

 

 

 

Dissolution reserves before taxes 

939.746,98

 

 

 

 

Dissolution capital reserves 

1.000.000,00

 

 

 

 

Transfer to reserves before taxes 

-6.451.931,38

 

 

 

 

Reserves movements totally 

-4.512.184,40

 

 

 

 

Annual profit/annual loss totally 

134.934.220,69

 

 

 

 

 

Transfer of profit/overcounting of losses from ontract of profit transfer 

-134.934.220,69

 

 

 

 

Transfer of profits totally 

-134.934.220,69

 

 

 

 

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account 

0,00

 

 

 

 

 


Key ratios

 

 

2010  

 

 

 

 

Cash flow II

  211.764.036,56

 

 

 

 

Debt amortisation period

  4,12

 

 

 

 

Bank indebtedness

  16,63

 

 

 

 

Equity capital share

  12,30

 

 

 

 

Social capital share

  8,64

 

 

 

 

Fixed assets coverage

  45,11

 

 

 

 

Net profit ratio

  9,87

 

 

 

 

Capital turnover

  1,41

 

 

 

 

Return on investment

  14,87

 

 

 

 

Cash flow in % of operating performance

  14,96

 

 

 

 

Cash flow I

  211.990.108,15

 

 

 

 

Gross productivity

  7,11

 

 

 

 

Net productivity

  2,87

 

 

 

 

Operating performance

  1.414.841.358,23

 

 

 

 

Inventories in % of operating performance

  15,85

 

 

 

 

Gross profit

  571.998.441,31

 

 

 

 

 

Locations

 

Type

Locations

Description

 

 

E-mail 

operational 

Dr. Hans Bachmannstraße  7, A-6250 Kundl, (umben.auf Biochemiestraße 10)

registered headquarters 

 

 

 

operational 

Biochemiestraße  10, A-6250 Kundl

registered office 

 

 

 

operational 

Biochemiestraße  10, A-6250 Kundl

registered headquarters, owned property 

 

 

kundl.austria@sandoz.com

operational 

Brunnerstraße  59, A-1230 Wien

branch office, rented premises 

 

 

 

operational 

Schaftenau Biochemiestraße  10, A-6330 Kufstein

factory, owned property 

 

 

 

former 

Wagramerstraße  19, A-1220 Wien

branch office 

 

 

 

 

related companies

 

Company name

 

Postal code

 

Stake in %

 

number

Companies House

 

Shares in this company are held by:

Novartis Austria GmbH

 

Stella Klein Löwweg  17, A-1020 Wien

99.99 % 2006-07-27

 

1.466.251

 

FN 274620 d

 

Novartis Holding AG

 

Lichtstraße  35, CH-4056 Basel

0.01 % 1997-02-22

 

876.742

 

 

 

This company holds 100% of the shares in:

Novartis Animal Health GmbH

 

Biochemiestraße  10, A-6250 Kundl

100 % 1996-12-03

 

865.445

 

FN 152616 k

 

HEXAL PHARMA GmbH

 

Stella Klein Löw Weg  17, A-1020 Wien

100 % 2005-12-17

 

397.728

 

FN 44896 z

 

Novartis Institutes for Biomedical Research GmbH

Brunnerstraße  59, A-1235 Wien

100 % 1993-08-13

 

23.273

 

FN 43251 f

 

 

This company holds 50% to 99% of the shares in:

Biozym GmbH

 

Biochemiestraße  10, A-6250 Kundl

51 % 1993-12-17

 

42.978

 

FN 47953 w

 

 

Affiliated companies and further participations:

Novartis Pharma GmbH

 

Stella Klein Löwweg  17, A-1020 Wien

 

 

3.272

 

FN 41622 i

 

Novartis Pharma GmbH

 

Stella Klein Löwweg  17, A-1020 Wien

 

 

3.272

 

FN 41622 i

 

CIBA Vision GmbH

 

Stella Klein Löwweg  17, A-1020 Wien

 

 

496.302

 

FN 82357 p

 

EBEWE Spezial-Pharma Holding GmbH

Stella Klein Löwweg  17, A-1020 Wien

 

 

1.684.054

 

FN 331193 z

 

Novartis Institutes for BioMedical Research GmbH & Co KG

Brunnerstraße  59, A-1235 Wien

2004-10-23

 

1.375.606

 

FN 253505 b

 

Austrian Center of Biopharmaceutical Technology

Muthgasse  18, A-1190 Wien

 

 

1.240.954

 

 

 

Bankers

 

Banker

Bank sort code

Type of banking connection

UniCredit Bank Austria AG, 1011 Wien

 

12000

 

main bank connection

 

 

Historical development

 

Year of incorporation:

1965

Date of registration:

1965-11-26

 

Change of company name:

From

To

Company name

   

  2003-05-02

Biochemie GmbH 

  2003-05-02

   

Sandoz GmbH 

 

Change in share capital:

From

To

Capital

   

  2001-10-05

ATS  450.000.000,00

  2001-10-05

   

EUR  32.703.000,00

 

Former executives:

From

To

Function

Name

  2003-10-01

  2007-06-15

joint signing clerk 

Mag.Dr. Otto Scheidl 

  2002-07-17

  2007-06-15

joint signing clerk 

Dr. Elisabeth Schneider Scherzer 

  1998-04-02

  2007-06-15

joint signing clerk 

Dr. Bruno Wallnöfer 

  2000-01-12

  2007-06-15

joint signing clerk 

Mag. Barbara Weigl Aman 

  2004-10-06

  2008-05-29

joint signing clerk 

Mag. Elgar Schnegg 

  2000-05-31

  2009-02-19

joint signing clerk 

Kurt Unterkircher 

  2000-01-12

  2010-01-09

joint signing clerk 

Dr. Josef Egerbacher 

  1993-09-23

  2010-03-19

joint signing clerk 

Mag. Friedrich Fuchs 

  2008-05-29

  2010-06-18

joint signing clerk 

Dipl-Betriebsw. Björn Komischke 

  2006-06-23

  2011-02-10

joint signing clerk 

Mag. Helmuth Hofer 

  2001-12-19

  2012-05-01

joint signing clerk 

Dr. Maria Schmalzl 

  1993-05-10

  1997-05-16

chairman of the supervisory board 

Dr. Urs Bärlocher 

  1997-05-16

  1998-04-18

chairman of the supervisory board 

Pierre Douaze 

  1998-04-18

  1999-10-12

chairman of the supervisory board 

Dr. Argeric Karabelas 

  1999-10-12

  2001-10-02

chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Oswald Sellemond 

  2001-10-02

  2002-05-30

chairman of the supervisory board 

Mag. Christian Seiwald 

  2002-05-30

  2005-04-19

chairman of the supervisory board 

Mag. Christian Seiwald 

  2006-06-23

  2007-06-15

joint signing clerk 

Lorraine Lynne Christina Perry 

  2005-04-19

  2009-02-19

chairman of the supervisory board 

Dr. Andreas Rummelt 

  2009-02-19

  2010-07-29

chairman of the supervisory board 

Dr. Horst Uwe Groh 

  1998-10-20

  1999-04-15

joint signing clerk 

Eric Gorka 

   

  1999-04-13

manager 

Dipl-Ing.Dr. Oswald Sellemond 

   

  2003-04-29

manager 

Werner Meßner 

  2003-04-29

  2004-09-01

manager 

Mag.Dr. Franz Stumpf 

  1993-09-23

  2000-09-13

joint signing clerk 

Dr. Otto Streichsbier 

  2003-04-29

  2005-07-28

manager 

Mag. Hubert Hirzinger 

  2003-04-29

  2005-07-28

manager 

Dr. Patrick Vink 

   

  2006-06-03

manager 

Dipl-Ing.Dr. Heinrich Scherfler 

  2004-09-01

  2007-06-06

manager 

Mag. Johannes Schwertner 

  2003-04-29

  2008-02-21

manager 

Mag. Bernhard Sigl 

  2008-02-21

  2010-02-20

manager 

Dipl-Ing. Bianca Stöhr 

  2010-01-09

  2012-02-03

manager 

Mag. Hannes Teißl 

  1993-09-23

  1999-02-16

joint signing clerk 

Dr. Paul Inama Sternegg 

   

  1997-05-16

member of the supervisory board 

Dr. Raymund Breu 

   

  1998-04-18

member of the supervisory board 

Daniel Wagniere 

  1998-04-18

  1999-08-06

member of the supervisory board 

Dr. Hans Kindler 

  1997-05-16

  1999-08-06

member of the supervisory board 

Dr. Erwin Schillinger 

  1999-08-06

  1999-10-12

member of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Oswald Sellemond 

  1999-08-06

  2001-10-02

member of the supervisory board 

Mag. Christian Seiwald 

  2001-10-02

  2002-05-30

member of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Oswald Sellemond 

  2002-03-12

  2005-07-14

member of the supervisory board 

Dr. Urs Bärlocher 

  2005-07-14

  2007-03-16

member of the supervisory board 

Kevin Plummer 

  2002-05-30

  2007-06-28

member of the supervisory board 

Dr. Erwin Schillinger 

  1999-08-06

  2008-08-01

member of the supervisory board 

Hermann Egger 

  2007-06-28

  2008-08-01

member of the supervisory board 

Dr. Peter Jager 

  2008-08-01

  2009-03-11

member of the supervisory board 

Knut Mager 

  2009-03-11

  2010-04-20

member of the supervisory board 

Dr. Andreas Rummelt 

  2010-04-20

  2010-07-29

member of the supervisory board 

Christina Ackermann Swistara 

  2010-07-29

  2010-09-22

member of the supervisory board 

Dr. Horst Uwe Groh 

  2007-03-16

  2011-06-30

member of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Heinrich Scherfler 

  2010-09-22

  2012-03-09

member of the supervisory board 

Dr. Gerhard Schaefer 

   

  1998-01-24

employee's representative on the supervisory board 

Johann Auer 

   

  1999-08-06

employee's representative on the supervisory board 

Helmuth Stubenvoll 

  2005-04-19

  2010-07-29

deputy chairman of the supervisory board 

Mag. Christian Seiwald 

  1995-06-21

  1997-05-16

deputy chairman of the supervisory board 

Dr. Daniel Vasella 

  1999-10-12

  2000-11-30

deputy chairman of the supervisory board 

Dr. Argeric Karabelas 

  1997-05-16

  2002-03-12

deputy chairman of the supervisory board 

Dr. Jörg Reinhardt 

  2000-11-30

  2002-05-30

deputy chairman of the supervisory board 

Thomas Ebeling 

  2002-05-30

  2005-04-19

deputy chairman of the supervisory board 

Paul Choffat 

  1993-09-23

  2000-10-11

joint signing clerk 

Mag. Hubert Hirzinger 

  1993-09-23

  2001-03-13

joint signing clerk 

Dr. Eberhard Pirich 

  1993-09-23

  2001-10-02

joint signing clerk 

Dr. Walter Killiches 

  1998-01-27

  2002-04-25

joint signing clerk 

Mag. Vinzenz Plörer 

  1997-11-07

  2002-10-01

joint signing clerk 

Dr. Helmut Deimel 

  1999-04-15

  2003-03-19

joint signing clerk 

Mag. Gerhard Hörl 

  1993-09-23

  2003-04-29

joint signing clerk 

Mag. Bernhard Sigl 

  1999-08-17

  2003-04-29

joint signing clerk 

Mag.Dr. Franz Stumpf 

  2001-10-02

  2003-12-18

joint signing clerk 

Dr. Johannes Gerstenbauer 

  1998-01-27

  2003-12-18

joint signing clerk 

Mag. Gottfried Rieser 

  2003-05-06

  2004-11-03

joint signing clerk 

Mag. Siegfried Johann Leitner 

  1998-02-02

  2005-03-08

joint signing clerk 

Peter Haselböck 

  1993-09-23

  2005-03-08

joint signing clerk 

Dr. Ernst Leitner 

  1998-01-27

  2006-05-16

joint signing clerk 

Dr. Santiago Alonso Ciriza 

  2004-08-10

  2006-05-16

joint signing clerk 

Knut Ulrich Mager 

  2000-03-14

  2006-05-16

joint signing clerk 

Hans Schaller 

  1993-09-23

  2007-02-09

joint signing clerk 

Mag. Rupert Labner 

 

Former shareholders:

From

To

Function

Name

   

  1997-02-22

partner 

Sandoz Holding AG 

  1997-02-22

  2000-08-26

partner 

Novartis AG 

 

Former shareholdings:

From

To

Name

  1996-05-08

  1998-11-24

Novartis Handelsgesellschaft m.b.H. 

  2004-09-16

  2004-10-23

Novartis Forschungsinstitut GmbH 

  2005-01-27

  2005-10-06

Grandis Handel mit pharmazeutischen Produkten Gesellschaft mbH 

  2006-01-24

  2007-11-10

Nabriva Therapeutics AG 

 

Mergers:

Date

Function

Name

  2006-12-14

merged with 

Sandoz GmbH 

  2005-10-06

merged with 

Grandis Handel mit pharmazeutischen Produkten Gesellschaft mbH 

  2000-11-24

merged with 

Novartis Handelsgesellschaft m.b.H. 

 

 


FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.54.20

UK Pound

1

Rs.86.99

Euro

1

Rs.70.22

 

INFORMATION DETAILS

 

Report Prepared by :

SDA

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

----

NB

New Business

----

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.