MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

12.06.2012

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Correct Name :

TAPIS SAINT MACLOU

 

 

Registered Office :

330 Rue Carnot, Bp 149, 59391 Wattrelos Cedex

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2010

 

 

Date of Incorporation :

January 1970

 

 

Com. Reg. No.:

RCS Roubaix-Tourcoing 7 470 500 943

 

 

Legal Form :

Public limited company with board of directors

 

 

Line of Business :

Retail sale of carpets, rugs and wall coverings and floor coverings in specialized stores

 

 

No. of Employees :

1 000 to 1 999 employees

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Good

Payment Behaviour :

No Complaints

Litigation :

Clear

 

NOTES:

Any query related to this report can be made on e-mail: infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31st, 2012

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2011)

Current Rating

(31.03.2012)

France

A2

A2

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D


REGISTERED NAME & COMPANY SUMMARY

 

Name

TAPIS SAINT MACLOU

SIRET

470 500 943 00019

 

 

Company Summary

 

Acronym

TSM

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity (APE)

Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (4753Z)

 

(Retail sale of carpets, rugs and wall coverings and floor coverings in specialized stores (4753Z))

Legal form

Public limited company with board of directors

 

 

Phone

03 20 81 56 43

RCS Registration

RCS Roubaix-Tourcoing 7 470 500 943

 

 

Fax

 

Share capital

1,588,416 Euros

 

 

Address

TAPIS SAINT MACLOU
TSM
330 RUE CARNOT
BP 149
59391 WATTRELOS CEDEX

Incorporated Date

10/1970

 

 

Nationality

France

Status

Economically active

 

 

 

Company details

 

 

 

Activity (APE)

Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (4753Z)

 

RCS Registration

RCS Roubaix-Tourcoing 7 470 500 943

Share capital

1,588,416 Euros

 

Registration Court

Roubaix-Tourcoing (59)

Legal form

Public limited company with board of directors

 

Court Registry Number

19 7 0B000

EU VAT Number

FR66470500943

 

Incorporation Date

10/1970

Formation Date

01/1970

 

Deregistration Date

 

Last account Date

31/12/2010

 

Nationality

France

 

 

DIRECTORS/MANAGEMENT

 

Previous Directors

 

Vous pouvez consulter ici l'historique des dirigeants de l'entreprise.
Si vous souhaitez consulter l'historique d'un dirigeant, il vous suffit de cliquer sur le lien voir le détail pour y accéder.

 

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

 

Président du conseil d'administration

M CHRISTOPHE RIBAULT

 

 

Président du conseil d'administration

M CHRISTOPHE RIBAULT

 

 

Président du conseil d'administration

M CHRISTOPHE RIBAULT

 

 

Directeur général

M PHILIPPE BLANC

 

 

Directeur général

M PHILIPPE BLANC

 

 

Directeur général

M VINCENT FAUVET

 

 

Directeur général

M VINCENT FAUVET

 

 

Directeur général

M VINCENT FAUVET

 

 

Vice-président

M YVON JOLIVET

 

 

Vice-président

M YVON JOLIVET

 

 

Administrateur

Mme FANNY BOUCHEZ

 

 

Administrateur

Mme FANNY BOUCHEZ

 

 

Administrateur

CIMOFLU

 

 

Administrateur

CIMOFLU

 

 

Administrateur

CIMOFLU

 

 

Administrateur

M MARC DELOZANNE

 

 

Administrateur

M MARC DELOZANNE

 

 

Administrateur

M YVON JOLIVET

 

 

Administrateur

M YVON JOLIVET

 

 

Administrateur

MME FANNY MULLIEZ

 

 

Administrateur

M CHRISTOPHE RIBAULT

 

 

Administrateur

M CHRISTOPHE RIBAULT

 

 

Administrateur

M CHRISTOPHE RIBAULT

 

 

Administrateur

SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL

 

 

Administrateur

SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL

 

 

Administrateur

SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL

 

 

Administrateur

SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL

 

 

Administrateur

T.S.2.M.

 

 

Administrateur

T.S.2.M.

 

 

Administrateur

TAPIMA

 

 

Administrateur

TAPIMA

 

 

Administrateur

TAPIMA

 

 

Administrateur

TAPIMA

 

 

Administrateur

M GUY THOMAS

 

 

Administrateur

M GUY THOMAS

 

 

Administrateur

M GUY THOMAS

 

 

Administrateur

TS2M

 

 

Président du directoire

M VINCENT FAUVET

 

 

Président du conseil de surveillance

M GONZAGUE MULLIEZ

 

 

Président du conseil de surveillance

M CHRISTOPHE RIBAULT

 

 

 

 

NEGATIVE INFORMATION

 

judgements

Collective procedures

No judgment information for the company

 

 

SHARE & SHARE CAPITAL INFORMATION

 

Shareholder(s)

 

Name

T.S.2.M.

 

Name of representative

 

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

 

 

Place of birth

 

 

 

 

Type of manager

Moral person

Name at birth of manager

 

 

 

 

Name

TAPIMA

 

Name of representative

 

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

 

 

Place of birth

 

 

 

 

Type of manager

Moral person

Name at birth of manager

 

 

 

 

Name

M. RIBAULT CHRISTOPHE

 

Manager position

Président du conseil d'administration, Administrateur

Date of birth

26/12/1958

 

Place of birth

TOURCOING (59200)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

Name

M. JOLIVET YVON

 

Manager position

Vice-président, Administrateur

Date of birth

17/02/1951

 

Place of birth

PETOSSE (85570)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

Name

M. BLANC PHILIPPE

 

Manager position

Directeur général

Date of birth

15/10/1958

 

Place of birth

LYON (69006)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

Name

M. THOMAS GUY

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

09/01/1952

 

Place of birth

LAMBERSART (59130)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

Name

M. DELOZANNE MARC

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

16/11/1962

 

Place of birth

PARIS (75013)

 

 

 

Type of manager

Individual

Name at birth of manager

 

 

 

 

 

PAYMENT INFORMATION

 

Na

 

 

GROUP STRUCTURE & AFFILIATED COMPANIES

 

Ultimate Parent

1 ultimate parent company for this company
>  SCA VALMA  - Fonds de placement et entités financières similaires (6430Z)  in ROUBAIX  (59100)

Group data

Ultimate parent company

SCA VALMA

Direct parent

TAPIMA - 81 %

Group – Number of companies

221

Linkages – Number of companies

7

 


 

 

Raison sociale

 

SIREN

Parts

Score

Limite

Derniers
comptes
publiés

SCA VALMA

 

351813233

-

93

250 000 €

-

SURAUMARCHE

 

519087837

100%

90

250 000 €

-

AUMARCHE

 

439529512

100%

82

250 000 €

31/12/2009

GROUPE AUCHAN

 

476180625

57.12%

100

2 000 000 €

31/12/2010

RT MART INTERNATIONAL

 

-

61%

-

-

-

AUCHAN FINANCES

 

420017006

100%

100

250 000 €

31/12/2010

SAMOS

 

480076272

100%

98

250 000 €

31/12/2010

IMMOCHAN

 

428803746

100%

96

230 000 €

31/12/2010

IMMOCHAN FRANCE

 

969201532

100%

100

2 000 000 €

31/12/2010

SERVICIMMOG

 

410777643

50%

55

16 000 €

-

SCI IMMOCHAMP

 

431816289

93.75%

95

-

-

DES FRAIS FONDS

 

442686952

Min de blocage

95

-

-

CITANIA

 

480076298

100%

19

0 €

31/12/2010

MAS COSTE

 

439099748

Min de blocage

90

500 €

31/12/2010

IMMOPROXI

 

384812061

100%

100

7 100 €

31/12/2010

AUX NOUVELLES BOUTIQUES

 

410410468

100%

100

135 000 €

31/12/2010

SNC LA GARENNE

 

479326316

50%

33

2 000 €

-

SCI BAGGERSEE OUEST

 

778843425

46.63%

95

-

-

STRATANIM

 

480076215

100%

97

5 300 €

31/12/2010

MARRELIMMO

 

422904409

99.99%

49

150 000 €

31/12/2010

GALLERIE COMMERCIALI ITALIA SPA

 

-

100%

-

-

-

IMMOCHAN ESPANA

 

-

100%

-

-

-

IMMOCHAN MAGYARORSZAG

 

-

100%

-

-

-

IMMOCHAN ALAPOK

 

-

95%

-

-

-

ALINEA

 

345197552

85.69%

87

2 000 000 €

31/12/2010

SAFIPAR

 

444409551

100%

92

1 530 000 €

31/12/2010

SOCIETE DE DISTRIBUTION REGI...

 

487702961

100%

99

2 600 €

31/12/2010

SOCIETE DE DISTRIBUTION COMM...

 

487702896

100%

19

0 €

31/12/2010

SARCELDIS

 

407755230

100%

99

350 000 €

31/12/2010

SOCIETA ITALIANA DISTRIBUZIONE MODERNA

 

-

99%

-

-

-

AUCHAN ITALIA

 

-

99%

-

-

-

SMA

 

-

97%

-

-

-

AUCHANHYPER

 

410408959

100%

100

1 700 000 €

31/12/2010

ORGANISATION INTRA-GROUPE DE...

 

421982745

99.89%

100

2 000 000 €

31/12/2010

ALCAMPO

 

-

100%

-

-

-

ZENALCO

 

-

100%

-

-

-

ZENOR ESPAGNE

 

-

95%

-

-

-

REDARPA

 

-

95%

-

-

-

AUCHAN HOLDING USA

 

-

100%

-

-

-

 

AUCHAN USA

 

-

100%

-

-

-

SOFINANCE

 

417572955

100%

100

4 300 €

31/12/2010

AUCHAN LUXEMBOURG

 

B45515

100%

66

300 000 €

31/12/2010

GALERIE DE KIRCHBERG

 

-

96%

-

-

-

AUCHAN INTERNATIONAL S.A.

 

B73616

100%

No Rating

-

-

AUCHAN MAGYARDRSZÀG

 

-

100%

-

-

-

SOC DEVELOPPEMENT FINANCEMEN...

 

381120179

100%

99

250 000 €

31/12/2010

AUCHAN FRANCE

 

410409460

100%

96

250 000 €

31/12/2010

SERVICIMMOG

 

410777643

50%

55

16 000 €

-

AUCHAN CARBURANT

 

379548001

100%

100

2 000 000 €

31/12/2010

PETROVEX

 

317007342

100%

100

2 000 000 €

31/12/2010

GIE AUCHAN INTERNATIONAL T...

 

422332312

100%

47

14 000 €

31/12/2005

EURAUCHAN

 

410410260

78.30%

100

1 770 000 €

31/12/2010

DISTICKET

 

422628289

66%

83

250 000 €

30/09/2009

TICKETNET

 

412888133

34%

19

0 €

30/09/2005

AUCHAN ASSURANCES

 

422231100

99.99%

99

30 000 €

31/12/2010

SOC POUR COMMERCIALISATION...

 

312668692

100%

100

320 000 €

31/12/2010

TOMBLAINE DISTRIBUTION

 

332640770

98.97%

100

250 000 €

31/12/2009

CENTRALE DE SERVICES AUCHA...

 

340143668

79.31%

56

16 000 €

-

MONDIAL TRAVEL

 

400669768

100%

19

0 €

31/12/2010

SOGEP

 

381491323

65.79%

95

-

-

AUCHAN TELECOM

 

480067719

100%

19

0 €

31/12/2010

SOMARVRAC

 

481977460

Min de blocage

97

410 000 €

31/12/2010

AU COMMERCE RENNAIS

 

504697228

100%

98

500 €

31/12/2010

MIROIR DU SOLEIL

 

507763712

100%

96

25 000 €

31/12/2010

AUCHAN SERVICES A DOMICILE

 

498062702

100%

99

2 800 €

31/12/2010

BDL

 

-

100%

-

-

-

AUCHAN PORTUGAL

 

-

100%

-

-

-

ISENBOURG

 

-

100%

-

-

-

ALVERCA HIPERMERCADOS

 

-

100%

-

-

-

SINTRAPARQUE

 

-

100%

-

-

-

MENDES E.COSTA

 

-

100%

-

-

-

MULTICENCO

 

-

100%

-

-

-

OMNIA CONSTRUTORA

 

-

100%

-

-

-

PAO DE AÇUCAR

 

-

100%

-

-

-

COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCARDOS

 

-

100%

-

-

-

AUCHAN HIPERMERCADO PORTUGAL

 

-

100%

-

-

-

FLOORAGEST IMOBILIARIA

 

-

100%

-

-

-

PLANCO

 

-

100%

-

-

-

RESIMOVEL

 

-

100%

-

-

-

 

EMPREENDIMENTOS DO CARNAVIAL

 

-

100%

-

-

-

AUCHAN POLSKA

 

-

100%

-

-

-

AUCHAN ESPANA

 

-

100%

-

-

-

SUN ART RETAIL

 

-

50%

-

-

-

SCHIEVER POLSKA

 

-

50%

-

-

-

SOGEPAR

 

433713963

100%

100

2 150 €

31/12/2010

AUCHAN RUSSIE

 

-

100%

-

-

-

AUCHAN NEDVIZHIMOST

 

-

100%

-

-

-

RUSSKIE PRODUKTY TRADING COMPLEX

 

-

100%

-

-

-

STOYINVEST ALPHA

 

-

100%

-

-

-

STROYINVEST BETA

 

-

100%

-

-

-

DRAYCOTT

 

-

100%

-

-

-

CHRONODRIVE

 

433513892

90%

19

0 €

31/12/2004

AUCHAN CHINE HONG KONG

 

-

67%

-

-

-

SOPARALINEA

 

345127583

82.58%

100

250 000 €

31/12/2010

BANQUE ACCORD

 

546380197

98%

85

250 000 €

-

ONEY IFIC

 

-

100%

-

-

-

ACCORD FINANCE

 

-

60%

-

-

-

ACCORD ITALIA

 

-

100%

-

-

-

ONEY FINANCE

 

-

100%

-

-

-

ACCORD MAGYARORSZÀG

 

-

100%

-

-

-

 

ACCORDFIN

 

-

51%

-

-

-

ACCORD BUSINESS CONSULTING COMPANY

 

-

100%

-

-

-

GEFIRUS

 

483303228

60%

100

210 000 €

31/12/2010

BA FINANS

 

-

100%

-

-

-

ONEY COURTAGE

 

503428989

100%

88

18 000 €

31/12/2010

ONEY CESSATION LIMITED

 

IE452426

100%

No Rating

-

31/12/2010

ONEY MVL LIMITED

 

IE452472

100%

No Rating

-

31/12/2010

ONEY UKRAINE

 

-

100%

-

-

-

ONEY INVESTMENT

 

521009357

100%

86

4 600 €

-

ARONDE

 

-

100%

-

-

-

INTERNATIONAL SUPERMARKET STOR...

 

674801329

97%

99

480 000 €

31/12/2010

FREMARC

 

342281409

100%

100

2 000 000 €

31/12/2010

SODIPAR

 

444410773

100%

19

0 €

31/12/2010

ISMS POLSKA

 

-

60%

-

-

-

ELEA

 

-

60%

-

-

-

ATAC

 

410409015

99%

100

2 000 000 €

31/12/2010

SA CHOLDIS

 

383272226

100%

94

500 €

31/12/2010

COUSTE

 

439974551

100%

19

0 €

31/12/2010

SOMADIS SOC MAGDUNOISE D...

 

442726923

100%

99

220 000 €

31/12/2010

SODIMA

 

433701554

100%

96

850 €

31/12/2010

PASCAL

 

439974502

100%

49

5 100 €

31/12/2010

CACHAN DISTRIBUTION

 

339544314

93%

59

8 900 €

31/12/2010

PAREA

 

481020022

100%

100

2 000 000 €

31/12/2010

                                                                                                          

SABECO SA

 

-

97%

-

-

-

S.I. LACANAU

 

-

100%

-

-

-

SABEKO BANAKETA

 

-

100%

-

-

-

SERCO ASTOR

 

-

100%

-

-

-

EL ASTORGANO

 

-

100%

-

-

-

CESARAUGUSTA

 

-

100%

-

-

-

SABEKO EUSKADI

 

-

100%

-

-

-

SUPER LAUKO

 

-

100%

-

-

-

AUCHAN COORDINATION SERVICES S...

 

878922641

100%

75

28 000 000 €

31/12/2010

LITTLE EXTRA

 

480089853

100%

19

0 €

31/12/2010

ORGANISATION INTERNATIONALE DES ACHATS

 

-

100%

-

-

-

ATAK

 

-

97%

-

-

-

FCAU

 

-

100%

-

-

-

AUCHAN-E-COMMERCE INTERNATIONA...

 

480075431

100%

94

250 000 €

31/12/2010

GROSBILL

 

420437311

100%

95

240 000 €

31/12/2010

AUCHAN E-COMMERCE FRANCE

 

413176033

100%

19

0 €

31/12/2010

SOPACCORD

 

487947863

65.87%

95

-

-

SOPARATAC

 

429389687

34.97%

95

-

-

SURBOLEM

 

519087928

Majoritaire

88

250 000 €

-

BOLEM

 

439529140

66%

59

250 000 €

31/12/2009

HIGH TECH MULTICANAL GROUP

 

478613169

94%

27

16 000 €

31/12/2009

BOULANGER

 

347384570

100%

99

250 000 €

31/12/2009

CLIXITY

 

482339645

100%

92

250 000 €

31/12/2008

WEBDISTRIB

 

443041926

100%

19

0 €

31/12/2007

STOCK MENAGER SERVICE

 

451220677

100%

56

250 000 €

31/12/2008

CAP BOULANGER HOLDING

 

349210237

100%

19

0 €

31/12/2010

CAP BOULANGER

 

392327607

100%

19

0 €

31/12/2010

LOKEO

 

509637161

100%

68

250 000 €

-

VENDIDO

 

494707482

Majoritaire

19

0 €

31/12/2009

SOPAR-HTM

 

422194811

Majoritaire

100

250 000 €

31/12/2010

SURHOLYMPIADES

 

519088231

Majoritaire

62

250 000 €

31/12/2009

DECATHLON

 

306138900

43%

100

2 000 000 €

31/12/2010

COROT

 

488981531

Majoritaire

99

250 000 €

31/12/2008

DEVELOP MOBILIER INDUSTRIEL

 

442112371

Min de blocage

95

-

-

SOC CIVILE DE LA PORTE DE LYON

 

783881907

Min de blocage

95

-

-

SURFIPAR

 

519088124

Majoritaire

55

250 000 €

31/12/2009

SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATIO...

 

313455610

Majoritaire

93

250 000 €

31/12/2009

TROIS SUISSES INTERNATIONAL

 

477180467

44%

46

1 310 000 €

31/12/2010

BEAUTE CREATEURS PARTICIPATION...

 

393258298

91.63%

99

145 000 €

31/12/2010

YI MEI JA SHANGHAI TRADING

 

-

50%

-

-

-

COMMERCE BTOB

 

398259853

100%

100

250 000 €

31/12/2010

JM. BRUNEAU

 

343958138

99.99%

100

2 000 000 €

31/12/2010

ORGA SYSTEM

 

308549310

99.99%

99

97 500 €

31/12/2010

OTTO OFFICE FRANCE

 

404451494

100%

19

0 €

31/12/2010

JM BRUNEAU ESPANA

 

-

100%

-

-

-

 

DIREXI

 

351746094

99.99%

100

660 000 €

31/12/2010

COMMERCE BTOC

 

408536928

Majoritaire

100

2 000 000 €

31/12/2010

EQUIPAR

 

378176473

99.99%

100

250 000 €

31/12/2010

XPL

 

332211739

99.98%

19

0 €

31/12/2010

CIE INTERNATIONALE VENTE A DIS...

 

321008013

100%

100

2 000 000 €

31/12/2010

ZABOR SARL

 

-

100%

-

-

-

BECQUET

 

466500683

51%

99

1 500 000 €

31/12/2010

MONABANQ

 

341792448

49%

36

50 000 €

-

CONTENTIA FRANCE

 

348967332

100%

82

250 000 €

31/12/2010

ID3SI

 

434279600

99.94%

40

0 €

31/12/2010

MARTINTER

 

487602740

100%

100

250 000 €

31/12/2010

COFIDIS PARTICIPATIONS

 

378176291

44%

36

50 000 €

31/12/2003

CREATIS

 

419446034

100%

81

250 000 €

-

BANCO ARGENTINA

 

-

66%

-

-

-

COFIDIS

 

325307106

100%

97

250 000 €

-

COFIDIS BELGIQUE

 

-

100%

-

-

-

COFIDIS ESPAGNE

 

-

100%

-

-

-

 

 

 SOC DE CREDIT A LA CONSO...

 

341888998

100%

99

250 000 €

-

COFIDIS CESKA

 

-

100%

-

-

-

COFIDIS VECOFIN ITALIE

 

-

100%

-

-

-

COFIDIS SLOVAQUIE

 

-

100%

-

-

-

COFIDIS ROUMANIE

 

-

100%

-

-

-

MONABANQ

 

341792448

51%

36

50 000 €

-

ARIANTA

 

519190136

100%

19

0 €

31/12/2010

CAVABANQUE

 

339019275

99.99%

92

1 200 €

31/12/2003

SODEREC

 

344364666

100%

95

-

-

HAPPY CHIC

 

509508628

100%

95

50 000 €

31/12/2010

BRICE

 

312560584

100%

No Rating

-

31/12/2010

DISTRIBUTION TEXTILE HENNUYE...

 

477722228

100%

No Rating

-

31/12/2010

SCI BONNEUIL

 

348867615

100%

95

-

-

JULES INTERNATIONAL

 

480057736

99%

No Rating

-

31/12/2010

JULES

 

305154262

94%

100

2 000 000 €

31/12/2010

JULES SPAIN

 

-

100%

-

-

-

JULES SRL

 

-

100%

-

-

-

SODISTRI

 

344124177

100%

100

65 000 €

31/12/2009

GARGANO

 

494308356

Min de blocage

95

-

-

SURLEBRICO

 

519088348

Min de blocage

45

250 000 €

-

SURHOLKIA

 

519088199

Majoritaire

88

250 000 €

-

HOLKIA

 

508941739

Min de blocage

45

250 000 €

31/12/2009

SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION LOUIS MULLIEZ L...

 

-

Majoritaire

-

-

-

SURMUFIL

 

519088512

Min de blocage

9

0 €

31/12/2009

SURESTAG

 

519088033

Min de blocage

45

250 000 €

-

PIMINVEST

 

353526551

Min de blocage

95

-

-

SOPARTHLON B

 

351819248

Min de blocage

99

250 000 €

31/12/2008

SURTAPIMA

 

519088611

Majoritaire

55

250 000 €

31/12/2009

TAPIMA

 

439528910

Majoritaire

70

250 000 €

31/12/2009

TAPIS SAINT MACLOU

 

470500943

81%

86

2 000 000 €

31/12/2010

MONDIAL MOQUETTE

 

328412440

100%

19

0 €

31/12/2010

MONDIAL SERVICES

 

383929783

100%

20

1 350 €

31/12/2010

SAINT MACLOU

 

-

100%

-

-

-

TAPIS INVESTISSEMENT

 

326464997

57.85%

95

-

-

FILUNOR SA

 

-

Min de blocage

-

-

-

HAPED BV

 

-

Min de blocage

-

-

-

 

Number of countries

4

 

 

 

 

SIREN

Dernier bilan

Score

Limite

CA

AUCHAN II HOLDING UK LTD

 

 

06277184

31/12/2010

94

2 250 000 £

0 £

SPORTSTOCK LIMITED

 

 

03883733

31/12/2010

96

275 000 £

873 000 £

DECATHLON UK LIMITED

 

 

03140144

31/12/2010

74

60 000 £

69 792 000 £

UNIGRET B.V.

 

 

34228434

31/12/2010

86

295 000 €

-

MAASOORD B.V.

 

 

34269365

31/12/2010

82

4 950 000 €

-

COFIDIS SA

 

 

400359283

31/12/2010

100

62 750 000 €

40 503 944 €

CAISSE AUCHAN ITALIE SA

 

 

879996173

31/12/2010

54

0 €

-

 

 

FINANCIAL INFORMATION

 

Trading to Date

12/31/2010

12/31/2009

12/31/2008

Turnover

224,764,649 €

230,125,000 €

254,369,000 €

Gross Operating Surplus

0,93 % Turnover

2,18 % Turnover

7 % Turnover

Net worth

45,587,822 €

58,997,000 €

53,954,000 €

accounts

Active Account |  Passive Account |  Account Results

 

Synthesized Accounts

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

Comparison mode

Average

Median

 

 

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

 

Account period (month)

12

 

12

 

12

 

 

Account Type

Normal

 

Normal

 

Normal

 

 

Deposit date

14/10/2011

 

11/11/2010

 

18/02/2010

 

 

Activity Code

4753Z

 

4753Z

 

4753Z

 

 

Employees

1601

 

1566

 

0

 

 


Active account

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

91 464 743

-8,5%

99 930 000

-4,0%

104 125 000

38 480

237594,2%

- Intangible assets

3 233 227

6,8%

3 028 000

-3,0%

3 122 000

1 500

215448,5%

- Tangible assets

38 760 203

0,1%

38 713 000

-3,3%

40 040 000

12 650

306304,8%

- Financial assets

49 471 313

-15,0%

58 189 000

-4,6%

60 963 000

1 517

3261028,1%

Net current assets

59 920 004

-14,6%

70 203 000

-0,1%

70 240 000

153 587

38913,7%

- Stocks

37 434 204

-8,9%

41 077 000

-4,2%

42 864 000

53 083

70420,1%

- Advanced payments

538 867

-14,6%

0

0%

0

0

0%

- Receivables

17 851 139

-38,7%

29 126 000

6,4%

27 376 000

34 262

52001,9%

- Securities and cash

4 095 794

0%

0

0%

0

24 320

16741,3%

- Prepaid expenses

-

-

-

-

-

744

-

Accounts of regularization

6 809

0%

0

0%

3 096 000

0

0%

Total Assets

151 391 556

-11,0%

170 133 000

-4,1%

177 461 000

209 236

72254,4%


Passive Account

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Shareholders' equity

45 587 822

-22,7%

58 997 000

9,3%

53 954 000

51 022

89249,3%

Share capital

1 363 786

0,0%

1 364 000

0%

1 364 000

10 000

13537,9%

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

6 297 348

2,1%

6 166 000

-59,1%

15 063 000

0

0%

Liabilities

98 865 230

-5,8%

104 970 000

-2,8%

108 012 000

139 712

70663,6%

- Financial liabilities

59 892 438

-13,7%

69 409 000

1,4%

68 484 000

26 230

228235,6%

- Advanced payments received

2 868 979

0%

0

0%

0

0

0%

- Trade account payables

14 591 013

15,1%

12 672 000

-48,7%

24 717 000

44 183

32924,0%

- Tax and social liabilities

18 140 441

0%

0

0%

0

37 886

47781,6%

- Other debts and fixed assets liabilities

776 184

-96,6%

22 824 000

49,9%

15 223 000

3 020

25601,5%

Account regularization

3 237 332

4880,5%

65 000

225,0%

20 000

0

0%

Total liabilities

151 391 556

-11,0%

170 133 000

-4,1%

177 461 000

209 235

72254,8%

 

Results

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Sales of Goods

227 591 613

-1,9%

231 925 000

-9,5%

256 253 000

340 609

66719,0%

Net turnover

224 764 649

-2,3%

230 125 000

-9,5%

254 369 000

337 855

66427,0%

- of which net export turnover

0

0%

0

0%

0

0

0%

Operating charges

228 723 430

-1,4%

231 872 000

-4,8%

243 658 000

340 319

67108,5%

Operating profit/loss

-1 131 817

-2235,5%

53 000

-99,6%

12 595 000

4 492

-25296,3%

Financial income

3 051 900

229,2%

927 000

0%

0

20

15259400%

Financial charges

17 472 519

0%

0

0%

68 910 000

911

1917849,4%

Financial profit/loss

-14 420 619

-1655,6%

927 000

101,3%

-68 910 000

-378

-3814878,6%

Pretax net operating income

-15 552 436

-1687,0%

980 000

101,7%

-56 315 000

3 389

-459009,3%

Extraordinary income

8 061 425

-92,8%

112 653 000

6967,3%

1 594 000

10

80614150,0%

Extraordinary charges

5 928 398

-94,5%

108 404 000

999,9%

9 856 000

183

3239461,7%

Extraordinary profit/loss

2 133 027

-410,8%

4 249 000

151,4%

-8 262 000

0

0%

Net result

-13 206 185

-349,4%

5 295 000

107,9%

-66 746 000

3 925

-336563,3%


 

 

 

 

Display parameter

Currency

 

Euro

Kilo Euro

 

 

Normal Account

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Months

 

12

 

12

 

12


Accounts - Active
Current Assets |  Equalization accounts |  Reference

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Grand Total (I to VI)

Net

151 391 556

-11,0%

170 133 000

-4,1%

177 461 000

Gross

CO

272 128 967

60,0%

170 133 000

-4,1%

177 461 000

Amortisation

1A

120 737 411

0%

0

0%

0

 

Non declared distributed capital (I)

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AA

0

0%

0

0%

0

 

Active fixed asset (II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total Active fixed asset (II)

Net

91 464 743

-8,5%

99 930 000

-4,0%

104 125 000

 

Gross

BJ

208 964 714

109,1%

99 930 000

-4,0%

104 125 000

 

Amortisation

BK

117 499 971

0%

0

0%

0

 

Intangilble fixed assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R & D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AE

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

183 723

0%

0

0%

0

 

Gross

AF

818 362

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AG

634 639

0%

0

0%

0

Goodwill

Net

3 049 504

0%

0

0%

3 122 000

 

Gross

AH

3 049 504

0%

0

0%

3 122 000

 

Amortisation

AI

0

0%

0

0%

0

Other intangible fixed assets

Net

0

0%

3 028 000

0%

0

 

Gross

AJ

0

0%

3 028 000

0%

0

 

Amortisation

AK

0

0%

0

0%

0

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible Assets

Net

3 233 227

6,8%

3 028 000

-3,0%

3 122 000

 

Tangilble fixed assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Lands

Net

8 075 626

0%

0

0%

8 934 000

 

Gross

AN

8 190 276

0%

0

0%

8 934 000

 

Amortisation

AO

114 650

0%

0

0%

0

Buildings

Net

25 399 655

0%

0

0%

24 452 000

 

Gross

AP

97 082 651

0%

0

0%

24 452 000

 

Amortisation

AQ

71 682 996

0%

0

0%

0

Plant

Net

168 550

0%

0

0%

186 000

 

Gross

AR

1 875 160

0%

0

0%

186 000

 

Amortisation

AS

1 706 610

0%

0

0%

0

Other tangible fixed assets

Net

4 646 314

-88,0%

38 713 000

860,9%

4 029 000

 

Gross

AT

30 056 802

-22,4%

38 713 000

860,9%

4 029 000

 

Amortisation

AU

25 410 488

0%

0

0%

0

Fixed assets in construction

Net

458 148

0%

0

0%

2 439 000

 

Gross

AV

458 148

0%

0

0%

2 439 000

 

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

11 910

0%

0

0%

0

 

Gross

AX

11 910

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Tangible asset

Net

38 760 203

 

38 713 000

 

40 040 000

 

 

Financial assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

33 320 286

0%

0

0%

60 597 000

 

Gross

CU

49 153 562

0%

0

0%

60 597 000

 

Amortisation

CV

15 833 276

0%

0

0%

0

Inter-company receivables

Net

15 732 412

0%

0

0%

0

 

Gross

BB

17 849 724

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BC

2 117 312

0%

0

0%

0

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

Loans

Net

5 962

0%

0

0%

0

 

Gross

BF

5 962

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BG

0

 

0

 

0

Other financial assets

Net

412 653

-99,3%

58 189 000

15798,6%

366 000

 

Gross

BH

412 653

-99,3%

58 189 000

15798,6%

366 000

 

Amortisation

BI

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Financial Assets

 

49 471 313

 

58 189 000

 

60 963 000

 

Current Assets (III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total Assets

Net

59 920 004

-14,6%

70 203 000

-0,1%

70 240 000

 

Gross

CJ

63 157 445

-10,0%

70 203 000

-0,1%

70 240 000

 

Amortisation

CK

3 237 441

0%

0

0%

0

 

Stocks

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Raw materials

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BL

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BM

0

0%

0

0%

0

Work in progress (goods)

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BN

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BR

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BS

0

0%

0

0%

0

Goods for resale

Net

37 434 204

-8,9%

41 077 000

-4,2%

42 864 000

 

Gross

BT

39 585 351

-3,6%

41 077 000

-4,2%

42 864 000

 

Amortisation

BU

2 151 147

0%

0

0%

0

 

Sub Total Stocks

Net

37 434 204

-8,9%

41 077 000

-4,2%

42 864 000

 

Advance payments to suppliers

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Advance payments to suppliers

Net

538 867

0%

0

0%

0

 

Gross

BV

538 867

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0

 

Debtors

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Trade accounts receivable

Net

11 136 670

3,8%

10 730 000

10,4%

9 717 000

 

Gross

BX

11 530 277

7,5%

10 730 000

10,4%

9 717 000

 

Amortisation

BY

393 607

0%

0

0%

0

Other debtors

Net

5 347 765

-69,4%

17 453 000

5,3%

16 572 000

 

Gross

BZ

5 347 765

-69,4%

17 453 000

5,3%

16 572 000

 

Amortisation

CA

0

0%

0

0%

0

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Debtors

Net

16 484 435

-41,5%

28 183 000

7,2%

26 289 000

 

Divers

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Investment securities

Net

1 538 232

0%

0

0%

0

 

Gross

CD

2 230 919

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CE

692 687

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

2 557 562

0%

0

0%

0

 

Gross

CF

2 557 562

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Divers

Net

4 095 794

0%

0

0%

0



Prepaid expenses

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Prepaid expenses

Net

1 366 704

44,9%

943 000

-13,2%

1 087 000

 

Gross

CH

1 366 704

44,9%

943 000

-13,2%

1 087 000

 

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts (IV to VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Multi-period charges

CW3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

0%

0

 

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

0%

0

 

Currency differential gain

CN3

6 809

0%

0

0%

3 096 000

 

Gross

 

6 809

0%

0

0%

3 096 000

 

References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

 

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

Accounts - Passive
Other capital resources | Provisions for risks and charges | Liabilities | Translation loss | Equalization accounts | References

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Grand Total (I to V)

EE

151 391 556

-11,0%

170 133 000

-4,1%

177 461 000

 

Shareholder Equity (I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total shareholders' equity (Total I)

DL

45 587 822

-22,7%

58 997 000

9,3%

53 954 000

 

Equity and shareholders' equity

DA

1 363 786

0,0%

1 364 000

0%

1 364 000

 

Issue and merger premiums

DB

3 608 124

0%

0

0%

0

 

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

 

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

 

Legal reserve

DD

136 379

0%

0

0%

0

 

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

 

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

 

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

 

Other reserves

DG

100 378 563

91,8%

52 338 000

-56,1%

119 336 000

 

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

 

0

0%

0

 

Profits or losses brought forward

DH

-49 444 498

0%

0

0%

0

 

Profit or loss for the period

DI

-13 206 185

-349,4%

5 295 000

107,9%

-66 746 000

 

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

 

Special tax-allowable reserves

DK

2 751 653

0%

0

0%

0

 

Other capital resources (II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

 

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

 

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

 

Provisions for risks and charges (III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

6 297 348

2,1%

6 166 000

-59,1%

15 063 000

 

Risk provisions

DP

942 065

-84,7%

6 166 000

0%

0

 

Reserves for charges

DQ

5 355 283

0%

0

0%

15 063 000

 

 

Liabilities (IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total Liabilities (Total IV)

EC

98 865 230

-5,8%

104 970 000

-2,8%

108 012 000

 

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

 

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

 

Bank loans and liabilities

DU

54 238 280

0%

0

0%

0

 

Sundry loans and financial liabilities

DV

5 654 158

-91,9%

69 409 000

1,4%

68 484 000

 

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

 

Advance payments received for current orders

DW

2 868 979

0%

0

0%

0

 

Trade accounts payables

DX

14 591 013

15,1%

12 672 000

-48,7%

24 717 000

 

Tax and social security liabilities

DY

18 140 441

0%

0

0%

0

 

Fixed asset liabilities

DZ

0

0%

0

0%

0

 

Other debts

EA

135 027

-99,4%

22 824 000

54,3%

14 791 000

 

Translation loss (V)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Translation loss (Total V)

ED

641 157

0%

0

0%

432 000

 Equalization accounts

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Deferred income

EB

3 237 332

4880,5%

65 000

225,0%

20 000

References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

 

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

 

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

Result account
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges | Financial income | Financial charges | Financial charges | Extraordinary charges | Employee profit sharing | Tax on profits | References

1- Operating result (I-II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Operating result (Total I-II)

GG

-1 131 817

-2235,5%

53 000

-99,6%

12 595 000

2 - Financial result (V - VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Financial result (Total V-VI)

GV

-14 420 619

-1655,6%

927 000

101,3%

-68 910 000

3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

-15 552 436

-1687,0%

980 000

101,7%

-56 315 000

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

2 133 027

-49,8%

4 249 000

151,4%

-8 262 000

Profit or loss

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Profit or loss

HN

-13 206 185

-349,4%

5 295 000

107,9%

-66 746 000

Total Income (I+III+V+VII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total Income (I+III+V+VII)

HL

238 704 938

-30,9%

345 505 000

34,0%

257 847 000

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

251 911 122

-26,0%

340 210 000

4,8%

324 593 000

Operating income (I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total operating income (Total I)

FR

227 591 613

-1,9%

231 925 000

-9,5%

256 253 000

Operating income (details)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sale of goods for resale

FC

189 511 477

0%

0

0%

0

 

France

FA

189 511 477

0%

0

0%

0

 

Export

FB

0

0%

0

0%

0

Sale of goods produced

FF

0

0%

0

0%

0

 

France

FD

0

0%

0

0%

0

 

Export

FE

0

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

35 253 172

-84,7%

230 125 000

-9,5%

254 369 000

 

France

FG

35 253 172

-84,7%

230 125 000

-9,5%

254 369 000

 

Export

FH

0

0%

0

0%

0

Net turnover

FL

224 764 649

-2,3%

230 125 000

-9,5%

254 369 000

 

France

FJ

224 764 649

-2,3%

230 125 000

-9,5%

254 369 000

 

Export

FK

0

0%

0

0%

0

 

Stocked production

FM

0

0%

0

0%

0

 

Self-constructed assets

FN

0

0%

0

0%

0

 

Operating grants

FO

17 654

0%

0

0%

0

 

Release of reserves and provisions

FP

2 753 141

0%

0

0%

0

 

Other income

FQ

56 169

-96,9%

1 800 000

-4,5%

1 884 000

 

Operating charges (II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total operating charges (Total II)

GF

228 723 430

-1,4%

231 872 000

-4,8%

243 658 000

 

Exploitation charges

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Purchase of goods for resale

FS

89 967 803

0%

0

0%

0

 

Change in stocks of goods for resale

FT

2 304 816

0%

0

0%

0

 

Purchase of raw materials

FU

779 725

0%

0

0%

0

 

Change in stocks of raw materials

FV

0

0%

0

0%

0

 

Other external purchases and charges

FW

58 002 289

-62,3%

154 000 000

-8,5%

168 386 000

 

Tax, duty and similar payments

FX

10 980 648

0%

0

0%

0

 

Payroll

FY

43 073 663

0%

0

0%

0

 

Social security costs

FZ

17 586 768

-75,3%

71 099 000

4,3%

68 177 000

 

Depreciation

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Depreciation of fixed assets

GA

5 164 826

-23,7%

6 773 000

-4,5%

7 095 000

 

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

0

 

Depreciation/amortisation of current assets

GC

76 522

0%

0

0%

0

 

Provisions for risks and charges

GD

303 671

0%

0

0%

0

 

Other charges

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Other charges

GE

482 699

0%

0

0%

0

 


Operating charges (III-IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

 

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

 

Financial income (V)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total financial income (Total V)

GP

3 051 900

229,2%

927 000

0%

0

 

Share financial income

GJ

407 004

0%

0

0%

0

 

Other investment income & capitalised receivables

GK

827

0%

0

0%

0

 

Other interest and similar income

GL

2 526 730

172,6%

927 000

0%

0

 

Released provisions and transferred charges

GM

40 755

0%

0

0%

0

 

Exchange gains

GN

74 651

0%

0

0%

0

 

Net income from disposal of investment securities

GO

1 933

0%

0

0%

0

 

Financial Charge (VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total financial charge (Total VI)

GU

17 472 519

0%

0

0%

68 910 000

 

Financial reserves and provisions

GQ

15 541 574

0%

0

0%

0

 

Interest and similar charges

GR

1 363 648

0%

0

0%

68 910 000

 

Exchange losses

GS

567 297

0%

0

0%

0

 

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

 

Financial Charge (VII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total extraordinary income (Total VII)

HD

8 061 425

-92,8%

112 653 000

6967,3%

1 594 000

 

Extraordinary operating income

HA

1 853 228

-98,4%

112 653 000

6967,3%

1 594 000

 

Extraordinary income from capital transactions

HB

4 845 338

0%

0

0%

0

 

Released provisions and transferred charges

HC

1 362 859

0%

0

0%

0

 

Extraordinary charges (VIII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

5 928 398

-94,5%

108 404 000

999,9%

9 856 000

 

Extraordinary operating charges

HE

1 872 019

-98,3%

108 404 000

999,9%

9 856 000

 

Extraordinary charges from capital transactions

HF

888 534

0%

0

0%

0

 

Extraordinary reserves and provisions

HG

3 167 845

0%

0

0%

0

 

Employee profit sharing (IX)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

0

0%

0

0%

0

 

Tax on profits (X)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Tax on profits (Total X)

HK

-213 225

-223,1%

-66 000

-103,0%

2 169 000

 

References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

 

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

 

Of which transferred charges

A1

0

0%

0

0%

0

 

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Other incomer tax return forms
Reserve for depreciation | Provisions included in balance sheet | State deadlines claims and debts at the end of period
Table allocation results and other information

Fixed Assets
Grand Total Fixed Assets (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

OK2

6 357 884

0%

0

0%

0

 

Gross value at the end of period

OL

208 964 713

0%

0

0%

0


Research and development Charge (Total I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

C01

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

C02

0

0%

0

0%

0

 

Gross value at the end of period

D0

0

0%

0

0%

0


Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

KD

3 534 531

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

459 964

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

LV2

126 630

0%

0

0%

0

 

Gross value at the end of period

LW

3 867 865

0%

0

0%

0


Tangible fixed assets (Total III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

LN

136 703 432

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

6 239 431

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NG2

5 267 915

0%

0

0%

0

 

Gross value at the end of period

NH

137 674 948

0%

0

0%

0


Fiancial assets (Total IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

LQ

60 665 937

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

7 719 301

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NJ2

963 338

0%

0

0%

0

 

Gross value at the end of period

NK

67 421 900

0%

0

0%

0

 

Reserve for depreciation
Situation and movement of reserve for depreciation
Grand total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

0N

0

0%

0

0%

0

Increases

0P

0

0%

0

0%

0

Decreasess

0Q

0

0%

0

0%

0

 

Reserve for depreciation value at the end of period

0R

0

0%

0

0%

0

 

Research and development charge (Total I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0


Other intangible assets (Total II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

506 337

0%

0

0%

0

Increases

PF

128 302

0%

0

0%

0

Decreasess

PG

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PH

634 639

0%

0

0%

0


Total fixed assets amotisation (Total III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

97 990 252

0%

0

0%

0

Increases

QV

5 036 523

0%

0

0%

0

Decreases

QW

4 112 034

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

QX

98 914 741

0%

0

0%

0


Movements during period affecting charge allocated over several period
Charges à répartir ou frais d'émission d'emprunt

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0


Premium refund of obligations

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Net value at begining of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

 

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

 

Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

7C

13 513 620

0%

0

0%

0

Increases

UB

19 089 612

0%

0

0%

0

Decreases

UC

2 251 553

0%

0

0%

0

 

Value at the end of period

UD

30 351 679

0%

0

0%

0

 


Includes Total allocations

 

Operating

UE

380 193

0%

0

0%

0

 

Financial

UG

15 541 574

0%

0

0%

0

 

Exceptional

UJ

3 167 845

0%

0

0%

0

 

Includes Total Withdrawal

 

Operating

UF

930 811

0%

0

0%

0

 

Financial

UH

40 755

0%

0

0%

0

 

Exceptional

UK

1 279 987

0%

0

0%

0

 

Total regulated provisions (Total I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

3Z

2 954 605

0%

0

0%

0

Increases

TS

420 971

0%

0

0%

0

Decreases

TT

623 923

0%

0

0%

0

 

Value at the end of period

TU

2 751 653

0%

0

0%

0

Total risk and charge provisions (Total II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

5Z

6 165 752

0%

0

0%

0

Increases

TV

1 625 859

0%

0

0%

0

Decreases

TW

1 494 263

0%

0

0%

0

 

Value at the end of period

TX

6 297 348

0%

0

0%

0

 

Total Provision for depreciation (Total III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

7B

4 393 264

0%

0

0%

0

Increases

TY

17 042 782

0%

0

0%

0

Decreases

TZ

133 366

0%

0

0%

0

 

Value at the end of period

UA

21 302 680

0%

0

0%

0

 


State deadlines claims and debts at the end of period
State claims

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Gross value

VT

36 513 084

0%

0

0%

0

 

1 year at most

VU

18 250 707

0%

0

0%

0

 

More than one year

VV

18 262 377

0%

0

0%

0

 

State of loans

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Claims related to holdings (gross)

UL

17 849 724

0%

0

0%

0

 

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

0%

0

0%

0

 

Loans (gross)

UP

5 962

0%

0

0%

0

 

Loans (1 year at most)

UR

5 962

0%

0

0%

0

 

Other financial assets (gross)

UT

412 653

0%

0

0%

0

 

Other financial assets (1 year at most)

UV

0

0%

0

0%

0

 

Receivables statement of assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Customers doubtful or disputed

VA

705 168

0%

0

0%

0

 

Other claims customer

UX

10 825 109

0%

0

0%

0

 

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

 

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

 

Personnel and associated accounts

UY

13 135

0%

0

0%

0

 

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

0

0%

0

 

Income taxes

VM

212 072

0%

0

0%

0

 

Value added tax

VB

303 204

0%

0

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

VN

0

0%

0

0%

0

 

State and other public - Miscellaneous

VP

1 025 825

0%

0

0%

0

 

Group and Associates

VC

0

0%

0

0%

0

 

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

3 793 530

0%

0

0%

0

 

Prepaid

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Prepaid

VS

1 366 704

0%

0

0%

0

State Debt

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total debt (gross)

VY

95 996 250

0%

0

0%

0

1 year at most

VZ2

62 061 270

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

33 934 980

0%

0

0%

0

More than 5 years

VZ4

0

0%

0

0%

0

Details

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

13 533 375

0%

0

0%

0

1 year at most

VG2

13 533 375

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

40 704 905

0%

0

0%

0

1 year at most

VH2

12 382 355

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VH3

28 322 550

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

5 654 158

0%

0

0%

0

1 year at most

8A2

41 728

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8A3

5 612 430

0%

0

0%

0

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

14 591 013

0%

0

0%

0

1 year at most

8B2

14 591 013

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8B3

14 591 013

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

8 704 856

0%

0

0%

0

1 year at most

8C2

8 704 856

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

5 854 402

0%

0

0%

0

1 year at most

8D2

5 854 402

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (gross)

VW1

1 091 307

0%

0

0%

0

1 year at most

VW2

1 091 307

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

2 489 875

0%

0

0%

0

1 year at most

VQ2

2 489 875

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8J2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

0

0%

0

 

1 year at most

VI2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

 

More 5 years

VI4

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

135 027

0%

0

0%

0

1 year at most

8K2

135 027

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

3 237 332

0%

0

0%

0

1 year at most

8L2

3 237 332

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0

References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Loans made during the period

VJ

18 905 449

0%

0

0%

0

 

Debt repaid during the period

VK

18 971 500

0%

0

0%

0

 

Table allocation results and other information
Dividends distributed

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0

Commitments

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Commitments leasing furniture

YQ

12 010 931

0%

0

0%

0

 

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

 

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0

Other charges Externes

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

 

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

 

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

 

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

 

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

 

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

 

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0

Taxes and Fees

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

 

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0

VAT

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

 

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0

Average number of employees

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Average number of employees

YP

1 601

2,2%

1 566

0%

0

Groups and Shareholders

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Groups and Shareholders

ZR

0

-

0

-

-

 

 

 

Display parameter

Comparison mode

Average

Median


Ratios
Structure and liquidity | Management or rotation | Profitability of the business | Return on capital

Structure and Liquidity

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Fixed Asset Financing

1,10

-18,5%

1,35

2,3%

1,32

1,72

-36,0%

Global Debt

158 days

-3,7%

164 days

7,2%

153 days

125 days

26,4%

Working Capital Fund overall net

33 days

-38,9%

54 days

14,9%

47 days

56 days

-41,1%

Financial independence

84,05%

-

%

-

%

244,77%

-65,7%

More ratios

Solvability

30,11%

-13,2%

34,68%

14,1%

30,40%

31,07%

-3,1%

Capacity debt futures

175,91%

-

%

-

%

567,07%

-69,0%

Coverage of current assets by net working capital overall

31,73%

-36,6%

50,02%

3,6%

48,26%

34,58%

-8,2%

General Liquidity

0,29

-

 

-

 

0,33

-12,1%

Restricted Liquidity

0,37

-

 

-

 

0,70

-47,1%

 


Management or rotation

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Need background in operating working capital

30 days

-43,4%

53 days

26,2%

42 days

17,50 days

71,4%

Treasury

8 days

0%

0 days

0%

0 days

10,50 days

-23,8%

Inventory turnover of goods

154 days

-

days

-

days

129 days

19,4%

Average length of credit granted to customers

18 days

5,9%

17 days

21,4%

14 days

16 days

12,5%

Average length of credit obtained suppliers

35 days

16,7%

30 days

-43,4%

53 days

58 days

-39,7%

More ratios

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

0 days

-

days

-

days

0 days

0%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

days

-

days

-

days

536 days

-

Rotation tangible assets

163,26%

-

%

-

%

610,80%

-73,3%


Profitability of the business

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Margin trading

43,26%

0%

0%

0%

0

38,90%

11,2%

Profitability of the business

0,93

-57,3%

2,18

-68,9%

7

2,92%

-68,2%

Net profit

-5,88%

-355,7%

2,30%

108,8%

-26,24%

1,45%

-505,5%

More ratios

Growth rate of turnover (excluding VAT)

-2,33%

75,6%

-9,53%

-80,5%

-5,28%

-2,55%

8,6%

Rates integration

32,79%

-0,9%

33,08%

-2,1%

33,80%

26,49%

23,8%

Rate leasing furniture

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Work Factor

82,30%

-11,9%

93,40%

17,8%

79,29%

80,41%

2,4%

Weight interests

7,77

0%

0%

0%

27,09%

0,29%

2579,3%


Return on capital

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Cash flow from the overall profitability

1,98%

-62,2%

5,24%

122,3%

-23,45%

2,66%

-25,6%

Rates of economic profitability

2%

-50,0%

4%

-73,3%

15%

11%

-81,8%

Financial profitability

45587822%

-22,7%

58997000%

9,3%

53954000%

35392%

128708,3%

Return on investment

4,04%

-1,9%

4,12%

132,8%

1,77%

7,24%

-44,2%

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

Comparison mode

Average

Median


Soldes Intermédiaires de Gestion

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Turnover

224 764 649

-2,3%

230 125 000

-9,5%

254 369 000

337 855 € 

66427,0% 

 

Sales of goods

189 511 477

0%

0

0%

0

 

 

- Purchase of goods

89 967 803

0%

0

0%

0

 

 

+/- Stock of goods variation

2 304 816

0%

0

0%

0

 

 

Trading margin

97 238 858 €

0%

0 €

0%

0 €

105 604 € 

91978,8% 

 

43,26 % CA

0%

0,00 % CA

0%

0,00 % CA

39,32 % CA 

10,0%

 


Sale of goods produced

35 253 172

-84,7%

230 125 000

-9,5%

254 369 000

 

 

+/- Stocked production

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Self-constructed assets

0

0%

0

0%

0

 

 

Period production

35 253 172 €

-84,7%

230 125 000 €

-9,5%

254 369 000 €

12 975 € 

271600,7% 

 

15,68 % CA

-84,3%

100,00 % CA

0%

100,00 % CA

4,42 % CA 

254,8% 

 

Trading margin

97 238 858

0%

0

0%

0

105 604 

91978,8% 

+ Period Production

35 253 172

-84,7%

230 125 000

-9,5%

254 369 000

12 975 

271600,7% 

- Purchase of raw materials

779 725

0%

0

0%

0

 

 

+/- Change in stocks of raw materiels

0

0%

0

0%

0

 

 

- Other external purchases and charges

58 002 289

-62,3%

154 000 000

-8,5%

168 386 000

 

 

Added value

73 710 016 €

-3,2%

76 125 000 €

-11,5%

85 983 000 €

91 408 € 

80538,5% 

 

32,79 % CA

-0,9%

33,08 % CA

-2,1%

33,80 % CA

26,49 % CA 

23,8% 

 

Added value

73 710 016 €

-3,2%

76 125 000 €

-11,5%

85 983 000 €

91 408 € 

80538,5% 

+ Operating grants

17 654

0%

0

0%

0

 

 

- Tax, duty and similar payments

10 980 648

0%

0

0%

0

 

 

- Personal charges

60 660 431

-14,7%

71 099 000

4,3%

68 177 000

 

 

Gross operating surplus

2 086 591 €

-58,5%

5 026 000 €

-71,8%

17 806 000 €

9 424 € 

22041,2% 

 

0,93 % CA

-57,3%

2,18 % CA

-68,9%

7,00 % CA

2,92 % CA 

-68,2% 

 

Gross operating surplus

2 086 591 €

-58,5%

5 026 000 €

-71,8%

17 806 000 €

9 424 € 

22041,2% 

+ Release of reserves and provisions

2 753 141

0%

0

0%

0

 

 

+ Other operating income

56 169

-96,9%

1 800 000

-4,5%

1 884 000

 

 

- Depreciation/Amortisation

5 545 019

-18,1%

6 773 000

-4,5%

7 095 000

 

 

- Other charges

482 699

0%

0

0%

0

 

 

Operating result

-1 131 817 €

-2235,5%

53 000 €

-99,6%

12 595 000 €

4 507 € 

-25212,4% 

 

-0,50 % CA

-2600%

0,02 % CA

-99,6%

4,95 % CA

1,52 % CA 

-132,9% 

 

Operating result

-1 131 817 €

-2235,5%

53 000 €

-99,6%

12 595 000 €

4 507 € 

-25212,4% 

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Financial income

3 051 900

229,2%

927 000

0%

0

 

 

- Financial charges

17 472 519

0%

0

0%

68 910 000

 

 

Pre-tax result

-15 552 436 €

-1687,0%

980 000 €

101,7%

-56 315 000 €

3 390 € 

-458873,9% 

 

-6,92 % CA

-1709,3%

0,43 % CA

101,9%

-22,14 % CA

1,32 % CA 

-624,2% 

 

Extraordinary income

8 061 425

-92,8%

112 653 000

6967,3%

1 594 000

10 

80614150,0% 

- Extraordinary charges

5 928 398

-94,5%

108 404 000

999,9%

9 856 000

 

 

Extraordinary result

2 133 027 €

-49,8%

4 249 000 €

151,4%

-8 262 000 €

0 € 

0% 

 

0,95 % CA

-48,6%

1,85 % CA

156,9%

-3 % CA

0 % CA 

0% 

 

Pre-tax result

-15 552 436 €

-1687,0%

980 000 €

101,7%

-56 315 000 €

3 390 € 

-458873,9% 

Extraordinary result

2 133 027 €

-49,8%

4 249 000 €

151,4%

-8 262 000 €

0 € 

0% 

- Employee profit sharing

0

0%

0

0%

0

 

 

- Tax on profits

-213 225

-223,1%

-66 000

-103,0%

2 169 000

 

 

Net result

-13 206 184 €

-349,4%

5 295 000 €

107,9%

-66 746 000 €

3 922 € 

-336820,7% 

-5,88 % CA

-355,7%

2,30 % CA

108,8%

-26,24 % CA

1,40 % CA 

-520,0%

 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Na

 

 

ADDITIONAL INFORMATION

 

Establishment details

 

 

 

Acronym

TSM

 

Activity (APE)

Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (4753Z)

Business Pages FT®

 

 

Postal Address

TAPIS SAINT MACLOU
TSM
330 RUE CARNOT
BP 149
59391 WATTRELOS CEDEX

Trading Address

330 RUE CARNOT
59150 WATTRELOS

 

Telephone

03 20 81 56 43

 

Fax

 

 

 

 

Type

Head office

Status

Economically active

 

Formation Date

 

Reason for formation

 

 

Closure Date

 

Reason for closure

 

 

Reactivation Date

 

Production Role

 

 

Activity Nature

Retail trade

Activity Location

Store

 

Location surface

 

Seasonality

 

 

 

 

Department

Nord (59)

Region

Nord-Pas-de-Calais

 

District

5

Area

99

 

City

WATTRELOS

Size of urban area

Urban unit with 200 000 to 1 999 999 inhabitants

 

 

Other establishments

 

 

 

Branches

156 branch entities in this company

 

Head office

 
> TAPIS SAINT MACLOU <<<  - Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (4753Z)  in WATTRELOS  (59150)
 

 

Secondary establishments

>  TAPIS SAINT MACLOU  - Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (4753Z)  in LESCURE D'ALBIGEOIS  (81380)
>  TAPIS SAINT MACLOU  - Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (4753Z)  in VILLABE  (91100)
>  TAPIS SAINT MACLOU  - Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (4753Z)  in EPINAL  (88000)
>  TAPIS SAINT MACLOU  - Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (4753Z)  in FOUQUIERES LES BETHUNE  (62232)
> ...

 

 

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas but no one grouping more than 50% of workforce

 

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which one activity grouping from 80 to 99% of workforce

 

 

Workforces

 

 

 

Workforce at address

100 to 199 employees

Company workforce

1 000 to 1 999 employees

 

 

Status history

 

 

Date

Description

No Status History

 

 

 

Recent publications in Gazettes

 

 

Publication date

Gazette Name

Description

 

15/02/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

2469 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle : T S M. Administration : Président du conseil d'administration : RIBAULT Christophe Vice-président : JOLIVET Yvon Directeur général : BLANC Philippe Administrateur : THOMAS Guy Administrateur : RIBAULT Christophe Administrateur : T.S.2.M., représenté par MME MULLIEZ Sybille Administrateur : TAPIMA, représenté par M LECLERCQ Bertrand Administrateur : DELOZANNE Marc Administrateur : JOLIVET Yvon Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1588416 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. L'organisation de formation en qualité de prestataire de la formation professionnelle continue. Adresse de l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Augmentation de capital. Date de commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 24/01/2012.

04/02/2012

JAL

Modification of the share capital

 

Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord


Date de décision : 24/01/2012
La société : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, TSM, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS a subi une augmentation de son capital social désormais de 1 588 416 €
Date d'effet : 24/01/2012

25/10/2011

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

9329 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2010.

20/09/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1168 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle : T S M. Administration : Président du conseil d'administration : RIBAULT Christophe Vice-président : JOLIVET Yvon Directeur général : BLANC Philippe Administrateur : THOMAS Guy Administrateur : RIBAULT Christophe Administrateur : T.S.2.M., représenté par MME MULLIEZ Sybille Administrateur : TAPIMA, représenté par M LECLERCQ Bertrand Administrateur : DELOZANNE Marc Administrateur : JOLIVET Yvon Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1363786 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. L'organisation de formation en qualité de prestataire de la formation professionnelle continue. Adresse de l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Départ d'un administrateur. Date de commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 04/03/2011.

10/09/2011

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord


Date de décision : 15/04/2011
La société 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, TSM, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Fait l'objet du départ de Non renseignée SAS SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSE
Date d'effet : 04/03/2011

09/03/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1457 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle : T S M. Administration : Président du conseil d'administration : RIBAULT Christophe Vice-président : JOLIVET Yvon Directeur général : BLANC Philippe Administrateur : THOMAS Guy Administrateur : SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL, représenté par M GASPARD Georges Administrateur : RIBAULT Christophe Administrateur : T.S.2.M., représenté par MME MULLIEZ Sybille Administrateur : TAPIMA, représenté par M LECLERCQ Bertrand Administrateur : DELOZANNE Marc Administrateur : JOLIVET Yvon Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1363786 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. L'organisation de formation en qualité de prestataire de la formation professionnelle continue. Adresse de l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Changement d'administrateur Changement de directeur général. Date de commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 01/01/2011.

19/02/2011

JAL

Appointment of the social representative

 

Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord


Société faisant l'objet d'une nomination : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, TSM, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Nominé : Monsieur Yvon JOLIVET, 22 Rue du Quai, LILLE
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Monsieur Philippe BLANC, 49 Rue Auguste Lançon, PARIS
En la fonction de : Directeur général
Date d'effet : 21/01/2011

19/02/2011

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord


Date de décision : 21/01/2011
La société 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, TSM, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Fait l'objet du départ de Date d'effet : 21/01/2011

26/01/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

2290 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle : T S M. Administration : Président du conseil d'administration : RIBAULT Christophe Directeur général : FAUVET Vincent Administrateur : THOMAS Guy Administrateur : SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL, représenté par M GASPARD Georges Administrateur : RIBAULT Christophe Administrateur : T.S.2.M., représenté par MME MULLIEZ Sybille Administrateur : TAPIMA, représenté par MME MULLIEZ Muriel Administrateur : MULLIEZ Fanny Administrateur : DELOZANNE Marc Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1363786 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. L'organisation de formation en qualité de prestataire de la formation professionnelle continue. Adresse de l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Changement d'administrateur. Date de commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 24/06/2010.

17/12/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

754 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle : T S M. Administration : Président du conseil d'administration : RIBAULT Christophe Directeur général : FAUVET Vincent Administrateur : THOMAS Guy Administrateur : SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL, représenté par M GASPARD Georges Administrateur : RIBAULT Christophe Administrateur : CIMOFLU, représenté par M MULLIEZ Thierry Administrateur : T.S.2.M., représenté par MME MULLIEZ Sybille Administrateur : TAPIMA, représenté par MME MULLIEZ Muriel Administrateur : MULLIEZ Fanny Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1363786 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. L'organisation de formation en qualité de prestataire de la formation professionnelle continue. Adresse de l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Changement de l'objet et de l'activité. Date de commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 01/12/2010.

12/10/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

7407 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

30/12/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

7741 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

25/06/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1461 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle : T S M. Administration : Président du conseil d'administration : RIBAULT Christophe. Directeur général : FAUVET Vincent. Administrateur : THOMAS Guy. Administrateur : SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL, représenté par M GASPARD Georges. Administrateur : RIBAULT Christophe. Administrateur : CIMOFLU, représenté par M MULLIEZ Thierry. Administrateur : T.S.2.M., représenté par MME MULLIEZ Sybille. Administrateur : TAPIMA, représenté par MME MULLIEZ Muriel. Administrateur : MULLIEZ Fanny. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés. Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit. Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1363786 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse de l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Transformation en société anonyme à conseil d'administration. Date de commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 12/05/2009.

24/04/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

7259 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

12/08/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1423 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à directoire. Sigle : T S M. Administration : Président du directoire : FAUVET VincentMembre du directoire : FAUVET Vincent. Membre du directoire : CAPELIEZ Laurent. Président du conseil de surveillance : RIBAULT Christophe. Membre du conseil de surveillance : THOMAS Guy. Membre du conseil de surveillance : T.S.2.M., représenté par MME MULLIEZ Sybille. Membre du conseil de surveillance : TAPIMA, représenté par M MULLIEZ Yann Guy. Membre du conseil de surveillance : SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL, représenté par M GASPARD Georges. Membre du conseil de surveillance : RIBAULT Christophe. Membre du conseil de surveillance : CIMOFLU, représenté par M MULLIEZ Thierry. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés. Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit. Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1363786 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse de l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Changement de membres du directoire. Date de commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 13/06/2008.

15/06/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1046 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à directoire. Sigle : T S M. Administration : Président du directoire : FAUVET VincentMembre du directoire : BASEDEN Eric. Membre du directoire : FAUVET Vincent. Membre du directoire : CAPELIEZ Laurent. Président du conseil de surveillance : RIBAULT Christophe. Membre du conseil de surveillance : THOMAS Guy. Membre du conseil de surveillance : T.S.2.M.. Membre du conseil de surveillance : TAPIMA. Membre du conseil de surveillance : SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL. Membre du conseil de surveillance : RIBAULT Christophe. Membre du conseil de surveillance : CIMOFLU. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés. Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit. Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1363786 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse de l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Changement membres conseil surveillance Changement de président du conseil de surveillance. Date de commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 22/04/2008.

11/06/2008

Bodacc A

Immatriculation

 

86 - VIENNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

2090 - 502 082 324 RCS Poitiers. FUTUROSOL. Forme : S.A.R.L. à associé unique. Administration : Gérant : RICHET Olivier François Hervé. Capital : 1000 EUR. Adresse : 10 rue du Commerce, 86360 Chasseneuil-du-Poitou.
Etablissement : Siège social et établissement principal.
Activité : Vente et pose de revêtements de sols en tant que mandataire de la société Tapis Saint Maclou. Adresse : 10 rue du Commerce, 86360 Chasseneuil-du-Poitou.
Précédent exploitant : TAPIS SAINT MACLOU. 470 500 943 RCS Poitiers.
A dater du : 29/01/2008. Date de commencement de l’activité : 23/01/2008. Descriptif : Fonds principal reçu en gérance mandat de la société TAPIS SAINT MACLOU. Commentaires : Autre immatriculation personne morale. Date d’effet : 23/01/2008.

08/06/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

3971 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2006.

24/08/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

659 - Ancienne situation du siège social : RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943. RC 70-B 94. TAPIS SAINT MACLOU. Sigle : TSM. Forme : S.A. à directoire. Capital : 1 358 286 euros. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Nouvelle situation du siège social - Capital : 1 363 786 euros. Etablissement principal - Activité : industrie, commerce de tout textile et plus particulièrement, de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Date d'effet : 30 juin 2007.

05/05/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

7396 - RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943. RC 70-B 94. TAPIS SAINT MACLOU. Sigle: T S M Forme: S.A. à directoire. . Adresse du siège social: 330, rue Carnot,59150 Wattrelos. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

20/10/2006

Bodacc A

Vente et cession

 

 

0223 - RCS B 470 500 943. RC AP-B 40019. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : S.A. à directoire. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Etablissement secondaire - Activité : achat, vente de tapis, de revêtements de sols et muraux. Adresse : 8 boulevard Voltaire, 19100 Brive. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 324 000 euros. Date d'effet : 1er septembre 2006. Précédent propriétaire : S.A.R.L. GRAU. RCS 340 898 444. Publication légale : La Montagne du 15 septembre 2006. Oppositions : Me Masmonteil, 28 boulevard Jules-Ferry, 19100 Brive, pour la validité et la correspondance.

27/09/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

0985 - RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943. RC 70-B 94. TAPIS SAINT MACLOU. Sigle : TSM. Forme : S.A. à directoire. Capital : 1 358 286 euros. Adresse du siège social : 330 rue Carnot,, 59150 Administration : président du directoire : FAUVET (Vincent). Président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Gonzague). Vice-président du conseil de surveillance : LECLERCQ (Olivier). Membres du conseil de surveillance : THOMAS (Guy) T.S.2.M. TAPIMA SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL CIMOFLU LECLERCQ (Olivier). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES BMD ASSOCIES. Commissaires aux comptes suppléants : DE REU (Benoît) DARROUSEZ (Jean-François). Ancienne administration : ancien gérant : STE T.S.2.M. Anciens associés en commandite : STE T.S.2.M. MULLIEZ (Gonzague). Ancien gérant : MULLIEZ (Gonzague). Anciens membres du conseil de surveillance : S.C. GOMA GRAS (Emmanuel). Ancien président du conseil de surveillance : GRAS (Emmanuel). Anciens membres du conseil de surveillance : STE TAPIMA STE SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL. Etablissement principal - Activité : industrie, commerce de tout textile et plus particulièrement, de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Commentaires : modification survenue sur la forme juridique. Ancienne : S.C.A. Date d'effet : 13 juin 2006.

16/11/2005

Bodacc A

Vente et cession

 

 

199 - RCS B 470 500 943. RC 05-B 258. TAPIS SAINT MACLOU. Sigle : TSM. Forme : société en commandite par action. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Etablissement secondaire - Activité : vente, pose de moquettes, de tapis, de revêtements plastiques, de tissu et d'articles d'ameublement. Adresse : 44 rue de la Grassinais, 35400 Saint-Malo. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 175 001 euros. Date de début d'activité : 19 septembre 2005. Précédent propriétaire : SOCIETE CHRISTIAN FOUGERAY & Cie S.A. RCS B 896 780 079. Publication légale : Le Paysan breton du 30 septembre 2005. Oppositions : Me Lebranchu, notaire, 61 rue Georges-Clemenceau, B.P. 33, 35403 Saint-Malo Cedex.

16/11/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

684 - RCS Saint-Malo B 483 917 027. RC 05-B 287. DYKE. Forme : S.A.R.L. à associé unique. Capital : 1 500 euros. Adresse du siège social : 44 rue de la Grassinais, 35400 Saint-Malo. Commentaires : le fonds fait l'objet d'une gérance par mandat et non d'une création comme précédemment déclaré. Modification de la date de début d'activité. Ancienne : 15 septembre 2005. Fonds reçu en location-gérance. Date de début d'activité : 19 septembre 2005. Propriétaire : SOCIETE TAPIS SAINT MACLOU. RCS B 470 500 943.

05/01/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

980 - Ancienne situation du siège social : RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943. RC 70-B 94. TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : TSM. Forme : S.C.A. Capital : 1 035 346,83 euros. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Nouvelle situation du siège social - Capital : 1 358 286 euros. Etablissement principal - Activité : industrie, commerce de tous textiles et plus particulièrement, de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Date d'effet : 7 décembre 2004.

07/08/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 470500943 RC 70- B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : TSM. Forme : S.C.A. Capital : 1 035 346 euros. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Administration : président du conseil de surveillance : GRAS (Emmanuel). Membres du conseil de surveillance : STE CIVILE GOMA GRAS ( Emmanuel) TAPIMA STE MOUVALLOISE DE CONSEIL. Gérants : T.S. 2M MULLIEZ ( Gonzague). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET BRACQ ET ASSOCIES STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MOLARD (Jean- Paul). Commissaires aux comptes suppléants : DESURMONT (Jean, Marie) BMD ASSOCIES. Associés en commandite : T.S. 2M MULLIEZ (Gonzague). Ancien président du conseil de surveillance : BASEDEN (Eric). Anciens membres du conseil de surveillance : BASEDEN (Eric) LECLERCQ (Bertrand) THOMAS (Guy) Etablissement principal: Activité : industrie et commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Date d'effet : 11 juin 2003.

17/12/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 470500943 RC 70- B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : TSM. Forme : S.C.A. Capital : 1 035 346 euros. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Administration : président du conseil de surveillance : BASEDEN (Eric). Membres du conseil de surveillance : LECLERCQ (Bertrand) THOMAS (Guy) BASEDEN (Eric). Gérants : MULLIEZ (Gonzague) TS 2M. Commissaires aux comptes titulaires : CABINET BRACQ ET ASSOCIES STE D' EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MOLARD (Jean-Paul). Commissaires aux comptes suppléants : DESURMONT (Jean, Marie) B.M.D. ASSOCIES. Associés en commandite : MULLIEZ (Gonzague) TS 2M. Ancien président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann, Guy) Etablissement principal: Activité : industrie et commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Date d'effet : 17 juin 2002.

26/12/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 470500943 RC 70- B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.C.A. Capital : 6 791 430 F. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Administration : président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann, Guy). Membres du conseil de surveillance : LECLERCQ (Bertrand) THOMAS (Guy). Gérants : MULLIEZ ( Gonzague) TS 2M. Commissaires aux comptes titulaires : CABINET BRACQ ET ASSOCIES STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MOLARD ( Jean-Paul). Commissaires aux comptes suppléants : DESURMONT (Jean, Marie) B.M.D. ASSOCIES. Associés en commandite MULLIEZ (Gonzague) TS 2M. Ancien commissaire aux comptes titulaire : VANDENBURIE (Pierre). Ancien commissaire aux comptes suppléant : MOLARD (Jean-Paul) Etablissement principal: Activité : industrie, vente d' articles de tout textile et plus particulièrement de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Date d'effet : 29 juin 2001.

21/01/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 470500943 RC 70- B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.C.A. Capital : 6 791 430 F. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Administration : président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann, Guy). Membres du conseil de surveillance : LECLERCQ (Bertrand) THOMAS (Guy). Gérants : MULLIEZ ( Gonzague) T.S. 2M. Commissaires aux comptes titulaires : VANDENBURIE ( Pierre) CABINET BRACQ ET ASSOCIES STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES. Commissaires aux comptes suppléants : DESURMONT ( Jean, Marie) MOLARD (Jean-Paul). Ancien commissaire aux comptes suppléant : BRACQ (Léon). Ancien gérant et associé en commandite : S.A.R.L. T.S. 2M Etablissement principal: Activité : industrie et commerce de tout textile plus particulièrement, de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Date d'effet : 30 juin 2000.

24/12/2000

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS B 470500943 RC AP-B 573 SAINT- MACLOU. Forme : société en commandité par actions. Capital : 6 696 030 F. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59391 Wattrelos Etablissement principal: Activité : vente au détail de fournitures, de mobilier et de matériel de bureau de dessin. Adresse : 131 avenue Aristide-Briand, 92120 Montrouge Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 385 000 F. Date d'effet : 27 octobre 2000. Précédent propriétaire : SOCIETE MULTIGRAPHIC. RCS B 632041596 Publication légale: Les Petites affiches du 5 décembre 2000. Oppositions : M e Riffier, 205 avenue Georges-Clemenceau, 92000 Nanterre.

30/09/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

o. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC 70-B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T. S.M. Forme : S.A.S. Capital : 6 791 430 F. Adresse du siège social : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos. Administration : président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann, Guy) Membres du conseil de surveillance : LECLERCQ (Bertrand) THOMAS (Guy). Ancien membre du conseil de surveillance : DE BUCK (Jacques). Gérant : MULLIEZ (Gonzague) Etablissement principal: Activité : industrie et commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos. Date d'effet : 30 juin 1999 Date de début d'activité: 1er octobre 1969.

30/09/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

o. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC 70-B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T. S.M. Forme : Société en commandite par actions. Capital : 6 791 430 F. Adresse du siège social : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : ancien capital : 6 743 580 F Etablissement principal: Activité : industrie et commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos. Date d'effet : 2 septembre 1999 Date de début d'activité: 1er octobre 1969.

29/09/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 470500943 RC 70- B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.-M. Forme : S.C.A. Capital : 6 743 580 F. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Administration : président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann, Guy). Membres du conseil de surveillance : DE BUCK (Jacques) LECLERCQ (Bertrand). Gérant : MULLIEZ ( Gonzague) Etablissement principal: Activité : industrie, commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Commentaires : apport partiel d'actif à SAINT-MACLOU PRODUCTION S.A.R. L. Date d'effet : 30 juin 1999.

12/06/1999

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS Roubaix-Tourcoing 470500943 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.C.A. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59391 Wattrelos Cedex ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Montauban 99-B 140. A dater du : 20 mai 1999. Activité : vente de revetements de sols, de moquettes, de tapis et de tissus collés. Adresse : 700 avenue de Paris, 82000 Montauban Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 150 000 F Date de début d'activité: 1er avril 1999. Précédent propriétaire : indivision VESSIO Germaine. RCS 780142824 RC 73-A 219. Précédent exploitant : S.A.R.L. VESSIO. RCS 349086272 RC 89-B 7 Publication légale: Le Journal du Palais de Tarn-et-Garonne du 29 avril 1999. Oppositions : Alizé Conseil, avocat, 42 avenue Gambetta, B.P. 443, 82004 Montauban Cedex.

27/10/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

Propriétaire. RCS Dunkerque A 309 666 709 RC 64-A 33 KRABANSKY Raphael, Noel Français. Activité : vente à titre ambulant de boulangerie, de patisserie, de pain et de confiserie. Adresse : centre commercial 2 59760 Grande-Synthe Fonds donné en location-gérance. Commentaires : fin de la location- gérance consentie à la S.A. BOULANGERIE PATISSERIE KRABANSKY, à compter du 31 juillet 1998. Date d'effet : 1er aout 1998 Bénéficiaire: E.U.R.L. SAINT- JACQUES.

03/07/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS o. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC RC 70-B 94 TAPIS SAINT MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : Société en commandite par actions. Capital : 6 743 580 F. Adresse du siège social : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : ancien capital : 6 696 030 F Etablissement principal: Activité : industrie et commerce de tous textiles plus particulièrement de tapis. Adresse : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos Date de début d'activité: 1er octobre 1969. Date d'effet : 20 janvier 1998.

30/01/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS o. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC RC 70-B 94 TAPIS SAINT MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : Société en commandite par actions. Capital : 6 696 030 F. Adresse du siège social : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos. Administration : président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann, Guy) Membres du conseil de surveillance : DE BUCK (Jacques) LECLERCQ (Bertrand). Gérant : MULLIEZ ( Gonzague). Ancien membre du conseil de surveillance : LECONTE (Sandrine) Etablissement principal: Activité : industrie et commerce de tous textiles plus particulièrement de tapis. Adresse : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos Date de début d'activité: 1er octobre 1969. Date d'effet : 31 mai 1997.

01/06/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC 70-B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 6 691 680 F. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Administration : P.-D.G. : MULLIEZ (Gonzague). Administrateurs : MULLIEZ (Yann, Guy) DE BUCK (Jacques) LECLERCQ (Bertrand) GUERMONPREZ (Marc) Mme LECONTE, née DERVILLE (Sandrine). Commissaires aux comptes titulaires : VANDENBURIE ( Pierre) CABINET BRACQ ET ASSOCIES-STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES. Commissaires aux comptes suppléants : BRACQ (Léon) DESURMONT (Jean, Marie). Anciens administrateurs : PLANCKE (Michel) SACCHI (Emmanuel) Nouvelle situation du siège social. Capital : 6 749 200 F Etablissement principal: Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Date d'effet : 30 octobre 1995.

01/06/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC 70-B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 6 696 030 F. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Administration : président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann, Guy). Membres du conseil de surveillance : DE BUCK (Jacques) LECLERCQ (Bertrand) LECONTE, née DERVILLE (Sandrine). Gérant : MULLIEZ ( Gonzague) Nouvelle situation du siège social. Forme : société en commandite par actions Etablissement principal: Activité : industrie et commerce de tous textiles, plus particulièrement de tapis. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Date d'effet : 1er janvier 1997.

01/06/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC 70-B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 6 749 200 F. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos Nouvelle situation du siège social. Capital : 6 696 030 F Etablissement principal: Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Date d'effet : 18 décembre 1995.

28/01/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC 70-B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.A. Capital : 6 727 000 F. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Administration : P.-D.G. : MULLIEZ ( Gonzague). Administrateurs : MULLIEZ ( Yann, Guy) DE BUCK (Jacques) PLANCKE (Michel) LECLERCQ (Bertrand) GUERMONPREZ (Marc) Mme LECONTE, née DERVILLE (Sandrine) SACCHI (Emmanuel). Commissaires aux comptes titulaires : VANDENBURIE (Pierre) CABINET BRACQ ET ASSOCIES-STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES. Commissaires aux comptes suppléants : BRACQ (Léon) DESURMONT (Jean, Marie). Anciens administrateurs : MULLIEZ ( Olivier) DUPREZ (Philippe) MULLIEZ ( Damien) TAPIS INVESTISSEMENT Nouvelle situation du siège social. Capital : 6 691 680 F Etablissement principal: Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Date d'effet : 16 novembre 1994.

18/01/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS o. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC RC 70-B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 6 727 000 F. Adresse du siège social : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos. Administration : président-directeur général : MULLIEZ ( Gonzague) Administrateurs : MULLIEZ ( Damien) TAPIS INVESTISSEMENT DUPREZ (Philippe) MULLIEZ (Yann, Guy). Nouveaux administrateurs : DE BUCK ( Jacques) GUERMONPREZ (Marc) MULLIEZ (Olivier). Commissaires aux comptes titulaires : VANDENBURIE (Pierre) CABINET BRACQ ET ASSOCIES SOCIETE D' EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES. Commissaires aux comptes suppléants : BRACQ (Léon) DESURMONT ( Jean-Marie) Etablissement principal: Adresse : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos Date de début d'activité: 1er octobre 1969. Date d'effet : 17 juin 1994.

 


Company events history

 

 

 

Date

Description

15/02/2012

Bodacc B: Various editing or changing

03/02/2012

Capital increase

03/02/2012

Minutes of Board meeting

03/02/2012

Updated articles of association

24/01/2012

Legal Gazette: Modification of the share capital

24/01/2012

Other modification of Establishment

25/10/2011

Bodacc C : Deposit accounts notice

19/10/2011

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

20/09/2011

Bodacc B: Various editing or changing

10/09/2011

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

09/09/2011

Changes to the Board of Directors

09/09/2011

Minutes of Board meeting

09/03/2011

Bodacc B: Various editing or changing

04/03/2011

New ultimate parent

28/02/2011

Minutes of Board meeting

28/02/2011

Changes to the Board of Directors

28/02/2011

Minutes of general meeting of shareholders

28/02/2011

Appointment/resignation of company officers

19/02/2011

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

26/01/2011

Bodacc B: Various editing or changing

21/01/2011

Legal Gazette: Appointment of the social representative

13/01/2011

Minutes of general meeting of shareholders

13/01/2011

Changes to the Board of Directors

31/12/2010

New accounts available

17/12/2010

Bodacc B: Various editing or changing

06/12/2010

Updated articles of association

06/12/2010

Minutes of general meeting of shareholders

06/12/2010

Change to corporate purpose

30/11/2010

Modification of Company Activity

30/11/2010

Update of Company Activity

12/10/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

13/08/2010

New subsidiarie(s) detected

13/08/2010

New ultimate parent

13/08/2010

New parent detected

30/03/2010

Payment incident closed

26/01/2010

Payment incident detected

31/12/2009

New accounts available

30/12/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

25/06/2009

Bodacc B: Various editing or changing

16/06/2009

Minutes of general meeting of shareholders

16/06/2009

Appointment/resignation of company officers

16/06/2009

Private document

16/06/2009

Changes to the Board of Directors

16/06/2009

New chairman (CEO, CoB)

16/06/2009

Updated articles of association

16/06/2009

Minutes of Board meeting

15/05/2009

Payment incident closed

12/05/2009

Other modification of Establishment (error correction)

12/05/2009

Modification to Establishment Address or Identifier

12/05/2009

Update of Company Legal Form

24/04/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

25/02/2009

Payment incident detected

31/12/2008

New accounts available

01/12/2008

Formation of Establishment

12/08/2008

Bodacc B: Various editing or changing

12/08/2008

New Bodacc B ads detected

01/08/2008

Appointment/resignation of company officers

01/08/2008

Nomination/démission des organes de gestion

01/08/2008

Private document

01/08/2008

Minutes of general meeting of shareholders

01/08/2008

PV d'Assemblée

15/06/2008

Bodacc B: Various editing or changing

15/06/2008

New Bodacc B ads detected

11/06/2008

New Bodacc A ads detected

11/06/2008

Bodacc A : Registration

08/06/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

02/06/2008

Private document

02/06/2008

Capital increase

02/06/2008

Nomination/démission des organes de gestion

02/06/2008

Minutes of general meeting of shareholders

02/06/2008

Changement de Président (PDG, PCA)

02/06/2008

PV d'Assemblée

02/06/2008

New chairman (CEO, CoB)

02/06/2008

Appointment/resignation of company officers

18/04/2008

Collection of preferential rights activated for this company

31/12/2007

New accounts available

20/07/2007

Updated articles of association

20/07/2007

Private document

20/07/2007

Minutes of general meeting of shareholders

20/07/2007

PV d'Assemblée

20/07/2007

Statuts mis à jour

20/07/2007

Augmentation de Capital

20/07/2007

Capital increase

30/06/2007

Other modification of Establishment

31/12/2006

New accounts available

12/09/2006

Updated articles of association

12/09/2006

Audit or Management Report

12/09/2006

Minutes of general meeting of shareholders

12/09/2006

Private document

12/09/2006

Appointment/resignation of company officers

12/09/2006

PV d'Assemblée

12/09/2006

Statuts mis à jour

12/09/2006

New legal form – no new category

31/12/2005

New accounts available

20/12/2004

Minutes of general meeting of shareholders

20/12/2004

Augmentation de Capital

20/12/2004

Updated articles of association

20/12/2004

Private document

20/12/2004

Acte sous seing privé

20/12/2004

Capital increase

20/12/2004

PV d'Assemblée

20/12/2004

Statuts mis à jour

21/06/2004

PV d'Assemblée

21/06/2004

Minutes of general meeting of shareholders

21/06/2004

Private document

21/06/2004

Updated articles of association

21/06/2004

Statuts mis à jour

21/06/2004

Acte sous seing privé

28/07/2003

Changement de Président (PDG, PCA)

28/07/2003

Modification du Conseil d'Administration

28/07/2003

PV d'Assemblée

28/07/2003

Nomination/démission des organes de gestion

28/07/2003

Acte sous seing privé

04/12/2002

Changement de Président (PDG, PCA)

04/12/2002

Modification du Conseil d'Administration

04/12/2002

Acte sous seing privé

04/12/2002

PV d'Assemblée

04/12/2002

Nomination/démission des organes de gestion

23/09/2002

PV d'Assemblée

23/09/2002

Statuts mis à jour

23/09/2002

Acte sous seing privé

12/12/2001

Acte sous seing privé

12/12/2001

PV d'Assemblée

12/12/2001

Nomination/démission des organes de gestion

12/12/2001

Changement de Commissaire aux Comptes

05/01/2001

Statuts mis à jour

05/01/2001

Nomination/démission des organes de gestion

05/01/2001

Acte sous seing privé

05/01/2001

Changement de Gérant

05/01/2001

PV d'Assemblée

05/01/2001

Changement de Commissaire aux Comptes

16/09/1999

Acte sous seing privé

16/09/1999

PV d'Assemblée

16/09/1999

Statuts mis à jour

16/09/1999

Augmentation de Capital

15/09/1999

PV d'Assemblée

15/09/1999

Nomination/démission des organes de gestion

15/09/1999

Acte sous seing privé

02/06/1999

Acte modificatif

02/06/1999

Acte sous seing privé

18/06/1998

Augmentation de Capital

18/06/1998

Statuts mis à jour

18/06/1998

PV d'Assemblée

18/06/1998

Acte sous seing privé

13/01/1998

Acte sous seing privé

13/01/1998

PV d'Assemblée

13/01/1998

Nomination/démission des organes de gestion

16/05/1997

PV du Conseil d'Administration

16/05/1997

Augmentation de Capital

16/05/1997

PV d'Assemblée

16/05/1997

Acte sous seing privé

16/05/1997

Statuts mis à jour

16/05/1997

Acte modificatif

16/05/1997

Changement de Président (PDG, PCA)

16/05/1997

Réduction de Capital

16/05/1997

Changement de Forme Juridique sans changement de catégorie

16/05/1997

Nomination/démission des organes de gestion

16/05/1997

Modification du Conseil d'Administration

12/01/1996

Modification du Conseil d'Administration

12/01/1996

Réduction de Capital

12/01/1996

Nomination/démission des organes de gestion

12/01/1996

Statuts mis à jour

12/01/1996

PV du Conseil d'Administration

12/01/1996

PV d'Assemblée

29/12/1995

Modification du Conseil d'Administration

29/12/1995

PV d'Assemblée

29/12/1995

Nomination/démission des organes de gestion

23/12/1993

Déclaration de conformité

23/12/1993

PV du Conseil d'Administration

23/12/1993

Réduction de Capital

23/12/1993

Statuts mis à jour

22/12/1993

Déclaration de conformité

22/12/1993

Statuts mis à jour

22/12/1993

Augmentation de Capital

22/12/1993

PV du Conseil d'Administration

03/12/1993

PV du Conseil d'Administration

03/12/1993

Statuts mis à jour

03/12/1993

Augmentation de Capital

03/12/1993

Déclaration de conformité

09/09/1993

PV d'Assemblée

09/09/1993

Augmentation de Capital

03/05/1993

PV du Conseil d'Administration

03/05/1993

Modification du Conseil d'Administration

03/05/1993

PV d'Assemblée

03/05/1993

Nomination/démission des organes de gestion

11/12/1991

Augmentation de Capital

11/12/1991

Déclaration de conformité

11/12/1991

PV d'Assemblée

11/12/1991

Fusion

11/12/1991

Statuts mis à jour

 

 

Establishment events history

 

 

 

Date

Description

07/04/2012

Update Rating

07/02/2012

Update Rating

24/01/2012

Update of Establishment Workforce

07/01/2012

Update Rating

19/10/2011

Update Rating

19/10/2011

Update Limit

08/10/2011

Update Limit

03/09/2011

Update Rating

25/04/2011

Update of phone numbers

21/04/2011

Update Rating

05/01/2011

Update Rating

31/12/2010

Update Rating

30/11/2010

Modification of Head office Activity

30/11/2010

Update of Establishment Activity

16/11/2010

Update Limit

16/11/2010

Update Rating

02/09/2010

Update Rating

02/09/2010

Update Limit

19/08/2010

Update Rating

19/08/2010

Update Limit

30/03/2010

Update Limit

19/02/2010

Update Rating

11/02/2010

Update Rating

11/02/2010

Update Limit

21/01/2010

Update of phone numbers

22/10/2009

Update of phone numbers

11/10/2009

Update Limit

14/09/2009

Update Rating

05/09/2009

Update Rating

29/06/2009

Update Rating

17/06/2009

Update Rating

15/05/2009

Update Limit

15/05/2009

Update Rating

12/05/2009

Modification of Head office

13/03/2009

Update Rating

13/03/2009

Update Limit

16/02/2009

Update of phone numbers

01/12/2008

Modification of Head office

01/10/2008

Update Limit

12/06/2008

Update of phone numbers

29/05/2008

Update Limit

11/12/2007

Update Limit

09/12/2007

Update Limit

21/08/2007

Update of phone numbers

07/06/2007

Update Limit

07/06/2007

Update Rating

NOTES & COMMENTS

 

Na

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.55.24

UK Pound

1

Rs.85.93

Euro

1

Rs.69.82

 

INFORMATION DETAILS

 

Report Prepared by :

MNL

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

----

NB

New Business

----

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.