MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

25.10.2012

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

3 SUISSES FRANCE

 

 

Registered Office :

12 Rue De La Centenaire, 59170 Croix

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2010

 

 

Date of Incorporation :

August 1955

 

 

Com. Reg. No.:

RCS Roubaix-Tourcoing 5 475 581 591

 

 

Legal Form :

Public limited company with board of directors

 

 

Line of Business :

On distance selling catalog

 

 

No. of Employees :

2 000 to 4 999 employees

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ca

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

Limited with full security

 

Status :

Moderate

Payment Behaviour :

Slow and delayed

Litigation :

Clear

 


NOTES:

Any query related to this report can be made on e-mail: infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – June 30th, 2012

 

Country Name

Previous Rating

(31.03.2012)

Current Rating

(30.06.2012)

France

A2

A2

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


france - ECONOMIC OVERVIEW

 

France was transitioning from an economy that has featured extensive government ownership and intervention to one that relies more on market mechanisms but is in the midst of a euro-zone crisis. The government has partially or fully privatized many large companies, banks, and insurers, and has ceded stakes in such leading firms as Air France, France Telecom, Renault, and Thales. It maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With at least 75 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that reduce income disparity and the impact of free markets on public health and welfare. France's real GDP contracted 2.6% in 2009, but recovered somewhat in 2010 and 2011. The unemployment rate increased from 7.4% in 2008 to 9.3% in 2010 and 9.1% in 2011. Lower-than-expected growth and increased unemployment have cut government revenues and increased borrowing costs, contributing to a deterioration of France's public finances. The government budget deficit rose sharply from 3.4% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 5.8% of GDP in 2011, while France's public debt rose from 68% of GDP to 86% over the same period. Under President SARKOZY, Paris implemented austerity measures that eliminated tax credits and froze most government spending in an effort to bring the budget deficit under the 3% euro-zone ceiling by 2013 and to highlight France's commitment to fiscal discipline at a time of intense financial market scrutiny of euro-zone debt levels. Socialist Francois HOLLANDE won the May 2012 presidential election, after advocating pro-growth economic policies, as well as measures such as forcing banks to separate their traditional deposit taking and lending activities from more speculative businesses, increasing taxes on bank profits, introducing a new top bracket on income taxes for people earning over €1 million ($1.3 million) a year, and hiring an additional 60,000 civil servants during his five-year term of office.

 

Source : CIA

 

 


REGISTERED NAME & COMPANY SUMMARY

 

Name

3 SUISSES FRANCE

 

company summary

 

 

 

 

 

EUR VAT Number

FR12475581591

 

 

Activity (APE)

Vente à distance sur catalogue général (4791A)

On distance selling catalog

Legal form

Public limited company with board of directors

 

 

Phone

03 20 82 38 68

RCS Registration

RCS Roubaix-Tourcoing 5 475 581 591

 

 

Fax

 

Share capital

49,375,851 Euros

 

 

Address

3 SUISSES FRANCE
12 RUE DE LA CENTENAIRE
59170 CROIX

Incorporated Date

08/1955

 

 

Nationality

France

Status

Economically active

 

 

Establishment details

 

 

 

 

Activity (APE)

Vente à distance sur catalogue général (4791A)

Business Pages FT®

VENTE CORRESPONDANCE DISTANCE

 

Postal Address

3 SUISSES FRANCE
12 RUE DE LA CENTENAIRE
59170 CROIX

Trading Address

12 RUE DE LA CENTENAIRE
59170 CROIX

 

Telephone

03 20 82 38 68

 

Fax

 

 

 

 

 

DIRECTORS/MANAGEMENT

 

Current Directors

5

 

 

directors

 

Name

M. FAINTRENY ERIC

 

Manager position

Président Directeur Général, Administrateur

Date of birth

24/04/1961

 

Place of birth

BOULOGNE-BILLANCOURT (92012)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

Name

Mme. LIEVOIS CAROLINE

 

Manager position

Directeur général délégué

Date of birth

21/03/1967

 

Place of birth

TOURCOING (59200)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

OPIGEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. BERNARD JEAN-MARC

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

14/11/1960

 

Place of birth

ATTICHES (59022)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

Name

M. BOUACHA KHELAF

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

12/11/1958

 

Place of birth

AKFADOU(ALGERIE)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

Name

M. AVRIL BERNARD

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

01/08/1959

 

Place of birth

MARSEILLE (13001)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Directors

 

 

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

 

Président du conseil d'administration

M ERIC FAINTRENY

24/04/1961 - 92 BOULOGNE-BILLANCOURT

 

Gérant

Mme LAURENCE PAGANINI

31/01/1964 - 06 NICE

 

Gérant

Mme LAURENCE PAGANINI

31/01/1964 - 06 NICE

 

Co-gérant

M PASCAL GIRES

- - -

 

Co-gérant

M PASCAL GIRES

18/03/1959 - PARIS 14

 

Co-gérant

MME LAURENCE PAGANINI

- - -

 

Co-gérant

MME LAURENCE PAGANINI

31/01/1964 - NICE

 

Co-gérant

M ERIC PLATIAU

- - BLENDECQUES

 

Directeur général

Mme LAURENCE PAGANINI

31/01/1964 - 06 NICE

 

Administrateur

M BERNARD AVRIL

01/08/1959 - 13 MARSEILLE

 

Administrateur

M JEAN-MARC BERNARD

14/11/1960 - 59 ATTICHES

 

Administrateur

M ERIC FAINTRENY

24/04/1961 - 92 BOULOGNE-BILLANCOURT

 

Président Directeur Général

M ERIC FAINTRENY

24/04/1961 - BOULOGNE-BILLANCOURT (92012)

 

 

 

NEGATIVE INFORMATION

 

judgements

Collective procedures

 

No judgment information for the company

   Social security, pension funds preferential rights | Tax office preferential rights

Preferential rights details and history

Summary of preferential rights

Company monitored since

10/10/2007

 

 

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

 

Recent publications in Gazettes

 

 

 

Publication date

Gazette Name

Description

 

08/10/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

8421 - 475581591 RCS. 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 12 rue de la Centenaire 59170 Croix. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011.

06/07/2012

JAL

Continuation of activity in spite of stockholders' equity become lower in the middle of the share capital

 

 

Syndicat agricole (Le)


Date de décision : 11/06/2012
Poursuite d'activité malgré des fonds propres devenus inférieurs à la moitié du capital social de la société 475581591 -  3 SUISSES FRANCE, 12 RUE DE LA CENTENAIRE, 59170 CROIX
Date d'effet : 11/06/2012

18/03/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1174 - 475 581 591 RCS Roubaix / Tourcoing. 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle : 3S. Administration : modification du Président directeur général Faintreny, Eric, nomination du Directeur général délégué : Opigez, nom d'usage : Lievois, Caroline, Directeur général partant : Paganini, Laurence. Capital : 49375851 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 12 rue de la Centenaire, 59170 Croix.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

08/03/2012

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

295 - 529 192 155 RCS Roubaix / Tourcoing. ENOPLA. Forme : S.A.S. unipersonnelle. Capital : 10000 EUR. Adresse : 12 rue de la Centenaire, 59170 Croix.
Origine du fonds : Achat au prix stipulé de 1060729,00 euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Routage de mailings. Adresse : 14 rue Jean Paul Sartre, 59290 Wasquehal.
Précédent propriétaire : 3 SUISSES FRANCE. 475 581 591 RCS Roubaix / Tourcoing.
A dater du : 23/12/2010. Date de commencement de l’activité : 01/02/2012. Publication légale : le Syndicat Agricole du 02/03/2012. Oppositions : Enopla 14 rue Jean Paul Sartre 59290 Wasquehal pour la validité, Enopla 12 rue de la Centenaire 59170 Croix pour la correspondance . Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

02/03/2012

JAL

Activity or goodwill cession

 

 

Syndicat agricole (Le)


Date de décision : 21/02/2012
Cédant : 475581591 - 3 SUISSES FRANCE, 12 RUE DE LA CENTENAIRE, 59170 CROIX
Cessionnaire : 529192155 - ENOPLA, 12 RUE DE LA CENTENAIRE, 59170 CROIX
Prix de vente : 1060729 €
Date d’effet : 01/02/2012

02/03/2012

JAL

Appointment of the social representative

 

 

Syndicat agricole (Le)


Date de décision : 02/02/2012
Société faisant l'objet d'une nomination : 475581591 - 3 SUISSES FRANCE, 12 RUE DE LA CENTENAIRE, 59170 CROIX
Nominé : Monsieur Eric FAINTRENY
En la fonction de : Directeur général
Nominé : Madame Caroline LIEVOIS, 59700 MARCQ EN BAROEUL

02/03/2012

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

Syndicat agricole (Le)


Date de décision : 02/02/2012
La société 475581591 - 3 SUISSES FRANCE, 12 RUE DE LA CENTENAIRE, 59170 CROIX
Fait l'objet du départ de Madame Laurence PAGANINI

31/01/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1328 - 475 581 591 RCS Roubaix-Tourcoing. 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle : 3S. Administration : Président du conseil d'administration : FAINTRENY Eric Directeur général : PAGANINI Laurence Administrateur : BERNARD Jean-Marc Administrateur : FAINTRENY Eric Administrateur : BOUACHA Khelaf Administrateur : AVRIL Bernard Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : ACEA Commissaire aux comptes suppléant : SAUVAGE Catherine Commissaire aux comptes suppléant : GOALEC Isabelle. Capital : 49375851 EUR. Activité : Vente au détail de toutes marchandises par tous moyens notamment à distance, internet, magasin Toutes opérations de courtage d'assurances. Adresse de l’établissement principal : 12 rue de la Centenaire, 59170 Croix.
Adresse du siège social : 12 rue de la Centenaire, 59170 Croix.
Commentaires : Augmentation de capital. Date de commencement de l’activité : 01/05/1938. Date d’effet : 30/12/2011.

07/01/2012

JAL

Modification of the share capital

 

 

Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord


Date de décision : 15/12/2011
La société : 475581591 - 3 SUISSES FRANCE, 12 RUE DE LA CENTENAIRE, 59170 CROIX a subi une augmentation de son capital social désormais de 49 375 851 €
Date d'effet : 30/12/2011

18/10/2011

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

5536 - 475581591 RCS. 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Adresse : 12 rue de la Centenaire 59170 Croix. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2010.

15/09/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

528 - 475 581 591 RCS Roubaix-Tourcoing. 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle : 3S. Administration : Président du conseil d'administration : FAINTRENY Eric Directeur général : PAGANINI Laurence Administrateur : BERNARD Jean-Marc Administrateur : FAINTRENY Eric Administrateur : BOUACHA Khelaf Administrateur : AVRIL Bernard Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : ACEA Commissaire aux comptes suppléant : SAUVAGE Catherine Commissaire aux comptes suppléant : GOALEC Isabelle. Capital : 26599646.55 EUR. Activité : Vente au détail de toutes marchandises par tous moyens notamment à distance, internet, magasin Toutes opérations de courtage d'assurances. Adresse de l’établissement principal : 12 rue de la Centenaire, 59170 Croix.
Adresse du siège social : 12 rue de la Centenaire, 59170 Croix.
Commentaires : Transformation en SA à conseil d'administration. Date de commencement de l’activité : 01/05/1938. Date d’effet : 30/06/2011.

03/06/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

521 - 475 581 591 RCS Roubaix-Tourcoing. 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société en commandite simple. Sigle : 3S. Administration : Gérant : PAGANINI Laurence Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : ACEA Commissaire aux comptes suppléant : SAUVAGE Catherine Commissaire aux comptes suppléant : GOALEC Isabelle Associé commandite : VAD HOLDING. Capital : 26599646.55 EUR. Activité : Vente au détail de toutes marchandises par tous moyens notamment à distance, internet, magasin Toutes opérations de courtage d'assurances. Adresse de l’établissement principal : 12 rue de la Centenaire, 59170 Croix.
Adresse du siège social : 12 rue de la Centenaire, 59170 Croix.
Commentaires : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création. Date de commencement de l’activité : 01/05/1938. Date d’effet : 28/02/2011.

18/03/2011

JAL

Head Office Transfer

 

 

Syndicat agricole (Le)


Date de décision : 28/02/2011
Transfert du siège social de la société 475581591 -  3 SUISSES FRANCE
Adresse du nouveau siège : 12 Rue de la Centenaire, 59170 CROIX
Ancienne localisation : 4 PL DE LA REPUBLIQUE, BP 75, 59170 CROIX
Date d'effet : 28/02/2011

09/09/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

7327 - 475581591 RCS. 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société en commandite simple. Adresse : 4 place de la République 59170 Croix. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

03/09/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

482 - 475 581 591 RCS Roubaix-Tourcoing. 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société en commandite simple. Enseigne : VPC; VAD; CATALOGUE; FEMME; MODE; TEXTILE;. Sigle : 3S. Administration : Gérant : PAGANINI Laurence Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : ACEA Commissaire aux comptes suppléant : SAUVAGE Catherine Commissaire aux comptes suppléant : GOALEC Isabelle Associé commandite : VAD HOLDING. Capital : 26599646.55 EUR. Activité : Vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont correspondance téléphone, magasins toutes opérations de courtage d'assurances... vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont notamment à distance, internet, magasins. Adresse de l’établissement principal : 4 place de la République, 59170 Croix.
Adresse du siège social : 4 place de la République, 59170 Croix.
Commentaires : Changement de commissaire aux comptes. Date de commencement de l’activité : 01/05/1938. Date d’effet : 14/06/2010.

20/12/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

609 - 475 581 591 RCS Roubaix-Tourcoing. 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société en commandite simple. Enseigne : VPC; VAD; CATALOGUE; FEMME; MODE; TEXTILE;. Sigle : 3S. Administration : Gérant : PAGANINI Laurence Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : ACEA Commissaire aux comptes suppléant : BMD Associés Commissaire aux comptes suppléant : GOALEC Isabelle Associé commandite : VAD HOLDING. Capital : 26599646.55 EUR. Activité : Vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont correspondance téléphone, magasins toutes opérations de courtage d'assurances... vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont notamment à distance, internet, magasins. Adresse de l’établissement principal : 4 place de la République, 59170 Croix.
Adresse du siège social : 4 place de la République, 59170 Croix.
Commentaires : Départ de co-gérant. Date de commencement de l’activité : 01/05/1938. Date d’effet : 16/11/2009.

20/11/2009

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

LE SYNDICAT AGRICOLE


Date de décision : 16/11/2009
La société 475581591 - 3 SUISSES FRANCE, 4 PL DE LA REPUBLIQUE, BP 75, 59170 CROIX
Fait l'objet du départ de Monsieur Eric PLATIAU, 20 RUE 20 RUE DE LILLE, 59420 MOUVAUX

13/11/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

6164 - 475581591 RCS. 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société en commandite simple. Adresse : 4 place de la République 59170 Croix. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

27/08/2009

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

 

33 - GIRONDE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

115 - 487 600 686 RCS Bordeaux. MEZZO. Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle. Adresse : 4 place de la République, 59170 Croix.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce. Etablissement : Etablissemennt complémentaire. Activité : toutes prestations de services à la clientèle pour le compte de tiers. Adresse : 74 rue Georges Bonnac, Quartier Meriadeck Tour N°2, 33000 Bordeaux.
Précédent propriétaire : 3 SUISSES FRANCE. 475 581 591 RCS Roubaix-tourcoing.
Date de commencement de l’activité : 01/01/2007. Publication légale : La vie économique d'Aquitaine du 31/01/2007. Oppositions : Au Mandataire 4 PLACE DE LA REPUBLIQUE 59170 CROIX pour la validité et pour la correspondance 4 PLACE DE LA REPUBLIQUE 4 place De la république CROIX 59170 CROIX. Descriptif : Etablissement secondaire/complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 180467 Euros. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

26/08/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1889 - 475 581 591 RCS Roubaix-Tourcoing. 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société en commandite simple. Enseigne : VPC; VAD; CATALOGUE; FEMME; MODE; TEXTILE;. Sigle : 3S. Administration : Co-gérant : PLATIAU Eric Co-gérant : PAGANINI Laurence Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : ACEA Commissaire aux comptes suppléant : BMD Associés Commissaire aux comptes suppléant : GOALEC Isabelle Associé commandite : VAD HOLDING. Capital : 26599646.55 EUR. Activité : Vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont correspondance téléphone, magasins toutes opérations de courtage d'assurances... vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont notamment à distance, internet, magasins. Adresse de l’établissement principal : 4 place de la République, 59170 Croix.
Adresse du siège social : 4 place de la République, 59170 Croix.
Commentaires : Changement de gérant. Date de commencement de l’activité : 01/05/1938. Date d’effet : 07/07/2009.

08/03/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1015 - 475 581 591 RCS Roubaix-Tourcoing. 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société en commandite simple. Enseigne : VPC; VAD; CATALOGUE; FEMME; MODE; TEXTILE;. Sigle : 3S. Administration : Co-gérant : PLATIAU Eric. Co-gérant : GIRES Pascal. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes titulaire : ACEA. Commissaire aux comptes suppléant : BMD Associés. Commissaire aux comptes suppléant : GOALEC Isabelle. Associé commandite : VAD HOLDING. Capital : 26599646.55 EUR. Activité : Vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont correspondance téléphone, magasins toutes opérations de courtage d'assurances... vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont notamment à distance, internet, magasins. Adresse de l’établissement principal : 4 place de la République, 59170 Croix.
Adresse du siège social : 4 place de la République, 59170 Croix.
Commentaires : Nomination d'un co-gérant. Date de commencement de l’activité : 01/05/1938. Date d’effet : 09/02/2009.

17/02/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1222 - 475 581 591 RCS Roubaix-Tourcoing. 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société en commandite simple. Enseigne : VPC; VAD; CATALOGUE; FEMME; MODE; TEXTILE;. Sigle : 3S. Administration : Gérant non associé : PLATIAU Eric. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes titulaire : ACEA. Commissaire aux comptes suppléant : BMD Associés. Commissaire aux comptes suppléant : GOALEC Isabelle. Associé commandite : VAD HOLDING. Capital : 26599646.55 EUR. Activité : Vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont correspondance téléphone, magasins toutes opérations de courtage d'assurances... vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont notamment à distance, internet, magasins. Adresse de l’établissement principal : 4 place de la République, 59170 Croix.
Adresse du siège social : 4 place de la République, 59170 Croix.
Commentaires : Augmentation de capital. Date de commencement de l’activité : 01/05/1938. Date d’effet : 22/12/2008.

14/01/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1163 - 475 581 591 RCS Roubaix-Tourcoing. 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société en commandite simple. Enseigne : VPC; VAD; CATALOGUE; FEMME; MODE; TEXTILE;. Sigle : 3S. Administration : Gérant non associé : PLATIAU Eric. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes titulaire : ACEA. Commissaire aux comptes suppléant : BMD Associés. Commissaire aux comptes suppléant : GOALEC Isabelle. Associé commandite : VAD HOLDING. Capital : 4015053 EUR. Activité : Vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont correspondance téléphone, magasins toutes opérations de courtage d'assurances... vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont notamment à distance, internet, magasins. Adresse de l’établissement principal : 4 place de la République, 59170 Croix.
Adresse du siège social : 4 place de la République, 59170 Croix.
Commentaires : Changement de gérant. Date de commencement de l’activité : 01/05/1938. Date d’effet : 15/12/2008.

12/01/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

5640 - 475581591 RCS. 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société en commandite simple. Adresse : 4 place de la République 59170 Croix. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2006.

12/01/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

5641 - 475581591 RCS. 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société en commandite simple. Adresse : 4 place de la République 59170 Croix. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

25/10/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

9637 - 475581591 RCS. 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société en commandite simple. Adresse : 4 place de la République 59170 Croix. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2005.

24/10/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

920 - 475 581 591 RCS Roubaix-Tourcoing. 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société en commandite simple. Enseigne : VPC; VAD; CATALOGUE; FEMME; MODE; TEXTILE;. Sigle : 3S. Administration : Gérant non associé : BOUCKAERT Jean-Marie. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes titulaire : ACEA. Commissaire aux comptes suppléant : BMD Associés. Commissaire aux comptes suppléant : GOALEC Isabelle. Associé commandite : VAD HOLDING. Capital : 4015053 EUR. Activité : Vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont correspondance téléphone, magasins toutes opérations de courtage d'assurances... vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont notamment à distance, internet, magasins. Adresse de l’établissement principal : 4 place de la République, 59170 Croix.
Adresse du siège social : 4 place de la République, 59170 Croix.
Commentaires : Changement de l'objet et de l'activité. Date de commencement de l’activité : 01/05/1938. Date d’effet : 25/06/2008.

10/10/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1159 - RCS Roubaix-Tourcoing B 475 581 591. RC 55-B 159. 3 SUISSES FRANCE. Forme : S.C.S. Capital : 4 015 053 euros. Nom commercial : VPC VAD Catalogue Femme Mode Textile. Adresse du siège social : 4 place de la République,, 59170 Administration : gérant non associé : BOUCKAERT (Jean-Marie). Commissaires aux comptes titulaires : K.P.M.G. S.A. ACEA. Commissaires aux comptes suppléants : BMD ASSOCIES Mme GOALEC (Isabelle). Associé en commandite : VAD HOLDING. Ancienne administration : ancien commissaire aux comptes suppléant : PEROT (Bernard). Etablissement principal - Activité : vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont par correspondance, téléphone et en magasins toutes opérations de courtage d'assurances . Adresse : 4 place de la République, 59170 Date d'effet : 26 juin 2007.

20/09/2007

Bodacc A

Vente et cession

 

 

828 - RCS B 475 581 591. RC 07-B 525. 3 SUISSES FRANCE. Forme : S.C.S. Adresse du siège social : 4 place de la République, 59170 Croix. Etablissement secondaire - Activité : vente de tous produits par tous moyens, dont la vente à distance et directe, de textile. Adresse : 10 ter -12 rue Adrien-Dubouche, 87000 Limoges. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 470 000 euros. Date de début d'activité : 1er septembre 2007. Précédent propriétaire : BANCO MJC ENSEIGNE MANGO. RCS 420 146 748. Publication légale : Le Courrier français du 13 juillet 2007. Oppositions : Me Maury (Jean-Charles), avocat, 67 boulevard Gambetta, 87000 Limoges.

24/06/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1036 - RCS Roubaix-Tourcoing B 475 581 591. RC 55-B 159. 3 SUISSES FRANCE. Forme : S.C.S. Capital : 4 015 053 euros. Nom commercial : VPC VAD Catalogue Femme Mode Textile. Adresse du siège social : 4 place de la République,, 59170 Etablissement principal - Activité : vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont la correspondance ou le téléphone et toutes opérations de courtage d'assurances. Adresse : 4 place de la République, 59170 Etablissement principal - nouvelle situation - Adjonction d'activité : vente au détail en magasins. Date d'effet : 16 avril 2007.

10/05/2007

Bodacc A

Vente et cession

 

 

1054 - RCS Toulouse B 487 600 686. RC 07-B 1532. MEZZO. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 4, place de la République, 59170 Croix. Etablissement secondaire - Activité : activité de vente au détail de toutes marchandises dont correspondance téléphone est comprise dans l'activité de toutes prestations de services. Adresse : 214, route de Saint Simon, 31100 Toulouse. Fonds secondaire acquis par achat au prix stipulé de 180 467 euros . Date de début d'activité : 1er janvier 2007. Précédent propriétaire : 3 SUISSES FRANCE. RCS 475 581 591. Publication légale : La Gazette du Midi du 16 avril 2007 . Oppositions : au siège du fonds vendu: 214 route de saint simon, 31000 Toulouse.

21/03/2007

Bodacc A

Vente et cession

 

 

0636 - RCS B 487 600 686. MEZZO. Forme : S.A.S. Capital : 37 000 euros. Adresse du siège social : 4 place de la République, 59170 Croix. Administration : P.-D.G. : SCHIPPERS (Paul). Etablissement principal - Activité : exploitation de deux centres d'appel. Adresse : 4 place de la République, 59170 Croix. Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 180 467 euros. Date d'effet : 1er janvier 2007. Précédent propriétaire : 3 SUISSES FRANCE S.C.S. RCS B 475 581 591. Publication légale : La Gazette Nord-Pas de Calais du 1er février 2007. Oppositions : au fonds, 4 place de la République, 59170 Croix.

15/01/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1239 - RCS Roubaix-Tourcoing B 475 581 591. RC 55-B 159. 3 SUISSES FRANCE. Forme : S.C.S. Capital : 4 015 053 euros. Nom commercial : VPC VAD Catalogue Femme Mode Textile. Adresse du siège social : 4 place de la République,, 59170 Administration : gérant non associé : BOUCKAERT (Jean-Marie). Commissaires aux comptes titulaires : K.P.M.G. S.A. ACEA. Commissaires aux comptes suppléants : BMD ASSOCIES PEROT (Bernard). Associé en commandite : VAD HOLDING. Ancienne administration : ancien gérant non associé : DESJOBERT (Xavier). Etablissement principal - Activité : vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont la correspondance ou le téléphone et toutes opérations de courtage d'assurances. Adresse : 4 place de la République, 59170 Date d'effet : 30 novembre 2005.

30/12/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

3112 - RCS Roubaix-Tourcoing B 475 581 591. RC 55-B 159. 3 SUISSES FRANCE. Forme: société en commandite simple. . Adresse du siège social: 4, place de la République,59170 Croix. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

25/12/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1142 - RCS Roubaix-Tourcoing B 475 581 591. RC 55-B 159. 3 SUISSES FRANCE. Forme : S.C.S. Capital : 4 015 053 euros. Nom commercial : VPC VAD Catalogue Femme Mode Textile. Adresse du siège social : 4 place de la République,, 59170 Administration : gérant non associé : DESJOBERT (Xavier). Commissaires aux comptes titulaires : K.P.M.G. S.A. ACEA. Commissaires aux comptes suppléants : BMD ASSOCIES PEROT (Bernard). Associé en commandite : VAD HOLDING. Ancienne administration : ancien commissaire aux comptes titulaire : STE CABINET BRACQ. Etablissement principal - Activité : vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont la correspondance ou le téléphone et toutes opérations de courtage d'assurances. Adresse : 4 place de la République, 59170 Date d'effet : 27 octobre 2005.

01/10/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 475581591 RC 55- B 159 3 SUISSES FRANCE. Forme : S.C.S. Capital : 4 015 053 euros Nom commercial: VPC VAD Catalogue Femme Mode Textile. Adresse du siège social : 4 place de la République, 59170 Croix. Administration : gérant non associé : DESJOBERT (Xavier). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET BRACQ ET ASSOCIES STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES K.P.M.G. S.A. Commissaires aux comptes suppléants : BMD ASSOCIES PEROT ( Bernard). Associé en commandite : VAD HOLDING. Ancienne administration : ancien commissaire aux comptes suppléant : DESURMONT (Jean, Marie) Etablissement principal: Activité : vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont la correspondance ou le téléphone et toutes opérations de courtage d'assurances. Adresse : 4 place de la République, 59170 Croix. Date d'effet : 24 juin 2004.

02/03/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 475581591 RC 55- B 159 3 SUISSES FRANCE. Forme : S.C.S. Capital : 4 015 053 euros Nom commercial: VPC Vad Catalogue Femme Mode Textile. Adresse du siège social : 4 place de la République, 59170 Croix Etablissement principal: Activité : vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont vente par correspondance et par téléphone. Adresse : 4 place de la République, 59170 Croix ETABLISSEMENT PRINCIPAL nouvelle situation Adjonction d'activité: toutes opérations de courtage d'assurances. Date d'effet : 2 février 2004.

02/01/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 475581591 RC 55-B 159 3 SUISSES FRANCE. Forme : S.C.S. Capital : 28 678 950 F. Adresse : 4 place de la République, 59170 Croix. Administration : gérant non associé : DESJOBERT (Xavier). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET BRACQ ET ASSOCIES-STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES K.P.M.G. S.A. Commissaires aux comptes suppléants : DESURMONT (Jean, Marie) PEROT (Bernard). Ancien commissaire aux comptes suppléant : RIVIERE (Gérard). Ancien commissaire aux comptes titulaire : LA FIDUCIAIRE DE FRANCE. Ancien associé en commandite : S.A. VAD HOLDING Nouvelle situation du siège social. Capital : 4 015 053 euros Etablissement principal: Activité : vente au détail de toutes marchandises, par tous moyens, dont la correspondance téléphonique. Adresse : 4 place de la République, 59170 Croix. Commentaires : augmentation du capital et conversion en euros. Date d'effet : 29 aout 2001.

14/02/2001

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS Paris B 432371086 RC 00-B 12317 FASHION LIVE. Forme : S.A. Capital : 500 000 F Nom commercial: Concept Live. Activité : exploitation, création de sites Internet, commerce, presse et édition électronique, notamment dans le domaine de la mode vestimentaire, des accessoires, du design, des objets de décoration, ainsi que dans les domaines et les styles de vie en général. Conception, vente, mise en place, hébergement, maintenance de logiciels et de contenus. Toutes opérations y afférentes. Eléments d'actifs sur un site internet "Placemonde.com". Adresse du siège social : 82 rue Beaubourg, 75003 Paris Eléments d'actifs acquis par achat au prix stipulé de 2 F. Date d'effet : 30 janvier 2001 Précédents propriétaires 3 SUISSES INTERNATIONAL. RCS Roubaix-Tourcoing B 477180467 3 SUISSES FRANCE. RCS Roubaix-Tourcoing B 475581591 Publication légale: La Gazette du Nord du 23 janvier 2001. Oppositions : au siège de la société des 3 SUISSES, 4 place de la République, 59170 Croix.

14/05/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 475581591 RC 55-B 159 3 SUISSES FRANCE. Forme : S.C.S. Capital : 28 678 950 F. Adresse : 4 place de la République, 59170 Croix Etablissement principal: Activité : vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont la correspondance téléphone. Adresse : 4 place de la République, 59170 Croix Nouvelle situation du siège social Nom commercial: V.P.C V.A.D Catalogue Femme Mode Textile Habillement Maison Habitation Lingerie Vetement Jouet Sport Linge de Maison Féminin. Date d'effet : 19 avril 2000.

10/02/2000

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS Tours B 475581591 A dater du: 24 janvier 2000 RC 2000-B 65 3 SUISSES FRANCE. Forme : Société en commandite simple. Adresse du siège social : 4, place de la République 59170 Croix ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente au détail de toutes marchandises par tous moyens dont correspondance, téléphone. Adresse : 32, rue Nationale 37000 Tours Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 2 000 000 F Date de début d'activité: 1 e r janvier 2000. Précédent propriétaire : MARIE-HELENE. RCS B 401024054 Publication légale: Courrier Français de Touraine du 14 janvier 2000. Oppositions : cabinet Cojef, 81, rue de Boisdenier, 37000 Tours.

07/12/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 475 581 591 RC 55-B 159 3 SUISSES FRANCE. Forme : société en commandite simple. Capital : 28 678 950 F. Adresse du siège social : 4 place de la République 59170 Croix. Administration : gérant non associé : RICHARD (Daniel). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET BRACQ ET ASSOCIES-STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES LA FIDUCIAIRE DE FRANCE. Commissaires aux comptes suppléants : DESURMONT (Jean- Marie) RIVIERE (Gérard). Ancien associé en commandite : 3 SUISSES INTERNATIONAL Etablissement principal: Activité : vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont la correspondance et le téléphone. Adresse : 4 place de la République 59170 Croix. Date d'effet : 28 aout 1997.

07/12/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 475 581 591 RC 55-B 159 3 SUISSES FRANCE. Forme : S.C.S. Capital : 28 678 950 F. Adresse du siège social : 4 place de la République 59170 Croix. Administration : gérant non associé : DAIGNES (Thierry). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET BRACQ ET ASSOCIES-STE D' EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES LA FIDUCIAIRE DE FRANCE. Commissaires aux comptes suppléants : DESURMONT (Jean-Marie) RIVIERE ( Gérard). Ancien gérant non associé : RICHARD (Daniel) Etablissement principal: Activité : vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont correspondance et téléphone. Adresse : 4 place de la République 59170 Croix. Date d'effet : 2 octobre 1997.

12/11/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 475 581 591 RC 55-B 159 3 SUISSES FRANCE. Forme : S.A. Capital : 28 334 805 F. Adresse : 4 place de la République 59170 Croix. Administration : gérant non associé : RICHARD (Daniel). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET BRACQ ET ASSOCIES STE D' EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES FIDUCIAIRE DE FRANCE. Commissaires aux comptes suppléants : DESURMONT (Jean, Marie) RIVIERE ( Gérard) Nouvelle situation du siège social. Forme : société en commandite simple. Capital : 28 678 950 F Etablissement principal: Activité : vente au détail de toutes marchandises par tous moyens, dont correspondance téléphonique. Adresse : 4 place de la République 59170 Croix. Date d'effet : 28 aout 1996.

27/10/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 475 581 591 RC 55-B 159 3 SUISSES FRANCE. Forme : S.A. Capital : 28 334 805 F. Adresse du siège social : 4 place de la République 59170 Croix. Administration : P.-D.G. : RICHARD (Daniel). Administrateurs : 3 SUISSES INTERNATIONAL BASQUAISE DE COURTAGE COFIDIS PARTICIPATIONS MONIEZ ( Jacques). Ancien représentant de la STE BEAUTE CREATEURS PARTICIPATIONS, administrateur : ZECCHINI (Pierre). Nouveau : MONIEZ (Jacques). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET BRACQ ET ASSOCIES-STE D' EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES FIDUCIAIRE DE FRANCE. Commissaires aux comptes suppléants : DESURMONT (Jean, Marie) RIVIERE ( Gérard) Etablissement principal: Adresse : 4 place de la République 59170 Croix. Date d'effet : 25 juin 1996.

03/06/1996

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

RCS Roubaix B 475 581 591 S.A. 3 SUISSES FRANCE. Forme : S.A. Capital : 28 334 805 F. Adresse du siège social : 4 place de la République, 59- Croix Droit au bail dépendant du fonds principal acquis par cession, au prix stipulé de 400 000 F Etablissement principal: Adresse : 28 place Ducale, à l'angle de la rue du Moulin, 08000 Charleville-Mézières. Date d'effet : 15 avril 1996 Précédente propriétaire- exploitante S.A. GEORGES MARCUS. RCS Charleville-Mézières B 785 620 220 Publication légale: Les Petites Affiches Matot Braine du 10 mai 1996. Oppositions : S.C.P. Conreur Drappier Charlier Laurent et Conreur, 1 bis rue de Lorraine, 08000 Charleville-Mézières.

14/07/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS o. RCS Roubaix-Tourcoing B 475 581 591 RC RC 55-B 159 3 SUISSES FRANCE. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 28 334 805 F. Adresse du siège social : 4, place de la République 59170 Croix. Administration : président- directeur général : RICHARD (Daniel) Administrateurs : 3 SUISSES INTERNATIONAL BASQUAISE DE COURTAGE COFIDIS PARTICIPATIONS MONIEZ ( Jacques) BEAUTE CREATEURS PARTICIPATIONS. Commissaires aux comptes titulaires : CABINET BRACQ ET ASSOCIES SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES LA FIDUCIAIRE DE FRANCE. Commissaires aux comptes suppléants : DESURMONT (Jean- Marie) RIVIERE (Gérard). Anciens administrateurs : COFIDIS BANQUE COVEFI Etablissement principal: Adresse : 4, place de la République 59170 Croix Date de début d'activité: 1er mai 1938. Date d'effet : 24 mars 1995.

26/04/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 475 581 591 RC 55-B 159 3 SUISSES FRANCE. Forme : S.A. Capital : 28 334 805 F. Adresse du siège social : 4 place de la République 59170 Croix. Administration : P.-D.G. : RICHARD (Daniel). Administrateurs : 3 SUISSES INTERNATIONAL BASQUAISE DE COURTAGE COMPAGNIE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION BANQUE COVEFI MONIEZ ( Jacques). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET BRACQ ET ASSOCIES- STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES FIDUCIAIRE DE FRANCE. Commissaires aux comptes suppléants : DESURMONT (Jean, Marie) RIVIERE (Gérard). Ancien président du conseil d'administration : D'ANDRE ( Emmanuel). Ancien directeur général : RICHARD (Daniel) Etablissement principal: Adresse : 4 place de la République 59170 Croix. Date d'effet : 7 février 1995.

 

 

SHARE & SHARE CAPITAL INFORMATION

 

Na

 

 

GROUP STRUCTURE & AFFILIATED COMPANIES

 

Ultimate Holding Company

 

Company Name

 

 

Company number

 

 

SCA VALMA

 

 

351813233

8 companies in 4 countries.

 

 

Ultimate Parent

1 ultimate parent company for this company
>  SCA VALMA  - Fonds de placement et entités financières similaires (6430Z)  in ROUBAIX  (59100)

 

Group data

 

 

Ultimate parent company

SCA VALMA

Direct parent

COMMERCE BTOC - 99.8 %

Group – Number of companies

224

Linkages – Number of companies

8

Number of countries

4

 

Go directly to the current company

Display only where participation % > 33 %

Display all participations

This company is a part of several groups, choose the group you wish to see the structure

Display the group

SCA VALMA

 

 

Company Name

 

SIREN

Parts

Limit

Last account published

SCA VALMA

 

351813233

-

250 000 €

-

SURAUMARCHE

 

519087837

100%

250 000 €

-

AUMARCHE

 

439529512

100%

250 000 €

31/12/2009

GROUPE AUCHAN

 

476180625

57.12%

250 000 €

31/12/2011

RT MART INTERNATIONAL

 

-

61%

-

-

AUCHAN FINANCES

 

420017006

100%

270 000 €

31/12/2011

IMMOCHAN

 

428803746

100%

320 000 €

31/12/2011

IMMOCHAN FRANCE

 

969201532

100%

250 000 €

31/12/2010

SERVICIMMOG

 

410777643

50%

16 000 €

-

SCI IMMOCHAMP

 

431816289

93.75%

-

-

DES FRAIS FONDS

 

442686952

Min blocking

-

-

CITANIA

 

480076298

100%

14 000 €

31/12/2011

MAS COSTE

 

439099748

Min blocking

500 €

31/12/2010

IMMOPROXI

 

384812061

100%

7 900 €

31/12/2011

AUX NOUVELLES BOUTIQUES

 

410410468

100%

135 000 €

31/12/2011

SNC LA GARENNE

 

479326316

50%

2 000 €

-

SCI BAGGERSEE OUEST

 

778843425

46.63%

-

-

STRATANIM

 

480076215

100%

5 800 €

31/12/2011

MARRELIMMO

 

422904409

99.99%

57 500 €

31/12/2011

GALLERIE COMMERCIALI ITALIA SPA

 

-

100%

-

-

IMMOCHAN ESPANA

 

-

100%

-

-

IMMOCHAN MAGYARORSZAG

 

-

100%

-

-

IMMOCHAN ALAPOK

 

-

95%

-

-

ALINEA

 

345197552

85.69%

250 000 €

31/12/2010

SAFIPAR

 

444409551

100%

250 000 €

31/12/2010

SOCIETE DE DISTRIBUTION REGI...

 

487702961

100%

2 600 €

31/12/2010

SOCIETE DE DISTRIBUTION COMM...

 

487702896

100%

0 €

31/12/2010

SARCELDIS

 

407755230

100%

250 000 €

31/12/2010

SOCIETA ITALIANA DISTRIBUZIONE MODERNA

 

-

99%

-

-

AUCHAN ITALIA

 

-

99%

-

-

SMA

 

-

97%

-

-

AUCHANHYPER

 

410408959

100%

250 000 €

31/12/2010

ORGANISATION INTRA-GROUPE DE...

 

421982745

99.89%

2 000 000 €

31/12/2011

ALCAMPO

 

-

100%

-

-

ZENALCO

 

-

100%

-

-

ZENOR ESPAGNE

 

-

95%

-

-

REDARPA

 

-

95%

-

-

AUCHAN HOLDING USA

 

-

100%

-

-

AUCHAN

 

-

100%

900

-

SOFINANCE

 

417572955

100%

4 100 €

31/12/2011

AUCHAN LUXEMBOURG

 

B45515

100%

300 000 €

31/12/2010

GALERIE DE KIRCHBERG

 

-

96%

-

-

AUCHAN INTERNATIONAL S.A.

 

B73616

100%

-

-

AUCHAN MAGYARDRSZÀG

 

-

100%

-

-

AUCHAN FRANCE

 

410409460

100%

250 000 €

31/12/2010

SERVICIMMOG

 

410777643

50%

16 000 €

-

AUCHAN CARBURANT

 

379548001

100%

250 000 €

31/12/2010

PETROVEX

 

317007342

100%

250 000 €

31/12/2010

GIE AUCHAN INTERNATIONAL T...

 

422332312

100%

16 000 €

31/12/2011

EURAUCHAN

 

410410260

78.30%

250 000 €

31/12/2010

DISTICKET

 

422628289

66%

250 000 €

30/09/2009

TICKETNET

 

412888133

34%

0 €

30/09/2005

AUCHAN ASSURANCES

 

422231100

99.99%

30 000 €

31/12/2010

SOC POUR COMMERCIALISATION...

 

312668692

100%

250 000 €

31/12/2010

CENTRALE DE SERVICES AUCHA...

 

340143668

79.31%

16 000 €

-

MONDIAL TRAVEL

 

400669768

100%

0 €

31/12/2010

SOGEP

 

381491323

65.79%

-

-

AUCHAN TELECOM

 

480067719

100%

0 €

31/12/2010

SOMARVRAC

 

481977460

Min blocking

250 000 €

31/12/2010

AU COMMERCE RENNAIS

 

504697228

100%

500 €

31/12/2010

MIROIR DU SOLEIL

 

507763712

100%

3 800 €

31/12/2011

AUCHAN SERVICES A DOMICILE

 

498062702

100%

2 800 €

31/12/2010

BDL

 

-

100%

-

-

AUCHAN PORTUGAL

 

-

100%

-

-

ISENBOURG

 

-

100%

-

-

ALVERCA HIPERMERCADOS

 

-

100%

-

-

SINTRAPARQUE

 

-

100%

-

-

MENDES E.COSTA

 

-

100%

-

-

MULTICENCO

 

-

100%

-

-

OMNIA CONSTRUTORA

 

-

100%

-

-

PAO DE AÇUCAR

 

-

100%

-

-

COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCARDOS

 

-

100%

-

-

AUCHAN HIPERMERCADO PORTUGAL

 

-

100%

-

-

FLOORAGEST IMOBILIARIA

 

-

100%

-

-

PLANCO

 

-

100%

-

-

RESIMOVEL

 

-

100%

-

-

EMPREENDIMENTOS DO CARNAVIAL

 

-

100%

-

-

AUCHAN POLSKA

 

-

100%

-

-

AUCHAN ESPANA

 

-

100%

-

-

SUN ART RETAIL

 

-

50%

-

-

SCHIEVER POLSKA

 

-

50%

-

-

SOGEPAR

 

433713963

100%

250 000 €

31/12/2011

AUCHAN RUSSIE

 

-

100%

-

-

AUCHAN NEDVIZHIMOST

 

-

100%

-

-

RUSSKIE PRODUKTY TRADING COMPLEX

 

-

100%

-

-

STOYINVEST ALPHA

 

-

100%

-

-

STROYINVEST BETA

 

-

100%

-

-

DRAYCOTT

 

-

100%

-

-

CHRONODRIVE

 

433513892

90%

0 €

31/12/2004

AUCHAN CHINE HONG KONG

 

-

67%

-

-

SOPARALINEA

 

345127583

82.58%

250 000 €

31/12/2010

BANQUE ACCORD

 

546380197

98%

250 000 €

-

ONEY IFIC

 

-

100%

-

-

ACCORD FINANCE

 

-

60%

-

-

ACCORD ITALIA

 

-

100%

-

-

ONEY FINANCE

 

-

100%

-

-

ACCORD MAGYARORSZÀG

 

-

100%

-

-

ACCORDFIN

 

-

51%

-

-

ACCORD BUSINESS CONSULTING COMPANY

 

-

100%

-

-

GEFIRUS

 

483303228

60%

210 000 €

31/12/2010

BA FINANS

 

-

100%

-

-

ONEY COURTAGE

 

503428989

100%

16 000 €

31/12/2010

ONEY CESSATION LIMITED

 

IE452426

100%

-

31/12/2010

ONEY MVL LIMITED

 

IE452472

100%

-

31/12/2010

ONEY UKRAINE

 

-

100%

-

-

ONEY INVESTMENT

 

521009357

100%

4 600 €

-

ARONDE

 

-

100%

-

-

INTERNATIONAL SUPERMARKET STOR...

 

674801329

97%

250 000 €

31/12/2010

FREMARC

 

342281409

100%

250 000 €

31/12/2010

SODIPAR

 

444410773

100%

0 €

31/12/2010

ISMS POLSKA

 

-

60%

-

-

ELEA

 

-

60%

-

-

ATAC

 

410409015

99%

250 000 €

31/12/2010

SA CHOLDIS

 

383272226

100%

500 €

31/12/2010

COUSTE

 

439974551

100%

0 €

31/12/2010

SOMADIS SOC MAGDUNOISE D...

 

442726923

100%

220 000 €

31/12/2010

SODIMA

 

433701554

100%

850 €

31/12/2010

PASCAL

 

439974502

100%

5 100 €

31/12/2010

CACHAN DISTRIBUTION

 

339544314

93%

5 200 €

31/12/2010

PAREA

 

481020022

100%

250 000 €

31/12/2010

SABECO SA

 

-

97%

-

-

S.I. LACANAU

 

-

100%

-

-

SABEKO BANAKETA

 

-

100%

-

-

SERCO ASTOR

 

-

100%

-

-

EL ASTORGANO

 

-

100%

-

-

CESARAUGUSTA

 

-

100%

-

-

SABEKO EUSKADI

 

-

100%

-

-

SUPER LAUKO

 

-

100%

-

-

AUCHAN COORDINATION SERVICES S...

 

878922641

100%

75 000 000 €

31/12/2011

LITTLE EXTRA

 

480089853

100%

0 €

31/12/2010

ORGANISATION INTERNATIONALE DES ACHATS

 

-

100%

-

-

ATAK

 

-

97%

-

-

FCAU

 

-

100%

-

-

AUCHAN-E-COMMERCE INTERNATIONA...

 

480075431

100%

250 000 €

31/12/2010

GROSBILL

 

420437311

100%

240 000 €

31/12/2010

AUCHAN E-COMMERCE FRANCE

 

413176033

100%

0 €

31/12/2010

SOPACCORD

 

487947863

65.87%

-

-

SOPARATAC

 

429389687

34.97%

-

-

SURBOLEM

 

519087928

Majority

250 000 €

-

BOLEM

 

439529140

66%

250 000 €

31/12/2009

HIGH TECH MULTICANAL GROUP

 

478613169

94%

16 000 €

31/12/2009

BOULANGER

 

347384570

100%

250 000 €

31/12/2009

CLIXITY

 

482339645

100%

250 000 €

31/12/2008

WEBDISTRIB

 

443041926

100%

0 €

31/12/2007

STOCK MENAGER SERVICE

 

451220677

100%

250 000 €

31/12/2008

CAP BOULANGER HOLDING

 

349210237

100%

0 €

31/12/2010

CAP BOULANGER

 

392327607

100%

0 €

31/12/2010

LOKEO

 

509637161

100%

250 000 €

-

VENDIDO

 

494707482

Majority

0 €

31/12/2009

SOPAR-HTM

 

422194811

Majority

250 000 €

31/12/2010

SURHOLYMPIADES

 

519088231

Majority

250 000 €

31/12/2009

DECATHLON

 

306138900

43%

250 000 €

31/12/2010

COROT

 

488981531

Majority

250 000 €

31/12/2008

DEVELOP MOBILIER INDUSTRIEL

 

442112371

Min blocking

-

-

SOC CIVILE DE LA PORTE DE LYON

 

783881907

Min blocking

-

-

SURFIPAR

 

519088124

Majority

250 000 €

31/12/2009

SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATIO...

 

313455610

Majority

250 000 €

31/12/2009

TROIS SUISSES INTERNATIONAL

 

477180467

44%

1 550 000 €

31/12/2011

BEAUTE CREATEURS PARTICIPATION...

 

393258298

91.63%

145 000 €

31/12/2010

YI MEI JA SHANGHAI TRADING

 

-

50%

-

-

COMMERCE BTOB

 

398259853

100%

250 000 €

31/12/2011

JM. BRUNEAU

 

343958138

99.99%

250 000 €

31/12/2010

ORGA SYSTEM

 

308549310

99.99%

97 500 €

31/12/2010

OTTO OFFICE FRANCE

 

404451494

100%

0 €

31/12/2010

JM BRUNEAU ESPANA

 

-

100%

-

-

DIREXI

 

351746094

99.99%

540 000 €

31/12/2011

COMMERCE BTOC

 

408536928

Majority

250 000 €

31/12/2010

3 SUISSES FRANCE

 

475581591

99.80%

0 €

31/12/2010

3S ASSURANCES

 

349807388

90%

65 000 €

31/12/2011

CIDAL

 

552019697

99.80%

110 000 €

31/12/2010

COGEDAC SNC

 

309495299

99.99%

250 000 €

31/12/2011

MONDIAL RELAY

 

385218631

100%

0 €

31/12/2011

CITE NUMERIQUE

 

377559646

99.99%

0 €

31/12/2003

COGEMAG

 

475580437

99.87%

0 €

31/12/2005

3 SUISSES VOYAGES

 

389655978

99.80%

0 €

31/12/2011

EQUIPAR

 

378176473

99.99%

250 000 €

31/12/2010

XPL

 

332211739

99.98%

0 €

31/12/2010

CIE INTERNATIONALE VENTE A DIS...

 

321008013

100%

250 000 €

31/12/2010

ZABOR SARL

 

-

100%

-

-

BECQUET

 

466500683

100%

250 000 €

31/12/2010

CONTENTIA FRANCE

 

348967332

100%

250 000 €

31/12/2010

ID3SI

 

434279600

99.94%

800 €

31/12/2011

MARTINTER

 

487602740

100%

250 000 €

31/12/2011

COFIDIS PARTICIPATIONS

 

378176291

44%

250 000 €

31/12/2003

CREATIS

 

419446034

100%

250 000 €

-

COFIDIS ARGENTINE

 

-

66%

-

-

COFIDIS

 

325307106

100%

250 000 €

-

COFIDIS BELGIQUE

 

-

100%

-

-

SOC DE CREDIT A LA CONSO...

 

341888998

100%

250 000 €

-

COFIDIS CESKA

 

-

100%

-

-

COFIDIS ITALIE

 

-

100%

-

-

COFIDIS SLOVAQUIE

 

-

100%

-

-

COFIDIS ROUMANIE

 

-

100%

-

-

MONABANQ

 

341792448

100%

250 000 €

-

ARIANTA

 

519190136

100%

0 €

31/12/2010

CAVABANQUE

 

339019275

99.99%

1 200 €

31/12/2003

SODEREC

 

344364666

100%

-

-

HAPPY CHIC

 

509508628

100%

50 000 €

31/12/2010

BRICE

 

312560584

100%

250 000 €

31/12/2010

DISTRIBUTION TEXTILE HENNUYE...

 

477722228

100%

-

31/12/2011

SCI BONNEUIL

 

348867615

100%

-

-

JULES INTERNATIONAL

 

480057736

99%

-

31/12/2010

JULES

 

305154262

94%

250 000 €

31/12/2010

JULES SPAIN

 

-

100%

-

-

JULES SRL

 

-

100%

-

-

SODISTRI

 

344124177

100%

65 000 €

31/12/2009

GARGANO

 

494308356

Min blocking

-

-

SURLEBRICO

 

519088348

Min blocking

250 000 €

-

SURHOLKIA

 

519088199

Majority

250 000 €

-

HOLKIA

 

508941739

Min blocking

250 000 €

31/12/2009

SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION LOUIS MULLIEZ L...

 

-

Majority

-

-

SURMUFIL

 

519088512

Min blocking

0 €

31/12/2009

SURESTAG

 

519088033

Min blocking

250 000 €

-

PIMINVEST

 

353526551

Min blocking

-

-

SOPARTHLON B

 

351819248

Min blocking

250 000 €

31/12/2008

SURTAPIMA

 

519088611

Majority

250 000 €

31/12/2009

TAPIMA

 

439528910

Majority

250 000 €

31/12/2009

TAPIS SAINT MACLOU

 

470500943

81%

250 000 €

31/12/2010

MONDIAL MOQUETTE

 

328412440

100%

0 €

31/12/2011

MONDIAL SERVICES

 

383929783

100%

0 €

31/12/2011

SAINT MACLOU

 

-

100%

-

-

TAPIS INVESTISSEMENT

 

326464997

57.85%

-

-

FILUNOR SA

 

-

Min blocking

-

-

HAPED BV

 

-

Min blocking

-

-

 

Linkages

Ultimate parent company

SCA VALMA

Direct parent

COMMERCE BTOC - 99.8 %

Group – Number of companies

224

Linkages – Number of companies

8

Number of countries

4

Company Name

 

 

SIREN

Last account

 

Limit

Turnover

SPORTSTOCK LIMITED

 

 

03883733

31/12/2011

 

100 000 £

1 632 000 £

DECATHLON UK LIMITED

 

 

03140144

31/12/2011

 

60 000 £

76 166 000 £

AUCHAN II HOLDING UK LTD

 

 

06277184

31/12/2011

 

50 000 £

-

UNIGRET B.V.

 

 

34228434

31/12/2011

 

1 950 000 €

-

MAASOORD B.V.

 

 

34269365

31/12/2011

 

9 100 000 €

-

IMMOCHAN II HOLDING UK LTD

 

 

06277183

31/12/2011

 

-

-

COFIDIS SA

 

 

400359283

31/12/2011

 

67 950 000 €

43 592 394 €

CAISSE AUCHAN ITALIE SA

 

 

879996173

31/12/2011

 

305 000 €

-

 

 

FINANCIAL INFORMATION

 

Trading to Date

12/31/2010

12/31/2009

12/31/2008

Turnover

702,033,886 €

719,585,427 €

843,989,093 €

Gross Operating Surplus

-10,37 % Turnover

-7,59 % Turnover

-3,55 % Turnover

Shareholders’ equity

-58,094,659 €

-103,127,935 €

19,409,762 €

Net result

-76,860,996 €

-134,698,065 €

-15,350,936 €

Employees

2 000 to 4 999 employees

-

-

 


accounts

Active Account |  Passive Account |  Account Results

 

Synthesized Accounts

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

Comparison mode

Average

Median

 

 

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

 

Account period (month)

12

 

12

 

12

 

 

Account Type

Normal

 

Normal

 

Normal

 

 

Deposit date

19/10/2011

 

14/10/2010

 

29/10/2009

 

 

Activity Code

4791A

 

4791A

 

4791A

 

 

Employees

0

 

2853

 

0

 

 


Active account

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

13 096 289

27,0%

10 308 924

-76,3%

43 500 126

4 023

325435,4%

- Intangible assets

9 293 560

-2,1%

9 493 978

-1,7%

9 661 630

09

103261677,8%

- Tangible assets

3 790 332

1485,8%

239 017

-99,2%

30 446 302

960

394726,2%

- Financial assets

1 510 177

-3,0%

1 556 235

-54,1%

3 392 194

0

0%

Net current assets

233 800 107

39,4%

167 764 305

-25,7%

225 769 635

40 858

572126,0%

- Stocks

113 289 481

42,9%

79 291 761

-15,8%

94 126 722

6 878

1647028,2%

- Advanced payments

313 575

39,4%

136 164

-22,0%

174 526

0

0%

- Receivables

115 449 361

33,7%

86 367 015

-26,6%

117 602 535

6 945,50

1662118,1%

- Securities and cash

4 747 688

141,1%

1 969 365

-85,8%

13 865 850

8 469

55959,6%

- Prepaid expenses

-

-

-

-

-

0

-

Accounts of regularization

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total Assets

246 896 396

38,6%

178 073 228

-33,9%

269 269 762

50 199

491735,3%


Passive Account

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Shareholders' equity

-58 094 659

43,7%

-103 127 935

-631,3%

19 409 762

8 173

-710911,9%

Share capital

26 599 646

0%

26 599 646

0%

26 599 646

7 624

348793,6%

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

42 236 590

-12,8%

48 417 005

198,6%

16 212 957

0

0%

Liabilities

262 754 462

12,9%

232 784 155

-0,4%

233 647 038

39 248

669372,2%

- Financial liabilities

69 883 531

-15,3%

82 522 833

8,5%

76 087 446

2 765

2527333,3%

- Advanced payments received

694 092

-12,1%

789 620

4,4%

756 519

0

0%

- Trade account payables

143 090 788

54,5%

92 629 722

-0,5%

93 091 511

8 256

1733073,3%

- Tax and social liabilities

24 781 395

-14,7%

29 048 252

-14,4%

33 939 014

7 647

323966,9%

- Other debts and fixed assets liabilities

16 864 271

-9,5%

18 643 628

-10,4%

20 817 865

3 696,50

456122,7%

Account regularization

7 440 385

-18,7%

9 150 100

2,2%

8 954 683

0

0%

Total liabilities

246 896 395

38,6%

178 073 228

-33,9%

269 269 761

50 552

488300,8%


Results

Annual Accounts

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Sales of Goods

734 215 551

-2,6%

753 638 779

-13,9%

875 291 701

79 331,50

925403,2%

Net turnover

702 033 886

-2,4%

719 585 427

-14,7%

843 989 093

77 404

906873,7%

- of which net export turnover

96 200 880

0,0%

96 164 815

-6,3%

102 651 743

0

0%

Operating charges

807 507 901

0,0%

807 660 918

-11,3%

910 361 236

82 908

973880,7%

Operating profit/loss

-73 292 350

-35,7%

-54 022 139

-54,0%

-35 069 535

-347

-21121614,7%

Financial income

8 287 780

-11,9%

9 402 091

-38,4%

15 273 856

0

0%

Financial charges

10 148 548

-4,4%

10 621 145

9,4%

9 709 782

60,50

16774359,5%

Financial profit/loss

-1 860 768

-52,6%

-1 219 054

-121,9%

5 564 074

0

0%

Pretax net operating income

-75 153 118

-36,0%

-55 241 193

-87,2%

-29 505 461

-453,50

-16571701,1%

Extraordinary income

42 491 547

230,9%

12 842 492

-34,6%

19 629 933

0

0%

Extraordinary charges

44 203 141

-52,1%

92 370 166

1576,9%

5 508 237

0

0%

Extraordinary profit/loss

-1 711 594

3,4%

-79 527 674

-663,2%

14 121 696

0

0%

Net result

-76 860 996

42,9%

-134 698 065

-777,5%

-15 350 936

0

0%


 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

 

Normal Account

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Months

 

12

 

12

 

12


Accounts - Active
Current Assets |  Equalization accounts |  Reference

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Grand Total (I to VI)

Net

246 896 396

38,6%

178 073 228

-33,9%

269 269 762

 

Gross

CO

368 488 322

21,2%

304 097 217

-15,7%

360 907 280

 

Amortisation

1A

121 591 926

-3,5%

126 023 989

37,5%

91 637 518


Non declared distributed capital (I)

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AA

0

0%

0

0%

0


Active fixed asset (II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total Active fixed asset (II)

Net

13 096 289

27,0%

10 308 924

-76,3%

43 500 126

 

Gross

BJ

114 820 741

-0,8%

115 760 940

3,9%

111 389 698

 

Amortisation

BK

101 724 452

-3,5%

105 452 016

55,3%

67 889 572


Intangilble fixed assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R & D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AE

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

243 881

-45,1%

444 299

-27,4%

611 951

 

Gross

AF

5 937 124

1,3%

5 859 280

3,6%

5 655 330

 

Amortisation

AG

5 693 243

5,1%

5 414 981

7,4%

5 043 379

Goodwill

Net

7 551 895

-6,4%

8 069 369

-10,8%

9 049 679

 

Gross

AH

9 049 679

0%

9 049 679

0%

9 049 679

 

Amortisation

AI

1 497 784

52,8%

980 310

0%

0

Other intangible fixed assets

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AJ

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AK

0

0%

0

0%

0

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible Assets

Net

7 795 776

-8,4%

8 513 668

-11,9%

9 661 630



Tangilble fixed assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Lands

Net

12 562

0%

0

0%

148 497

 

Gross

AN

1 176 078

1,2%

1 162 618

0,6%

1 155 748

 

Amortisation

AO

1 163 516

0,1%

1 162 618

15,4%

1 007 251

Buildings

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AP

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AQ

0

0%

0

0%

0

Plant

Net

269 153

0%

0

0%

5 499 385

 

Gross

AR

19 563 041

-5,7%

20 737 825

-0,5%

20 839 286

 

Amortisation

AS

19 293 888

-7,0%

20 737 825

35,2%

15 339 901

Other tangible fixed assets

Net

2 746 176

0%

0

0%

23 978 373

 

Gross

AT

75 038 144

-0,4%

75 372 230

7,0%

70 462 170

 

Amortisation

AU

72 291 968

-4,1%

75 372 230

62,1%

46 483 797

Fixed assets in construction

Net

144 941

186,4%

50 610

0%

0

 

Gross

AV

144 941

186,4%

50 610

0%

0

 

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

617 500

227,7%

188 407

-77,0%

820 047

 

Gross

AX

617 500

227,7%

188 407

-77,0%

820 047

 

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Tangible asset

Net

3 790 332

 

239 017

 

30 446 302



Financial assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

958 588

0%

958 588

-64,9%

2 729 005

 

Gross

CU

2 742 640

0%

2 742 640

-0,1%

2 744 249

 

Amortisation

CV

1 784 052

0%

1 784 052

11603,3%

15 244

Inter-company receivables

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BC

0

0%

0

0%

0

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

Loans

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BF

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BG

0

 

0

 

0

Other financial assets

Net

551 589

-7,7%

597 647

-9,9%

663 189

 

Gross

BH

551 589

-7,7%

597 647

-9,9%

663 189

 

Amortisation

BI

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Financial Assets

 

1 510 177

 

1 556 235

 

3 392 194

 

Current Assets (III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total Assets

Net

233 800 107

39,4%

167 764 305

-25,7%

225 769 635

 

Gross

CJ

253 667 581

34,7%

188 336 274

-24,5%

249 517 578

 

Amortisation

CK

19 867 474

-3,4%

20 571 969

-13,4%

23 747 943



Stocks

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Raw materials

Net

8 140 659

-16,7%

9 777 793

-3,5%

10 135 881

 

Gross

BL

9 826 505

-14,7%

11 516 047

-5,5%

12 184 082

 

Amortisation

BM

1 685 846

-3,0%

1 738 254

-15,1%

2 048 201

Work in progress (goods)

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BN

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BR

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BS

0

0%

0

0%

0

Goods for resale

Net

105 148 822

51,3%

69 513 968

-17,2%

83 990 841

 

Gross

BT

120 220 026

42,8%

84 186 987

-16,6%

100 988 347

 

Amortisation

BU

15 071 204

2,7%

14 673 019

-13,7%

16 997 506

 

Sub Total Stocks

Net

113 289 481

42,9%

79 291 761

-15,8%

94 126 722



Advance payments to suppliers

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Advance payments to suppliers

Net

313 575

130,3%

136 164

-22,0%

174 526

 

Gross

BV

313 575

130,3%

136 164

-22,0%

174 526

 

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0



Debtors

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Trade accounts receivable

Net

54 117 624

33,1%

40 667 116

-30,2%

58 245 710

 

Gross

BX

56 732 119

29,3%

43 877 439

-27,9%

60 889 270

 

Amortisation

BY

2 614 495

-18,6%

3 210 323

21,4%

2 643 560

Other debtors

Net

49 523 073

26,8%

39 054 022

-26,2%

52 913 117

 

Gross

BZ

50 019 001

25,0%

40 004 395

-27,2%

54 971 793

 

Amortisation

CA

495 928

-47,8%

950 373

-53,8%

2 058 676

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Debtors

Net

103 640 697

30,0%

79 721 138

-28,3%

111 158 827



Divers

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CD

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

4 747 688

141,1%

1 969 365

-85,8%

13 865 850

 

Gross

CF

4 747 688

141,1%

1 969 365

-85,8%

13 865 850

 

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Divers

Net

4 747 688

141,1%

1 969 365

-85,8%

13 865 850



Prepaid expenses

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Prepaid expenses

Net

11 808 664

77,7%

6 645 877

3,1%

6 443 708

 

Gross

CH

11 808 664

77,7%

6 645 877

3,1%

6 443 708

 

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts (IV to VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Multi-period charges

CW3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

0%

0

 

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

0%

0

 

Currency differential gain

CN3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

0%

0

 

References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

 

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Accounts - Passive
Other capital resources | Provisions for risks and charges | Liabilities | Translation loss | Equalization accounts | References

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Grand Total (I to V)

EE

246 896 395

38,6%

178 073 228

-33,9%

269 269 761


Shareholder Equity (I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total shareholders' equity (Total I)

DL

-58 094 659

43,7%

-103 127 935

-631,3%

19 409 762

 

Equity and shareholders' equity

DA

26 599 646

0%

26 599 646

0%

26 599 646

 

Issue and merger premiums

DB

77 824

0%

77 824

0%

77 824

 

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

 

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

 

Legal reserve

DD

0

0%

0

0%

0

 

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

 

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

 

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

 

Other reserves

DG

0

0%

0

0%

0

 

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

 

0

0%

0

 

Profits or losses brought forward

DH

-20 290 976

-91,2%

-10 609 875

-11,3%

-9 529 531

 

Profit or loss for the period

DI

-76 860 996

42,9%

-134 698 067

-777,5%

-15 350 935

 

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

 

Special tax-allowable reserves

DK

12 379 843

-20,1%

15 502 537

-12,0%

17 612 758

 

Other capital resources (II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

 

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

 

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

 

Provisions for risks and charges (III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

42 236 590

-12,8%

48 417 005

198,6%

16 212 957

 

Risk provisions

DP

17 058 839

-13,5%

19 728 430

170,6%

7 291 073

 

Reserves for charges

DQ

25 177 751

-12,2%

28 688 575

221,6%

8 921 884

 

Liabilities (IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total Liabilities (Total IV)

EC

262 754 462

12,9%

232 784 155

-0,4%

233 647 038

 

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

 

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

 

Bank loans and liabilities

DU

28 957 109

56,6%

18 485 428

-49,2%

36 377 072

 

Sundry loans and financial liabilities

DV

40 926 422

-36,1%

64 037 405

61,3%

39 710 374

 

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

 

Advance payments received for current orders

DW

694 092

-12,1%

789 620

4,4%

756 519

 

Trade accounts payables

DX

143 090 788

54,5%

92 629 722

-0,5%

93 091 511

 

Tax and social security liabilities

DY

24 781 395

-14,7%

29 048 252

-14,4%

33 939 014

 

Fixed asset liabilities

DZ

299 413

34,3%

222 942

-84,4%

1 427 855

 

Other debts

EA

16 564 858

-10,1%

18 420 686

-5,0%

19 390 010

 

Translation loss (V)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Translation loss (Total V)

ED

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Deferred income

EB

7 440 385

-18,7%

9 150 100

2,2%

8 954 683

 

References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

 

Deferred income and liabilities

EG

260 835 409

14,6%

227 644 201

-0,2%

228 115 139

 

Of which current bank facilities

EH

28 957 109

56,8%

18 466 493

-49,2%

36 377 072

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Result account
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges | Financial income | Financial charges | Financial charges | Extraordinary charges | Employee profit sharing | Tax on profits | References

1- Operating result (I-II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Operating result (Total I-II)

GG

-73 292 350

-35,7%

-54 022 139

-54,0%

-35 069 535


2 - Financial result (V - VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Financial result (Total V-VI)

GV

-1 860 768

-52,6%

-1 219 054

-121,9%

5 564 074


3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

-75 153 118

-36,0%

-55 241 193

-87,2%

-29 505 461


4 - Extraordinary result (VII-VIII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

-1 711 594

97,8%

-79 527 674

-663,2%

14 121 696


Profit or loss

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Profit or loss

HN

-76 860 996

42,9%

-134 698 065

-777,5%

-15 350 936


Total Income (I+III+V+VII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total Income (I+III+V+VII)

HL

784 994 878

1,2%

775 883 362

-14,8%

910 195 490


Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

861 855 873

-5,4%

910 581 427

-1,6%

925 546 426


Operating income (I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total operating income (Total I)

FR

734 215 551

-2,6%

753 638 779

-13,9%

875 291 701


Operating income (details)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sale of goods for resale

FC

540 834 297

-4,4%

565 467 759

-13,3%

652 010 716

 

France

FA

462 394 433

-5,1%

487 311 796

-14,5%

569 653 092

 

Export

FB

78 439 864

0,4%

78 155 963

-5,1%

82 357 624

Sale of goods produced

FF

52 842 771

12,9%

46 819 377

-4,4%

48 990 999

 

France

FD

37 863 497

17,7%

32 173 504

0,3%

32 076 788

 

Export

FE

14 979 274

2,3%

14 645 873

-13,4%

16 914 211

Sale of services

FI

108 356 818

1,0%

107 298 291

-25,0%

142 987 378

 

France

FG

105 575 076

1,6%

103 935 312

-25,6%

139 607 470

 

Export

FH

2 781 742

-17,3%

3 362 979

-0,5%

3 379 908

Net turnover

FL

702 033 886

-2,4%

719 585 427

-14,7%

843 989 093

 

France

FJ

605 833 006

-2,8%

623 420 612

-15,9%

741 337 350

 

Export

FK

96 200 880

0,0%

96 164 815

-6,3%

102 651 743

 

Stocked production

FM

0

0%

0

0%

0

 

Self-constructed assets

FN

0

0%

0

0%

0

 

Operating grants

FO

0

0%

0

0%

0

 

Release of reserves and provisions

FP

25 903 550

-4,0%

26 988 099

27,8%

21 123 287

 

Other income

FQ

6 278 115

-11,1%

7 065 253

-30,6%

10 179 321


Operating charges (II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total operating charges (Total II)

GF

807 507 901

0,0%

807 660 918

-11,3%

910 361 236


Exploitation charges

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Purchase of goods for resale

FS

337 088 477

17,1%

287 892 894

-20,2%

360 735 252

 

Change in stocks of goods for resale

FT

-36 033 039

-314,5%

16 801 360

465,5%

-4 597 067

 

Purchase of raw materials

FU

66 446 187

8,1%

61 495 420

-19,9%

76 776 338

 

Change in stocks of raw materials

FV

1 689 542

152,9%

668 034

-84,0%

4 169 311

 

Other external purchases and charges

FW

315 363 089

4,4%

302 176 745

-5,1%

318 551 664

 

Tax, duty and similar payments

FX

5 540 784

-12,6%

6 340 917

-34,4%

9 659 148

 

Payroll

FY

60 784 225

-13,3%

70 072 221

-9,4%

77 337 617

 

Social security costs

FZ

23 968 031

-16,6%

28 734 260

-8,2%

31 284 990


Depreciation

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Depreciation of fixed assets

GA

4 348 023

-1,4%

4 409 131

15,0%

3 834 465

 

Amortisation of fixed assets

GB

517 474

0%

0

0%

0

 

Depreciation/amortisation of current assets

GC

19 685 583

-1,4%

19 958 765

-16,0%

23 747 944

 

Provisions for risks and charges

GD

3 500 428

9,6%

3 194 003

239,1%

942 010


Other charges

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Other charges

GE

4 609 097

-22,1%

5 917 168

-25,3%

7 919 564

 

Operating charges (III-IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

 

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

 

Financial income (V)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total financial income (Total V)

GP

8 287 780

-11,9%

9 402 091

-38,4%

15 273 856

 

Share financial income

GJ

2 321 300

-28,0%

3 224 763

31,9%

2 445 515

 

Other investment income & capitalised receivables

GK

0

0%

0

0%

0

 

Other interest and similar income

GL

5 845 722

-2,2%

5 977 310

-27,9%

8 292 453

 

Released provisions and transferred charges

GM

0

0%

0

0%

0

 

Exchange gains

GN

120 758

-39,6%

200 018

-95,6%

4 535 888

 

Net income from disposal of investment securities

GO

0

0%

0

0%

0

 

Financial Charge (VI)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total financial charge (Total VI)

GU

10 148 548

-4,4%

10 621 145

9,4%

9 709 782

 

Financial reserves and provisions

GQ

462 138

-73,9%

1 768 807

0%

0

 

Interest and similar charges

GR

8 865 120

2,7%

8 630 386

-8,8%

9 468 187

 

Exchange losses

GS

821 290

270,0%

221 952

-8,1%

241 595

 

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

 

Financial Charge (VII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total extraordinary income (Total VII)

HD

42 491 547

230,9%

12 842 492

-34,6%

19 629 933

 

Extraordinary operating income

HA

1 773 490

3584,9%

48 128

-99,6%

13 020 970

 

Extraordinary income from capital transactions

HB

62 579

-91,6%

743 770

89,8%

391 945

 

Released provisions and transferred charges

HC

40 655 478

237,4%

12 050 594

93,8%

6 217 018

 

Extraordinary charges (VIII)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

44 203 141

-52,1%

92 370 166

1576,9%

5 508 237

 

Extraordinary operating charges

HE

16 640 390

6,6%

15 615 221

1751,7%

843 310

 

Extraordinary charges from capital transactions

HF

951 694

-26,4%

1 292 379

25,1%

1 032 801

 

Extraordinary reserves and provisions

HG

26 611 057

-64,7%

75 462 566

1977,6%

3 632 126

 

Employee profit sharing (IX)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

0

0%

0

0%

0

 

Tax on profits (X)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Tax on profits (Total X)

HK

-3 717

94,8%

-70 802

-115,7%

-32 829

 

References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

 

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

 

Of which transferred charges

A1

1 444 382

181,2%

513 726

-40,1%

857 997

 

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

82 613

6,5%

77 550

-0,1%

77 650

 

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

38 869

-94,7%

735 893

1,0%

728 750

 

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Other incomer tax return forms
Reserve for depreciation | Provisions included in balance sheet | State deadlines claims and debts at the end of period
Table allocation results and other information

Fixed Assets
Grand Total Fixed Assets (I to IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

OK2

5 017 000

-34,3%

7 642 000

0%

0

 

Gross value at the end of period

OL

114 821 000

-0,8%

115 761 000

0%

0


Research and development Charge (Total I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

C01

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

C02

0

0%

0

0%

0

 

Gross value at the end of period

D0

0

0%

0

0%

0


Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

KD

14 909 000

1,4%

14 705 000

0%

0

 

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

78 000

-97,9%

3 711 000

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

LV2

0

0%

3 507 000

0%

0

 

Gross value at the end of period

LW

14 987 000

0,5%

14 909 000

0%

0


Tangible fixed assets (Total III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

LN

97 512 000

4,5%

93 277 000

0%

0

 

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

3 983 000

-51,8%

8 256 000

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NG2

4 956 000

23,3%

4 021 000

0%

0

 

Gross value at the end of period

NH

96 539 000

-1,0%

97 512 000

0%

0


Fiancial assets (Total IV)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

LQ

3 341 000

-1,9%

3 407 000

0%

0

 

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

15 000

-68,1%

47 000

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NJ2

61 000

-47,0%

115 000

0%

0

 

Gross value at the end of period

NK

3 295 000

-1,3%

3 339 000

0%

0

 

Reserve for depreciation
Situation and movement of reserve for depreciation
Grand total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

0N

0

0%

0

0%

0

Increases

0P

0

0%

0

0%

0

Decreasess

0Q

0

0%

0

0%

0

 

Reserve for depreciation value at the end of period

0R

0

0%

0

0%

0


Research and development charge (Total I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0


Other intangible assets (Total II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

6 396 000

26,8%

5 044 000

0%

0

Increases

PF

796 000

-41,1%

1 352 000

0%

0

Decreasess

PG

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PH

7 192 000

12,4%

6 396 000

0%

0


Total fixed assets amotisation (Total III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

97 273 000

54,8%

62 830 000

0%

0

Increases

QV

4 070 000

-88,8%

36 449 000

0%

0

Decreases

QW

8 594 000

328,4%

2 006 000

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

QX

92 749 000

-4,7%

97 273 000

0%

0


Movements during period affecting charge allocated over several period
Charges à répartir ou frais d'émission d'emprunt

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0


Premium refund of obligations

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Net value at begining of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

 

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

 

Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

7C

63 919 000

89,0%

33 824 000

0%

0

Increases

UB

30 575 000

-47,2%

57 948 000

0%

0

Decreases

UC

39 876 000

43,2%

27 854 000

0%

0

 

Value at the end of period

UD

54 618 000

-14,5%

63 918 000

0%

0

Includes Total allocations

 

Operating

UE

0

0%

0

0%

0

 

Financial

UG

0

0%

0

0%

0

 

Exceptional

UJ

0

0%

0

0%

0

Includes Total Withdrawal

 

Operating

UF

0

0%

0

0%

0

 

Financial

UH

0

0%

0

0%

0

 

Exceptional

UK

0

0%

0

0%

0


Total regulated provisions (Total I)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

3Z

15 503 000

-12,0%

17 613 000

0%

0

Increases

TS

765 000

-41,7%

1 312 000

0%

0

Decreases

TT

3 888 000

13,6%

3 422 000

0%

0

 

Value at the end of period

TU

12 380 000

-20,1%

15 503 000

0%

0


Total risk and charge provisions (Total II)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

5Z

48 416 000

198,6%

16 212 000

0%

0

Increases

TV

29 810 000

-47,4%

56 637 000

0%

0

Decreases

TW

35 988 000

47,3%

24 433 000

0%

0

 

Value at the end of period

TX

42 238 000

-12,8%

48 416 000

0%

0


Total Provision for depreciation (Total III)

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

7B

0

0%

0

0%

0

Increases

TY

0

0%

0

0%

0

Decreases

TZ

0

0%

0

0%

0

 

Value at the end of period

UA

0

0%

0

0%

0

 

State deadlines claims and debts at the end of period
State claims

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Gross value

VT

119 111 000

30,7%

91 125 000

0%

0

 

1 year at most

VU

118 559 000

31,0%

90 527 000

0%

0

 

More than one year

VV

552 000

-7,7%

598 000

0%

0


State of loans

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Claims related to holdings (gross)

UL

0

0%

0

0%

0

 

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

0%

0

0%

0

 

Loans (gross)

UP

0

0%

0

0%

0

 

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

0

0%

0

 

Other financial assets (gross)

UT

552 000

-7,7%

598 000

0%

0

 

Other financial assets (1 year at most)

UV

0

0%

0

0%

0


Receivables statement of assets

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Customers doubtful or disputed

VA

2 514 000

-4,3%

2 626 000

0%

0

 

Other claims customer

UX

54 219 000

31,4%

41 252 000

0%

0

 

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

 

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

 

Personnel and associated accounts

UY

334 000

-22,5%

431 000

0%

0

 

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

0

0%

0

 

Income taxes

VM

9 000

12,5%

8 000

0%

0

 

Value added tax

VB

12 695 000

63,3%

7 775 000

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

VN

1 005 000

7630,8%

13 000

0%

0

 

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

1 700 000

0%

0

 

Group and Associates

VC

3 464 000

-78,0%

15 717 000

0%

0

 

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

32 513 000

126,4%

14 360 000

0%

0


Prepaid

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Prepaid

VS

11 809 000

77,7%

6 646 000

0%

0


State Debt

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total debt (gross)

VY

262 060 000

13,0%

231 995 000

0%

0

1 year at most

VZ2

260 141 000

13,3%

229 616 000

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

1 919 000

-19,3%

2 379 000

0%

0

More than 5 years

VZ4

0

0%

0

0%

0


Details

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

28 957 000

56,7%

18 485 000

0%

0

1 year at most

VG2

28 957 000

56,7%

18 485 000

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VH2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8A2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8A3

0

0%

0

0%

0

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

143 091 000

54,5%

92 630 000

0%

0

1 year at most

8B2

143 091 000

54,5%

92 630 000

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8B3

143 091 000

54,5%

92 630 000

0%

0

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

10 575 000

-10,6%

11 829 000

0%

0

1 year at most

8C2

10 575 000

-10,6%

11 829 000

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

10 229 000

-19,5%

12 704 000

0%

0

1 year at most

8D2

10 229 000

-19,5%

12 704 000

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (gross)

VW1

1 157 000

-42,8%

2 022 000

0%

0

1 year at most

VW2

1 157 000

-42,8%

2 022 000

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

2 821 000

13,2%

2 493 000

0%

0

1 year at most

VQ2

2 821 000

13,2%

2 493 000

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

299 000

34,1%

223 000

0%

0

1 year at most

8J2

299 000

34,1%

223 000

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

40 926 000

-36,1%

64 037 000

0%

0

1 year at most

VI2

40 926 000

-36,1%

64 037 000

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More 5 years

VI4

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

16 565 000

-10,1%

18 421 000

0%

0

1 year at most

8K2

16 565 000

-10,1%

18 421 000

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

9 150 000

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

6 771 000

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

2 379 000

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

7 440 000

0%

0

0%

0

1 year at most

8L2

5 521 000

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8L3

1 919 000

0%

0

0%

0


References

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Loans made during the period

VJ

0

0%

0

0%

0

 

Debt repaid during the period

VK

0

0%

0

0%

0

 

Table allocation results and other information
Dividends distributed

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0


Commitments

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

 

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

 

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0


Other charges Externes

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

 

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

 

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

 

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

 

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

 

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

 

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0


Taxes and Fees

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

 

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0


VAT

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

 

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0


Average number of employees

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Average number of employees

YP

0

0%

2 853

0%

0


Groups and Shareholders

 

 

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Groups and Shareholders

ZR

0

-

0

-

-

 

 

 

Display parameter

Comparison mode

Average

Median


Ratios
Structure and liquidity | Management or rotation | Profitability of the business | Return on capital

Structure and Liquidity

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Fixed Asset Financing

1,10

11,1%

0,99

-23,3%

1,29

1,95

-43,6%

Global Debt

135 days

16,4%

116 days

16,0%

100 days

142 days

-4,9%

Working Capital Fund overall net

6 days

0%

0 days

0%

14 days

46 days

-87,0%

Financial independence

-200,62%

64,0%

-557,89%

-1145,5%

53,36%

94,74%

-311,8%

More ratios

Solvability

-23,53%

59,4%

-57,91%

-903,2%

7,21%

21,19%

-211,0%

Capacity debt futures

-200,62%

64,0%

-557,90%

-

%

434,05%

-146,2%

Coverage of current assets by net working capital overall

4,95%

1034,0%

-0,53%

-104,0%

13,10%

33%

-85,0%

General Liquidity

0,46

17,9%

0,39

-

 

0,24

91,7%

Restricted Liquidity

0,47

17,5%

0,40

-

 

0,73

-35,6%


Management or rotation

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Need background in operating working capital

16 days

77,8%

9 days

-62,5%

24 days

-5 days

420,0%

Treasury

-12 days

-50,0%

-8 days

20,0%

-10 days

3 days

-500%

Inventory turnover of goods

144 days

45,5%

99 days

-2,9%

102 days

85 days

69,4%

Average length of credit granted to customers

29 days

31,8%

22 days

-15,4%

26 days

6 days

383,3%

Average length of credit obtained suppliers

75 days

50,0%

50 days

13,6%

44 days

44,50 days

68,5%

More ratios

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

24 days

-20,0%

30 days

7,1%

28 days

0 days

0%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

727 days

-1,5%

738 days

-

days

5070 days

-85,7%

Rotation tangible assets

727,20%

-1,5%

737,95%

-

%

1622,15%

-55,2%


Profitability of the business

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Margin trading

34,15%

-5,8%

36,24%

3,4%

35,06

34,64%

-1,4%

Profitability of the business

-10,37

-36,6%

-7,59

-113,8%

-3,55

1,19%

-971,4%

Net profit

-10,95%

41,5%

-18,72%

-928,6%

-1,82%

0,35%

-3228,6%

More ratios

Growth rate of turnover (excluding VAT)

-2,44%

83,4%

-14,74%

-782,6%

-1,67%

4,45%

-154,8%

Rates integration

2,49%

-64,6%

7,03%

-32,9%

10,47%

11,42%

-78,2%

Rate leasing furniture

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Work Factor

484,86%

148,1%

195,46%

59,0%

122,94%

8,28%

5755,8%

Weight interests

1,45

-2,0%

1,48%

28,7%

1,15%

0,07%

1971,4%


Return on capital

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Cash flow from the overall profitability

-6,27%

14,1%

-7,30%

-748,8%

-0,86%

1,45%

-532,4%

Rates of economic profitability

-618%

-333,2%

265%

954,8%

-31%

14%

-4514,3%

Financial profitability

-58094659%

43,7%

-103127935%

-631,3%

19409762%

91,46%

-63519298,6%

Return on investment

-565,89%

-194,0%

602,17%

10289,0%

-5,91%

10,05%

-5730,7%

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

Comparison mode

Average

Median


Soldes Intermédiaires de Gestion

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2010

 

Turnover

702 033 886

-2,4%

719 585 427

-14,7%

843 989 093

77 404 € 

906873,7% 

 

Sales of goods

540 834 297

-4,4%

565 467 759

-13,3%

652 010 716

 

 

- Purchase of goods

337 088 477

17,1%

287 892 894

-20,2%

360 735 252

 

 

+/- Stock of goods variation

-36 033 039

-314,5%

16 801 360

465,5%

-4 597 067

 

 

Trading margin

239 778 859 €

-8,1%

260 773 505 €

-11,9%

295 872 531 €

17 750 € 

1350766,8% 

 

34,15 % CA

-5,8%

36,24 % CA

3,4%

35,06 % CA

35,89 % CA 

-4,8% 

 

Sale of goods produced

161 199 589

4,6%

154 117 668

-19,7%

191 978 377

 

 

+/- Stocked production

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Self-constructed assets

0

0%

0

0%

0

 

 

Period production

161 199 589 €

4,6%

154 117 668 €

-19,7%

191 978 377 €

2 144 € 

7518537,5% 

 

22,96 % CA

7,2%

21,42 % CA

-5,8%

22,75 % CA

8,63 % CA 

166,0% 

 

Trading margin

239 778 859

-8,1%

260 773 505

-11,9%

295 872 531

17 750 

1350766,8% 

+ Period Production

161 199 589

4,6%

154 117 668

-19,7%

191 978 377

2 144 

7518537,5% 

- Purchase of raw materials

66 446 187

8,1%

61 495 420

-19,9%

76 776 338

 

 

+/- Change in stocks of raw materiels

1 689 542

152,9%

668 034

-84,0%

4 169 311

 

 

- Other external purchases and charges

315 363 089

4,4%

302 176 745

-5,1%

318 551 664

 

 

Added value

17 479 630 €

-65,4%

50 550 974 €

-42,8%

88 353 595 €

6 177,50 € 

282856,4% 

 

2,49 % CA

-64,6%

7,03 % CA

-32,9%

10,47 % CA

11,42 % CA 

-78,2% 

 

Added value

17 479 630 €

-65,4%

50 550 974 €

-42,8%

88 353 595 €

6 177,50 € 

282856,4% 

+ Operating grants

0

0%

0

0%

0

 

 

-          Tax, duty and similar payment

-          s

5 540 784

-12,6%

6 340 917

-34,4%

9 659 148

 

 

- Personal charges

84 752 256

-14,2%

98 806 481

-9,0%

108 622 607

 

 

Gross operating surplus

-72 813 410 €

-33,4%

-54 596 424 €

-82,4%

-29 928 160 €

259 € 

-28113385,7% 

 

-10,37 % CA

-36,6%

-7,59 % CA

-113,8%

-3,55 % CA

1,19 % CA 

-971,4% 

 

Gross operating surplus

-72 813 410 €

-33,4%

-54 596 424 €

-82,4%

-29 928 160 €

259 € 

-28113385,7% 

+ Release of reserves and provisions

25 903 550

-4,0%

26 988 099

27,8%

21 123 287

 

 

+ Other operating income

6 278 115

-11,1%

7 065 253

-30,6%

10 179 321

 

 

- Depreciation/Amortisation

28 051 508

1,8%

27 561 899

-3,4%

28 524 419

 

 

- Other charges

4 609 097

-22,1%

5 917 168

-25,3%

7 919 564

 

 

Operating result

-73 292 350 €

-35,7%

-54 022 139 €

-54,0%

-35 069 535 €

-347 € 

-21121614,7% 

 

-10,44 % CA

-39,0%

-7,51 % CA

-80,5%

-4,16 % CA

0,37 % CA 

-2921,6% 

 

Operating result

-73 292 350 €

-35,7%

-54 022 139 €

-54,0%

-35 069 535 €

-347 € 

-21121614,7% 

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Financial income

8 287 780

-11,9%

9 402 091

-38,4%

15 273 856

 

 

- Financial charges

10 148 548

-4,4%

10 621 145

9,4%

9 709 782

 

 

Pre-tax result

-75 153 118 €

-36,0%

-55 241 193 €

-87,2%

-29 505 461 €

-453,50 € 

-16571701,1% 

 

-10,71 % CA

-39,5%

-7,68 % CA

-119,4%

-3,50 % CA

-00,02 % CA 

-53450,0% 

 

Extraordinary income

42 491 547

230,9%

12 842 492

-34,6%

19 629 933

0% 

- Extraordinary charges

44 203 141

-52,1%

92 370 166

1576,9%

5 508 237

 

 

Extraordinary result

-1 711 594 €

97,8%

-79 527 674 €

-663,2%

14 121 696 €

0 € 

0% 

 

-0,24 % CA

97,8%

-11,05 % CA

-761,7%

2 % CA

0 % CA 

0% 

 

Pre-tax result

-75 153 118 €

-36,0%

-55 241 193 €

-87,2%

-29 505 461 €

-453,50 € 

-16571701,1% 

Extraordinary result

-1 711 594 €

97,8%

-79 527 674 €

-663,2%

14 121 696 €

0 € 

0% 

- Employee profit sharing

0

0%

0

0%

0

 

 

- Tax on profits

-3 717

94,8%

-70 802

-115,7%

-32 829

 

 

Net result

-76 860 995 €

42,9%

-134 698 065 €

-777,5%

-15 350 936 €

-01,50 € 

-5124066233,3% 

-10,95 % CA

41,5%

-18,72 % CA

-928,6%

-1,82 % CA

0,30 % CA 

-3750,0% 

 

 

ADDITIONAL INFORMATION

 

 

Trends

 

 

Profitability

 

Liquidity

 

Net worth

 

 

 

 

Company details

 

 

 

 

Activity (APE)

Vente à distance sur catalogue général (4791A)

 

RCS Registration

RCS Roubaix-Tourcoing 5 475 581 591

Share capital

49,375,851 Euros

 

Registration Court

Roubaix-Tourcoing (59)

Legal form

Public limited company with board of directors

 

Court Registry Number

19 5 5B001

EUR VAT Number

FR12475581591

 

Incorporation Date

08/1955

Formation Date

01/1955

 

Deregistration Date

 

Last account Date

31/12/2010

 

Nationality

France

Type

Head office

Status

Economically active

 

 

Formation Date

 

Reason for formation

 

 

 

Closure Date

 

Reason for closure

 

 

 

Reactivation Date

 

Production Role

 

 

 

Activity Nature

 

Activity Location

 

 

 

Location surface

 

Seasonality

 

 

 

 

 

 

Department

Nord (59)

Region

Nord-Pas-de-Calais

 

District

5

Area

54

 

City

CROIX

Size of urban area

Urban unit with 200 000 to 1 999 999 inhabitants

 

 

 

Other establishments

 

 

 

 

Branches

49 branch entities in this company

 

 

 

Head office

 
> 3 SUISSES FRANCE <<<  - Vente à distance sur catalogue général (4791A)  in CROIX  (59170)
 

 

 

Secondary establishments

>  3 SUISSES FRANCE  - Vente à distance sur catalogue général (4791A)  in CROIX  (59170)
>  3 SUISSES FRANCE  - Vente à distance sur catalogue général (4791A)  in VILLENEUVE D'ASCQ  (59491)
>  3 SUISSES FRANCE  - Vente à distance sur catalogue général (4791A)  in WASQUEHAL  (59290)
>  3 SUISSES FRANCE  - Vente à distance sur catalogue général (4791A)  in WASQUEHAL  (59290)
> ...

 

 

 

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas having at least 80% of workforce in same area

 

 

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which one activity grouping from 80 to 99% of workforce

 

 

 

Workforces

 

 

 

 

Workforce at address

500 to 999 employees

Company workforce

2 000 to 4 999 employees

 

event history

 

 

Status history

 

 

 

Date

Description

28/02/2011

Economically active

 

Company events history

 

 

Date

Description

08/10/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

27/09/2012

Minutes of Board meeting

27/09/2012

Reconstitution of net assets

07/09/2012

Disengagement of the group

07/09/2012

New ultimate parent

22/08/2012

Other modification of Establishment

11/07/2012

Continuation of business despite loss of equity

11/06/2012

Legal Gazette: Continuation of activity

06/04/2012

Disengagement of the group

18/03/2012

Bodacc B: Various editing or changing

08/03/2012

Bodacc A : Sale and transfer

02/03/2012

Minutes of Board meeting

02/03/2012

Changes to the Board of Directors

02/03/2012

New chairman (CEO, CoB)

02/03/2012

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

21/02/2012

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

02/02/2012

Legal Gazette: Appointment of the social representative

31/01/2012

Bodacc B: Various editing or changing

20/01/2012

Minutes of general meeting of shareholders

20/01/2012

Capital increase

20/01/2012

Updated articles of association

30/12/2011

Other modification of Establishment

15/12/2011

Legal Gazette: Modification of the share capital

20/10/2011

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

18/10/2011

Bodacc C : Deposit accounts notice

15/09/2011

Bodacc B: Various editing or changing

05/09/2011

Minutes of Board meeting

05/09/2011

Minutes of general meeting of shareholders

05/09/2011

New chairman (CEO, CoB)

05/09/2011

Updated articles of association

05/09/2011

Changes to the Board of Directors

29/08/2011

Amendment

29/08/2011

Capital reduction

29/08/2011

Capital increase

29/08/2011

Minutes of general meeting of shareholders

30/06/2011

Update of Company Legal Form

30/06/2011

Other modification of Establishment (error correction)

10/06/2011

Other modification of Establishment

03/06/2011

Bodacc B: Various editing or changing

12/05/2011

Minutes of general meeting of shareholders

12/05/2011

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

12/05/2011

Updated articles of association

18/03/2011

Legal Gazette: Head Office Transfer

04/03/2011

New ultimate parent

28/02/2011

Transfer of Establishment

28/02/2011

Update of Company Head Office Identifier

31/12/2010

New accounts available

09/09/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

03/09/2010

Bodacc B: Various editing or changing

23/08/2010

Updated articles of association

23/08/2010

New auditor

23/08/2010

Minutes of general meeting of shareholders

13/08/2010

Update of participations in other companies

13/08/2010

New ultimate parent

31/12/2009

New accounts available

20/12/2009

Bodacc B: Various editing or changing

08/12/2009

Appointment/resignation of company officers

20/11/2009

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

13/11/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

27/08/2009

Bodacc A : Sale and transfer

26/08/2009

Bodacc B: Various editing or changing

14/08/2009

Appointment/resignation of company officers

14/08/2009

New manager

14/08/2009

Private document

14/08/2009

Changement de Gérant

14/08/2009

Minutes of general meeting of shareholders

14/08/2009

PV d'Assemblée

21/07/2009

Private document

21/07/2009

Acte sous seing privé

21/07/2009

Sale of shares

21/07/2009

Cession de parts

21/07/2009

Minutes of general meeting of shareholders

21/07/2009

Updated articles of association

21/07/2009

Statuts mis à jour

21/07/2009

PV d'Assemblée

08/03/2009

Bodacc B: Various editing or changing

08/03/2009

New Bodacc B ads detected

23/02/2009

Minutes of general meeting of shareholders

23/02/2009

Private document

23/02/2009

Appointment/resignation of company officers

23/02/2009

Nomination/démission des organes de gestion

23/02/2009

PV d'Assemblée

17/02/2009

Bodacc B: Various editing or changing

17/02/2009

New Bodacc B ads detected

03/02/2009

Private document

03/02/2009

Augmentation de Capital

03/02/2009

Capital increase

03/02/2009

Updated articles of association

03/02/2009

PV d'Assemblée

03/02/2009

Statuts mis à jour

03/02/2009

Minutes of general meeting of shareholders

14/01/2009

Bodacc B: Various editing or changing

14/01/2009

New Bodacc B ads detected

12/01/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

31/12/2008

New manager

31/12/2008

Appointment/resignation of company officers

31/12/2008

Private document

31/12/2008

Minutes of general meeting of shareholders

31/12/2008

PV d'Assemblée

31/12/2008

New accounts available

31/12/2008

Changement de Gérant

16/12/2008

Private document

16/12/2008

Sale of shares

16/12/2008

Cession de parts

16/12/2008

Acte sous seing privé

25/10/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

24/10/2008

New Bodacc B ads detected

24/10/2008

Bodacc B: Various editing or changing

14/10/2008

Private document

14/10/2008

Statuts mis à jour

14/10/2008

Updated articles of association

14/10/2008

Modification de l'objet social

14/10/2008

Change to corporate purpose

14/10/2008

PV d'Assemblée

14/10/2008

Minutes of general meeting of shareholders

31/12/2007

New accounts available

10/10/2007

Collection of preferential rights activated for this company

07/09/2007

Appointment/resignation of company officers

07/09/2007

Private document

07/09/2007

Minutes of general meeting of shareholders

07/09/2007

New auditor

07/09/2007

Changement de Commissaire aux Comptes

07/09/2007

PV d'Assemblée

02/08/2007

Updated articles of association

02/08/2007

Statuts mis à jour

02/08/2007

PV d'Assemblée

02/08/2007

Private document

02/08/2007

Minutes of general meeting of shareholders

31/12/2006

New accounts available

19/07/2006

Sale of shares

19/07/2006

Acte sous seing privé

19/07/2006

Private document

19/07/2006

PV d'Assemblée

19/07/2006

Statuts mis à jour

19/07/2006

Updated articles of association

19/07/2006

Cession de parts

19/07/2006

Minutes of general meeting of shareholders

31/12/2005

New accounts available

21/12/2005

Minutes of general meeting of shareholders

21/12/2005

Nomination/démission des organes de gestion

21/12/2005

Appointment/resignation of company officers

21/12/2005

Changement de Gérant

21/12/2005

Acte sous seing privé

21/12/2005

Private document

21/12/2005

PV d'Assemblée

28/11/2005

Nomination/démission des organes de gestion

28/11/2005

Appointment/resignation of company officers

28/11/2005

Private document

28/11/2005

Acte sous seing privé

28/11/2005

New auditor

28/11/2005

Changement de Commissaire aux Comptes

28/11/2005

PV d'Assemblée

28/11/2005

Minutes of general meeting of shareholders

04/08/2005

Private document

04/08/2005

Statuts mis à jour

04/08/2005

Minutes of general meeting of shareholders

04/08/2005

Acte sous seing privé

04/08/2005

Updated articles of association

04/08/2005

PV d'Assemblée

31/12/2004

New accounts available

20/09/2004

Changement de Commissaire aux Comptes

20/09/2004

Acte sous seing privé

20/09/2004

Private document

20/09/2004

PV d'Assemblée

20/09/2004

Nomination/démission des organes de gestion

20/09/2004

Minutes of general meeting of shareholders

20/09/2004

New auditor

20/09/2004

Appointment/resignation of company officers

17/02/2004

Statuts mis à jour

17/02/2004

Acte sous seing privé

17/02/2004

Modification de l'objet social

17/02/2004

PV d'Assemblée

31/12/2003

New accounts available

20/10/2003

Acte sous seing privé

20/10/2003

Statuts mis à jour

20/10/2003

Cession de parts

20/10/2003

PV d'Assemblée

18/12/2002

Acte sous seing privé

18/12/2002

PV d'Assemblée

18/12/2002

Statuts mis à jour

18/12/2002

Acte modificatif

30/01/2002

Cession de parts

30/01/2002

Acte sous seing privé

17/12/2001

Changement de Commissaire aux Comptes

17/12/2001

Conversion du Capital Social en Euros

17/12/2001

Réduction de Capital

17/12/2001

Statuts mis à jour

17/12/2001

PV d'Assemblée

17/12/2001

Nomination/démission des organes de gestion

17/12/2001

Acte sous seing privé

17/12/2001

Changement de date de clôture

23/11/2000

Statuts mis à jour

23/11/2000

Cession de parts

23/11/2000

PV d'Assemblée

23/11/2000

Acte sous seing privé

28/04/2000

Nomination/démission des organes de gestion

28/04/2000

Acte sous seing privé

28/04/2000

PV d'Assemblée

28/04/2000

Changement de Gérant

02/11/1998

PV d'Assemblée

02/11/1998

Acte sous seing privé

02/11/1998

Cession de parts

02/11/1998

Nomination/démission des organes de gestion

02/11/1998

Statuts mis à jour

21/11/1997

Changement de Gérant

21/11/1997

Cession de parts

21/11/1997

Statuts mis à jour

21/11/1997

Acte sous seing privé

21/11/1997

Acte modificatif

21/11/1997

Nomination/démission des organes de gestion

21/11/1997

PV d'Assemblée

04/02/1997

PV d'Assemblée

04/02/1997

Acte sous seing privé

04/02/1997

Statuts mis à jour

25/10/1996

Acte sous seing privé

25/10/1996

Modification du Conseil d'Administration

25/10/1996

Réduction de Capital

25/10/1996

Changement de Forme Juridique sans changement de catégorie

25/10/1996

Augmentation de Capital

25/10/1996

Rapport des Commissaires ou du Gérant

25/10/1996

Statuts mis à jour

25/10/1996

PV d'Assemblée

25/10/1996

Nomination/démission des organes de gestion

11/10/1996

Acte sous seing privé

11/10/1996

Acte modificatif

02/10/1996

Nomination/démission des organes de gestion

02/10/1996

PV d'Assemblée

02/10/1996

Modification du Conseil d'Administration

27/06/1995

Modification du Conseil d'Administration

27/06/1995

Nomination/démission des organes de gestion

27/06/1995

PV du Conseil d'Administration

10/04/1995

PV du Conseil d'Administration

10/04/1995

Changement de Président (PDG, PCA)

10/04/1995

Modification du Conseil d'Administration

10/04/1995

Nomination/démission des organes de gestion

18/10/1994

Statuts mis à jour

18/10/1994

Nomination/démission des organes de gestion

18/10/1994

PV d'Assemblée

18/10/1994

Modification du Conseil d'Administration

24/05/1994

PV du Conseil d'Administration

24/05/1994

Modification du Conseil d'Administration

19/04/1994

PV d'Assemblée

19/04/1994

Statuts mis à jour

01/12/1993

PV d'Assemblée

01/12/1993

PV du Conseil d'Administration

27/05/1993

Acte sous seing privé

27/05/1993

Cession de parts

27/05/1993

Déclaration de conformité

27/05/1993

Statuts mis à jour

01/02/1993

Déclaration de conformité

01/02/1993

PV d'Assemblée

01/02/1993

Changement de Commissaire aux Comptes

01/02/1993

Statuts mis à jour

01/02/1993

Réduction de Capital

 

 

 

Establishment events history

 

 

Date

Description

30/06/2011

Modification of Head office

28/02/2011

Modification of Head office (after transfer)

20/09/2009

Update of phone numbers

 


FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.53.59

UK Pound

1

Rs.85.81

Euro

1

Rs.69.91

 

INFORMATION DETAILS

 

Report Prepared by :

MNL

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

----

NB

New Business

----

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.