MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

13.08.2013

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES GMBH

 

 

Registered Office :

Turmstraße  44, A-4031 Linz

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

30.09.2012

 

 

Year of Incorporation :

1987

 

 

Legal Form :

Limited Liability Company

 

 

Line of Business :

Engineering activities and related technical consultancy

 

 

No. of Employees :

1575

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Good

Payment Behaviour :

Regular

Litigation :

Clear

 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail: infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31st, 2013

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2012)

Current Rating

(31.03.2013)

Austria

A2

A2

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 

 

AUSTRIA - ECONOMIC OVERVIEW

 

Austria, with its well-developed market economy, skilled labor force, and high standard of living, is closely tied to other EU economies, especially Germany's. Its economy features a large service sector, a sound industrial sector, and a small, but highly developed agricultural sector. Following several years of solid foreign demand for Austrian exports and record employment growth, the international financial crisis of 2008 and subsequent global economic downturn led to a sharp but brief recession. Austrian GDP contracted 3.8% in 2009 but saw positive growth of about 2% in 2010 and 2.7% in 2011. Growth fell to 0.6% in 2012. Unemployment did not rise as steeply in Austria as elsewhere in Europe, partly because the government subsidized reduced working hour schemes to allow companies to retain employees. The 2012 unemployment rate of 4.3% was the lowest within the EU. Stabilization measures, stimulus spending, and an income tax reform pushed the budget deficit to 4.5% in 2010 and 2.6% in 2011, from only about 0.9% in 2008. The international financial crisis of 2008 caused difficulties for Austria's largest banks whose extensive operations in central, eastern, and southeastern Europe faced large losses. The government provided bank support - including in some instances, nationalization - to support aggregate demand and stabilize the banking system. Austria's fiscal position compares favorably with other euro-zone countries, but it faces external risks, such as Austrian banks' continued exposure to Central and Eastern Europe as well as political and economic uncertainties caused by the European sovereign debt crisis. In 2011 the government attempted to pass a constitutional amendment limiting public debt to 60% of GDP by 2020, but it was unable to obtain sufficient support in parliament and instead passed the measure as a simple law. In March 2012, the Austrian parliament approved an austerity package consisting of a mix of expenditure cuts and new revenues that will bring public finances into balance by 2016. In 2012, the budget deficit rose to 3.1% of GDP.

Source : CIA


Basic company information

 

Company name:

Siemens VAI Metals Technologies GmbH

Status:

active company

Locations:

Turmstraße  44, A-4031 Linz

Phone:

0043 (732) 6592

Fax:

0043 (732) 6592 - 8942

E-mail:

contact@vai.at

Internet:

http://www.vai.co.at

Activities:

Önace 71120 30% Engineering activities and related technical consultancy

 

Önace 41209 30% Construction of other non-residential buildings

 

Önace 28290 20% Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c.

 

Önace 28920 10% Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction

 

Önace 28410 10% Manufacture of metal forming machinery

 

Probability of Default (Basel II):

0,15%

Very low risk

Recommendation:

In respect to solvency reasons, there is nothing to say against an establishment of a business relationship.

 

Detail Assessment:

Payment

Payments are made within net agreements.

 

Assessment

Company's financial situation is in order. Earnings potential, however, is unsatisfactory.

 

Additional company information

 

Year of incorporation:

1987

 

Activities:

 

 

Type of company:

Manufacturing

 

Legal form:

limited liability company since 1992-08-18

 

companies' house number:

FN 92230 h Linz 1992-09-17

 

ARA-number:

7943

 

VAT number:

ATU 23363303

 

number - Austrian National Bank:

1963970

 

 

 

 

Export 

Country 

 

 

 

Export

world-wide

 

2013

 

 


Financial data

 

total turnover (total sales)

2012

EUR  655.553.081,00

(exact)

total turnover (total sales)

2011

EUR  936.622.567,00

(exact)

total turnover (total sales)

2010

EUR  71.746.843,00

(exact)

total turnover (total sales)

2009

EUR  4.046.600,00

(exact)

total turnover (total sales)

2008

EUR  3.819.000,00

(exact)

total employees

2013

1575

(average)

total stock

2013

EUR  50.000.000,00

(average)

 

Extraxt from the Companies' House

 

firm (style):

   74      Siemens VAI Metals Technologies GmbH

legal form:

    1      Gesellschaft mit beschränkter Haftung

registered office:

    2      politischer Gemeinde Linz

business adress:

    1      Turmstr. 44
           4031 Linz Postfach

capital:

   62      EUR 72.672.834,17

reference date annual accounts:

   62      30. September

annual accounts:

  122      zum 30.09.2012 eingereicht am 24.01.2013

power of representation:

    1      Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer
           bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
           durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen
           vertreten.
    1   Gesellschaftsvertrag  vom 18.08.1992                                001
    1   Verschmelzungsvertrag  vom 24.02.1993                               002
    1   Generalversammlungsbeschluss  vom 24.02.1993                        003
          Diese Gesellschaft wurde als
          übernehmende Gesellschaft mit der
          VOEST-ALPINE Industrieanlagenbau GmbH
          als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
          Sitz der übertragenden Gesellschaft in Linz.
    3   Generalversammlungsbeschluss  vom 03.05.1994                        005
          Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
   11   Verschmelzungsvertrag  vom 27.06.1996                               006
   11   Generalversammlungsbeschluss  vom 27.06.1996                        007
          Diese Gesellschaft wurde als
          übernehmende Gesellschaft mit der
          VOEST Engineering GmbH
          (FN 91088 d)
          als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
          Sitz der übertragenden Gesellschaft in Linz.
   23   Einbringungsvertrag  vom 16.12.1998                                 008
   23   Übertragung des Teilbetriebes in die                                009
          VOEST-ALPINE MECHATRONICS GmbH
          (FN 170758 s)
          Teilbetrieb:
          TAW 4 Forschung und Entwicklung
   27   Generalversammlungsbeschluss  vom 26.08.1999                        010
          Abspaltung
   27   zur Aufnahme in die                                                 011
          VOEST-ALPINE Industriedienstleistungs
          GmbH
          (FN 82077 b)
          durch Übertragung
          des gesamten Betriebes mit Ausnahme bestimmter Vermögens-
          teile
          gemäß Spaltungs- und Übernahmsvertrag vom 26.08.1999.
   28   Generalversammlungsbeschluss  vom 26.08.1999                        012
          Abspaltung
   28   zur Aufnahme in die                                                 013
          VA Technologie Aktiengesellschaft
          (FN 67032 b)
          durch Übertragung
          des Geschäftsanteiles der "VOEST-ALPINE Industrieanlagenbau
          GmbH" an der "VOEST-ALPINE Industriedienstleistungs GmbH"
          gemäß Spaltungs- und Übernahmsvertrag vom 26.08.1999.
   33   Generalversammlungsbeschluss  vom 10.05.2000                        014
          Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
   62   Gesellschaftsvertrag mit Generalversammlungsbeschluss               015
          vom 16.08.2005
          gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.
   62   Generalversammlungsbeschluss  vom 16.08.2005                        016
          Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 und 17.
   70   Verschmelzungsvertrag  vom 26.06.2006                               017
   70   Generalversammlungsbeschluss  vom 26.06.2006                        018
          Diese Gesellschaft wurde als
          übernehmende Gesellschaft mit der
          VA TECH International GmbH
          (FN 87603 d)
          als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
          Sitz der übertragenden Gesellschaft in Linz.
   74   Generalversammlungsbeschluss  vom 04.12.2006                        019
          Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
   82   Verschmelzungsvertrag  vom 16.07.2007                               020
   82   Generalversammlungsbeschluss  vom 16.07.2007  der                   021
          ARCMET Technologie GmbH
          (FN 140244 t)
          als übertragender Gesellschaft. Verschmelzung mit dieser
          Gesellschaft als übernehmender Gesellschaft.
          Sitz der übertragenden Gesellschaft in Linz.
   96   Generalversammlungsbeschluss  vom 28.11.2008                        022
          Neufassung des Gesellschaftsvertrages
  104   Einbringungsvertrag (Sacheinlagevertrag) vom 30.06.2010             024
  104   Übernahme des Vermögens der                                         025
          Siemens VAI Metals Technologies
          GmbH & Co
          (FN 187238 a)
          gemäß § 142 UGB.
  116   Generalversammlungsbeschluss  vom 29.07.2011                        026
          Spaltung zur Aufnahme eines Vermögensteiles der
          vatron gmbh
          (FN 170758 s)
          und zwar
          des Teilbetriebes "MT Mechatronic"
          gemäß Spaltungs- und Übernahmsvertrag vom 29.6.2011.

proxy:

        AS   Mag. Dr. Peter Steiner, geb. 03.07.1956
    1        vertritt seit 16.03.1994 gemeinsam mit
             einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer
             oder einem weiteren Gesamtprokuristen
        BR   Dr.Ing. Walter Gebert, geb. 14.01.1957
   35        vertritt seit 08.11.2000 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Gesamtprokuristen
        CC   Dr. Anton Stallinger, geb. 26.03.1957
   42        vertritt seit 03.04.2002 gemeinsam mit
             einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer oder
             einem weiteren Gesamtprokuristen
        CE   Alfred Piesinger, geb. 18.12.1957
  120        vertritt seit 29.02.2012 gemeinsam mit
             einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer oder
             einem weiteren Gesamtprokuristen
        CI   DI Andreas Flick, geb. 21.11.1958
   50        vertritt seit 11.07.2003 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Gesamtprokuristen
        CM   Dr. Bernhard Starzer, geb. 15.02.1956
   94        vertritt seit 18.12.2008 gemeinsam mit
             einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer
             oder einem weiteren Gesamtprokuristen
        CP   DI Andreas Kropf, geb. 31.07.1965
   61        vertritt seit 22.07.2005 gemeinsam mit
             einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer
             oder einem weiteren Gesamtprokuristen
        CQ   DI. Dieter Siuka, geb. 12.10.1957
   63        vertritt seit 09.11.2005 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Gesamtprokuristen
        DH   Dipl.-Vw. Ewald Feidner, geb. 16.01.1954
   91        vertritt seit 30.07.2008 gemeinsam mit
             einem kollektiv vertretretungsbefugten Geschäftsführer
             oder einem weiteren Gesamtprokuristen
        DJ   Mag. Andreas Weinhengst, geb. 29.08.1964
   94        vertritt seit 18.12.2008 gemeinsam mit
             einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer
             oder einem weiteren Gesamtprokuristen
        DK   Mag. Norbert Petermaier, geb. 21.12.1967
   95        vertritt seit 16.01.2009 gemeinsam mit
             einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer
             oder einem weiteren Gesamtprokuristen
        DR   Dipl.Ing. Josef Lanschützer, geb. 06.07.1967
  110        vertritt seit 29.03.2011 gemeinsam mit
             einem weiteren Gesamtprokuristen oder einem
             kollektiv vertretungsbefungten Geschäftsführer
        DU   Dipl.-Ing. Stefan Rieberer, geb. 10.03.1965
  114        vertritt seit 07.07.2011 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Gesamtprokuristen
        DV   Ing. Mag. Josef Strasser, geb. 10.06.1959
  118        vertritt seit 10.11.2011 gemeinsam mit
             einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer oder
             einem weiteren Gesamtprokuristen
        DX   Dr. Heiner Röhrl, geb. 30.04.1966
  123        vertritt seit 01.02.2013 gemeinsam mit
             einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer oder
             einem weiteren Gesamtprokuristen
        DY   Dr. Rainer Oberleitner, geb. 30.01.1972
  124        vertritt seit 13.02.2013 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Gesamtprokuristen

supervisory board:

        DA   Gerhard Bayer, geb. 21.09.1956
  106        Mitglied
        DD   Reinhard Pinzer, geb. 31.08.1952
   84        Mitglied
        DO   Ing. Wolfgang Hesoun, geb. 15.02.1960
  106        Vorsitzender
        DP   Berta Haring, geb. 22.12.1960
  106        Mitglied
        DS   Dr. Siegfried Russwurm, geb. 27.06.1963
  111        Stellvertreter des Vorsitzenden
        DT   Dr. Ralf P. Thomas, geb. 07.03.1961
  111        Mitglied

managing director:

         E   Dipl.-Ing. Werner Auer, geb. 25.04.1955
  100        vertritt seit 01.10.2009 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder einem Gesamtprokuristen
        DM   Martin Dieter Krauss, geb. 12.06.1963
  100        vertritt seit 01.10.2009 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder einem Gesamtprokuristen

shareholder:

        CW   Landis & Staefa (Österreich) GmbH
   66        ........................    EUR 100
   66        ...................................................    EUR 100
        CY   Siemens Aktiengesellschaft Österreich
   67        ..............    EUR 72.672.734,17
   67        .........................................    EUR 72.672.734,17
                          ------------------------------------------------------
                   Summen:     EUR 72.672.834,17          EUR 72.672.834,17

general table:

 Landesgericht Linz
   1 datenersterfaßt am 22.04.1994              Geschäftsfall 902 Fr   533/94 v
       Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
   2 Ersterfassung abgeschlossen am 22.04.1994  Geschäftsfall 902 Fr   582/94 s
       Übernahme in das ADV-Firmenbuch
   3 eingetragen am 06.07.1994                  Geschäftsfall  17 Fr  1225/94 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.04.1994
     eingetragen am 06.07.1994                  Geschäftsfall  17 Fr  2060/94 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.06.1994
  11 eingetragen am 10.07.1996                  Geschäftsfall  12 Fr  3241/96 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.06.1996
  23 eingetragen am 28.05.1999                  Geschäftsfall  34 Fr   487/99 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.03.1999
  27 eingetragen am 28.09.1999                  Geschäftsfall  34 Fr  3468/99 x
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.09.1999
  28 eingetragen am 29.09.1999                  Geschäftsfall  34 Fr  3469/99 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.09.1999
  33 eingetragen am 21.07.2000                  Geschäftsfall  34 Fr  2034/00 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.06.2000
  35 eingetragen am 08.11.2000                  Geschäftsfall  34 Fr  4223/00 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.10.2000
  42 eingetragen am 03.04.2002                  Geschäftsfall  32 Fr  1416/02 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 15.03.2002
  46 eingetragen am 02.10.2002                  Geschäftsfall  32 Fr  4133/02 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 27.09.2002
  50 eingetragen am 11.07.2003                  Geschäftsfall  32 Fr  2921/03 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.07.2003
  57 eingetragen am 14.10.2004                  Geschäftsfall  32 Fr  4279/04 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.09.2004
  61 eingetragen am 22.07.2005                  Geschäftsfall  32 Fr  3654/05 a
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.07.2005
  62 eingetragen am 03.09.2005                  Geschäftsfall  32 Fr  4118/05 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.08.2005
  63 eingetragen am 09.11.2005                  Geschäftsfall  32 Fr  5624/05 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.11.2005
  66 eingetragen am 02.03.2006                  Geschäftsfall  32 Fr   957/06 v
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.02.2006
  67 eingetragen am 21.06.2006                  Geschäftsfall  32 Fr  3025/06 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.06.2006
  69 eingetragen am 26.07.2006                  Geschäftsfall  32 Fr  2984/06 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.06.2006
  70 eingetragen am 08.08.2006                  Geschäftsfall  32 Fr  3265/06 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.06.2006
  74 eingetragen am 22.12.2006                  Geschäftsfall  32 Fr  7428/06 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.12.2006
  77 eingetragen am 22.03.2007                  Geschäftsfall  32 Fr  1396/07 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 15.03.2007
  80 eingetragen am 04.05.2007                  Geschäftsfall  32 Fr  2016/07 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.04.2007
  82 eingetragen am 06.09.2007                  Geschäftsfall  32 Fr  3565/07 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.08.2007
  84 eingetragen am 11.12.2007                  Geschäftsfall  32 Fr  6867/07 v
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.11.2007
  91 eingetragen am 30.07.2008                  Geschäftsfall  32 Fr  3196/08 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.07.2008
  94 eingetragen am 18.12.2008                  Geschäftsfall  32 Fr  7518/08 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 15.12.2008
  95 eingetragen am 16.01.2009                  Geschäftsfall  32 Fr    70/09 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.01.2009
  96 eingetragen am 12.02.2009                  Geschäftsfall  32 Fr   346/09 x
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.01.2009
 100 eingetragen am 02.10.2009                  Geschäftsfall  32 Fr  4686/09 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.09.2009
 104 eingetragen am 27.08.2010                  Geschäftsfall  32 Fr  3745/10 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.07.2010
 106 eingetragen am 06.10.2010                  Geschäftsfall  32 Fr  5543/10 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 01.10.2010
 110 eingetragen am 29.03.2011                  Geschäftsfall  32 Fr  2853/11 a
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.03.2011
 111 eingetragen am 22.06.2011                  Geschäftsfall  32 Fr  5045/11 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.06.2011
 114 eingetragen am 07.07.2011                  Geschäftsfall  32 Fr  5439/11 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.07.2011
 116 eingetragen am 30.07.2011                  Geschäftsfall  32 Fr  5951/11 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.07.2011
 118 eingetragen am 10.11.2011                  Geschäftsfall  32 Fr  9302/11 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.11.2011
 120 eingetragen am 29.02.2012                  Geschäftsfall  32 Fr   755/12 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 27.02.2012
 122 eingetragen am 25.01.2013                  Geschäftsfall  32 Fr   363/13 g
       Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 24.01.2013
 123 eingetragen am 01.02.2013                  Geschäftsfall  32 Fr   413/13 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.01.2013
 124 eingetragen am 13.02.2013                  Geschäftsfall  32 Fr   573/13 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.02.2013

Real estate

 

Real estate text:

No real estate property registered

 

Private data

 

 

Surname

 

 

Date of birth

 

 

Address

 

 

Executive positions

 

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Dipl-Ing.  Werner Auer

1955-04-25 

4040 Linz Ferihumerstraße 33

manager

1

Martin Dieter Krauss

1963-06-12 

4031 Linz Turmstraße 44

manager

0

Dipl-Vw  Ewald Feidner

1954-01-16 

4031 Linz Turmstraße 44(c/o)

joint signing clerk

0

Dipl-Ing.  Andreas Flick

1958-11-21 

4031 Linz Turmstraße 44(c/o)

joint signing clerk

0

Ing.Dr.  Walter Gebert

1957-01-14 

4031 Linz Turmstraße 44(c/o)

joint signing clerk

0

Dipl-Ing.  Andreas Kropf

1965-07-31 

4048 Puchenau Espenweg 8

joint signing clerk

1

Dipl-Ing.  Josef Landschützer

1967-07-06 

 

4031 Linz Turmstraße 44(c/o)

 

joint signing clerk

 

0

 

Dr.  Rainer Oberleitner

1972-01-30 

4031 Linz Turmstraße 44(c/o)

joint signing clerk

0

Mag.  Norbert Petermaier

1967-12-21 

4031 Linz Turmstraße 44(c/o)

joint signing clerk

1

Alfred Piesinger

1957-12-18 

4031 Linz Turmstraße 44(c/o)

joint signing clerk

0

Dipl-Ing.  Stefan Rieberer

1965-03-10 

 

1050 Wien Schönbrunnerstraße 58

joint signing clerk

 

0

 

Dr.  Heiner Röhrl

 

1966-04-30 

 

4031 Linz Postfach Turmstr. 44(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Dipl-Ing.  Dieter Siuka

1957-10-12 

4031 Linz Turmstraße 44(c/o)

joint signing clerk

0

Dr.  Anton Stallinger

1957-03-26 

1180 Wien Starkfriedgasse 21

joint signing clerk

0

Dr.  Bernhard Starzer

1956-02-15 

4040 Linz Kaarstraße 5

joint signing clerk

1

Mag.Dr.  Peter Steiner

1956-07-03 

4031 Linz Turmstraße 44(c/o)

joint signing clerk

0

Ing. Mag.  Josef Strasser

1959-06-10 

 

4031 Linz Postfach Turmstr. 44(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Mag.  Andreas Weinhengst

1964-08-29 

4030 Linz Turmstraße 44(c/o)

joint signing clerk

0

Ing.  Wolfgang Hesoun

1960-02-15 

1210 Wien Siemensstraße 90

chairman of the supervisory board

2

Dipl. Ing. Dr.-Ing.  Siegfried Russwurm

1963-06-27 

 

1210 Wien Siemensstraße 90-92

 

deputy chairman of the supervisory board

 

0

 

Gerhard Bayer

1956-09-21 

4031 Linz Turmstraße 44(c/o)

member of the supervisory board

1

Berta Haring

1960-12-22 

4030 Linz In der Neupeint 10

member of the supervisory board

0

 

kfm. Angestellte

Dkfm.  Reinhard Pinzer

1952-08-31 

1141 Wien Penzingerstraße 76

member of the supervisory board

3

Dr.  Ralf Thomas

1961-03-07 

4031 Linz Turmstraße 44(c/o)

member of the supervisory board

0

Josef Lang

1945-09-05 

4031 Linz Turmstraße 44(c/o)

head of accounting

0

Klaus Mittendorfer

 

  

 

4031 Linz Turmstraße 44 c/o(c/o)

head of accounting

 

0

 

 

Balance Sheet 

(absolute) all amounts in EUR 

 

 

2012-09-30 

Intangible assets

562.640.617,00

Sum intangible assets

562.640.617,00

Tangible assets

19.417.625,00

Sum tangible assets

19.417.625,00

Financial assets

136.256.129,00

Sum financial assets

136.256.129,00

Sum fixed assets

718.314.371,00

Outstanding service claims

41.151.060,00

Advanced payments

11.343.888,00

Sum stock

52.494.948,00

Claims from delivered goods and performed services

29.292.577,00

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

102.084.852,00

Special account claims

41.036.663,00

Sum claims

172.414.092,00

Cash on hand, cheques and bank deposits

12.842.185,00

Sum cash and bank

12.842.185,00

Sum current assets

237.751.225,00

Assets

956.065.596,00

Subscribed/declared capital

72.672.834,00

Legal reserves

7.267.834,00

Balance sheet profit/balance sheet loss

184.249.777,00

Thereof profit/loss carried forward

207.519.917,00

Sum equity capital

264.190.445,00

Valuation reserves and other reserves before taxes

282.759,00

Sum reserves before taxes

282.759,00

Reservesfor severance pays

35.831.192,00

Reserves for pensions

16.901.524,00

Tax reserves

4.263.689,00

Other reserves

223.310.486,00

Sum reserves

280.306.891,00

Liabilities against credit institutes

1.649.090,00

Received advanced payments for orders

323.563.642,00

Liabilities from delivered goods and performed services from the acceptance of drafts and emission of promissory notes

53.588.278,00

Liabilities against related firms

1.682.402,00

Other liabilities

30.802.089,00

Sum liabilities

411.285.501,00

Liabilities

956.065.596,00

Balance sheet sum

956.065.596,00

 

P / L Account 

(absolute) all amounts in EUR 

 

 

2012-09-30 

Gross sales 

655.553.081,00

Increase or decrease in finished and unfinished goods and in service claims 

-55.988.521,00

Other manufacturing costs capitalized 

237.822,00

Sum turnover or sum gross profit 

599.802.382,00

Profits from retirement of fixed assets, except financial assets 

63.381,00

Income from dissolution of reserves 

570.200,00

Other operating profits 

19.159.662,00

Other operating profits totally 

19.793.243,00

Costs for obtained services 

-96.329.047,00

Special account material costs 

-244.955.727,00

Costs for obtained services totally 

-341.284.774,00

Salaries 

-115.676.113,00

Costs for severance pays 

-4.523.981,00

Costs for old age pension 

-9.034.097,00

Legal fringe benefits and other payments depending on salaries 

-27.181.296,00

Other social fringe benefits 

-345.577,00

Personnel expenses totally 

-156.761.064,00

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation 

-96.652.164,00

Depreciation tangible assets / intangible assets totally 

-96.652.164,00

Different operating costs 

-53.053.590,00

Other taxes 

-1.041.296,00

Other operating costs totally 

-54.094.886,00

Operating result totally 

-29.197.263,00

Profits from shareholdings 

5.706.893,00

Income from other securities and loans of financial assets 

910.516,00

Profits from the retirement of and investment in financial assets and securities of current assets 

210.699,00

Interest income, securties income and similar income 

2.019.960,00

Disbursements from other financial assets and from securities of current assets (e.g. depreciations) 

-5.521,00

Interest and similar disbursements 

-1.801.139,00

Financial profits totally 

7.041.408,00

Results from usual business activity totally 

-22.155.855,00

Taxes on income and profits 

-1.266.599,00

Taxes on income and profits totally 

-1.266.599,00

Annual surplus/annual deficit totally 

-23.422.454,00

Dissolution reserves before taxes 

152.314,00

Reserves movements totally 

152.314,00

Annual profit/annual loss totally 

-23.270.140,00

Profit and loss carried forward from previous year 

207.519.917,00

Transfer of profits totally 

207.519.917,00

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account 

184.249.777,00

 

Key ratios

 

 

2012  

Cash flow II

  73.229.710,00

Debt amortisation period

  4,85

Bank indebtedness

  0,17

Equity capital share

  41,81

Social capital share

  5,51

Fixed assets coverage

  44,15

Net profit ratio

  -3,69

Capital turnover

  0,62

Return on investment

  -2,12

Cash flow in % of operating performance

  12,20

Cash flow I

  74.496.309,00

Gross productivity

  3,82

Net productivity

  1,64

Operating performance

  599.802.382,00

Inventories in % of operating performance

  8,75

Gross profit

  258.517.608,00

 

Locations

 

Type

Locations

Description

 

 

E-mail 

operational 

Turmstr.  44, A-4031 Linz, Postfach

registered office 

 

 

 

operational 

Turmstraße  44, A-4031 Linz

registered headquarters, rented premises 

 

 

contact@vai.at

operational 

Postfach  4, A-4031 Linz

postbox 

 

 

 

operational 

Stahlstraße  14, A-4031 Linz

branch office 

 

 

 

former 

Floragasse  7/5, A-1040 Wien

registered headquarters 

 

 

 

 

related companies

 

Company name

 

Postal code

 

Stake in %

 

Companies House

 

 

Shares in this company are held by:

Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Siemensstraße  90, A-1210 Wien

100 % 2006-06-21

 

FN 60562 m

 

 

Landis & Staefa (Österreich) GmbH

Siemensstraße  90, A-1210 Wien

2006-03-02

 

FN 57483 i

 

 

 

This company holds 100% of the shares in:

Saudi VOEST-ALPINE GmbH

 

Turmstraße  44, A-4031 Linz

100 % 2012-12-21

 

FN 170604 p

 

 

 

Affiliated companies and further participations:

Landis & Staefa GmbH

 

Siemensstraße  90, A-1210 Wien

 

 

FN 223302 k

 

 

E-Mobility Provider Austria GmbH

Am Hof  5, A-1010 Wien

 

 

FN 386453 p

 

 

Aspern Smart City Research GmbH & Co KG

Seestadtstraße  27, A-1220 Wien

 

 

FN 398764 v

 

 

addIT Dienstleistungen GmbH & Co KG

Lakeside  B 09 b, A-9020 Klagenfurt

 

 

FN 203964 y

 

 

 

Bankers

 

Banker

Bank sort code

Type of banking connection

UniCredit Bank Austria AG, 1011 Wien

 

11000

 

main bank connection

 

 

Historical development

 

Year of incorporation:

1987

Date of registration:

1992-09-17

 

Change of company name:

From

To

Company name

  2006-12-22

   

Siemens VAI Metals Technologies GmbH 

   

  2006-12-22

VOEST-ALPINE Industrieanlagenbau GmbH 

 

Change in share capital:

From

To

Capital

   

  2005-09-03

ATS  1.000.000.000,00

  2005-09-03

   

EUR  72.672.834,17

 

Former executives:

From

To

Function

Name

   

  1999-05-18

manager 

Mag.Dr. Reinhard Wödlinger 

   

  1999-05-18

manager 

Dipl-Ing. Horst Wiesinger 

   

  1999-08-14

manager 

Mag.Dr. Richard Guserl 

  1999-08-14

  2002-01-29

manager 

Mag. Peter Waldner 

  2002-01-29

  2006-07-26

manager 

Mag. Erich Ennsbrunner 

  1999-05-18

  2006-09-06

manager 

Dipl-Ing. Gerhard Falch 

  1999-05-18

  2007-11-16

manager 

Ing. Karl Gruber 

  1999-05-18

  2008-03-15

manager 

Mag.Dr. Karl Schwaha 

  2007-03-30

  2008-03-15

manager 

Sanjeev Sinha 

  2006-06-27

  2009-07-08

manager 

Dr. Richard Pfeiffer 

  1994-04-22

  2003-02-18

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Ernst Fritz 

  1994-04-22

  2003-02-18

joint signing clerk 

Ing. Gottfried Kuttner 

  2001-04-27

  2003-05-24

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Josef Scheidl 

  1994-04-22

  2004-02-27

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Günter Holleis 

  2002-10-02

  2004-02-27

joint signing clerk 

Alfred Piesinger 

  1994-04-22

  2004-03-16

joint signing clerk 

Josef Lang 

  1994-04-22

  2006-09-06

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Fritz Kürbisch 

  1994-04-22

  2007-01-19

joint signing clerk 

Dkfm.Dr. Wolfram Lichtenegger 

  2002-04-03

  2007-01-19

joint signing clerk 

Dr. Bernd Schiefersteiner 

  1994-04-22

  2007-01-19

joint signing clerk 

Ing. Gert Dietmar Stohl 

  1994-04-22

  2007-04-06

joint signing clerk 

Dr. Kurt Bleier 

  2001-04-27

  2001-07-12

member of the supervisory board 

Dkfm.Dr. Erich Becker 

  2001-07-12

  2003-02-04

member of the supervisory board 

Dr. Georg Antesberger 

  2001-04-27

  2003-09-05

member of the supervisory board 

Kurt Divos 

  2003-02-04

  2004-10-14

member of the supervisory board 

Dipl-Ing. Klaus Brenner 

  2002-07-09

  2004-10-14

member of the supervisory board 

Christian Habegger 

  2001-04-27

  2004-10-14

member of the supervisory board 

Dr. Roland Ferdinand Scharb 

  2003-09-05

  2004-10-14

member of the supervisory board 

Michael Seidler 

  2001-04-27

  2004-10-14

member of the supervisory board 

Mag. Klaus Sernetz 

  2004-10-14

  2005-06-23

member of the supervisory board 

Dr. Hanno Bästlein 

  2004-12-14

  2005-06-23

member of the supervisory board 

Dipl-Ing. Jürgen Wild 

  2004-10-14

  2005-11-12

member of the supervisory board 

Johann Krempl 

  2004-10-14

  2005-11-12

member of the supervisory board 

Dr. Bernhard Starzer 

  1999-10-22

  2002-07-09

deputy chairman of the supervisory board 

Mag.Dr. Richard Guserl 

  2005-11-12

  2006-10-04

member of the supervisory board 

Mag. Peter Schönhofer 

  2004-10-14

  2005-06-23

deputy chairman of the supervisory board 

Christian Habegger 

  2005-06-23

  2005-11-12

deputy chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing. Jürgen Wild 

  2005-11-12

  2008-10-29

deputy chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing. Joergen Ole Haslestad 

  2008-12-10

  2011-06-22

deputy chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing. Jens Wegmann 

   

  1997-04-10

member of the supervisory board 

Ing. Herbert Brandmayer 

   

  1998-01-24

member of the supervisory board 

Dipl-Ing. Herbert Furch 

   

  1998-07-11

member of the supervisory board 

Walter Flöttl 

  1997-04-10

  1999-03-09

member of the supervisory board 

Gottfried Hoser 

  1999-03-09

  2001-04-27

member of the supervisory board 

Ing. Herbert Brandmayer 

   

  2001-04-27

member of the supervisory board 

Dipl-Ing. Gert Kincel 

   

  2007-03-22

member of the supervisory board 

Ing. Ernst Artner 

  2007-03-22

  2007-11-16

member of the supervisory board 

Gerhard Bayer 

  2006-10-04

  2007-11-16

member of the supervisory board 

Dipl-Ing. Gerhard Falch 

  1998-07-11

  2001-04-27

member of the supervisory board 

Dr. Paul Nilles 

   

  2001-04-27

member of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Richard Schenz 

  2007-08-01

  2007-12-11

member of the supervisory board 

Mag. Brigitte Ederer 

  2006-10-04

  2007-12-11

member of the supervisory board 

Mag.Dr. Harald Wasserburger 

  2002-10-02

  2007-11-16

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Heinz Hödl 

  2003-07-11

  2007-11-16

joint signing clerk 

Mag. Kurt Wiesinger 

  2000-01-20

  2008-03-15

joint signing clerk 

Ing.Mag. Georg Weger 

  1994-04-22

  2008-04-19

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Anton Franz Eberle 

  1994-04-22

  2008-06-06

joint signing clerk 

Mag. Wolfgang Lenz 

  2001-10-17

  2008-07-30

joint signing clerk 

Dipl-Betriebsw. Stefan Schwaab 

  1994-04-22

  2008-12-18

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Herbert Durnig 

  1998-07-11

  2008-12-18

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Bruno Lindorfer 

  1994-04-22

  2009-07-08

joint signing clerk 

Dr. Wolfram Brüstle 

  2008-01-16

  2009-07-08

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Martin Klein 

  1994-04-22

  2009-09-22

joint signing clerk 

Hermann Remplbauer 

  1994-04-22

  2009-10-16

joint signing clerk 

Dkfm. Harald Heider 

  1994-04-22

  2010-01-19

joint signing clerk 

Franz Federmair 

  2009-09-22

  2010-10-19

joint signing clerk 

Dr. Richard Pfeiffer 

  1994-04-22

  2010-10-19

joint signing clerk 

Dr. Armin Toifl 

  2005-11-12

  2008-04-19

member of the supervisory board 

Bernd Euler 

  2008-10-29

  2008-12-10

member of the supervisory board 

Dipl-Ing. Jens Wegmann 

  2006-10-04

  2010-10-06

member of the supervisory board 

Johann Krempl 

   

  2010-10-06

member of the supervisory board 

Helmut Zachhuber 

  2008-04-19

  2011-06-22

member of the supervisory board 

Wolfgang Hermann 

  1999-07-24

  2001-07-12

chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing. Horst Wiesinger 

  2001-07-12

  2004-10-14

chairman of the supervisory board 

Dkfm.Dr. Erich Becker 

  2004-10-14

  2005-06-23

chairman of the supervisory board 

Mag. Klaus Sernetz 

  2006-03-02

  2011-01-15

joint signing clerk 

Ing.Mag.Dr. Andreas Pichler 

  2002-04-13

  2011-07-01

joint signing clerk 

Mag.Dr. Rudolf Platzer 

  2000-11-08

  2011-07-01

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Helmut Riepl 

  2005-06-23

  2005-11-12

chairman of the supervisory board 

Christian Habegger 

  2005-11-12

  2007-08-01

chairman of the supervisory board 

Dipl.-Ing. Dr. hc Albert Hochleitner 

  2007-11-16

  2010-10-06

chairman of the supervisory board 

Mag. Brigitte Ederer 

  2004-03-10

  2011-07-01

joint signing clerk 

Josef Klaus Stefanc 

  2010-04-09

  2011-10-28

joint signing clerk 

Christian Rawer 

  1994-04-22

  2012-04-13

joint signing clerk 

Adolf Lagler 

   

  2012-04-13

joint signing clerk 

Michael Schöpe 

  2010-11-30

  2013-02-13

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Tim Dawidowsky 

  2009-09-22

  2013-04-30

joint signing clerk 

Mag. Marcos Boskamp Alexandre 

  2001-04-27

  2013-08-08

joint signing clerk 

Ing.Mag. Claus Mittendorfer 

   

  1999-07-24

chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing. Othmar Pühringer 

   

  1999-07-24

deputy chairman of the supervisory board 

Dkfm. Helmuth Hamminger 

 

Former shareholders:

From

To

Function

Name

  1992-09-17

  2006-06-21

partner 

VA Technologie Aktiengesellschaft 

 

Former shareholdings:

From

To

Name

   

 

TBP Paperconsult GmbH 

   

 

VAI Fabrikanlagen GmbH 

  1995-05-09

  1998-05-19

Beloit Austria GmbH in Liquidation 

  1996-06-15

  1998-09-23

VA TECH Finance GmbH 

  1999-06-22

  1999-10-05

Studiengesellschaft für das Recycling von Altautos GmbH 

  1994-03-03

  1999-10-09

VOEST-ALPINE Industriedienstleistungs GmbH 

  1994-02-15

  2000-02-01

VA TECH Patente GmbH 

  1999-08-05

  2000-02-09

VOEST-ALPINE INDUSTRIAL SERVICES GmbH 

  1997-06-06

  2000-02-11

ARCMET Technologie GmbH 

  1995-11-03

  2000-02-18

GWL Gebäude- Wohnungs- und Liegenschafts- Verwaltungsgesellschaft m.b.H. 

  1994-04-06

  2004-07-14

URALMASCH-VOEST Metallurgieanlagen Projektierungsgesellschaft m.b.H. in liqu. 

  2007-01-16

  2007-07-07

VAI Pomini GmbH 

  2007-08-23

  2007-09-06

ARCMET Technologie GmbH 

  1999-11-06

  2010-08-27

Siemens VAI Metals Technologies GmbH & Co 

  2007-07-07

  2007-07-13

VAI Pomini NfG GmbH & Co KG 

  2010-09-07

  2010-09-08

VACE Engineering GmbH & Co KG 

   

 

Vogelbusch Aktiengesellschaft 

 

Mergers:

Date

Function

Name

  2010-08-27

merged with 

Siemens VAI Metals Technologies GmbH & Co 

  2007-10-01

merged with 

ARCMET Technologie GmbH 

  2006-08-16

merged with 

VA TECH International GmbH 

 

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.60.80

UK Pound

1

Rs.94.21

Euro

1

Rs.81.03

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Report Prepared by :

PRL

 

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.