MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

19.12.2013

 

 

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

ALSTOM

 

 

Registered Office :

3 Av Andre Malraux, 92300 Levallois Perret

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.03.2009

 

 

Date of Incorporation :

October 1992

 

 

Com. Reg. No.:

RCS Nanterre 0 389 058 447

 

 

Legal Form :

Public limited company with board of directors

 

 

Line of Business :

Legal media management movable heritage

 

 

No. of Employees :

01 (2008)

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory

 

 

Payment Behaviour :

No Complaints 

 

 

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail: infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – September 30th, 2013

 

Country Name

Previous Rating

(30.06.2013)

Current Rating

(30.09.2013)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

 

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


france ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With at least 79 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that reduce income disparity and the impact of free markets on public health and welfare. France's real GDP contracted 2.6% in 2009, but recovered somewhat in 2010 and 2011, before stagnating in 2012. The unemployment rate increased from 7.4% in 2008 to 10.3% in 2012. Youth unemployment shot up to 24.2% during the third quarter of 2012 in metropolitan France. Lower-than-expected growth and high unemployment costs have strained France's public finances. The budget deficit rose sharply from 3.4% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 4.5% of GDP in 2012, while France's public debt rose from 68% of GDP to 89% over the same period. Under President SARKOZY, Paris implemented some austerity measures to bring the budget deficit under the 3% euro-zone ceiling by 2013 and to highlight France's commitment to fiscal discipline at a time of intense financial market scrutiny of euro-zone debt. Socialist Party candidate Francois HOLLANDE won the May 2012 presidential election, after advocating pro-growth economic policies, the separation of banks' traditional deposit taking and lending activities from more speculative businesses, increasing the top corporate and personal tax rates, and hiring an additional 60,000 teachers during his five-year term. The government's attempt to introduce a 75% wealth tax on income over one million euros for two years was struck down by the French Constitutional Council in December 2012 because it applied to individuals rather than households. France ratified the EU fiscal stability treaty in October 2012 and HOLLANDE's government has maintained France's commitment to meeting the budget deficit target of 3% of GDP during 2013 even amid signs that economic growth will be lower than the government's forecast of 0.8%. Despite stagnant growth and fiscal challenges, France's borrowing costs declined during the second half of 2012 to euro-era lows.

 

Source : CIA

 

 

 


REGISTERED NAME & COMPANY SUMMARY

 

 

company summary

 

 

 

 

 

EUR VAT Number

FR58389058447

 

 

Activity (APE)

Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (6619A)

 

(Legal media management movable heritage (6619A))

Legal form

Public limited company with board of directors

 

 

Phone

01 46 39 08 48

RCS Registration

RCS Nanterre 0 389 058 447

 

 

Fax

 

Share capital

2,160,471,145 Euros

 

 

Address

ALSTOM
3 AV ANDRE MALRAUX
92300 LEVALLOIS PERRET

Incorporated Date

11/1992

 

 

Nationality

France

Status

Economically active

 

 

 

Trading to Date

03/31/2009

03/31/2008

03/31/2007

 

 

Turnover

0 €

0 €

0 €

 

 

Gross Operating Surplus

-

-

-

 

 

Shareholders’ equity

11,569,000,000 €

11,488,000,000 €

11,288,000,000 €

 

 

Net result

238,000,000 €

180,000,000 €

2,701,000,000 €

 

 

Employees

1 employees

-

-

 

 

Company details

 

 

Activity (APE)

Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (6619A)

 

RCS Registration

RCS Nanterre 0 389 058 447

Share capital

2,160,471,145 Euros

 

Registration Court

Nanterre (92)

Legal form

Public limited company with board of directors

 

Court Registry Number

20 0 4B04807

EUR VAT Number

FR58389058447

 

Incorporation Date

11/1992

Formation Date

10/1992

 

Deregistration Date

 

Last account Date

31/03/2009

 

Nationality

France

 

 

 

Ultimate Parent

1 ultimate parent company for this company
>  ALSTOM  - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (6619A)  in LEVALLOIS PERRET  (92300)

 

 

Establishment details

 

 

 

Activity (APE)

Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (6619A)

Business Pages FT®

 

 

Postal Address

ALSTOM
3 AV ANDRE MALRAUX
92300 LEVALLOIS PERRET

Trading Address

3 AVENUE ANDRE MALRAUX
92300 LEVALLOIS PERRET

 

Telephone

01 46 39 08 48

 

Fax

 

 

 

 

Type

Head office

Status

Economically active

 

Formation Date

08/2004

Reason for formation

Formation

 

Closure Date

 

Reason for closure

 

 

Reactivation Date

 

Production Role

 

 

Activity Nature

-

Activity Location

Other

 

Location surface

 

Seasonality

 

 

 

 

Department

Hauts-de-Seine (92)

Region

Ile-de-France

 

District

2

Area

95

 

City

LEVALLOIS PERRET

Size of urban area

Paris conglomeration

 

 

Other establishments

 

 

Branches

1 branch entities in this company

 

Head office

 
> ALSTOM <<<  - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (6619A)  in LEVALLOIS PERRET  (92300)
 

 

Secondary establishments

>  ALSTOM  - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (6619A)  in PARIS 16  (75116)

 

 

 

 

Regionality

Legal unit with all establishments in same area

 

Mono-activity status

Legal unit having all establishments with the same main activity

 

 

Workforces

 

Workforce at address

1 employees

Company workforce

1 employees

 

DIRECTORS/MANAGEMENT

 

Current Directors

14

 

 

 

 

directors

 

Shareholder(s)

 

Name

BOUYGUES

 

Name of representative

M MARIEN PHILIPPE

 

Manager position

Administrator

Date of birth

18/06/1956

 

Place of birth

PARIS

 

 

 

Type

Moral person

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

Mme. MORALEDA MARTINEZ MARIA AMPARO

 

Manager position

Administrator

Date of birth

28/05/1964

 

Place of birth

MADRID(ESPAGNE)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

Mme. BEINECKE CANDACE KRUGMAN

 

Manager position

Administrator

Date of birth

26/11/1946

 

Place of birth

PATERSON NEW JERSEY(ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. KRON PATRICK

 

Manager position

Chairman of the Board, Managing director

Date of birth

26/09/1953

 

Place of birth

PARIS

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. CHODRON DE COURCEL LOUIS MARIE ANDRE GEORGES

 

Manager position

Administrator

Date of birth

20/05/1950

 

Place of birth

AMIENS

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. HAUSER GERARD

 

Manager position

Administrator

Date of birth

29/10/1941

 

Place of birth

PARIS

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. LENG JAMES WILLIAM

 

Manager position

Administrator

Date of birth

19/11/1945

 

Place of birth

SUNDERLAND(ROYAUME-UNI)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. COLOMBANI PASCAL

 

Manager position

Administrator

Date of birth

14/10/1945

 

Place of birth

NEUILLY SUR SEINE

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. BOUYGUES OLIVIER

 

Manager position

Administrator

Date of birth

14/09/1950

 

Place of birth

SURESNES

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. FOLZ JEAN MARTIN

 

Manager position

Administrator

Date of birth

11/01/1947

 

Place of birth

STRASBOURG

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. THOMSON ALAN

 

Manager position

Administrator

Date of birth

06/09/1946

 

Place of birth

LENNOXTOWN SCOTLAND(ROYAUME-UNI)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. MANGOLD KLAUS

 

Manager position

Administrator

Date of birth

06/06/1943

 

Place of birth

PFORZHEIM(ALLEMAGNE)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

Mme. LANDIS KATRINA

 

Manager position

Administrator

Date of birth

02/08/1959

 

Place of birth

TROY N.Y.(ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

RAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

Mme. LALITA DILEEP GUPTE LALITA DILEEP

 

Manager position

Administrator

Date of birth

04/10/1948

 

Place of birth

MUMBAI(INDE)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

LALITA DATTATRAYA JOSHI

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Directors

 

 

 

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

 

Chairman of the Board

M PATRICK KRON

- - PARIS

 

Managing director

M PATRICK KRON

- - PARIS

 

Administrator

M JEAN-PAUL BECHAT

- - -

 

Administrator

M JEAN-PAUL BECHAT

02/09/1942 - MONTLHERY

 

Administrator

M JEAN-PAUL BECHAT

- - MONTLHERY

 

Administrator

CANDACE BEINECKE

- - -

 

Administrator

Mme CANDACE KRUGMAN BEINECKE

- - PATERSON NEW JERSEY(ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

 

Administrator

M OLIVIER BOUYGUES

- - SURESNES

 

Administrator

BOUYGUES

- - PARIS

 

Administrator

M LOUIS CHODRON DE COURCEL

- - -

 

Administrator

M LOUIS MARIE ANDRE GEORGES CHODRON DE COURCEL

- - AMIENS

 

Administrator

M PASCAL COLOMBANI

- - NEUILLY SUR SEINE

 

Administrator

M JAMES CRONIN

- - -

 

Administrator

M JEAN FOLZ

- - -

 

Administrator

M JEAN MARTIN FOLZ

- - STRASBOURG

 

Administrator

M JAMES WILLIAM LENG

- - SUNDERLAND(ROYAUME-UNI)

 

Administrator

M KLAUS MANGOLD

- - -

 

Administrator

M KLAUS MANGOLD

- - PFORZHEIM(ALLEMAGNE)

 

Administrator

M ALAN THOMSON

- - -

 

Administrator

M ALAN THOMSON

- - LENNOXTOWN SCOTLAND(ROYAUME-UNI)

 

Administrator

Mme LALITA DILEEP LALITA DILEEP GUPTE

04/10/1948 - MUMBAI(INDE)

 

 

 

NEGATIVE INFORMATION

 

judgements

Collective procedures

 

No judgment information for the company

   Social security, pension funds preferential rights | Tax office preferential rights

Preferential rights details and history

Status of collection

This company is not under monitoring

 


SHARE & SHARE CAPITAL INFORMATION

 

Share capital

2,160,471,145 Euros

 

PAYMENT INFORMATION

 

Payment Information Summary - Trade Payment Data

 

 

Total number of Invoices available

1

 

Total number of Invoices paid within or up to 30 days after the due date

1

 

Total number of Invoices paid more than 30 days after the due date

0

 

Total number of Invoices currently outstanding where the due date has not yet been reached

0

 

Total number of Invoices currently outstanding beyond the due date

0

 

GROUP STRUCTURE & AFFILIATED COMPANIES

 

Ultimate Holding Company

 

Company Name

 

Company number

 

 

ALSTOM

 

389058447

 

 

Group data

 

 

Ultimate parent company

ALSTOM

Direct parent

-

Group – Number of companies

500

Linkages – Number of companies

3195

Number of countries

121

 

Group Structure

Go directly to the current company

Display only where participation % > 33 %

 

Linkages

 

Ultimate parent company

ALSTOM

Direct parent

-

Group – Number of companies

500

Linkages – Number of companies

3195

Number of countries

121

 

 

FINANCIAL INFORMATION

 

accounts

Active Account |  Passive Account |  Account Results

 

Synthesized Accounts

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

Comparison mode

Average

Median

 

 

Annual Accounts

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

 

Account period (month)

12

 

12

 

12

 

 

Account Type

Normal

 

Normal

 

Normal

 

 

Date of capture

-

 

-

 

-

 

 

Activity Code

6619A

 

6619A

 

6619A

 

 

Employees

0

 

1

 

0

 

 

 

Active account

Annual Accounts

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Sector Median 2009

 

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

11 956 000 000

-3,3%

12 368 000 000

-5,5%

13 087 000 000

70 616,50

16930787,3%

- Intangible assets

2 000 000

-33,3%

3 000 000

-40,0%

5 000 000

0

0%

- Tangible assets

0

0%

0

0%

0

296,50

0%

- Financial assets

11 954 000 000

-3,3%

12 365 000 000

-5,5%

13 082 000 000

2 030,50

588721889,7%

Net current assets

22 000 000

-61,4%

57 000 000

72,7%

33 000 000

52 169

42070,6%

- Stocks

0

0%

0

0%

0

0

0%

- Advanced payments

0

-61,4%

0

0%

0

0

0%

- Receivables

22 000 000

-61,4%

57 000 000

72,7%

33 000 000

11 732

187421,3%

- Securities and cash

0

0%

0

0%

0

8 069,50

0%

- Prepaid expenses

-

-

-

-

-

0

-

Accounts of regularization

0

0%

11 000 000

-62,1%

29 000 000

0

0%

Total Assets

11 978 000 000

-3,7%

12 436 000 000

-5,4%

13 149 000 000

174 595,50

6860328,8%

 

Passive Account

Annual Accounts

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Sector Median 2009

 

Shareholders' equity

11 569 000 000

0,7%

11 488 000 000

1,8%

11 288 000 000

26 743

43259818,5%

Share capital

2 014 000 000

1,6%

1 982 000 000

2,1%

1 941 000 000

8 000

25174900%

Other capital resources

0

0%

49 000 000

-38,8%

80 000 000

0

0%

Risk Provisions

44 000 000

0%

44 000 000

0%

44 000 000

0

0%

Liabilities

365 000 000

-57,3%

855 000 000

-50,8%

1 737 000 000

125 621

290456,5%

- Financial liabilities

276 000 000

-67,1%

840 000 000

-50,8%

1 709 000 000

24 049

1147556,9%

- Advanced payments received

0

0%

0

0%

0

0

0%

- Trade account payables

4 000 000

-66,7%

12 000 000

71,4%

7 000 000

2 122,50

188357,0%

- Tax and social liabilities

85 000 000

4150,0%

2 000 000

-33,3%

3 000 000

2 133,50

3983963,7%

- Other debts and fixed assets liabilities

0

0%

1 000 000

-94,4%

18 000 000

1 786

0%

Account regularization

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total liabilities

11 978 000 000

-3,7%

12 436 000 000

-5,4%

13 149 000 000

174 595,50

6860328,8%

 

Results

Annual Accounts

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Sector Median 2009

 

Sales of Goods

137 000 000

61,2%

85 000 000

10,4%

77 000 000

20 689

662087,6%

Net turnover

0

0%

0

0%

0

15 436

0%

- of which net export turnover

0

0%

0

0%

0

0

0%

Operating charges

33 000 000

26,9%

26 000 000

-38,1%

42 000 000

25 275,50

130461,2%

Operating profit/loss

104 000 000

76,3%

59 000 000

68,6%

35 000 000

-1 283,50

8102943,8%

Financial income

112 000 000

-37,8%

180 000 000

-93,6%

2 804 000 000

252,50

44356335,6%

Financial charges

46 000 000

-64,6%

130 000 000

-18,8%

160 000 000

271

16974069,7%

Financial profit/loss

66 000 000

32,0%

50 000 000

-98,1%

2 644 000 000

0

0%

Pretax net operating income

170 000 000

56,0%

109 000 000

-95,9%

2 679 000 000

2 748

6186217,3%

Extraordinary income

0

0%

0

0%

0

0

0%

Extraordinary charges

0

0%

0

0%

0

0

0%

Extraordinary profit/loss

0

0%

-1 000 000

85,7%

-7 000 000

0

0%

Net result

238 000 000

32,2%

180 000 000

-93,3%

2 701 000 000

2 264,50

10509946,4%


 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

 

Normal Account

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Months

 

12

 

12

 

12

 

Accounts - Active
Current Assets |  Equalization accounts |  Reference


Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Grand Total (I to VI)

Net

11 978 000 000

-3,7%

12 436 000 000

-5,4%

13 149 000 000

 

Gross

CO

12 407 000 000

-0,3%

12 446 000 000

-5,4%

13 157 000 000

 

Amortisation

1A

429 000 000

4190,0%

10 000 000

25,0%

8 000 000

 

Non declared distributed capital (I)

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AA

-

-

-

-

-

 

Active fixed asset (II)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Total Active fixed asset (II)

Net

11 956 000 000

-3,3%

12 368 000 000

-5,5%

13 087 000 000

 

Gross

BJ

12 378 000 000

0%

12 378 000 000

-5,5%

13 095 000 000

 

Amortisation

BK

422 000 000

4120,0%

10 000 000

25,0%

8 000 000

 

Intangilble fixed assets

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R & D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AE

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

0

0%

2 000 000

0%

0

 

Gross

AF

0

0%

2 000 000

0%

0

 

Amortisation

AG

0

0%

0

0%

0

Goodwill

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AH

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AI

0

0%

0

0%

0

Other intangible fixed assets

Net

2 000 000

100%

1 000 000

-80,0%

5 000 000

 

Gross

AJ

13 000 000

18,2%

11 000 000

-15,4%

13 000 000

 

Amortisation

AK

11 000 000

10,0%

10 000 000

25,0%

8 000 000

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible Assets

Net

2 000 000

-33,3%

3 000 000

-40,0%

5 000 000

 

Tangilble fixed assets

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Lands

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AN

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AO

0

0%

0

0%

0

Buildings

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AP

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AQ

0

0%

0

0%

0

Plant

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AR

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AS

0

0%

0

0%

0

Other tangible fixed assets

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AT

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AU

0

0%

0

0%

0

Fixed assets in construction

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AV

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AX

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Tangible asset

Net

0

 

0

 

0

 

Financial assets

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

9 216 000 000

0%

9 216 000 000

0,0%

9 217 000 000

 

Gross

CU

9 216 000 000

0%

9 216 000 000

0,0%

9 217 000 000

 

Amortisation

CV

0

0%

0

0%

0

Inter-company receivables

Net

2 738 000 000

-13,1%

3 149 000 000

-18,5%

3 865 000 000

 

Gross

BB

3 149 000 000

0%

3 149 000 000

-18,5%

3 865 000 000

 

Amortisation

BC

411 000 000

0%

0

0%

0

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

Loans

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BF

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BG

0

 

0

 

0

Other financial assets

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BH

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BI

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Financial Assets

 

11 954 000 000

 

12 365 000 000

 

13 082 000 000

 

Current Assets (III)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Total Assets

Net

22 000 000

-61,4%

57 000 000

72,7%

33 000 000

 

Gross

CJ

29 000 000

-49,1%

57 000 000

72,7%

33 000 000

 

Amortisation

CK

7 000 000

0%

0

0%

0

 

Stocks

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Raw materials

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BL

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BM

0

0%

0

0%

0

Work in progress (goods)

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BN

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BR

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BS

0

0%

0

0%

0

Goods for resale

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BT

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BU

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Stocks

Net

0

0%

0

0%

0

 

Advance payments to suppliers

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Advance payments to suppliers

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BV

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0

 

Debtors

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Trade accounts receivable

Net

16 000 000

0%

0

0%

0

 

Gross

BX

16 000 000

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BY

0

0%

0

0%

0

Other debtors

Net

0

0%

53 000 000

82,8%

29 000 000

 

Gross

BZ

0

0%

53 000 000

82,8%

29 000 000

 

Amortisation

CA

0

0%

0

0%

0

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Debtors

Net

16 000 000

-69,8%

53 000 000

82,8%

29 000 000

 

Divers

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CD

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CF

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Divers

Net

0

0%

0

0%

0

 

Prepaid expenses

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Prepaid expenses

Net

6 000 000

50,0%

4 000 000

0%

4 000 000

 

Gross

CH

13 000 000

225,0%

4 000 000

0%

4 000 000

 

Amortisation

CI

7 000 000

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts (IV to VI)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Multi-period charges

CW3

0

0%

11 000 000

-62,1%

29 000 000

 

Gross

 

-

-

-

-

-

 

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

-

-

-

-

-

 

Currency differential gain

CN3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

-

-

-

-

-

 

References

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

 

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

Accounts - Passive
Other capital resources | Provisions for risks and charges | Liabilities | Translation loss | Equalization accounts | References


Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Grand Total (I to V)

EE

11 978 000 000

-3,7%

12 436 000 000

-5,4%

13 149 000 000

 

Shareholder Equity (I)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Total shareholders' equity (Total I)

DL

11 569 000 000

0,7%

11 488 000 000

1,8%

11 288 000 000

 

Equity and shareholders' equity

DA

2 014 000 000

1,6%

1 982 000 000

2,1%

1 941 000 000

 

Issue and merger premiums

DB

414 000 000

11,9%

370 000 000

32,1%

280 000 000

 

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

 

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

 

Legal reserve

DD

198 000 000

2,1%

194 000 000

0,5%

193 000 000

 

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

 

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

 

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

 

Other reserves

DG

7 493 000 000

-0,1%

7 500 000 000

36,4%

5 500 000 000

 

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

 

0

0%

0

 

Profits or losses brought forward

DH

1 212 000 000

-4,0%

1 262 000 000

87,5%

673 000 000

 

Profit or loss for the period

DI

238 000 000

32,2%

180 000 000

-93,3%

2 701 000 000

 

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

 

Special tax-allowable reserves

DK

0

0%

0

0%

0

 

Other capital resources (II)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

49 000 000

-38,8%

80 000 000

 

Income from participating securities

DM

0

0%

49 000 000

-38,8%

80 000 000

 

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

 

Provisions for risks and charges (III)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

44 000 000

0%

44 000 000

0%

44 000 000

 

Risk provisions

DP

0

0%

42 000 000

0%

0

 

Reserves for charges

DQ

44 000 000

2100%

2 000 000

-95,5%

44 000 000

 

Liabilities (IV)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Total Liabilities (Total IV)

EC

365 000 000

-57,3%

855 000 000

-50,8%

1 737 000 000

 

Convertible debentures

DS

0

0%

840 000 000

0%

0

 

Other debentures

DT

276 000 000

0%

0

0%

1 709 000 000

 

Bank loans and liabilities

DU

0

0%

0

0%

0

 

Sundry loans and financial liabilities

DV

0

0%

0

0%

0

 

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

 

Advance payments received for current orders

DW

0

0%

0

0%

0

 

Trade accounts payables

DX

4 000 000

-66,7%

12 000 000

71,4%

7 000 000

 

Tax and social security liabilities

DY

85 000 000

4150,0%

2 000 000

-33,3%

3 000 000

 

Fixed asset liabilities

DZ

0

0%

0

0%

0

 

Other debts

EA

0

0%

1 000 000

-94,4%

18 000 000

 

Translation loss (V)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Translation loss (Total V)

ED

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Deferred income

EB

0

0%

0

0%

0

 

References

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

 

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

 

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

Result account
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges | Financial income | Financial charges | Financial charges | Extraordinary charges | Employee profit sharing | Tax on profits | References


1- Operating result (I-II)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Operating result (Total I-II)

GG

104 000 000

76,3%

59 000 000

68,6%

35 000 000

 

2 - Financial result (V - VI)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Financial result (Total V-VI)

GV

66 000 000

32,0%

50 000 000

-98,1%

2 644 000 000

 

3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

170 000 000

56,0%

109 000 000

-95,9%

2 679 000 000

 

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

0

0%

-1 000 000

85,7%

-7 000 000

 

Profit or loss

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Profit or loss

HN

238 000 000

32,2%

180 000 000

-93,3%

2 701 000 000

 

Total Income (I+III+V+VII)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Total Income (I+III+V+VII)

HL

249 000 000

-5,7%

264 000 000

-90,8%

2 874 000 000

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

11 000 000

-86,9%

84 000 000

-51,4%

173 000 000

 

Operating income (I)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Total operating income (Total I)

FR

137 000 000

61,2%

85 000 000

10,4%

77 000 000

 

Operating income (details)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Sale of goods for resale

FC

0

0%

0

0%

0

 

France

FA

0

0%

0

0%

0

 

Export

FB

0

0%

0

0%

0

Sale of goods produced

FF

0

0%

0

0%

0

 

France

FD

0

0%

0

0%

0

 

Export

FE

0

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

0

0%

0

0%

0

 

France

FG

0

0%

0

0%

0

 

Export

FH

0

0%

0

0%

0

Net turnover

FL

0

0%

0

0%

0

 

France

FJ

0

0%

0

0%

0

 

Export

FK

0

0%

0

0%

0

 

Stocked production

FM

0

0%

0

0%

0

 

Self-constructed assets

FN

0

0%

0

0%

0

 

Operating grants

FO

0

0%

0

0%

0

 

Release of reserves and provisions

FP

0

0%

0

0%

0

 

Other income

FQ

137 000 000

61,2%

85 000 000

10,4%

77 000 000

 

Operating charges (II)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Total operating charges (Total II)

GF

33 000 000

26,9%

26 000 000

-38,1%

42 000 000

 

Exploitation charges

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Purchase of goods for resale

FS

0

0%

0

0%

0

 

Change in stocks of goods for resale

FT

0

0%

0

0%

0

 

Purchase of raw materials

FU

0

0%

0

0%

0

 

Change in stocks of raw materials

FV

0

0%

0

0%

0

 

Other external purchases and charges

FW

32 000 000

39,1%

23 000 000

-41,0%

39 000 000

 

Tax, duty and similar payments

FX

0

0%

0

0%

0

 

Payroll

FY

0

0%

0

0%

0

 

Social security costs

FZ

0

0%

0

0%

0

 

Depreciation

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Depreciation of fixed assets

GA

0

0%

3 000 000

0%

3 000 000

 

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

0

 

Depreciation/amortisation of current assets

GC

0

0%

0

0%

0

 

Provisions for risks and charges

GD

0

0%

0

0%

0

 

Other charges

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Other charges

GE

1 000 000

0%

0

0%

0

 

Operating charges (III-IV)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

 

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

 

Financial income (V)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Total financial income (Total V)

GP

112 000 000

-37,8%

180 000 000

-93,6%

2 804 000 000

 

Share financial income

GJ

0

0%

0

0%

0

 

Other investment income & capitalised receivables

GK

0

0%

0

0%

0

 

Other interest and similar income

GL

112 000 000

-37,8%

180 000 000

-8,2%

196 000 000

 

Released provisions and transferred charges

GM

0

0%

0

0%

2 608 000 000

 

Exchange gains

GN

0

0%

0

0%

0

 

Net income from disposal of investment securities

GO

0

0%

0

0%

0

 

Financial Charge (VI)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Total financial charge (Total VI)

GU

46 000 000

-64,6%

130 000 000

-18,8%

160 000 000

 

Financial reserves and provisions

GQ

6 000 000

-66,7%

18 000 000

0%

18 000 000

 

Interest and similar charges

GR

40 000 000

-64,3%

112 000 000

-21,1%

142 000 000

 

Exchange losses

GS

0

0%

0

0%

0

 

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary income (VII)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Total extraordinary income (Total VII)

HD

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary operating income

HA

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary income from capital transactions

HB

0

0%

0

0%

0

 

Released provisions and transferred charges

HC

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary charges (VIII)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary operating charges

HE

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary charges from capital transactions

HF

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary reserves and provisions

HG

0

0%

0

0%

0

 

Employee profit sharing (IX)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

0

0%

0

0%

0

 

Tax on profits (X)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Tax on profits (Total X)

HK

-68 000 000

5,6%

-72 000 000

-148,3%

-29 000 000

 

References

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

 

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

 

Of which transferred charges

A1

0

0%

0

0%

0

 

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

 

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

Other incomes tax return forms
Reserve for depreciation | Provisions included in balance sheet | State deadlines claims and debts at the end of period
Table allocation results and other information


Fixed Assets
Grand Total Fixed Assets (I to IV)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Gross value at begin of period

OG

12 378 000 000

-5,5%

13 094 000 000

-3,0%

13 500 000 000

 

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

OK2

0

0%

716 000 000

75,9%

407 000 000

 

Gross value at the end of period

OL

12 378 000 000

0%

12 378 000 000

-5,5%

13 093 000 000

 

Research and development Charge (Total I)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

C01

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

C02

0

0%

0

0%

0

 

Gross value at the end of period

D0

0

0%

0

0%

0

 

Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Gross value at begin of period

KD

13 000 000

0%

13 000 000

0%

13 000 000

 

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

LV2

0

0%

0

0%

2 000 000

 

Gross value at the end of period

LW

13 000 000

0%

13 000 000

18,2%

11 000 000

 

Tangible fixed assets (Total III)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Gross value at begin of period

LN

0

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NG2

0

0%

0

0%

0

 

Gross value at the end of period

NH

0

0%

0

0%

0

 

Fiancial assets (Total IV)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Gross value at begin of period

LQ

12 365 000 000

-5,5%

13 081 000 000

-3,0%

13 487 000 000

 

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NJ2

0

0%

716 000 000

76,8%

405 000 000

 

Gross value at the end of period

NK

12 365 000 000

0%

12 365 000 000

-5,5%

13 082 000 000

 

Reserve for depreciation
Situation and movement of reserve for depreciation
Grand total (I-II-III)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Reserve for depreciation value at begin of period

0N

10 000 000

25,0%

8 000 000

33,3%

6 000 000

Increases

0P

1 000 000

-50,0%

2 000 000

0%

2 000 000

Decreasess

0Q

0

0%

0

0%

0

 

Reserve for depreciation value at the end of period

0R

11 000 000

10,0%

10 000 000

25,0%

8 000 000

 

Research and development charge (Total I)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0

 

Other intangible assets (Total II)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

10 000 000

25,0%

8 000 000

33,3%

6 000 000

Increases

PF

1 000 000

-50,0%

2 000 000

0%

2 000 000

Decreasess

PG

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PH

11 000 000

10,0%

10 000 000

25,0%

8 000 000

 

Total fixed assets amotisation (Total III)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

0

0%

0

0%

0

Increases

QV

0

0%

0

0%

0

Decreases

QW

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

QX

0

0%

0

0%

0


Movements during period affecting charge allocated over several period

Charges à répartir ou frais d'émission d'emprunt

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

29 000 000

 

Premium refund of obligations

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Net value at begining of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

 

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

 

Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Value at begining of period

7C

44 000 000

0%

44 000 000

25,7%

35 000 000

Increases

UB

0

0%

3 000 000

-66,7%

9 000 000

Decreases

UC

0

0%

3 000 000

0%

0

 

Value at the end of period

UD

44 000 000

0%

44 000 000

0%

44 000 000

Includes Total allocations

 

Operating

UE

0

0%

0

0%

0

 

Financial

UG

0

0%

0

0%

0

 

Exceptional

UJ

0

0%

0

0%

0

Includes Total Withdrawal

 

Operating

UF

0

0%

0

0%

0

 

Financial

UH

0

0%

0

0%

0

 

Exceptional

UK

0

0%

0

0%

0

 

Total regulated provisions (Total I)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Value at begining of period

3Z

0

0%

0

0%

0

Increases

TS

0

0%

0

0%

0

Decreases

TT

0

0%

0

0%

0

 

Value at the end of period

TU

0

0%

0

0%

0

 

Total risk and charge provisions (Total II)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Value at begining of period

5Z

44 000 000

0%

44 000 000

25,7%

35 000 000

Increases

TV

0

0%

3 000 000

-66,7%

9 000 000

Decreases

TW

0

0%

3 000 000

0%

0

 

Value at the end of period

TX

44 000 000

0%

44 000 000

0%

44 000 000

 

Total Provision for depreciation (Total III)

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Value at begining of period

7B

0

0%

0

0%

0

Increases

TY

0

0%

0

0%

0

Decreases

TZ

0

0%

0

0%

0

 

Value at the end of period

UA

0

0%

0

0%

0

 

State deadlines claims and debts at the end of period
State claims

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Gross value

VT

16 000 000

0%

0

0%

29 000 000

 

1 year at most

VU

16 000 000

0%

0

0%

29 000 000

 

More than one year

VV

0

0%

0

0%

0

 

State of loans

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Claims related to holdings (gross)

UL

0

0%

0

0%

0

 

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

0%

0

0%

0

 

Loans (gross)

UP

0

0%

0

0%

0

 

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

0

0%

0

 

Other financial assets (gross)

UT

0

0%

0

0%

0

 

Other financial assets (1 year at most)

UV

0

0%

0

0%

0

 

Receivables statement of assets

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Customers doubtful or disputed

VA

0

0%

0

0%

0

 

Other claims customer

UX

0

0%

0

0%

0

 

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

 

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

 

Personnel and associated accounts

UY

0

0%

0

0%

0

 

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

0

0%

0

 

Income taxes

VM

0

0%

0

0%

0

 

Value added tax

VB

0

0%

0

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

VN

0

0%

0

0%

0

 

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

0

0%

0

 

Group and Associates

VC

0

0%

0

0%

0

 

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

0

0%

0

0%

0

 

Prepaid

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Prepaid

VS

2 000 000

0%

0

0%

0

 

State Debt

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Total debt (gross)

VY

365 000 000

-57,3%

855 000 000

-50,8%

1 737 000 000

1 year at most

VZ2

365 000 000

35,2%

270 000 000

629,7%

37 000 000

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

0

0%

585 000 000

-65,6%

1 700 000 000

More than 5 years

VZ4

0

0%

0

0%

0

 

Details

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

840 000 000

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

255 000 000

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

585 000 000

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

276 000 000

0%

0

0%

1 709 000 000

1 year at most

7Z2

276 000 000

0%

0

0%

9 000 000

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

1 700 000 000

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VG2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VH2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8A2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8A3

0

0%

0

0%

0

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

4 000 000

-66,7%

12 000 000

71,4%

7 000 000

1 year at most

8B2

4 000 000

-66,7%

12 000 000

71,4%

7 000 000

More than 1 year and 5 years at most

8B3

0

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8C2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

0

0%

2 000 000

-33,3%

3 000 000

1 year at most

8D2

0

0%

2 000 000

-33,3%

3 000 000

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (gross)

VW1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VW2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

85 000 000

0%

0

0%

0

1 year at most

VQ2

85 000 000

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8J2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VI2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More 5 years

VI4

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

0

0%

1 000 000

-94,4%

18 000 000

1 year at most

8K2

0

0%

1 000 000

-94,4%

18 000 000

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8L2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0

 

References

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Loans made during the period

VJ

0

0%

0

0%

0

 

Debt repaid during the period

VK

0

0%

0

0%

0

 

Table allocation results and other information
Dividends distributed

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0

 

Commitments

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

 

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

 

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0

 

Other charges Externes

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

 

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

 

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

 

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

 

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

 

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

 

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0

 

Taxes and Fees

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

 

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0

 

VAT

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

 

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0

 

Average number of employees

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Average number of employees

YP

0

0%

01

0%

0

 

Groups and Shareholders

 

 

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

 

Groups and Shareholders

ZR

-

-

-

-

-

 

 

 

Display parameter

Comparison mode

Average

Median

 

Ratios
Structure and liquidity | Management or rotation | Profitability of the business | Return on capital


Structure and Liquidity

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Sector Median 2009

 

Fixed Asset Financing

0,99

-1,0%

1

0%

1

1,12

-11,6%

Global Debt

days

-

days

-

days

400 days

-

Working Capital Fund overall net

days

-

days

-

days

141,50 days

-

Financial independence

4191,67%

206,5%

1367,62%

107,1%

660,50%

107,17%

3811,2%

More ratios

Solvability

96,59%

4,1%

92,77%

7,3%

86,46%

24,90%

287,9%

Capacity debt futures

%

-

%

-

%

603,29%

-

Coverage of current assets by net working capital overall

-418,75%

-518,8%

100%

-14,7%

117,24%

48,34%

-966,3%

General Liquidity

0,04

0%

0

0%

0,78

0,27

-85,2%

Restricted Liquidity

0,04

0%

0

0%

0,78

0,76

-94,7%

 

Management or rotation

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Sector Median 2009

 

Need background in operating working capital

days

-

days

-

days

5,50 days

-

Treasury

days

-

days

-

days

11 days

-

Inventory turnover of goods

days

-

days

-

days

0 days

-

Average length of credit granted to customers

days

-

days

-

days

30 days

-

Average length of credit obtained suppliers

45 days

-76,1%

188 days

189,2%

65 days

88,50 days

-49,2%

More ratios

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

days

-

days

-

days

0 days

-

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

days

-

days

-

days

42 days

-

Rotation tangible assets

%

-

%

-

%

38,70%

-

 

Profitability of the business

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Sector Median 2009

 

Margin trading

%

-

%

-

 

0%

-

Profitability of the business

 

-

 

-

 

20,81%

-

Net profit

%

-

%

-

%

8,17%

-

More ratios

Growth rate of turnover (excluding VAT)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Rates integration

%

-

%

-

%

64,19%

-

Rate leasing furniture

%

-

%

-

%

0%

-

Work Factor

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Weight interests

 

-

%

-

%

1,14%

-

 

Return on capital

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Sector Median 2009

 

Cash flow from the overall profitability

%

-

%

-

%

23,41%

-

Rates of economic profitability

0%

0%

0%

0%

0%

0,80%

0%

Financial profitability

11569000000%

0,3%

11537000000%

1,5%

11368000000%

97,50%

11865640925,6%

Return on investment

2,40%

-4,0%

2,50%

-88,6%

21,88%

5,16%

-53,5%

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

Comparison mode

Average

Median

 

Soldes Intermédiaires de Gestion

 

31/03/2009

 

31/03/2008

 

31/03/2007

Sector Median 2009

 

Turnover

0

0%

0

0%

0

15 436 € 

0% 

 

Sales of goods

0

0%

0

0%

0

 

 

- Purchase of goods

0

0%

0

0%

0

 

 

+/- Stock of goods variation

0

0%

0

0%

0

 

 

Trading margin

0 €

0%

0 €

0%

0 €

0 € 

0% 

 

% CA

-

% CA

-

% CA

0 % CA 

 

Sale of goods produced

0

0%

0

0%

0

 

 

+/- Stocked production

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Self-constructed assets

0

0%

0

0%

0

 

 

Period production

0 €

0%

0 €

0%

0 €

13 653 € 

0% 

 

% CA

-

% CA

-

% CA

100 % CA 

 

Trading margin

0

0%

0

0%

0

0% 

+ Period Production

0

0%

0

0%

0

13 653 

0% 

- Purchase of raw materials

0

0%

0

0%

0

 

 

+/- Change in stocks of raw materiels

0

0%

0

0%

0

 

 

- Other external purchases and charges

32 000 000

39,1%

23 000 000

-41,0%

39 000 000

 

 

Added value

-32 000 000 €

-39,1%

-23 000 000 €

41,0%

-39 000 000 €

3 921,50 € 

-816114,3% 

 

% CA

-

% CA

-

% CA

64,19 % CA 

 

Added value

-32 000 000 €

-39,1%

-23 000 000 €

41,0%

-39 000 000 €

3 921,50 € 

-816114,3% 

+ Operating grants

0

0%

0

0%

0

 

 

- Tax, duty and similar payments

0

0%

0

0%

0

 

 

- Personal charges

0

0%

0

0%

0

 

 

Gross operating surplus

-32 000 000 €

-39,1%

-23 000 000 €

41,0%

-39 000 000 €

-438 € 

-7305836,1% 

 

% CA

-

% CA

-

% CA

20,81 % CA 

 

Gross operating surplus

-32 000 000 €

-39,1%

-23 000 000 €

41,0%

-39 000 000 €

-438 € 

-7305836,1% 

+ Release of reserves and provisions

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Other operating income

137 000 000

61,2%

85 000 000

10,4%

77 000 000

 

 

- Depreciation/Amortisation

0

0%

3 000 000

0%

3 000 000

 

 

- Other charges

1 000 000

0%

0

0%

0

 

 

Operating result

104 000 000 €

76,3%

59 000 000 €

68,6%

35 000 000 €

-1 283,50 € 

8102943,8% 

 

% CA

-

% CA

-

% CA

8,53 % CA 

 

Operating result

104 000 000 €

76,3%

59 000 000 €

68,6%

35 000 000 €

-1 283,50 € 

8102943,8% 

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Financial income

112 000 000

-37,8%

180 000 000

-93,6%

2 804 000 000

 

 

- Financial charges

46 000 000

-64,6%

130 000 000

-18,8%

160 000 000

 

 

Pre-tax result

170 000 000 €

56,0%

109 000 000 €

-95,9%

2 679 000 000 €

540,50 € 

31452258,9% 

 

% CA

-

% CA

-

% CA

9,37 % CA 

 

Extraordinary income

0

0%

0

0%

0

0% 

- Extraordinary charges

0

0%

0

0%

0

 

 

Extraordinary result

0 €

0%

0 €

0%

0 €

0 € 

0% 

 

% CA

-

% CA

-

% CA

0 % CA 

 

Pre-tax result

170 000 000 €

56,0%

109 000 000 €

-95,9%

2 679 000 000 €

540,50 € 

31452258,9% 

Extraordinary result

0 €

0%

0 €

0%

0 €

0 € 

0% 

- Employee profit sharing

0

0%

0

0%

0

 

 

- Tax on profits

-68 000 000

5,6%

-72 000 000

-148,3%

-29 000 000

 

 

Net result

238 000 000 €

31,5%

181 000 000 €

-93,3%

2 708 000 000 €

163,50 € 

145565649,2% 

% CA

-

% CA

-

% CA

8,05 % CA 

-

ADDITIONAL INFORMATION

 

This company is not under monitoring

Trends

 

 

Profitability

 

Liquidity

 

Net worth

 

Commentary

The comments are ordered according to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative for another or can change depending on its value. This is a purely statistical decision.

 

The ratio total assets to total liabilities is 29.29

 

 

The sales to current assets ratio is 0

 

The deviation in the equity percentage over the last two accounting periods is 260.92 %

 

The deviation in the return on capital employed over the last two accounting periods is 156.97 %

 

The growth in pre-tax profit over the last two accounting periods is 157.41 %

 

The net current assets are 22,000,000 €

 

The pre-tax profit is 170,000,000 €

 

The stocks value is 0 €

 

Low risk workforce size

 

Industry code with low risk rating

 

Region code with low risk rating

 

The company is 21 years old

 

The deviation in the gearing percentage over the last two accounting periods is 35.95 %

 

The growth in the pre-tax profit margin over the last two accounting periods is 0 %

 

The deviation in the current ratio over the last two accounting periods is 90.41 %

 

The trade payables value is 4,000,000 €

 

The tangible fixed assets are 0 €

 

The financial liabilities are 276,000,000 €

 

The receivables value is 22,000,000 €

 

The net turnover is 0 €

 

Linkages

Company Name

 

SIREN

Parts

Last account published

 

ALSTOM

 

389058447

-

31/03/2009

 

CITAL

 

-

49%

-

ALSTOM HOLDINGS

 

347951238

100%

31/03/2013

CIE INT DEVELOPPEMENT INFRASTRUCTU...

 

305394496

50.45%

31/12/2012

ALSTOM GRID AUSTRALIA LIMITED

 

-

100%

-

AUXILIAIRE MARITIME J31

 

410312342

100%

31/03/2012

ALSTOM GRID SAS

 

389191800

100%

31/03/2013

PASSONI & VILLA

 

-

Majority

-

ALSTOM GRID MIDDLE EAST FZE

 

-

100%

-

ALSTOM GRID ETUDES TECHNIQUES

 

-

99.44%

-

ALSTOM TRANSPORT HOLDING US

 

-

100%

-

ALSTOM TRANSPORTATION INC

 

US46466215

100%

-

ALSTOM SIGNALING, INC

 

US43476190

100%

-

GENERAL RAILWAY SIGNAL OF CANADA LTD

 

-

100%

-

COGELEX

 

313104572

50%

-

ALSTOM NEW ZEALAND HOLDINGS LTD

 

-

100%

-

ALSTOM POWER NEW ZEALAND LIMITED

 

-

100%

-

ALSTOM NEW ZEALAND LIMITED

 

-

100%

-

ALSTOM KLEBER TWENTY

 

481209245

100%

31/03/2013

LONG & CRAWFORD LIMITED

 

00118040

100%

31/03/2013

ALSTOM GRID UK LIMITED

 

04955841

100%

31/03/2013

ALSTOM KLEBER THIRTEEN

 

439116328

100%

31/03/2013

ALSTOM GRID PTE LTD

 

-

100%

-

ALSTOM MANAGEMENT SA

 

421395815

100%

31/03/2013

ALSTOM GRID PAKISTAN LIMITED

 

-

80%

-

ALSTOM POWER CONVERSION

 

424897692

100%

31/03/2013

CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES

 

420284226

60.84%

31/03/2011

ALSTOM MEXICANA SA DE CV

 

504322157

100%

-

ALSTOM POWER PROYECTOS S.A. DE C.V.

 

-

100%

-

ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA

 

-

100%

-

CMW EQUIPAMENTOS SA

 

-

100%

-

ALSTOM MEXICANA SA DE CV

 

-

100%

-

ROSARITO POWER SA DE CV

 

-

Majority

-

SUBURBANO EXPRESS SA DE CV

 

-

Majority

-

DELAS REPSA

 

-

Majority

-

AREVA T&D XIAMEN SWITCHGEAR CO LTD

 

-

100%

-

ALSTOM GRID CANADA INC

 

-

100%

-

ALSTOM GRID

 

115415

100%

31/03/2013

MOBILITE AGGLOMERATION REMOISE SAS

 

489034215

Majority

31/12/2012

ALSTOM POWER THAILAND LTD

 

-

100%

-

ALSTOM GRID ARGENTINA SA

 

-

94.94%

-

ALSTOM GRID SA DE CV

 

-

99.99%

-

AREVA T&D SA COLOMBIE

 

-

100%

-

ALSTOM KLEBER SIXTEEN

 

447767179

100%

31/03/2013

ALSTOM GRID AG

 

4695477

100%

-

ALSTOM GRID MAROC

 

-

100%

-

ALSTOM GRID JAPAN KK

 

-

100%

-

ALSTOM SUZHOU HIGH VOLTAGE SWITCHGEAR CO...

 

-

80%

-

TRANSLOHR

 

413424128

51%

31/12/2011

ALSTOM KLEBER TWENTY ONE

 

484513627

100%

31/03/2013

AREVA T&D BEIJING SWITCHGEAR CO. LTD

 

-

100%

-

ALSTOM RESOURCES MANAGEMENT

 

404434946

100%

31/03/2013

ALSTOM VENEZUELA SA

 

-

100%

-

PT UNELEC INDONESIA

 

-

67.65%

-

ALSTOM GRID INC

 

US41460793

100%

-

ALSTOM AUSTRALIA HOLDINGS LIMITED

 

-

100%

-

ALSTOM POWER SITE SERVICES PTY LIMITED

 

-

100%

-

ALSTOM AUSTRALIA LIMITED

 

-

100%

-

ALSTOM AUSTRALIA SUPERANNUATION PLAN PTY...

 

-

100%

-

ALSTOM MSC PTY LTD

 

-

100%

-

SIGMA ENERGY SOLUTIONS INC

 

US20740515

100%

-

ALSTOM LIMITED

 

-

100%

-

ALSTOM UGL ROLLING STOCK PTY LIMITED

 

-

100%

-

AREVA T&D SHANGAÏ POWER AUTOMATION CO LT...

 

-

58%

-

ALSTOM POWER AUSTRIA GMBH

 

-

100%

-

ALSTOM ARGENTINA SA

 

-

100%

-

ALSTOM GRID AB

 

-

100%

-

AREVA T&D CHILE SA

 

-

99.99%

-

AREVA T&D BELGIUM SA

 

-

99.99%

-

ALSTOM DENMARK AS

 

-

100%

-

ALSTOM TRANSPORT ROMANIA SA

 

-

98%

-

ALSTOM TRANSPORT SA

 

389191982

100%

31/03/2011

FRANCE METRO CARACAS

 

313536880

Majority

31/12/2012

ALSOMA GEIE

 

483775839

Majority

31/03/2012

ALSTOM TRACTION LTD

 

00221639

Majority

31/03/2006

ALSTOM SIGNALING KFT

 

-

Majority

-

ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES

 

752364778

100%

31/03/2013

ALSTOM GRID EGYPT

 

-

99.81%

-

ALSTOM TRANSPORTS PTE LTD

 

-

100%

-

ALSTOM SÉNÉGAL

 

-

100%

-

ALSTOM KONSTAL SPOLKA AKCYINA

 

-

100%

-

ALSTOM UK HOLDINGS LTD.

 

04267912

100%

31/03/2013

ALSTOM TRANSPORT LIMITED

 

-

100%

-

ALSTOM LTD

 

04267931

100%

31/03/2013

SOC ABB ALSTOM POWER UK LTD

 

437528730

100%

-

ALSTOM TRANSPORT HONG KONG LIMITED

 

-

Majority

-

ALSTOM TRANSPORT SERVICE LTD

 

02849471

Majority

31/03/2013

ALSTOM TURBINE GENERATORS INDIA ...

 

00632923

100%

31/03/2013

ALSTOM RESOURCES MANAGEMENT LTD

 

00540682

100%

31/03/2013

ALSTOM POWER CONSTRUCTION LIMITE...

 

02937311

100%

31/03/2006

ALSTOM GRID UK LIMITED

 

04955841

100%

31/03/2013

ALSTOM GRID POWER ELECTRONIC S...

 

00512211

100%

31/03/2013

ALSTOM GRID NIGERIA LIMITED

 

-

100%

-

PSYMETRIX

 

-

100%

-

ALSTOM NORTHERN LINE SERVICE PROVISION

 

-

100%

-

ALSTOM PENSION TRUST LIMITED

 

03579649

100%

31/03/2013

WEST COAST SERVICE PROVISION LIM...

 

03602414

Majority

31/03/2013

NEWBOLD DEFINED CONTRIBUTION PEN...

 

05623333

Majority

31/03/2012

NEWBOLD POWER PLANTS SERVICES LT...

 

00461146

100%

31/03/2012

ALSTOM TRANSPORTATION PROJECTS I...

 

00964379

Majority

31/03/2013

NEWBOLD CONTRACTING LIMITED

 

03639315

100%

31/03/2013

ALSTOM GROUP UK LIMITED

 

07365289

Majority

31/03/2013

ALSTOM NETWORK UK LTD

 

00954220

100%

31/03/2013

ALSTOM TRANSMISSION UK LIMITED

 

-

Majority

-

ALSTOM GRID SWITCHGEAR LIMITED

 

-

Majority

-

ALSTOM TRANSPORTATION PROJECTS LIMITED

 

-

Majority

-

COGELEX LIMITED

 

05144942

Majority

31/03/2013

HARDY TRAINCARE LTD

 

02968562

Majority

31/03/2009

COSTA HEAD WAVE FARM LIMITED

 

-

50%

-

AWS OCEAN ENERGY LTD

 

-

42.28%

-

AREVA T&D SP ZOO (POLOGNE)

 

-

100%

-

ALSTOM INC

 

US20542956

100%

-

ALSTOM POWER INC AIR PREHEATER C...

 

US42487705

100%

-

AIR PREHEATER EQUIPAMENTOS LTDA

 

-

100%

-

APCOMPOWER INC

 

US44781359

100%

-

ALSTOM USA INC

 

-

100%

-

ALSTOM POWER TURBOMACHINES LLC

 

-

Majority

-

POWER SYSTEMS MANUFACTURING, LLC

 

US08078618

100%

-

SGTB LLC

 

-

Majority

-

ALSTOM POWER INTERNATIONAL INC

 

-

Majority

-

ALSTOM MAINTENANCE INC

 

-

Majority

-

ALSTOM PAC INC

 

-

Majority

-

ALSTOM POWER CONVERSION INC

 

-

Majority

-

ALSTOM WIND TEXAS LLC

 

-

Majority

-

BBCP CORPORATION

 

-

Majority

-

BTGS LP

 

-

Majority

-

DANIELSON WIND FARMS LLC

 

-

Majority

-

 


DDCP INC

 

US36398463

Majority

-

 

F F C P

 

US18367571

Majority

-

MEEKER COUNTY WIND INVESTMENTS LLC

 

-

Majority

-

ALSTOM CHINA INVESTMENT CO LTD

 

-

100%

-

ALSTOM SIZHOU ELECTRIC POWER EQUIPMENT (...

 

-

Majority

-

ALSTOM TECHNICAL SERVICES (SHANGHAI) CO ...

 

-

100%

-

ALSTOM GRID SHANGHAI CO LTD

 

-

100%

-

WUHAN BOILER

 

2289583

51%

31/12/2012

WUHAN WUGUO ZHIXIN ENVIRONMENTAL PROTECT...

 

-

49%

-

WUHAN BOILER BOYU INDUSTRIAL CO LTD

 

-

90%

-

WUHAN LANXIANG ENERGY ENVIRONMENTAL PROT...

 

-

95%

-

ALSTOM SIZHOU BOILER AUXILIARY MACHINERY...

 

-

Majority

-

ALSTOM INSTRUMENT TRANSFORMERS (SHANGHAI...

 

-

51%

-

ALSTOM HONG KONG LTD

 

-

100%

-

ALSTOM SHANGHAI AOHAN ENERGY RECOVERY SY...

 

-

50%

-

ALSTOM BEIZHONG POWER (BEIJING) CO LTD

 

-

50%

-

ALSTOM POWER SERVICE HONG KONG LTD

 

-

100%

-

ALSTOM QINGDAO RAILWAY EQUIPMENT CO LTD

 

-

51%

-

ALSTOM STRONGWISH SHENZHEN CO LTD

 

-

100%

-

ALSTOM WUHAN ENGINEERING & TECHNOLOGY CO...

 

-

50%

-

CASCO SIGNAL LTD

 

-

50%

-

SHANGHAI ALSTOM TRANSPORT COMPANY LIMITE...

 

-

40%

-

SHANGHAI ALSTOM TRANSPORT ELECTRICAL EQU...

 

-

50%

-

XI'AN ALSTOM YONGJI ELECTRIC EQUIPMENT C...

 

-

51%

-

ALSTOM (YANGZHOU) HIGH VOLTAGE BUS DUCTS...

 

-

50%

-

ALSTOM (WUXI) DISCONNECTOR CO LTD

 

-

50%

-

ALSTOM GRID ENTREPRISE MANAGEMENT (SHANG...

 

-

100%

-

ALSTOM GRID LTD

 

-

100%

-

SEC ALSTOM (WUHAN) TRANSFORMERS CO LTD

 

-

50%

-

ALSTOM GRID TECHNOLOGY CENTER CO LTD

 

-

100%

-

ALSTOM POWER GENERATION LIMITED

 

-

Majority

-

ALSTOM (GUANGDONG) SWITCHGEAR CO LTD

 

-

50%

-

ALSTOM YULI (BEIJING) DISCONNECTOR CO LT...

 

-

50%

-

DALIAN PYUNG-IL CARIBONI POWER LINE PROD...

 

-

Majority

-

KEEN MASTER LIIMITED

 

-

Majority

-

SEC AREVA (SHANGHAI BAOSHAN) TRANSFORMER...

 

-

50%

-

SEC AREVA (SHANGHAI LINGANG) TRANSFORMER...

 

-

50%

-

WUXI ALUMIN CASTING CO LTD

 

-

Majority

-

ALSTOM INFORMAT SYSTEMS & TECHNOLO...

 

447767344

99.26%

31/03/2013

ALSTOM GRID ENERJI ENDUSTRISI AS

 

-

99.97%

-

ALSTOM GRID AS

 

937025440

100%

31/03/2013

ALSTOM POWER HIDROELEKTRIK URETIM TESIS ...

 

-

Majority

-

LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN

 

321735789

99.52%

31/03/2013

ALSTOM KHADAMAT SA

 

-

100%

-

ALSTOM MAROC SA

 

-

100%

-

ALSTOM GRID ENERGIA LTDA

 

-

99.99%

-

ALSTOM POWER HOLDINGS SA

 

315398214

100%

31/03/2013

ALSTOM POWER SYSTEMS SA

 

389192030

96.99%

31/03/2013

ALSTOM POWER SERVICE

 

424210599

100%

31/03/2012

PROTEA

 

489034165

100%

31/03/2011

ALSTOM POWER INDUSTRIE

 

424210888

100%

31/03/2013

ALSTOM POWER S.A

 

424210433

99.84%

31/03/2013

ALSTOM N.V.

 

34116556

100%

31/03/2013

ALSTOM SWEDEN AB

 

-

100%

-

ALSTOM TRANSPORT AB

 

5560589094

100%

31/03/2013

ALSTOM POWER SWEDEN AKTIEBOLAG

 

-

100%

-

ALSTOM POWER NORWAY AS

 

-

100%

-

ALSTOM ASIA PACIFIC SDN BHD

 

-

100%

-

ALSTOM POWER SERVICE (ARABIA) FZE

 

-

100%

-

ALSTOM TRANSPORT B.V.

 

24281270

100%

31/03/2013

ALSTOM AG

 

16016

100%

-

ALSTOM POWER O & M AG

 

4140289

100%

-

ALSTOM TECHNOLOGY LTD

 

-

100%

-

ALSTOM INSPECTION ROBOTICS A...

 

5423726

Majority

-

ALSTOM SRO

 

-

100%

-

ALSTOM POWER AG

 

-

100%

-

ALSTOM POWER BOILER GMBH

 

-

100%

-

ALSTOM POWER GENERATION AG

 

-

100%

-

ALSTOM GMBH

 

HRB 705754

100%

31/03/2013

ALSTOM SCHORCH TRANSFORMATOREN GMBH

 

-

100%

-

NTPC ALSTOM POWER SERVICES PRIVATE LTD

 

-

50%

-

ALSTOM DEUTSCHLAND AG

 

HRB 8660

100%

31/03/2012

ALSTOM LHB GMBH

 

-

100%

-

ALSTOM POWER GMBH

 

HRB 73134 B

100%

31/03/2013

ALSTOM KK

 

-

100%

-

ALSTOM POWER SP ZOO

 

-

100%

-

ALSTOM POWER SYSTEMS GMBH

 

HRB 703176

100%

31/03/2013

ALSTOM LOKOMOTIVEN SERVICE G...

 

HRB 3960

51%

31/03/2013

ALSTOM ERSTE VERWALTUNGS GMBH

 

-

Majority

-

ALSTOM POWER BOILER SERVICE GMBH

 

-

100%

-

INTER-ELECTRO GESELLSCHAFT MBH

 

-

Majority

-

VORBEREITUNGSGESELLSCHAFT TRANSPORTTECHN...

 

-

Majority

-

ALSTOM INFORMATION TECHNOLOG...

 

HRB 9819

Majority

31/03/2010

ALSTOM TRANSPORT DEUTSCHLAND...

 

HRB 6001

100%

31/03/2013

ALSTOM GRID GMBH

 

HRB 89214

100%

31/03/2013

ALSTOM GRID MESSWANDLER GM...

 

HRB 3182

100%

31/03/2013

ALSTOM CARBON CAPTURE GMBH

 

HRB 707361

100%

31/03/2012

ALSTOM ZWEITE VERWALTUNGS GMBH

 

-

Majority

-

SCHORCH ALTERSVERSORGUNG GMBH

 

-

Majority

-

ALSTOM CROATIA LTD

 

-

100%

-

ALSTOM POWER ROMANIA SRL

 

-

100%

-

ALSTOM LIMITED

 

-

100%

-

ALSTOM POWER STAVAN

 

-

Majority

-

ALSTOM POWER TURBOMACHINES LIMITED

 

-

Majority

-

ALSTOM GRID RUSAL ELECTRO ENGINEERING

 

-

Majority

-

ALSTOM POWER UNITURBO LIMITED

 

-

50%

-

TRTRANS

 

-

50%

-

PT ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONÉSIA

 

-

78.79%

-

ALSTOM FINANCE B.V.

 

24424380

100%

31/03/2013

ALSTOM PROJECTS INDIA LTD

 

498366103

58.55%

-

ALSTOM POWER BOILERS SERVICES LIMITED

 

-

100%

-

ALSTOM NETHERLANDS B.V.

 

24437182

Majority

31/03/2013

 

DE BARTE ZEELAND BV

 

-

Majority

-

 

GEC ALSTHOM NV

 

-

Majority

-

ALSTOM BERGERON

 

342952868

100%

31/03/2013

ALSTOM POWER HEAT EXCHANGE

 

552053357

100%

31/03/2013

ALSTOM EXPORT SDN BHD

 

-

100%

-

ALSTOM RENEWABLE HOLDING FRANCE

 

484517271

100%

31/03/2013

ALSTOM HYDRO FRANCE

 

327948907

100%

31/03/2013

ALSTOM HYDRO CHINA CO LTD

 

-

99%

-

GECI

 

348964487

50%

-

ALSTOM RENEWABLE TECHNOLOGIE...

 

752364711

100%

31/03/2013

ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA

 

-

100%

-

PCH OPERACAO E MANUTENCAO LTDA

 

-

50%

-

ALSTOM HYDRO MALAYSIA SDN BHD

 

-

Majority

-

ALSTOM POWER & TRANSPORT CANADA INC

 

-

100%

-

ALSTOM SITCA INC

 

-

100%

-

ALSTOM AFRICA HOLDING PTY LTD

 

-

100%

-

ALSTOM GENERAL TURBO SA

 

-

Majority

-

ALSTOM BELGIUM SA

 

436195241

100%

31/03/2013

ALSTOM ACEC ENERGIE

 

-

49%

-

ALSTOM NORWAY AS

 

980402274

100%

31/03/2013

ALSTOM VANNKRAFT AS

 

889467592

Majority

31/03/2013

ALSTOM BELGIUM POWER SERVICE

 

-

Majority

-

PT ALSTHOMINDO

 

-

66.67%

-

ALSTOM ESPAÑA IB

 

315850

100%

31/03/2012

ALSTOM POWER

 

588979

100%

31/03/2013

APLICACIONES TECNICAS INDUSTRIAL...

 

102990

100%

31/03/2011

ALSTOM TRANSPORTE

 

57399

100%

31/03/2012

IRVIA MANTENIMIENTO FERROVIARI...

 

2463491

50%

31/12/2012

ALSTOM PORTUGAL S.A.

 

-

100%

-

ALSTOM WIND SOCIEDAD LIMITADA

 

-

100%

-

ALSTOM WIND FRANCE SAS

 

451479208

Majority

31/03/2013

ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA

 

1142867

100%

31/03/2012

CALDERERIA TORRES ALTAMIRA SA

 

-

Majority

-

ECOTECNIA PROMOCIONES EOLICAS IN...

 

107323

Majority

-

EOLICA DE LA RUYA

 

800360

Majority

31/12/2012

EOLICA HORMILLA

 

236812

Majority

-

EOLICA ORTEGA

 

1570232

Majority

-

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA SA

 

-

Majority

-

PARC EOLIC COLL DEL PANISSOT SOCIEDAD LI...

 

-

Majority

-

PARC EOLIC L'ERA BELLA

 

1823180

Majority

-

PARQUE EOLICO LA SARGILLA

 

237446

Majority

-

PARQUE EOLICO LAS TADEAS

 

1281007

Majority

31/12/2010

PARQUE EOLICO VALDEHIERRO

 

1280983

Majority

31/12/2010

PARQUES EOLICOS DE CEUTA SL

 

-

Majority

-

PARQUES EOLICOS DE LA REGION DE ...

 

213588

Majority

-

VENT DEL MONTSIA

 

1460822

Majority

-

ECOTECNIA GALICIA SL

 

-

100%

-

ECOTECNIA INSTALACION SL

 

-

100%

-

ALSTOM WIND INSTALACION

 

1393217

100%

31/03/2011

ALSTOM WIND ALTAMIRA

 

365429

Majority

31/03/2011

ALSTOM WIND GALICIA

 

585230

Majority

31/03/2012

ALSTOM WIND NAVARRA

 

257976

Majority

31/03/2012

EOLICA TRAMUNTANA

 

5038965

Majority

-

SET VECIANA

 

2470704

Majority

31/12/2012

ALSTOM CANADA INC

 

-

100%

-

ALSTOM CANADA OCEAN TECHNOLOGY INC

 

-

Majority

-

MECANIKA CONSTRUCTION INC

 

-

Majority

-

LORELEC

 

786880401

100%

31/03/2013

GIE REST INTERENTREPRISES DES FLAN...

 

312646888

34.82%

-

ETOILE-KLEBER.

 

542051040

100%

31/03/2013

CHANTIERS DE L ATLANTIQUE

 

347951204

100%

31/03/2013

ALSTOM LEROUX NAVAL

 

410354682

100%

31/03/2013

ALSTOM ACEC ENERGIE

 

-

36%

-

ALSTOM LTD

 

04267931

100%

31/03/2013

ALSTOM POWER GENERATION LIMITED

 

-

100%

-

ALSTOM WEST COAST TRAINCARE LIMITED

 

-

100%

-

ALSTOM ELECTRICAL MACHINES LTD

 

00490074

100%

31/03/2006

ALSTOM TURBINE GENERATORS CHINA LTD

 

-

100%

-

ALSTOM POWER PLANTS LTD.

 

02403889

100%

31/03/2013

ALSTOM INDIA LIMITED

 

-

100%

-

ALSTOM HYDRO R&D INDIA LIMITED

 

-

Majority

-

ALSTOM BHARAT FORGE POWER LIMITED

 

-

50%

-

ALSTOM TRANSPORT INDIA LIMITED

 

-

Majority

-

KALYANI ALSTOM POWER LIMITED

 

-

49%

-

ZAO ALSTOM GRID

 

-

98.37%

-

ALSTOM GRID VENEZUELA SA

 

-

100%

-

ALSTOM GRID FOR ELECTRICAL NETWORK SAE

 

-

100%

-

ALSTOM KAZAKHSTAN LLP

 

-

100%

-

STE EQUIPEMENT HYDROMECANIQUE

 

330307158

Majority

31/03/2012

ALSTOM S.P.A.

 

MI1253789

100%

31/03/2012

ALSTOM GRID S.P.A.

 

VE129218

100%

31/03/2011

ALSTOM POWER ITALIA SPA

 

453985996

100%

-

ALSTOM POWER FLOWSYSTEMS SRL

 

-

100%

-

ALSTOM WIND ITALIA SRL

 

-

100%

-

ALSTOM FERROVIAIRIA

 

452962681

100%

-

OSVALDO CARIBONI LECCO S.P.A.

 

LC65021

70%

31/03/2012

SOCIETA' ITALIANA MONTAGGI SOCIE...

 

FR147916

Majority

31/12/2012

SISTEMA AUTOMATICO DI TRASPORTO SRL

 

-

Majority

-

ALSTOM GRID ALGÉRIE SPA

 

-

99.80%

-

ALSTOM T & D INDIA LTD

 

557987

73.40%

31/03/2013

GRID EQUIPMENTS LIMITED

 

-

100%

-

ENERGY GRID AUTOMATION TRANSFORMERS AND ...

 

-

100%

-

SMARTGRID AUTOMATION DISTRIBUTION AND SW...

 

-

100%

-

ALSTOM GRID HVDC INDIA LIMITED

 

02789805

100%

31/03/2013

ALSTOM BELGIUM BUSINESS & SERVICES SA NV

 

-

100%

-

AREVA T&D AUSTRIA AG

 

-

99%

-

ALSTOM GRID SPOL SRO

 

-

85%

-

ALSTOM GRID HELLAS AE

 

-

99.90%

-

ALSTOM GRID MALAYSIA SDN BHD

 

-

100%

-

PROFIT COMBO LTD

 

-

75%

-

ST LEONARDS SPR LIMITED

 

02820803

100%

31/03/2013

TOP YIELDS GROUP LTD

 

-

100%

-

WHOLEWISE INTERNATIONAL LTD

 

-

100%

-

PT ALSTOM GRID

 

-

95%

-

ALSTOM HYDRO SWITZERLAND LTD

 

-

100%

-

ALSTOM ALGÉRIE SAS

 

-

100%

-

CE ALSTOM POWER MASSY

 

322869603

100%

-

ALSTOM POWER HYDRAULIQUE

 

-

100%

-

ALSTOM POWER NEDERLAND B.V.

 

24191939

100%

31/03/2012

AGUAYTIA SUMINISTROS Y EQUIPAMIENTOS SA

 

-

Majority

-

ALSKAW LLC

 

-

Majority

-

ALSTOM CHILE SA

 

-

100%

-

ALSTOM POWER TOCOPILLA LIMITADA

 

-

100%

-

ALSTOM ESTONIA AS

 

-

100%

-

ALSTOM FINLAND OY

 

10227508

100%

31/03/2012

ALSTOM HUNGARY CO LTD

 

-

Majority

-

ALSTOM HYDRO AUSTRIA GMBH

 

-

100%

-

ALSTOM HYDRO CANADA INC

 

-

100%

-

ALSTOM HYDRO DEUTSCHLAND GMBH

 

HRB 701056

100%

31/03/2010

ALSTOM HYDRO SWEDEN AB

 

5566614680

Majority

31/03/2013

ALSTOM HYDRO VENEZUELA

 

-

Majority

-

ALSTOM IRELAND LTD

 

-

Majority

-

ALSTOM SAUDI ARABIA LIMITED

 

-

Majority

-

ALSTOM PHILIPPINES INC

 

-

Majority

-

ALSTOM NIGERIA LIMITED

 

-

Majority

-

ALSTOM TAIWAN LTD

 

-

Majority

-

ALSTOM CARIBE INC

 

-

Majority

-

ALSTOM KOREA LTD

 

-

Majority

-

ALSTOM POWER COLOMBIA SA

 

-

Majority

-

ALSTOM POWER CHICOASEN SA DE CV

 

-

100%

-

ALSTOM POWER SINGAPORE PTE LTD

 

-

Majority

-

ALSTOM LATVIA LTD

 

-

Majority

-

ALSTOM POWER SLOVAKIA SRO

 

-

100%

-

ALSTOM PROJECTS TAIWAN LTD

 

-

100%

-

ALSTOM ZIMBABWE PRIVATE LIMITED

 

-

Majority

-

ALSTOM PANAMA SA

 

-

Majority

-

ALSTOM HOLDINGS THAILAND CO LTD

 

-

Majority

-

ALSTOM INDUSTRIA LTDA

 

-

100%

-

ALSTOM POWER PROJECTS PTY LTD

 

-

Majority

-

ALSTOM TRANSPORT HELLAS SA

 

-

Majority

-

ALSTOM VIETNAM COMPANY LIMITED

 

-

Majority

-

ALSTOM BOILER FRANCE

 

493182505

100%

31/03/2013

ALSTOM WIND OFFSHORE SN

 

493278881

100%

31/03/2013

ALSTOM SEXTANT 4

 

493309942

100%

31/03/2013

ALSTOM WESSEX TRAINCARE (HOLDINGS)

 

02957753

Majority

31/03/2005

ALSTOM STH AFRICA POWER PROJECTS PTY LIM...

 

-

Majority

-

ALSTOM POWER ASIA PACIFIC

 

504571233

100%

-

ALSTOM ENERGIE SERVICE GMBH

 

HRB 706434

100%

31/03/2009

ALSTOM SCHIENENFAHRZEUGE AG

 

-

Majority

-

CEBRAF SERVICOS LTDA

 

-

100%

-

CITADIS ISRAEL

 

-

Majority

-

COMELEX

 

319861795

100%

31/03/2013

ECOTECNIAPORT-SISTEMAS DE ENERGIAS ALTER...

 

-

100%

-

ENERCON ENGINEERING UND MONTAGE AG

 

-

Majority

-

EUKORAIL CO.LTD

 

402235220

100%

-

KAJIWARA IRON WORKS CO LTD

 

-

Majority

-

KOLMEX SA

 

-

Majority

-

ALSTOM AUSTRIA GMBH

 

-

100%

-

NIHON KENGYO KK

 

-

Majority

-

NIHON SANGYO KK

 

-

Majority

-

 

 

PARC EOLIEN DE CHAMPS PUGET

 

479763849

Majority

31/03/2013

 

PARC EOLIEN DE VIALETTE

 

479763732

Majority

31/03/2013

PARC EOLIEN LES PIERRES PLATES

 

479762155

Majority

31/03/2013

PARC EOLIEN DU COIN GUERIN

 

479763906

Majority

31/03/2013

PLA DE MOULIS

 

490822335

Majority

31/03/2012

POWER EQUIPMENT & MATERIALS CO LTD

 

-

Majority

-

PT MITRA LANGKAH PRIMA

 

-

100%

-

SOCPE DE BREUILLEBAULT

 

493367056

Majority

31/03/2013

SOCPE DE CERMELLES

 

479763807

Majority

31/03/2012

SOCPE DE CHAMPS PERDUS

 

492745468

Majority

31/12/2012

SOCPE DE FOND DE LA DEMIE LIEUE

 

492745443

Majority

31/03/2013

SOCPE LA FORTE PLACE

 

489358549

Majority

31/03/2013

SOCPE DE LAME DE FER

 

492745492

Majority

31/03/2013

SOCPE DE POUZELAS

 

493367031

Majority

31/03/2013

SOCPE DE VERS CAYEUX

 

492745401

Majority

31/03/2013

SOCPE DES BEAUCES

 

493367064

Majority

31/03/2013

SOCPE DU BOIS DE LENS

 

490934528

Majority

31/03/2013

SOCPE LA MARGE

 

497737163

Majority

31/03/2013

SOCPE LANDES DE COUESME

 

492745344

Majority

31/12/2012

SOCPE PLANE DE MANSA

 

489358473

Majority

31/03/2012

SOCIEDADE PORTUGUESA DE GERACAO DE ELECT...

 

-

Majority

-

STOCZNIA GDYNIA S.A.

 

-

Majority

-

STROMSDAL OY

 

-

Majority

-

SWISSMETRO AG IN LIQUIDATION

 

578146

Majority

-

THE ELECTRICAL MATERIALS & EQUIPMENT CO ...

 

-

Majority

-

UAB ALSTOM POWER

 

-

Majority

-

ALSTOM COMBINED CYCLES LTD.

 

02775889

Majority

31/03/2006

ALSTOM THAILAND LIMITED

 

-

Majority

-

ALSTOM NAMIBIA (PTY) LIMITED

 

-

Majority

-

ACTOM

 

-

100%

-

ALSTOM JOHN THOMPSON (PTY) LIMITED

 

-

Majority

-

ALSTOM POWER SERVICE SA (PTY) LIMITED

 

-

100%

-

ALSTOM RAIL LTD

 

03624089

Majority

31/03/2006

ALSTOM S&E AFRICA PTY

 

-

100%

-

ALSTOM TRANSPORT INFORMATION ET SÉCURITÉ...

 

-

100%

-

CONSENEC AG

 

619593

Majority

-

ECOTECNIA ITALIA SRL UNIPERSONALE

 

-

100%

-

AP O&M LTD

 

-

100%

-

ALSTOM ATOMENERGOMASH

 

-

49%

-

ALSTOM POWER CONVERSION GMBH

 

-

100%

-

ALSTOM POWER FLOW SYSTEMS GMBH

 

-

100%

-

ALSTOM BULGARIA EOOD

 

-

100%

-

ALSTOM COLOMBIA SA

 

-

100%

-

ALSTOM GRID DANMARK

 

-

100%

-

ALSTOM GRID OY

 

-

100%

-

ALSTOM NETWORK POWER

 

520978842

100%

31/03/2013

ALSTOM NETWORK GRID

 

520979097

100%

31/03/2013

ALSTOM NETWORK TRANSPORT

 

520979014

100%

31/03/2013

SIGNALLING SOLUTIONS LIMITED

 

05894128

50%

31/03/2013

SOCPE CHAMPS CHAGNOTS

 

509643383

Majority

-

SOCPE LE CHENE COUTEAU

 

509631461

100%

31/03/2013

ALSTOM HELLAS SA

 

-

Majority

-

PT ALSTOM TRANSPORT INDONESIA

 

-

Majority

-

ALSTOM ISRAEL LIMITED

 

-

Majority

-

ALSTOM TRANSPORT KOREA LIMITED

 

-

Majority

-

ALGEC GT SERVICES

 

-

50%

-

FRENCH LIBYAN ELECTRICAL SERVICES COMPAN...

 

-

Majority

-

ALSTOM SERVICES SDN BHD

 

-

Majority

-

LCM SWITCHGEAR MANUFACTURING SDN BHD

 

-

Majority

-

CONCEPELEC

 

-

Majority

-

ALSTOM GRID RUSAL BV

 

-

50%

-

ALSTOM GRID HOLDING B.V.

 

50750445

100%

31/03/2013

TMH-ALSTOM BV

 

-

50%

-

ALSTOM GRID PORTUGAL LTDA

 

-

98%

-

ALSTOM GRID ROMANIA

 

-

100%

-

ALSTOM PERU SA

 

-

Majority

-

ALSTOM POLAND SSC SP ZOO

 

-

Majority

-

ALSTOM POWER CONSTRUCTION SP ZOO

 

-

Majority

-

ALSTOM POWER SPOLKA Z ORGRANICZONA ODPOW...

 

-

Majority

-

ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMANIA SRL

 

-

Majority

-

ALSTOM SAUDI ARABIA TRANSPORT AND POWER ...

 

-

Majority

-

AREVA T&D SAUDI ARABIA LIMITED

 

-

100%

-

AS 5 SINGAPORE PTE LTD

 

-

Majority

-

ALSTOM SLOVAKIA SRO

 

-

Majority

-

ALSTOM POWER SERVICE PROPRIETARY LIMITED

 

-

Majority

-

ALSTOM SOUTHERN AFRICA HOLDINGS

 

-

Majority

-

ALSTOM SWITZERLAND SERVICES LIMITED

 

-

Majority

-

ALSTOM MANAGEMENT RESOURCES AG

 

378052

Majority

-

ALSTOM NETWORK SCHWEIZ AG

 

-

Majority

-

ALSTOM POWER CONSULTING AG

 

-

Majority

-

ALSTOM POWER SWITZERLAND LTD

 

434469623

Majority

-

ALSTOM GRID LIMITED THAILAND

 

-

49%

-

ALSTOM TRANSPORTATION SERVICES LTD

 

-

Majority

-

ALSTOM T&T LTD

 

-

Majority

-

ALSTOM POWER VE ULASIM ANONIM SIRKETI

 

-

Majority

-

ALSTOM MIDDLE EAST FZE

 

-

Majority

-

ADAMS WIND GENERATIONS LLC

 

-

Majority

-

ALSTOM URUGUAY SA

 

-

100%

-

BYRCO CORP SA

 

-

Majority

-

ALSTOM GRID VIETNAM COMPANY LIMITED

 

-

100%

-

ASTER CAPITAL PARTNERS SAS

 

414286567

Min blocking

31/12/2012

ALSTOM POWER BULGARIA SP LTD

 

-

100%

-

ALSTOM INTERNATIONAL EGYPT S.A.E.

 

-

Majority

-

ALSTOM EGYPT FOR POWER & TRANSPORT PROJE...

 

-

Majority

-

EQUIPAMENTOS DE TRACAO ELETRICA LTDA

 

-

Majority

-

EMBIX

 

530721307

50%

31/12/2012

ALSTOM WIND EQUIPAMENTOS EOLICOS E SERVI...

 

-

Majority

-

INDÚSTRIA METALÚRGICA E MECÂNICA DA AMAZ...

 

-

50%

-

ALSTOM POWER CZ SRO

 

-

Majority

-

ALSTOM ACEC CONGO

 

-

Majority

-

ALSTOM WATER SYSTEMS SAE

 

-

Majority

-

SAMT

 

477914899

Majority

31/03/2009

TERRES DE L'ABBAYE

 

509631388

Majority

31/03/2013

CLEVER ENGINEERING GMBH

 

-

Majority

-

FFW GMBH GESELLSCHAFT FUR PERSONAL UND O...

 

-

Majority

-

HORIZON VENTURES

 

-

50%

-

MEGALIM SOLAR POWER LIMITED

 

-

Majority

-

ABRECO REALTY CORPORATION

 

-

Majority

-

CLEVER ENGINEERING AG

 

756833

Majority

-

ALSTOM SHANGHAI ELECTRIC BOILERS CO

 

-

50%

-

TIDAL GENERATION LIMITED

 

05338761

100%

31/12/2012

 

Linkages

Company Name

 

SIREN

Last account

Turnover

SIEMENS

 

76393

30/09/2012

1 958 771 785 €

ALSTOM INDIA

 

1479361

31/03/2013

428 107 260 €

SIEMENS (PAKISTAN) ENGINEERING

 

483733

30/09/2012

110 822 424 €

ROLLS-ROYCE MARINE AS

 

980371379

31/12/2012

85 632 342 KNOK

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

 

HRB 6684

30/09/2012

78 812 000 000 €

SCHNEIDER ELECTRIC SA

 

542048574

31/12/2011

261 000 €

SCHNEIDER ELECTRIC HOLDING AMERIQ NORD

 

303994537

31/12/2012

0 €

SCHNEIDER ELECTRIC HOLDING EUROPE

 

444578256

31/12/2012

0 €

SIEMENS AS

 

915826946

30/09/2012

46 060 745 KNOK

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

 

954503439

31/12/2012

3 608 391 081 €

SCHENKER AS

 

870896182

31/12/2012

29 585 001 KNOK

BALFOUR BEATTY OVERSEAS INVESTMENTS LIMI...

 

01198173

31/12/2012

0 £

DB NETZ AKTIENGESELLSCHAFT

 

HRB 50879

31/12/2012

5 524 000 000 €

BALFOUR BEATTY INVESTMENT HOLDINGS LIMIT...

 

01198315

31/12/2012

0 £

SIEMENS HOLDINGS PLC

 

02465263

30/09/2012

0 £

ALSTOM HOLDINGS

 

347951238

31/03/2013

0 €

SIEMENS FINANCIAL SERVICES GMBH

 

HRB 49074

30/09/2012

94 106 000 €

DB FRANCE HOLDING SAS

 

515351567

31/12/2012

0 €

DB FERNVERKEHR AKTIENGESELLSCHAFT

 

HRB 83173

31/12/2011

3 767 000 000 €

T & D HOLDING

 

449834308

31/12/2009

185 025 000 €

SIEMENS FRANCE HOLDING

 

388548091

30/09/2012

0 €

DB REGIO AKTIENGESELLSCHAFT

 

HRB 50977

31/12/2012

6 527 000 000 €

ROLLS-ROYCE OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

 

02658963

31/12/2012

0 £

ROLLS-ROYCE OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED

 

04060767

31/12/2012

0 £

ROLLS-ROYCE POWER ENGINEERING PLC

 

01305027

31/12/2012

1 043 000 000 £

ROLLS-ROYCE GROUP PLC

 

04706930

31/12/2012

0 £

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

 

07524813

31/12/2012

12 161 000 000 £

FIELDEN & ASHWORTH LIMITED

 

00863291

31/12/2012

5 348 000 £

BRUTON INVESTMENTS LIMITED

 

01790555

31/12/2012

0 £

MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED

 

01970801

31/12/2012

0 £

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

 

421106709

31/12/2012

2 409 543 858 €

BALFOUR BEATTY PLC

 

00395826

31/12/2012

9 483 000 000 £

ROLLS-ROYCE PLC

 

01003142

31/12/2012

12 161 000 000 £

ITALDATA S.P.A.

 

AV70558

30/09/2012

4 444 397 €

BALFOUR BEATTY GROUP LIMITED

 

00101073

31/12/2012

2 909 000 000 £

DB STATION&SERVICE AKTIENGESELLSCHAFT

 

HRB 87691 B

31/12/2012

1 242 000 000 €

ALSTOM FERROVIARIA S.P.A.

 

CN236229

31/03/2012

1 146 733 345 €

VINTERS INTERNATIONAL LIMITED

 

00542021

31/12/2012

0 £

ROLLS-ROYCE PLACEMENTS LIMITED

 

04959288

31/12/2012

0 £

SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY LIMITE...

 

04729734

30/09/2012

345 298 000 £

VINTERS ENGINEERING LIMITED

 

00003543

31/12/2012

15 700 000 £

SIEMENS RENTING SPA IN LIQUIDAZIONE

 

MI1554257

30/09/2012

34 005 628 €

BIRSE CONSTRUCTION LIMITED

 

01981677

31/12/2012

0 £

SIEMENS FINANCIAL SERVICES HOLDINGS LIMI...

 

04140043

30/09/2012

66 000 000 £

SIEMENS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION LI...

 

00631825

30/09/2012

292 164 000 £

MANSELL BUILD LIMITED

 

01300965

31/12/2012

16 233 000 £

ALSTOM SEXTANT 5

 

517793634

31/03/2011

0 €

JOHN LAING SERVICES LIMITED

 

01363079

31/12/2012

540 000 £

SIEMENS S.P.A.

 

MI525193

30/09/2012

1 622 284 741 €

BALFOUR BEATTY PROPERTY LIMITED

 

01881541

31/12/2012

0 £

BALFOUR BEATTY PROJECTS & ENGINEERING LI...

 

00169240

31/12/2012

0 £

S-BAHN BERLIN GMBH

 

HRB 51257 B

31/12/2012

609 642 000 €

SCHNEIDER ELECTRIC (UK) LIMITED

 

02886434

31/12/2012

0 £

SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE

 

444643720

31/12/2012

149 903 191 €

BALFOUR BEATTY PROPERTY INVESTMENTS LIMI...

 

02343440

31/12/2012

0 £

SCHNEIDER ELECTRIC LIMITED

 

01407228

31/12/2012

587 243 000 £

VINTERS LIMITED

 

03517200

31/12/2012

0 £

BALFOUR BEATTY INFRASTRUCTURE INVESTMENT...

 

00457719

31/12/2012

0 £

SCHENKER

 

550502942

31/12/2012

109 191 774 €

ROLLS-ROYCE POWER DEVELOPMENT LIMITED

 

03479694

31/12/2012

28 612 000 £

ULSTEIN HOLDING AS

 

940348714

31/12/2012

11 614 KNOK

DB ENERGIE GMBH

 

HRB 41705

31/12/2012

2 679 000 000 €

SIEMENS FINANCIAL SERVICES LIMITED

 

00646166

30/09/2012

128 428 000 £

PARSONS BRINCKERHOFF UK (EUROPE AFRICA) ...

 

07094787

31/12/2012

0 £

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.

 

MI1459360

30/09/2012

200 550 619 €

ALSTOM POWER ITALIA SPA

 

MI1497214

31/03/2012

132 739 054 €

VA TECH (UK) LIMITED

 

03562487

30/09/2012

0 £

JOHN LAING INFRASTRUCTURE LIMITED

 

04401816

31/12/2012

326 345 £

SIEMENS MAGNET TECHNOLOGY LIMITED

 

02342055

30/09/2008

152 341 000 £

ROLLS-ROYCE FUEL CELL SYSTEMS LIMITED

 

04433075

31/12/2012

0 £

USF HOLDING (UK) LIMITED

 

02417739

30/09/2008

0 £

GUINEA INVESTMENTS LIMITED

 

01114823

31/12/2012

0 £

ARMPLEDGE LIMITED

 

01594306

31/12/2012

0 £

ROLLS-ROYCE AIRCRAFT MANAGEMENT LIMITED

 

02830526

31/12/2012

0 £

IMS S.P.A.

 

MB264817

31/12/2012

110 788 228 €

SIEMENS BUSINESS SERVICES AS

 

916767285

30/09/2011

9 544 KNOK

THE TELEGRAPH CONSTRUCTION AND MAINTENAN...

 

00001147

31/12/2012

58 000 £

NEI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

 

01189545

31/12/2012

0 £

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.

 

BG288118

31/12/2012

587 479 482 €

PARSONS BRINCKERHOFF LTD

 

02554514

31/12/2012

167 500 000 £

SIEMENS S.A.S

 

562016774

30/09/2012

1 495 104 652 €

ALSTOM POWER SWEDEN AKTIEBOLAG

 

5560114224

31/03/2013

1 526 160 KSEK

SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME GMBH

 

HRB 143838

30/09/2012

-

JOHN LAING INVESTMENTS LIMITED

 

00780225

31/12/2012

0 £

EIMCO LIMITED

 

03159250

31/12/2012

0 £

CROUZET AUTOMATISMES

 

663820413

31/12/2012

126 700 968 €

ALSTOM BOILER DEUTSCHLAND GMBH

 

HRB 740764

31/03/2013

67 064 852 €

HADEN BUILDING SERVICES LIMITED

 

00152500

31/12/2012

0 £

LAING INVESTMENTS MANAGEMENT SERVICES LI...

 

03600959

31/12/2012

54 767 000 £

EIMSKIP-CTG AS

 

937019661

31/12/2012

329 152 KNOK

COMPOSITE TECHNOLOGY AND APPLICATIONS LI...

 

06604702

31/12/2011

0 £

LAING PROPERTY LIMITED

 

04058446

31/12/2012

0 £

BWI INFORMATIONSTECHNIK GMBH

 

HRB 15251

30/09/2012

677 451 000 €

ALSTOM SERVICES ITALIA S.P.A.

 

CN290168

-

-

BALFOUR BEATTY RAIL INVESTMENTS LIMITED

 

03048949

31/12/2012

0 £

SCHNEIDER TOSHIBA INVERTER SAS

 

402981070

31/12/2012

5 422 053 €

SCHNEIDER ELECTRIC FONCIERE

 

421107459

31/12/2012

11 080 451 €

UNIFLAIR S.P.A.

 

PD212586

31/12/2012

82 186 524 €

BIRSE GROUP LIMITED

 

00977257

31/12/2012

0 £

DB SCHENKER RAIL (UK) LIMITED

 

02938988

31/12/2012

429 000 000 £

 

 

event history

 

 

Status history

 

 

No Status History

 

 

Recent publications in Gazettes

 

 

Publication date

Gazette Name

Description

 

11/12/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

4475 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2160471145 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

21/11/2013

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 08/11/2013
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 160 471 145 €
Date d'effet : 08/11/2013

25/10/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2008 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2160422145 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

09/10/2013

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 11/09/2013
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 160 422 145 €
Date d'effet : 11/09/2013

18/08/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

9623 - 389058447 RCS. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Adresse : 3 avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/03/2013.

18/08/2013

Bodacc C

Comptes consolidés et rapports

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

9622 - 389058447 RCS. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Adresse : 3 avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/03/2013.

04/08/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1807 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur : BEINECKE Candace Krugman modification le 16 Mars 2012 Président du conseil d'administration Directeur général : KRON Patrick Administrateur : CHODRON DE COURCEL Louis Marie Andre Georges Administrateur : HAUSER Gerard Administrateur : LENG James William Administrateur : COLOMBANI Pascal modification le 16 Mars 2012 Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 18 Juillet 2006 Administrateur : FOLZ Jean Martin en fonction le 27 Juillet 2007 Administrateur : THOMSON Alan modification le 31 Juillet 2007 Administrateur : MANGOLD Klaus en fonction le 27 Juillet 2007 Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 09 Avril 2008 Commissaire aux comptes suppléant : DE CAMBOURG Patrick en fonction le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 16 Juillet 2009 Administrateur : RAY Katrina en fonction le 13 Août 2010 Administrateur : LALITA DATTATRAYA JOSHI Lalita Dileep modification le 06 Septembre 2011 Administrateur : MORALEDA MARTINEZ Maria Amparo en fonction le 26 Juillet 2013. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant.

26/07/2013

JAL

Appointment of the social representative

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 02/07/2013
Société faisant l'objet d'une nomination : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET
Nominé : Madame Maria Amparo MORALEDA MARTINEZ, 28002 MADRID
En la fonction de : Administrateur

26/07/2013

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 02/07/2013
La société 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET
Fait l'objet du départ de Monsieur Jean-Paul BECHAT

24/07/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

3837 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2159400180 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

11/07/2013

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 27/06/2013
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 159 400 180 €
Date d'effet : 27/06/2013

26/06/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

4548 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2158825354 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

02/06/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1185 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2158777754 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

24/05/2013

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 16/05/2013
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 158 777 754 €
Date d'effet : 16/05/2013

23/04/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2101 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2157106882 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

15/04/2013

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 31/03/2013
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 157 106 882 €
Date d'effet : 31/03/2013

05/04/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1254 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2156583744 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

28/02/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

5240 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2156405062 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

19/02/2013

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 11/02/2013
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 156 405 062 €
Date d'effet : 31/01/2013

03/02/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2259 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2156262129 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

02/01/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1489 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2156070952 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

24/12/2012

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 12/12/2012
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 156 070 952 €
Date d'effet : 30/11/2012

27/11/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2517 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2155870752 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

19/11/2012

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 08/11/2012
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 155 870 752 €
Date d'effet : 08/11/2012

26/10/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2010 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2155868183 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

17/10/2012

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 04/10/2012
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 155 868 183 €
Date d'effet : 04/10/2012

27/09/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1614 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2063810917 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

17/09/2012

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 07/09/2012
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 063 810 917 €
Date d'effet : 07/09/2012

13/09/2012

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 07/09/2012
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 063 810 917 €
Date d'effet : 07/09/2012

14/08/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

9310 - 389058447 RCS. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Adresse : 3 avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/03/2012.

14/08/2012

Bodacc C

Comptes annuels, consolidés et rapports

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

9311 - 389058447 RCS. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Adresse : 3 avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/03/2012.

25/07/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

3557 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2063659409 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

16/07/2012

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 30/06/2012
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 063 659 409 €
Date d'effet : 30/06/2012

01/06/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1340 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2062314891 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

17/05/2012

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 30/04/2012
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 062 314 891 €
Date d'effet : 30/04/2012

25/04/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

4197 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2061735760 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

13/04/2012

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 04/04/2012
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 061 735 760 €
Date d'effet : 04/04/2012

27/03/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

3288 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2061607520 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

15/03/2012

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 08/03/2012
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 061 607 520 €
Date d'effet : 08/03/2012

09/03/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2445 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2061197264 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

02/03/2012

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 17/02/2012
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 061 197 264 €
Date d'effet : 17/02/2012

22/02/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2792 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur : BECHAT Jean-Paul Administrateur : BEINECKE Candace Krugman Président du conseil d'administration et directeur général : KRON Patrick Administrateur : CHODRON DE COURCEL Louis Marie Andre Georges Administrateur : HAUSER Gerard Administrateur : LENG James William Administrateur : COLOMBANI Pascal Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 18 Juillet 2006 Administrateur : FOLZ Jean Martin en fonction le 27 Juillet 2007 Administrateur : THOMSON Alan modification le 31 Juillet 2007 Administrateur : MANGOLD Klaus en fonction le 27 Juillet 2007 Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 09 Avril 2008 Commissaire aux comptes suppléant : DE CAMBOURG Patrick en fonction le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 16 Juillet 2009 Administrateur : RAY Katrina en fonction le 13 Août 2010 Administrateur : LALITA DATTATRAYA JOSHI Lalita Dileep modification le 06 Septembre 2011. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant.

15/02/2012

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 16/01/2012
La société 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET
Fait l'objet du départ de Monsieur Philippe JOUBERT

09/02/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2849 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2061137064 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

30/01/2012

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 16/01/2012
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une diminution de son capital social désormais de 2 061 137 064 €
Date d'effet : 16/01/2012

29/01/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1464 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2061487064 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

20/01/2012

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 06/01/2012
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 061 487 064 €
Date d'effet : 06/01/2012

30/12/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1562 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2061452302 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

15/12/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1984 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2061393796 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

15/12/2011

JAL

Modification of the share capital

 

 

Tribune (La)


Date de décision : 30/11/2011
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 061 452 302 €
Date d'effet : 30/11/2011

18/11/2011

JAL

Modification of the share capital

 

 

Tribune (La)


Date de décision : 31/10/2011
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une diminution de son capital social désormais de 2 061 393 796 €
Date d'effet : 31/10/2011

20/10/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1145 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2062440191 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

12/10/2011

JAL

Modification of the share capital

 

 

Tribune (La)


Date de décision : 30/09/2011
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 062 440 191 €
Date d'effet : 30/09/2011

27/09/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2496 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2061610831 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

19/09/2011

JAL

Modification of the share capital

 

 

Tribune (La)


Date de décision : 08/09/2011
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 061 610 831 €
Date d'effet : 08/09/2011

24/07/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1484 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur : BECHAT Jean-Paul Administrateur : BEINECKE Candace Krugman Président du conseil d'administration et directeur général : KRON Patrick Administrateur : CHODRON DE COURCEL Louis Marie Andre Georges Administrateur : HAUSER Gerard Administrateur : LENG James William Administrateur : COLOMBANI Pascal Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 18 Juillet 2006 Administrateur : FOLZ Jean Martin en fonction le 27 Juillet 2007 Administrateur : THOMSON Alan modification le 31 Juillet 2007 Administrateur : MANGOLD Klaus en fonction le 27 Juillet 2007 Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 09 Avril 2008 Commissaire aux comptes suppléant : DE CAMBOURG Patrick en fonction le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 16 Juillet 2009 Administrateur : RAY Katrina en fonction le 13 Août 2010 Administrateur : LALITA DATTATRAYA JOSHI Lalita Dileep en fonction le 13 Août 2010 Directeur général délégué : JOUBERT Philippe en fonction le 14 Juillet 2011. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant.

24/07/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1506 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2061557309 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

17/07/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1331 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2061501176 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

13/07/2011

JAL

Modification of the share capital

 

 

Tribune (La)


Date de décision : 06/07/2011
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 061 557 309 €
Date d'effet : 06/07/2011

07/07/2011

JAL

Appointment of the social representative

 

 

Tribune (La)


Société faisant l'objet d'une nomination : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET
Nominé : Monsieur Philippe JOUBERT, 6 Place de la République Dominicaine, 75017 PARIS 17
En la fonction de : Directeur général
Date d'effet : 13/06/2011

30/06/2011

JAL

Modification of the share capital

 

 

Tribune (La)


Date de décision : 24/06/2011
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 061 501 176 €
Date d'effet : 23/06/2011

20/05/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1525 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2061103821 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

13/05/2011

JAL

Modification of the share capital

 

 

Tribune (La)


Date de décision : 03/05/2011
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 061 103 821 €
Date d'effet : 03/05/2011

20/04/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2588 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2060935128 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

12/04/2011

JAL

Modification of the share capital

 

 

Tribune (La)


Date de décision : 04/04/2011
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 060 935 128 €
Date d'effet : 04/04/2011

31/03/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

3563 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2060627387 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

17/03/2011

JAL

Modification of the share capital

 

 

Tribune (La)


Date de décision : 10/03/2011
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 060 627 387 €
Date d'effet : 10/03/2011

18/02/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2080 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2060120258 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

30/12/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2170 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2059653092 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

20/12/2010

JAL

Modification of the share capital

 

 

Tribune (La)


Date de décision : 14/12/2010
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 059 653 092 €
Date d'effet : 14/12/2010

03/11/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2121 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2059494346 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

19/10/2010

JAL

Modification of the share capital

 

 

Tribune (La)


Date de décision : 06/10/2010
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 059 494 346 €

26/09/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1751 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2059317757 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

04/09/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

7242 - 389058447 RCS. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Adresse : 3 avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/03/2010.

04/09/2010

Bodacc C

Comptes annuels, consolidés et rapports

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

7243 - 389058447 RCS. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Adresse : 3 avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/03/2010.

25/08/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2064 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur : BECHAT Jean-Paul Administrateur : BEINECKE Candace Krugman Président du conseil d'administration et directeur général : KRON Patrick Administrateur : CHODRON DE COURCEL Louis Marie Andre Georges Administrateur : HAUSER Gerard Administrateur : LENG James William Administrateur : COLOMBANI Pascal Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 18 Juillet 2006 Administrateur : FOLZ Jean Martin en fonction le 27 Juillet 2007 Administrateur : THOMSON Alan modification le 31 Juillet 2007 Administrateur : MANGOLD Klaus en fonction le 27 Juillet 2007 Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 09 Avril 2008 Commissaire aux comptes suppléant : DE CAMBOURG Patrick en fonction le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 16 Juillet 2009 Administrateur : RAY Katrina en fonction le 13 Août 2010 Administrateur : LALITA DATTATRAYA JOSHI Lalita Dileep en fonction le 13 Août 2010.
Commentaires : Modification de représentant.

18/08/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2169 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2059270332 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

03/08/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1815 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2058796915 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

20/07/2010

JAL

Modification of the share capital

 

 

LA TRIBUNE DESFOSSES


Date de décision : 30/06/2010
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 058 797 000 €

20/07/2010

JAL

Modification of the share capital

 

 

LA TRIBUNE DESFOSSES


Date de décision : 30/06/2010
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 058 797 000 €

08/07/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2557 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2058623175 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

29/06/2010

JAL

Modification of the share capital

 

 

LA TRIBUNE DESFOSSES


Date de décision : 18/06/2010
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 058 623 000 €

13/06/2010

JAL

Modification of the share capital

 

 

LA TRIBUNE DESFOSSES


Date de décision : 11/05/2010
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 058 520 000 €

29/04/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2673 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2056893972 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

20/04/2010

JAL

Modification of the share capital

 

 

LA TRIBUNE DESFOSSES


Date de décision : 13/04/2010
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 056 894 000 €

30/03/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1641 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2055962440 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

16/03/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2657 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2024869280 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

16/03/2010

JAL

Modification of the share capital

 

 

LA TRIBUNE DESFOSSES


Date de décision : 10/03/2010
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 055 962 000 €

02/03/2010

JAL

Modification of the share capital

 

 

LA TRIBUNE DESFOSSES


Date de décision : 02/02/2010
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 024 869 000 €

29/01/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2820 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2023793800 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

22/12/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1515 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2023190197 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

08/12/2009

JAL

Modification of the share capital

 

 

LES PETITES AFFICHES


Date de décision : 02/12/2009
La société : 389058447 - ALSTOM, 3 AV ANDRE MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 023 190 000 €

03/12/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2140 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2022621251 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

21/10/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1614 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2021635574 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

25/07/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

9445 - 389058447 RCS. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Adresse : 3 avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/03/2009.

25/07/2009

Bodacc C

Comptes consolidés et rapports

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

9446 - 389058447 RCS. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Adresse : 3 avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/03/2009.

24/07/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1829 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur : BECHAT Jean-Paul. Administrateur : BEINECKE Candace Krugman. Président du conseil d'administration et directeur général : KRON Patrick. Administrateur : CHODRON DE COURCEL Louis Marie Andre Georges. Administrateur : HAUSER Gerard. Administrateur : LENG James William. Administrateur : COLOMBANI Pascal. Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 18 Juillet 2006. Administrateur : FOLZ Jean Martin en fonction le 27 Juillet 2007. Administrateur : THOMSON Alan modification le 31 Juillet 2007. Administrateur : MANGOLD Klaus en fonction le 27 Juillet 2007. Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 09 Avril 2008. Commissaire aux comptes suppléant : DE CAMBOURG Patrick en fonction le 16 Juillet 2009. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 16 Juillet 2009. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Juillet 2009. Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 16 Juillet 2009. Capital : 2017122128 EUR.
Commentaires : Modification du capital. Modification de représentant.

26/05/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2707 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2021567338 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

29/04/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2024 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2013575921 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

05/02/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2047 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 2009335216 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

05/11/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1929 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 1992861038 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

05/08/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

8163 - 389058447 RCS. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Adresse : 3 avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/03/2008.

05/08/2008

Bodacc C

Comptes consolidés et rapports

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

8164 - 389058447 RCS. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Adresse : 3 avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/03/2008.

18/07/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2692 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 1190292724 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

08/06/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1988 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 1989122436 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

29/04/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1785 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 1982429778 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

03/04/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2939 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 10 Novembre 2006. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 23 Août 2005. Administrateur : BECHAT Jean-Paul. Administrateur : BEINECKE Candace Krugman. Président du conseil d'administration et directeur général : KRON Patrick. Administrateur : CHODRON DE COURCEL Louis Marie Andre Georges. Administrateur : HAUSER Gerard. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (SARL). Administrateur : LENG James William. Administrateur : COLOMBANI Pascal. Commissaire aux comptes suppléant : MACIOCE Pascal. Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 18 Juillet 2006. Administrateur : FOLZ Jean Martin en fonction le 27 Juillet 2007. Administrateur : THOMSON Alan modification le 31 Juillet 2007. Administrateur : MANGOLD Klaus en fonction le 27 Juillet 2007. Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 09 Avril 2008. Capital : 1982373778 EUR.
Commentaires : Modification du capital. Modification de représentant.

14/03/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

5409 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 10 Novembre 2006. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 23 Août 2005. Administrateur : BECHAT Jean-Paul. Administrateur : BEINECKE Candace Krugman. Président du conseil d'administration et directeur général : KRON Patrick. Administrateur : CHODRON DE COURCEL Louis Marie Andre Georges. Administrateur : HAUSER Gerard. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (SARL). Administrateur : LENG James William. Administrateur : COLOMBANI Pascal. Commissaire aux comptes suppléant : MACIOCE Pascal. Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 18 Juillet 2006. Administrateur : POUPART-LAFARGE Olivier en fonction le 18 Juillet 2006. Administrateur : FOLZ Jean Martin en fonction le 27 Juillet 2007. Administrateur : THOMSON Alan modification le 31 Juillet 2007. Administrateur : MANGOLD Klaus en fonction le 27 Juillet 2007.
Commentaires : Modification de représentant.

21/02/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

4147 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 1966054832 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

27/01/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

3503 - 389 058 447 RCS Nanterre. ALSTOM. Forme : Société anonyme. Capital : 1956246656 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

07/11/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1067 - RCS Nanterre B 389 058 447. RC 04-B 4807. ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 950 009 082 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

13/09/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

4821 - 389 058 447. RCS Nanterre ALSTOM. Forme: Société anonyme. Adresse du siège social: 3 avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 mars 2007.

13/09/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

4822 - 389 058 447. RCS Nanterre ALSTOM. Forme: Société anonyme. Adresse du siège social: 3 avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret. Comptes consolidés et rapport de l'exercice clos le: 31 mars 2007.

02/09/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1551 - RCS Nanterre B 389 058 447. RC 04-B 4807. ALSTOM. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'administrateurs : FOLZ (Jean, Martin) THOMSON (Alan) MANGOLD (Klaus).

01/08/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1317 - RCS Nanterre B 389 058 447. RC 04-B 4807. ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 940 692 628 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

13/05/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2185 - RCS Nanterre B 389 058 447. RC 04-B 4807. ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 940 640 814 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

12/11/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2417 - RCS Nanterre B 389 058 447. RC 04-B 4807. ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 935 625 916 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

31/08/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

1317 - RCS Nanterre B 389 058 447. RC 04-B 4807. ALSTOM. Forme: S.A. Adresse du siège social: 3, avenue André Malraux,92300 Levallois-Perret. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 mars 2006.

13/08/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

3413 - RCS Nanterre B 389 058 447. RC 04-B 4807. ALSTOM. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur représentant l'Etat partant : SAMUEL-LAJEUNESSE (Denis). Administrateur partant : MER (Francis). Nomination d'administrateurs : BOUYGUES (Olivier) POUPART-LAFARGE (Olivier).

26/07/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1461 - RCS Nanterre B 389 058 447. RC 04-B 4807. ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 935 457 272 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

09/05/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1831 - RCS Nanterre B 389 058 447. RC 04-B 4807. ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 934 390 864 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

23/11/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2253 - RCS Nanterre B 389 058 447. RC 04-B 4807. ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 924 350 638 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

16/09/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

3327 - RCS Nanterre B 389 058 447. RC 04-B 4807. ALSTOM. Forme: S.A. Adresse du siège social: 3, avenue André Malraux,92300 Levallois-Perret. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 mars 2005.

16/09/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

3328 - RCS Nanterre B 389 058 447. RC 04-B 4807. ALSTOM. Forme: S.A. Adresse du siège social: 3, avenue André Malraux,92300 Levallois-Perret. Comptes consolidés et rapport de l'exercice clos le: 31 mars 2005.

30/08/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

965 - RCS Nanterre B 389 058 447. RC 04-B 4807. ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 924 160 602 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

15/05/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

3225 - RCS Nanterre B 389 058 447. RC 04-B 4807. ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 924 023 993,15 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

13/05/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

3942 - RCS Nanterre B 389 058 447. RC 04-B 4807. ALSTOM. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : SIMPSON (George). Nomination d'un administrateur : MER (Francis).

31/01/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2312 - RCS Nanterre B 389 058 447. RC 04-B 4807. ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 923 823 081,60 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

18/01/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2303 - RCS Nanterre B 389 058 447. RC 04-B 4807. ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 921 897 682,25 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

01/12/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 389058447 RC 04-B 4807 ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 904 462 556,85 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

14/09/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS B 389058447 RC 04-B 4807 ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 904 251 240,15 euros. Activité : toutes opérations industrielles, commerciales, maritimes, financières et immobilières, tant en France qu'à l'étranger. Adresse du siège social : 3 avenue André-Malraux, 92300 Levallois-Perret. Administration : commissaires aux comptes titulaires : BARBIER FRINAULT & AUTRES DELOITTE TOUCHE TOHMATSU. Administrateurs : SIMPSON (George) BECHAT (Jean-Paul) CRONIN (James) BEINECKE (Candace, Krugman). Président du conseil d' administration et directeur général : KRON (Patrick). Administrateurs : CHODRON DE COURCEL (Louis, Marie, André, Georges) HAUSER (Gérard). Commissaire aux comptes suppléant : BEAS S.A.R.L. Administrateurs : LENG (James, William) COLOMBANI (Pascal). Administrateur représentant l'ETAT : SAMUEL-LAJEUNESSE (Denis). Commissaire aux comptes suppléant : MACIOCE (Pascal). Commentaires : cette société transfère son siège du 25 avenue Kléber, 75116 Paris. Date d'effet : 20 aout 2004.

07/09/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 904 251 240,15 euros Nom commercial: Alstom. Activité : réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, maritimes, financières ou immobilières et réalisation de toutes opérations, tant en France qu'à l'étranger. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'activité.

07/09/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un administrateur représentant l'Etat : SAMUEL-LAJEUNESSE (Denis).

31/08/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 456 908 221, 35 euros Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et l' administration. Administration : nomination d'un administrateur : COLOMBANI (Pascal).

27/05/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 320 821 965 euros Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

23/03/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 296 166 918,75 euros Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

22/02/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : ESSER (Klaus).

22/02/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 090 756 001,25 euros Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

11/01/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un administrateur : LENG (James, William).

19/12/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 651 991 945 euros Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

07/09/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : PURVES (William).

03/09/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 352 075 653, 75 euros Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

24/04/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un administrateur : HAUSER (Gérard).

04/04/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d' administration partant : BILGER (Jean- Pierre). Modification du président du conseil d'administration et directeur général : KRON (Patrick).

28/01/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification du président du conseil d'administration : BILGER (Jean, Pierre). Modification d' un directeur général et administrateur : KRON (Patrick).

25/10/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification du président du conseil d'administration et directeur général : BILGER (Jean, Pierre).

02/09/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : HALBRON (Jean-Pierre). Nomination d'un administrateur : CHODRON DE COURCEL ( Louis, Marie, André, Georges).

18/08/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 689 963 138 euros Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

27/03/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : SCARONI (Paolo).

12/09/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateurs partants : TCHURUK (Serge) MAYO (John, Charles) LAROSIERE DE CHAMPFEU ( Jacques). Nomination d'administrateurs : BECHAT (Jean-Paul) CRONIN (James) SCARONI (Paolo).

12/09/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d' administrateurs : BEINECKE (Candace, Krugman) KRON (Patrick).

24/09/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389058447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 292 324 754 euros Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

09/09/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

*. RCS Paris B 389 058 447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A Nom commercial: Alstom. Adresse du siège social : 25, avenue Kléber 75116 Paris. Commentaires : modification survenue sur l'adresse du siège social et de l'établissement principal Etablissement principal: Adresse : 25, avenue Kléber 75116 Paris.

12/08/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

*. RCS Paris B 389 058 447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 1 282 190 418 euros Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur le capital (diminution).

30/10/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Paris B 389 058 447 RC RC 92- B 13648 ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 8 430 261 360 F Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

30/10/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Paris B 389 058 447 RC RC 92- B 13648 ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 8 547 936 120 F Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

26/07/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389 058 447 RC 92-B 13648 ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 8 390 243 920 F Nom commercial: Alstom. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et l' administration. Administration : nomination d'administrateurs : PURVES ( William) LAROSIERE DE CHAMPFEU ( Jacques) ESSER (Klaus).

26/06/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Paris B 389 058 447 RC RC 92- B 13648 ALSTOM. Forme : S.A. Capital : 500 000 F Nom commercial: Alstom. Adresse du siège social : 38, avenue Kléber 75116 Paris Etablissement principal: Adresse : 38, avenue Kléber 75116 Paris. Administration : suppression : président du conseil d'administration : FISCHER ( Lucien, Edmond). Nomination en qualité de président du conseil d' administration : BILGER (Jean-Pierre) Suppression : administrateurs : BURNIER (Véronique, Françoise) COURTY (Marie-Martine) MURRAY ( Christopher, James). Nomination en qualité d'administrateurs : HALBRON ( Jean-Pierre) TCHURUK (Serge) SIMPSON (George) MAYO (John, Charles). Commentaires : modification survenue sur la dénomination, le nom commercial, l' adresse du siège social, l'adresse de l' établissement principal, l' administration et le capital ( augmentation).

30/04/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Paris B 389 058 447 RC RC 92- B 13648 JOTELEC. Forme : S.A Nom commercial: Jotelec. Administration : suppression : président-directeur général : Mme LAGUE, née ABGRALL ( Anne-Marie). Nomination en qualité de président du conseil d'administration : FISCHER (Lucien, Edmond) Suppression : administrateurs : COMPAGNIE IMMOBILIERE MERIDIONALE C.I.M. SOCIETE IMMOBILIERE KLEBER LAURISTON SIKL CENTRE D'EXPERTISE INTERNATIONAL C.E.I. Nomination en qualité d'administrateurs : BURNIER ( Véronique, Françoise) COURTY (Marie- Martine) MURRAY (Christopher, James). Suppression : commissaire aux comptes titulaire : MENNESSON (André). Nomination en qualité de commissaires aux comptes titulaires : BARBIER FRINAULT ET AUTRES DELOITTE TOUCHE TOHMATSU. Suppression : commissaire aux comptes suppléant : MARX (Paul). Nomination en qualité de commissaires aux comptes suppléants : SCHEIDECKER ( Francis) DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDIT. Commentaires : modification survenue sur l'administration.

26/10/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389 058 447 RC 92-B 13648 JOTELEC. Forme : S.A Nom commercial: Jotelec. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un administrateur : CENTRE D'EXPERTISE INTERNATIONAL. Modification d'un administrateur : COMPAGNIE IMMOBILIERE MERIDIONALE-C.I.M. Administrateur partant : STE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE CONTROLE ET DE GESTION-SOFICIM. Modification d'un administrateur : STE IMMOBILIERE KLEBER LAURISTON-S.I.K.L.

02/10/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Paris B 389 058 447 RC RC 92- B 13648 JOTELEC. Forme : S.A Nom commercial: Jotelec. Administration : président-directeur général : Mme LAGUE, née ABGRALL (Anne-Marie) Administrateurs : COMPAGNIE IMMOBILIERE MERIDIONALE C.I.M. SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE CONTROLE ET DE GESTION SO.FI.C.IM. SOCIETE IMMOBILIERE KLEBER LAURISTON S. I.K.L. Commissaire aux comptes titulaire : MENNESSON (André). Commissaire aux comptes suppléant : MARX (Paul). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

10/03/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Paris B 389 058 447 RC 92-B 13648 JOTELEC. Forme : S.A Nom commercial: Jotelec. Administration : P.-D.G. : LAGUE, née ABGRALL (Anne-Marie). Administrateurs : STE AUXILIAIRE MARSEILLAISE DE GESTION-SAMAG COMPAGNIE IMMOBILIERE MERIDIONALE-C.I.M. STE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE CONTROLE ET DE GESTION-SOFICIM. Commissaire aux comptes titulaire : MENNESSON (André). Commissaire aux comptes suppléant : MARX (Paul). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

07/03/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Paris B 389 058 447 RC RC 92- B 13648 JOTELEC. Forme : S.A. Capital : 250 000 F Nom commercial: Jotelec. Adresse du siège social : 12, rue de la Baume 75008 Paris. Activité : activité strictement limitée à la gestion de son patrimoine en vue de recevoir ultérieurement des apports. Commentaires : prise d'activité Date de début d' activité: 1er janvier 1996.

 

 

Company events history

 

 

Date

Description

11/12/2013

Bodacc B: Various editing or changing

03/12/2013

Amendment

03/12/2013

Capital increase

03/12/2013

Updated articles of association

26/11/2013

Invalid balance sheet

08/11/2013

Legal Gazette: Modification of the share capital

25/10/2013

Bodacc B: Various editing or changing

17/10/2013

Amendment

17/10/2013

Capital increase

17/10/2013

Updated articles of association

15/10/2013

Update Limit

03/10/2013

Other modification of Establishment

11/09/2013

Legal Gazette: Modification of the share capital

31/08/2013

Invalid balance sheet

18/08/2013

Bodacc C : Deposit accounts notice

04/08/2013

Bodacc B: Various editing or changing

26/07/2013

Minutes of general meeting of shareholders

26/07/2013

Changes to the Board of Directors

26/07/2013

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

24/07/2013

Bodacc B: Various editing or changing

16/07/2013

Capital increase

16/07/2013

Updated articles of association

16/07/2013

Amendment

15/07/2013

Invalid balance sheet

02/07/2013

Legal Gazette: Appointment of the social representative

01/07/2013

Other modification of Establishment

27/06/2013

Legal Gazette: Modification of the share capital

26/06/2013

Bodacc B: Various editing or changing

26/06/2013

Invalid balance sheet

17/06/2013

Amendment

17/06/2013

Capital increase

17/06/2013

Updated articles of association

12/06/2013

Other modification of Establishment

06/06/2013

Invalid balance sheet

02/06/2013

Bodacc B: Various editing or changing

24/05/2013

Capital increase

24/05/2013

Updated articles of association

24/05/2013

Amendment

16/05/2013

Other modification of Establishment

16/05/2013

Legal Gazette: Modification of the share capital

23/04/2013

Bodacc B: Various editing or changing

15/04/2013

Capital increase

15/04/2013

Updated articles of association

15/04/2013

Amendment

05/04/2013

Bodacc B: Various editing or changing

03/04/2013

Other modification of Establishment

31/03/2013

Legal Gazette: Modification of the share capital

27/03/2013

Amendment

27/03/2013

Capital increase

27/03/2013

Updated articles of association

08/03/2013

Other modification of Establishment

28/02/2013

Bodacc B: Various editing or changing

20/02/2013

Capital increase

20/02/2013

Amendment

20/02/2013

Updated articles of association

11/02/2013

Other modification of Establishment

11/02/2013

Legal Gazette: Modification of the share capital

03/02/2013

Bodacc B: Various editing or changing

02/02/2013

New subsidiarie(s) detected

25/01/2013

Updated articles of association

25/01/2013

Amendment

25/01/2013

Capital increase

07/01/2013

Other modification of Establishment

02/01/2013

Bodacc B: Various editing or changing

21/12/2012

Amendment

21/12/2012

Updated articles of association

21/12/2012

Capital increase

12/12/2012

Legal Gazette: Modification of the share capital

12/12/2012

Update of Company Workforce

12/12/2012

Other modification of Establishment

07/12/2012

New subsidiarie(s) detected

27/11/2012

Bodacc B: Various editing or changing

19/11/2012

Amendment

19/11/2012

Updated articles of association

19/11/2012

Capital increase

08/11/2012

Legal Gazette: Modification of the share capital

08/11/2012

Other modification of Establishment

26/10/2012

Bodacc B: Various editing or changing

18/10/2012

Updated articles of association

18/10/2012

Capital increase

18/10/2012

Amendment

04/10/2012

Legal Gazette: Modification of the share capital

04/10/2012

Other modification of Establishment

27/09/2012

Bodacc B: Various editing or changing

19/09/2012

Amendment

19/09/2012

Updated articles of association

19/09/2012

Capital increase

07/09/2012

New participations in other companies

07/09/2012

Other modification of Establishment

07/09/2012

Legal Gazette: Modification of the share capital

14/08/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

25/07/2012

Bodacc B: Various editing or changing

16/07/2012

Amendment

16/07/2012

Updated articles of association

16/07/2012

Capital increase

30/06/2012

Other modification of Establishment

30/06/2012

Legal Gazette: Modification of the share capital

01/06/2012

Bodacc B: Various editing or changing

23/05/2012

Capital increase

23/05/2012

Updated articles of association

23/05/2012

Amendment

14/05/2012

Update of Company Workforce

14/05/2012

Other modification of Establishment

30/04/2012

Legal Gazette: Modification of the share capital

25/04/2012

Bodacc B: Various editing or changing

17/04/2012

Capital increase

17/04/2012

Amendment

17/04/2012

Updated articles of association

04/04/2012

Legal Gazette: Modification of the share capital

31/03/2012

Other modification of Establishment

27/03/2012

Bodacc B: Various editing or changing

16/03/2012

Updated articles of association

16/03/2012

Amendment

16/03/2012

Capital increase

09/03/2012

Bodacc B: Various editing or changing

08/03/2012

Legal Gazette: Modification of the share capital

01/03/2012

Updated articles of association

01/03/2012

Amendment

01/03/2012

Capital increase

22/02/2012

Bodacc B: Various editing or changing

17/02/2012

Other modification of Establishment

17/02/2012

Legal Gazette: Modification of the share capital

15/02/2012

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

14/02/2012

Changes to the Board of Directors

14/02/2012

Minutes of Board meeting

14/02/2012

Amendment

09/02/2012

Bodacc B: Various editing or changing

31/01/2012

Updated articles of association

31/01/2012

Capital reduction

31/01/2012

Amendment

29/01/2012

Bodacc B: Various editing or changing

19/01/2012

Updated articles of association

19/01/2012

Capital increase

19/01/2012

Amendment

16/01/2012

Other modification of Establishment

16/01/2012

Legal Gazette: Modification of the share capital

06/01/2012

Legal Gazette: Modification of the share capital

06/01/2012

Other modification of Establishment

30/12/2011

Bodacc B: Various editing or changing

22/12/2011

Amendment

22/12/2011

Updated articles of association

22/12/2011

Minutes of general meeting of shareholders

22/12/2011

Capital increase

15/12/2011

Bodacc B: Various editing or changing

07/12/2011

Updated articles of association

07/12/2011

Capital reduction

07/12/2011

Amendment

05/12/2011

Other modification of Establishment

30/11/2011

Legal Gazette: Modification of the share capital

15/11/2011

Minutes of general meeting of shareholders

15/11/2011

Capital reduction

03/11/2011

Other modification of Establishment

31/10/2011

Legal Gazette: Modification of the share capital

20/10/2011

Bodacc B: Various editing or changing

12/10/2011

Amendment

12/10/2011

Updated articles of association

06/10/2011

Other modification of Establishment

30/09/2011

Legal Gazette: Modification of the share capital

27/09/2011

Bodacc B: Various editing or changing

19/09/2011

Capital increase

19/09/2011

Minutes of general meeting of shareholders

19/09/2011

Updated articles of association

19/09/2011

Amendment

08/09/2011

Legal Gazette: Modification of the share capital

02/09/2011

Disengagement in other companies

02/09/2011

New shareholders detected

02/09/2011

New subsidiarie(s) detected

31/08/2011

Other modification of Establishment

28/07/2011

Invalid balance sheet

24/07/2011

Bodacc B: Various editing or changing

17/07/2011

Bodacc B: Various editing or changing

15/07/2011

Capital increase

15/07/2011

Minutes of general meeting of shareholders

15/07/2011

Amendment

15/07/2011

Updated articles of association

14/07/2011

Changes to the Board of Directors

14/07/2011

Amendment

13/07/2011

Amendment

13/07/2011

Minutes of general meeting of shareholders

13/07/2011

Minutes of Board meeting

07/07/2011

Amendment

07/07/2011

Updated articles of association

06/07/2011

Other modification of Establishment

06/07/2011

Legal Gazette: Modification of the share capital

24/06/2011

Legal Gazette: Modification of the share capital

23/06/2011

Other modification of Establishment

13/06/2011

Legal Gazette: Appointment of the social representative

20/05/2011

Bodacc B: Various editing or changing

12/05/2011

Amendment

12/05/2011

Updated articles of association

09/05/2011

Other modification of Establishment

03/05/2011

Legal Gazette: Modification of the share capital

20/04/2011

Bodacc B: Various editing or changing

12/04/2011

Amendment

12/04/2011

Updated articles of association

12/04/2011

Capital increase

04/04/2011

Other modification of Establishment

04/04/2011

Legal Gazette: Modification of the share capital

01/04/2011

New shareholders detected

01/04/2011

New subsidiarie(s) detected

31/03/2011

Bodacc B: Various editing or changing

21/03/2011

Other modification of Establishment

17/03/2011

Updated articles of association

17/03/2011

Capital increase

17/03/2011

Amendment

10/03/2011

Other modification of Establishment

10/03/2011

Legal Gazette: Modification of the share capital

04/03/2011

New subsidiarie(s) detected

18/02/2011

Bodacc B: Various editing or changing

10/02/2011

Updated articles of association

10/02/2011

Amendment

08/02/2011

Updated articles of association

08/02/2011

Capital increase

08/02/2011

Amendment

04/02/2011

New subsidiarie(s) detected

04/02/2011

Other modification of Establishment

02/02/2011

Other modification of Establishment

21/01/2011

New subsidiarie(s) detected

30/12/2010

Bodacc B: Various editing or changing

21/12/2010

Amendment

21/12/2010

Capital increase

21/12/2010

Updated articles of association

21/12/2010

Other modification of Establishment

14/12/2010

Legal Gazette: Modification of the share capital

03/12/2010

New shareholders detected

03/11/2010

Bodacc B: Various editing or changing

25/10/2010

Augmentation de Capital

25/10/2010

Amendment

25/10/2010

Statuts mis à jour

25/10/2010

Updated articles of association

25/10/2010

Capital increase

25/10/2010

Acte modificatif

06/10/2010

Amendment

06/10/2010

Acte modificatif

06/10/2010

Other modification of Establishment

06/10/2010

Updated articles of association

06/10/2010

Statuts mis à jour

06/10/2010

Capital increase

06/10/2010

Augmentation de Capital

06/10/2010

Legal Gazette: Modification of the share capital

26/09/2010

Bodacc B: Various editing or changing

15/09/2010

Acte modificatif

15/09/2010

Augmentation de Capital

15/09/2010

Statuts mis à jour

15/09/2010

Amendment

15/09/2010

Updated articles of association

15/09/2010

Capital increase

06/09/2010

Other modification of Establishment

04/09/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

25/08/2010

Bodacc B: Various editing or changing

18/08/2010

Bodacc B: Various editing or changing

13/08/2010

Acte modificatif

13/08/2010

PV d'Assemblée

13/08/2010

Statuts mis à jour

13/08/2010

Updated articles of association

13/08/2010

Amendment

13/08/2010

Changes to the Board of Directors

13/08/2010

Minutes of general meeting of shareholders

13/08/2010

Modification du Conseil d'Administration

09/08/2010

Acte modificatif

09/08/2010

Capital increase

09/08/2010

Augmentation de Capital

09/08/2010

Amendment

09/08/2010

Updated articles of association

09/08/2010

Statuts mis à jour

03/08/2010

Bodacc B: Various editing or changing

02/08/2010

Other modification of Establishment

23/07/2010

Capital increase

23/07/2010

Updated articles of association

23/07/2010

Acte modificatif

23/07/2010

Amendment

23/07/2010

Statuts mis à jour

23/07/2010

Augmentation de Capital

08/07/2010

Bodacc B: Various editing or changing

30/06/2010

Other modification of Establishment

30/06/2010

Legal Gazette: Modification of the share capital

29/06/2010

Augmentation de Capital

29/06/2010

Capital increase

29/06/2010

Minutes of general meeting of shareholders

29/06/2010

Statuts mis à jour

29/06/2010

Updated articles of association

29/06/2010

Acte modificatif

29/06/2010

Amendment

18/06/2010

Legal Gazette: Modification of the share capital

31/05/2010

Other modification of Establishment

11/05/2010

Legal Gazette: Modification of the share capital

29/04/2010

Bodacc B: Various editing or changing

19/04/2010

Augmentation de Capital

19/04/2010

Acte modificatif

19/04/2010

Updated articles of association

19/04/2010

Statuts mis à jour

19/04/2010

Minutes of general meeting of shareholders

19/04/2010

Capital increase

19/04/2010

Amendment

13/04/2010

Legal Gazette: Modification of the share capital

13/04/2010

Other modification of Establishment

31/03/2010

New accounts available

30/03/2010

Bodacc B: Various editing or changing

24/03/2010

Amendment

24/03/2010

Acte modificatif

24/03/2010

Power of attorney

24/03/2010

Procuration

18/03/2010

Augmentation de Capital

18/03/2010

Capital increase

18/03/2010

Statuts mis à jour

18/03/2010

Acte modificatif

18/03/2010

Amendment

18/03/2010

Updated articles of association

16/03/2010

Bodacc B: Various editing or changing

12/03/2010

Other modification of Establishment

10/03/2010

Legal Gazette: Modification of the share capital

04/03/2010

Statuts mis à jour

04/03/2010

Amendment

04/03/2010

Capital increase

04/03/2010

Augmentation de Capital

04/03/2010

Updated articles of association

04/03/2010

Acte modificatif

03/02/2010

Other modification of Establishment

02/02/2010

Legal Gazette: Modification of the share capital

29/01/2010

Bodacc B: Various editing or changing

18/01/2010

Updated articles of association

18/01/2010

Capital increase

18/01/2010

Augmentation de Capital

18/01/2010

Acte modificatif

18/01/2010

Statuts mis à jour

18/01/2010

Amendment

12/01/2010

Other modification of Establishment

22/12/2009

Bodacc B: Various editing or changing

10/12/2009

PV d'Assemblée

10/12/2009

Minutes of general meeting of shareholders

10/12/2009

Augmentation de Capital

10/12/2009

Capital increase

10/12/2009

Statuts mis à jour

10/12/2009

Updated articles of association

03/12/2009

Bodacc B: Various editing or changing

02/12/2009

Legal Gazette: Modification of the share capital

30/11/2009

Other modification of Establishment

23/11/2009

Updated articles of association

23/11/2009

Amendment

23/11/2009

Acte modificatif

23/11/2009

Other modification of Establishment

23/11/2009

Augmentation de Capital

23/11/2009

Capital reduction

23/11/2009

Statuts mis à jour

23/11/2009

Réduction de Capital

23/11/2009

Capital increase

31/10/2009

Other modification of Establishment

21/10/2009

Bodacc B: Various editing or changing

09/10/2009

Augmentation de Capital

09/10/2009

Statuts mis à jour

09/10/2009

Updated articles of association

09/10/2009

PV d'Assemblée

09/10/2009

Minutes of general meeting of shareholders

09/10/2009

Capital increase

08/10/2009

Amendment

08/10/2009

Acte modificatif

08/10/2009

Application and court order

08/10/2009

Requête et Ordonnance

02/10/2009

Other modification of Establishment

25/07/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

24/07/2009

Bodacc B: Various editing or changing

20/07/2009

Augmentation de Capital

20/07/2009

Capital increase

20/07/2009

Minutes of general meeting of shareholders

20/07/2009

Statuts mis à jour

20/07/2009

Amendment

20/07/2009

Acte modificatif

20/07/2009

Private document

20/07/2009

Updated articles of association

16/07/2009

Amendment

16/07/2009

Augmentation de Capital

16/07/2009

Capital increase

16/07/2009

Réduction de Capital

16/07/2009

Capital reduction

16/07/2009

Private document

16/07/2009

Appointment/resignation of company officers

16/07/2009

PV d'Assemblée

16/07/2009

Minutes of general meeting of shareholders

16/07/2009

Minutes of Board meeting

16/07/2009

Statuts mis à jour

16/07/2009

Updated articles of association

16/07/2009

Changement de Commissaire aux Comptes

16/07/2009

New auditor

16/07/2009

Acte modificatif

09/07/2009

Other modification of Establishment

26/05/2009

Bodacc B: Various editing or changing

15/05/2009

Updated articles of association

15/05/2009

Statuts mis à jour

15/05/2009

Augmentation de Capital

15/05/2009

PV d'Assemblée

15/05/2009

Amendment

15/05/2009

Acte modificatif

15/05/2009

Minutes of general meeting of shareholders

15/05/2009

Private document

15/05/2009

Capital increase

06/05/2009

Other modification of Establishment

29/04/2009

Bodacc B: Various editing or changing

20/04/2009

Private document

20/04/2009

Acte modificatif

20/04/2009

Amendment

20/04/2009

Minutes of general meeting of shareholders

20/04/2009

Capital increase

20/04/2009

Statuts mis à jour

20/04/2009

Updated articles of association

20/04/2009

Augmentation de Capital

31/03/2009

Other modification of Establishment

31/03/2009

New accounts available

05/02/2009

New Bodacc B ads detected

26/01/2009

Amendment

26/01/2009

Acte modificatif

26/01/2009

Updated articles of association

26/01/2009

Statuts mis à jour

26/01/2009

Other modification of Establishment

26/01/2009

Augmentation de Capital

26/01/2009

Private document

26/01/2009

Capital increase

12/01/2009

Other modification of Establishment

05/11/2008

Bodacc B: Various editing or changing

05/11/2008

New Bodacc B ads detected

27/10/2008

Private document

27/10/2008

Acte modificatif

27/10/2008

Augmentation de Capital

27/10/2008

Capital increase

27/10/2008

Amendment

27/10/2008

PV du Conseil d'Administration

27/10/2008

Minutes of Board meeting

27/10/2008

Statuts mis à jour

27/10/2008

Updated articles of association

15/10/2008

Other modification of Establishment

05/08/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

18/07/2008

New Bodacc B ads detected

18/07/2008

Bodacc B: Various editing or changing

07/07/2008

Augmentation de Capital

07/07/2008

Capital increase

07/07/2008

Acte modificatif

07/07/2008

Appointment/resignation of company officers

07/07/2008

PV du Conseil d'Administration

07/07/2008

Private document

07/07/2008

PV d'Assemblée

07/07/2008

Minutes of general meeting of shareholders

07/07/2008

Other modification of Establishment

07/07/2008

Changes to the Board of Directors

07/07/2008

Updated articles of association

07/07/2008

Statuts mis à jour

07/07/2008

Minutes of Board meeting

02/07/2008

Other modification of Establishment

08/06/2008

New Bodacc B ads detected

08/06/2008

Bodacc B: Various editing or changing

28/05/2008

Statuts mis à jour

28/05/2008

Augmentation de Capital

28/05/2008

Updated articles of association

28/05/2008

Minutes of Board meeting

28/05/2008

Acte modificatif

28/05/2008

Capital increase

28/05/2008

Other modification of Establishment

28/05/2008

Minutes of general meeting of shareholders

28/05/2008

Private document

28/05/2008

Amendment

19/05/2008

Other modification of Establishment

29/04/2008

New Bodacc B ads detected

29/04/2008

Bodacc B: Various editing or changing

24/04/2008

Capital increase

24/04/2008

Minutes of general meeting of shareholders

24/04/2008

Updated articles of association

24/04/2008

Statuts mis à jour

24/04/2008

Correction of a material error

24/04/2008

Amendment

24/04/2008

Augmentation de Capital

24/04/2008

Private document

24/04/2008

Minutes of Board meeting

24/04/2008

Acte modificatif

09/04/2008

Updated articles of association

09/04/2008

Augmentation de Capital

09/04/2008

Minutes of general meeting of shareholders

09/04/2008

Modification du Conseil d'Administration

09/04/2008

Changes to the Board of Directors

09/04/2008

Minutes of Board meeting

09/04/2008

Appointment/resignation of company officers

09/04/2008

Private document

09/04/2008

Statuts mis à jour

09/04/2008

Acte modificatif

09/04/2008

Capital increase

03/04/2008

Bodacc B: Various editing or changing

31/03/2008

New accounts available

31/03/2008

Other modification of Establishment

14/03/2008

New Bodacc B ads detected

14/03/2008

Bodacc B: Various editing or changing

11/03/2008

Appointment/resignation of company officers

11/03/2008

Audit or Management Report

11/03/2008

Modification du Conseil d'Administration

11/03/2008

Changes to the Board of Directors

11/03/2008

Private document

11/03/2008

PV d'Assemblée

11/03/2008

Minutes of general meeting of shareholders

21/02/2008

Bodacc B: Various editing or changing

21/02/2008

New Bodacc B ads detected

12/02/2008

Augmentation de Capital

12/02/2008

Private document

12/02/2008

Statuts mis à jour

12/02/2008

Updated articles of association

12/02/2008

Capital increase

12/02/2008

Acte modificatif

12/02/2008

Minutes of general meeting of shareholders

12/02/2008

PV d'Assemblée

06/02/2008

Other modification of Establishment

31/01/2008

Other modification of Establishment

27/01/2008

Bodacc B: Various editing or changing

27/01/2008

New Bodacc B ads detected

17/01/2008

Other modification of Establishment

17/01/2008

Updated articles of association

17/01/2008

Augmentation de Capital

17/01/2008

Capital increase

17/01/2008

Statuts mis à jour

17/01/2008

Acte modificatif

17/01/2008

Minutes of general meeting of shareholders

17/01/2008

Private document

31/12/2007

Other modification of Establishment

25/10/2007

Statuts mis à jour

25/10/2007

Acte modificatif

25/10/2007

Augmentation de Capital

25/10/2007

Capital increase

25/10/2007

Updated articles of association

25/10/2007

Private document

12/10/2007

Other modification of Establishment

30/09/2007

Other modification of Establishment

27/07/2007

Statuts mis à jour

27/07/2007

PV d'Assemblée

27/07/2007

Minutes of general meeting of shareholders

27/07/2007

Minutes of Board meeting

27/07/2007

Modification du Conseil d'Administration

27/07/2007

Changes to the Board of Directors

27/07/2007

Private document

27/07/2007

Acte modificatif

27/07/2007

Updated articles of association

27/07/2007

Appointment/resignation of company officers

09/07/2007

Minutes of general meeting of shareholders

09/07/2007

Statuts mis à jour

09/07/2007

Acte modificatif

09/07/2007

Updated articles of association

09/07/2007

Capital increase

09/07/2007

Augmentation de Capital

09/07/2007

Private document

20/06/2007

Other modification of Establishment

16/04/2007

Updated articles of association

16/04/2007

Capital increase

16/04/2007

Acte modificatif

16/04/2007

Private document

16/04/2007

Augmentation de Capital

16/04/2007

Statuts mis à jour

31/03/2007

Other modification of Establishment

31/03/2007

New accounts available

27/10/2006

Statuts mis à jour

27/10/2006

Updated articles of association

27/10/2006

Capital increase

27/10/2006

Minutes of Board meeting

27/10/2006

Private document

27/10/2006

Amendment

27/10/2006

Minutes of general meeting of shareholders

27/10/2006

Augmentation de Capital

27/10/2006

Acte modificatif

18/07/2006

PV du Conseil d'Administration

18/07/2006

Minutes of Board meeting

18/07/2006

Amendment

18/07/2006

Acte modificatif

18/07/2006

Nomination/démission des organes de gestion

18/07/2006

Private document

18/07/2006

Acte sous seing privé

18/07/2006

Modification du Conseil d'Administration

18/07/2006

Changes to the Board of Directors

18/07/2006

PV d'Assemblée

18/07/2006

Minutes of general meeting of shareholders

18/07/2006

Appointment/resignation of company officers

26/06/2006

Augmentation de Capital

26/06/2006

Statuts mis à jour

26/06/2006

Acte modificatif

26/06/2006

Capital increase

26/06/2006

Private document

26/06/2006

Acte sous seing privé

26/06/2006

Updated articles of association

20/04/2006

Acte modificatif

20/04/2006

Statuts mis à jour

20/04/2006

Updated articles of association

20/04/2006

Private document

20/04/2006

Acte sous seing privé

20/04/2006

Augmentation de Capital

20/04/2006

Capital increase

31/03/2006

New accounts available

26/10/2005

Augmentation de Capital

26/10/2005

Acte sous seing privé

26/10/2005

Private document

26/10/2005

Updated articles of association

26/10/2005

Statuts mis à jour

26/10/2005

Capital increase

26/10/2005

PV d'Assemblée

17/08/2005

Acte modificatif

17/08/2005

Augmentation de Capital

17/08/2005

Acte sous seing privé

17/08/2005

Private document

17/08/2005

Updated articles of association

17/08/2005

Statuts mis à jour

17/08/2005

PV du Conseil d'Administration

17/08/2005

Minutes of Board meeting

17/08/2005

Minutes of general meeting of shareholders

17/08/2005

PV d'Assemblée

13/04/2005

Acte sous seing privé

13/04/2005

Capital increase

13/04/2005

Augmentation de Capital

13/04/2005

Updated articles of association

13/04/2005

Private document

13/04/2005

Statuts mis à jour

08/04/2005

Private document

08/04/2005

Modification du Conseil d'Administration

08/04/2005

Changes to the Board of Directors

08/04/2005

Nomination/démission des organes de gestion

08/04/2005

Appointment/resignation of company officers

08/04/2005

Acte modificatif

08/04/2005

PV du Conseil d'Administration

08/04/2005

Acte sous seing privé

08/04/2005

Minutes of Board meeting

31/03/2005

New accounts available

14/01/2005

Private document

14/01/2005

Acte sous seing privé

14/01/2005

PV d'Assemblée

14/01/2005

Minutes of general meeting of shareholders

14/01/2005

Nomination/démission des organes de gestion

14/01/2005

Appointment/resignation of company officers

14/01/2005

Updated articles of association

14/01/2005

Statuts mis à jour

14/01/2005

PV du Conseil d'Administration

14/01/2005

Minutes of Board meeting

14/01/2005

Acte modificatif

14/01/2005

Modification du Conseil d'Administration

14/01/2005

Changes to the Board of Directors

14/01/2005

Capital increase

14/01/2005

Augmentation de Capital

03/01/2005

Certificat de dépôt des fonds

03/01/2005

Augmentation de Capital

03/01/2005

Capital increase

03/01/2005

Minutes of Board meeting

03/01/2005

Acte modificatif

03/01/2005

Updated articles of association

03/01/2005

Private document

03/01/2005

PV du Conseil d'Administration

03/01/2005

Fund deposit certificate

03/01/2005

Minutes of general meeting of shareholders

03/01/2005

PV d'Assemblée

03/01/2005

Acte sous seing privé

03/01/2005

Statuts mis à jour

15/11/2004

Acte modificatif

15/11/2004

Minutes of Board meeting

15/11/2004

PV du Conseil d'Administration

15/11/2004

Statuts mis à jour

15/11/2004

Updated articles of association

15/11/2004

Appointment/resignation of company officers

15/11/2004

Nomination/démission des organes de gestion

15/11/2004

Minutes of general meeting of shareholders

15/11/2004

PV d'Assemblée

15/11/2004

Acte sous seing privé

15/11/2004

Private document

15/11/2004

Augmentation de Capital

15/11/2004

Capital increase

15/11/2004

Changes to the Board of Directors

15/11/2004

Modification du Conseil d'Administration

02/09/2004

Minutes of Board meeting

02/09/2004

Statuts mis à jour

02/09/2004

Acte modificatif

02/09/2004

PV du Conseil d'Administration

02/09/2004

Updated articles of association

02/09/2004

Private document

02/09/2004

Transfert du Siège hors du ressort du Tribunal de Commerce

02/09/2004

Acte sous seing privé

02/09/2004

Registration after transfer

02/09/2004

Immatriculation suite à transfert

24/08/2004

Updated articles of association

24/08/2004

Acte modificatif

24/08/2004

Certificat de dépôt des fonds

24/08/2004

Capital increase

24/08/2004

Fund deposit certificate

24/08/2004

Acte sous seing privé

24/08/2004

Statuts mis à jour

24/08/2004

Minutes of Board meeting

24/08/2004

PV du Conseil d'Administration

24/08/2004

Private document

24/08/2004

Augmentation de Capital

13/08/2004

Continuation of business despite loss of equity

13/08/2004

Continuation malgré perte supérieure à la moitié du capital

13/08/2004

Modification du Conseil d'Administration

13/08/2004

Minutes of general meeting of shareholders

13/08/2004

Nomination/démission des organes de gestion

13/08/2004

Appointment/resignation of company officers

13/08/2004

Updated articles of association

13/08/2004

Statuts mis à jour

13/08/2004

PV du Conseil d'Administration

13/08/2004

Minutes of Board meeting

13/08/2004

PV d'Assemblée

13/08/2004

Changes to the Board of Directors

13/08/2004

Réduction de Capital

13/08/2004

Capital reduction

13/08/2004

Augmentation de Capital

13/08/2004

Private document

13/08/2004

Acte sous seing privé

06/05/2004

Acte sous seing privé

06/05/2004

Acte modificatif

06/05/2004

Statuts mis à jour

06/05/2004

Augmentation de Capital

31/03/2004

New accounts available

10/03/2004

Statuts mis à jour

10/03/2004

Acte modificatif

10/03/2004

Acte sous seing privé

10/03/2004

Augmentation de Capital

10/02/2004

Modification du Conseil d'Administration

10/02/2004

Acte sous seing privé

10/02/2004

PV d'Assemblée

10/02/2004

Nomination/démission des organes de gestion

10/02/2004

Statuts mis à jour

10/02/2004

Augmentation de Capital

10/02/2004

PV du Conseil d'Administration

29/12/2003

Modification du Conseil d'Administration

29/12/2003

Nomination/démission des organes de gestion

29/12/2003

PV d'Assemblée

29/12/2003

Acte sous seing privé

09/12/2003

Statuts mis à jour

09/12/2003

PV du Conseil d'Administration

09/12/2003

Acte modificatif

09/12/2003

Modification du Conseil d'Administration

09/12/2003

Augmentation de Capital

09/12/2003

Certificat de dépôt des fonds

09/12/2003

Acte sous seing privé

09/12/2003

PV d'Assemblée

09/12/2003

Nomination/démission des organes de gestion

27/08/2003

PV du Conseil d'Administration

27/08/2003

Acte sous seing privé

27/08/2003

Nomination/démission des organes de gestion

27/08/2003

Modification du Conseil d'Administration

22/08/2003

Acte sous seing privé

22/08/2003

Nomination/démission des organes de gestion

22/08/2003

Changement de Commissaire aux Comptes

22/08/2003

Réduction de Capital

22/08/2003

PV d'Assemblée

22/08/2003

Continuation malgré perte supérieure à la moitié du capital

22/08/2003

Statuts mis à jour

31/03/2003

New accounts available

24/03/2003

Modification du Conseil d'Administration

24/03/2003

Acte sous seing privé

24/03/2003

PV du Conseil d'Administration

24/03/2003

Changement de Président (PDG, PCA)

24/03/2003

Nomination/démission des organes de gestion

15/01/2003

Changement de Président (PDG, PCA)

15/01/2003

Acte sous seing privé

15/01/2003

PV du Conseil d'Administration

15/01/2003

Nomination/démission des organes de gestion

15/01/2003

Modification du Conseil d'Administration

14/10/2002

Acte modificatif

14/10/2002

Changement de Président (PDG, PCA)

14/10/2002

Acte sous seing privé

14/10/2002

PV du Conseil d'Administration

21/08/2002

Acte sous seing privé

21/08/2002

Nomination/démission des organes de gestion

21/08/2002

PV d'Assemblée

21/08/2002

Statuts mis à jour

21/08/2002

Modification du Conseil d'Administration

06/08/2002

PV du Conseil d'Administration

06/08/2002

Certificat de dépôt des fonds

06/08/2002

PV d'Assemblée

06/08/2002

Augmentation de Capital

06/08/2002

Statuts mis à jour

06/08/2002

Acte sous seing privé

06/08/2002

Acte modificatif

29/07/2002

Acte sous seing privé

29/07/2002

PV d'Assemblée

29/07/2002

Nomination/démission des organes de gestion

29/07/2002

Statuts mis à jour

29/07/2002

Modification du Conseil d'Administration

14/03/2002

PV du Conseil d'Administration

14/03/2002

Nomination/démission des organes de gestion

14/03/2002

Modification du Conseil d'Administration

14/03/2002

Acte sous seing privé

06/02/2002

Acte sous seing privé

06/02/2002

PV d'Assemblée

06/02/2002

Statuts mis à jour

26/10/2001

Statuts mis à jour

26/10/2001

PV d'Assemblée

26/10/2001

Acte sous seing privé

26/10/2001

Modification du Conseil d'Administration

26/10/2001

Nomination/démission des organes de gestion

28/08/2001

PV du Conseil d'Administration

28/08/2001

Modification du Conseil d'Administration

28/08/2001

PV d'Assemblée

28/08/2001

Acte sous seing privé

28/08/2001

Nomination/démission des organes de gestion

08/09/2000

Acte modificatif

08/09/2000

Statuts mis à jour

08/09/2000

PV d'Assemblée

08/09/2000

Conversion du Capital Social en Euros

08/09/2000

Acte sous seing privé

08/09/2000

Certificat de dépôt des fonds

08/09/2000

Augmentation de Capital

08/09/2000

PV du Conseil d'Administration

24/08/1999

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

24/08/1999

PV du Conseil d'Administration

24/08/1999

Statuts mis à jour

24/08/1999

Acte sous seing privé

29/07/1999

Réduction de Capital

29/07/1999

PV d'Assemblée

29/07/1999

PV du Conseil d'Administration

29/07/1999

Acte sous seing privé

29/07/1999

Conversion du Capital Social en Euros

29/07/1999

Statuts mis à jour

14/10/1998

Certificat de dépôt des fonds

14/10/1998

Acte sous seing privé

14/10/1998

Acte modificatif

14/10/1998

Statuts mis à jour

14/10/1998

PV du Conseil d'Administration

14/10/1998

Augmentation de Capital

13/10/1998

Statuts mis à jour

13/10/1998

Acte modificatif

13/10/1998

Augmentation de Capital

13/10/1998

Acte sous seing privé

13/10/1998

PV du Conseil d'Administration

08/07/1998

Certificat de dépôt des fonds

08/07/1998

Modification du Conseil d'Administration

08/07/1998

Rapport des Commissaires ou du Gérant

08/07/1998

Acte sous seing privé

08/07/1998

Augmentation de Capital

08/07/1998

Statuts mis à jour

08/07/1998

Acte modificatif

08/07/1998

Apport Partiel

08/07/1998

PV d'Assemblée

08/07/1998

Nomination/démission des organes de gestion

11/06/1998

Modification du Conseil d'Administration

11/06/1998

Changement de Président (PDG, PCA)

11/06/1998

Changement de dénomination sociale

11/06/1998

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

11/06/1998

Augmentation de Capital

11/06/1998

PV du Conseil d'Administration

11/06/1998

Statuts mis à jour

11/06/1998

PV d'Assemblée

11/06/1998

Nomination/démission des organes de gestion

11/06/1998

Certificat de dépôt des fonds

11/06/1998

Acte sous seing privé

16/04/1998

PV du Conseil d'Administration

16/04/1998

Changement de Commissaire aux Comptes

16/04/1998

Changement de date de clôture

16/04/1998

Nomination/démission des organes de gestion

16/04/1998

Statuts mis à jour

16/04/1998

Modification du Conseil d'Administration

16/04/1998

Changement de Président (PDG, PCA)

16/04/1998

PV d'Assemblée

16/04/1998

Acte sous seing privé

01/01/1998

Nomination/démission des organes de gestion

01/01/1998

Requête et Ordonnance

13/10/1997

Acte modificatif

13/10/1997

Acte sous seing privé

13/10/1997

Nomination/démission des organes de gestion

13/10/1997

PV du Conseil d'Administration

13/10/1997

Modification du Conseil d'Administration

16/04/1997

PV d'Assemblée

16/04/1997

Acte sous seing privé

16/04/1997

Nomination/démission des organes de gestion

16/04/1997

Modification du Conseil d'Administration

09/09/1996

Modification du Conseil d'Administration

09/09/1996

Nomination/démission des organes de gestion

09/09/1996

PV du Conseil d'Administration

09/09/1996

Acte modificatif

10/05/1996

Nomination/démission des organes de gestion

10/05/1996

Acte modificatif

10/05/1996

PV d'Assemblée

10/05/1996

Modification du Conseil d'Administration

26/02/1996

Acte modificatif

26/02/1996

Nomination/démission des organes de gestion

26/02/1996

PV du Conseil d'Administration

26/02/1996

Changement de Président (PDG, PCA)

26/02/1996

Modification du Conseil d'Administration

09/05/1995

Acte modificatif

09/05/1995

PV du Conseil d'Administration

09/05/1995

PV d'Assemblée

12/11/1992

PV d'Assemblée

12/11/1992

Statuts

01/01/1992

Acte sous seing privé

01/01/1992

PV du Conseil d'Administration

01/01/1992

Certificat de dépôt des fonds

01/01/1992

Nomination/démission des organes de gestion

01/01/1992

Formation de Société

01/01/1992

Statuts

01/01/1992

Déclaration de conformité

 

 

Establishment events history

 

 

Date

Description

12/01/2013

Update of phone numbers

06/05/2011

Update Rating

21/03/2011

Modification of Head office

22/01/2011

Update Limit

03/12/2010

Update Rating

03/07/2008

Update Rating

11/12/2007

Update of phone numbers

09/12/2007

Update Limit

20/06/2007

Modification of Head office

 


FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.61.92

UK Pound

1

Rs.100.83

Euro

1

Rs.85.27

 

INFORMATION DETAILS

 

Report Prepared by :

MNL

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.