MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

06.02.2013

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

RIBER

 

 

Registered Office :

31 Rue Casimir Perier, 95870 Bezons

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2011

 

 

Date of Incorporation :

December, 1987

 

 

Com. Reg. No.:

RCS Pontoise 0 343 006 151

 

 

Legal Form :

Plc with management board

 

 

Line of Business :

Production of scientific and technical instruments

 

 

No. of Employees :

50 to 99 employees

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory

Payment Behaviour :

No Complaints

Litigation :

Clear

 

NOTES:

Any query related to this report can be made on e-mail: infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – June 30th, 2012

 

Country Name

Previous Rating

(31.03.2012)

Current Rating

(30.06.2012)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 

France - ECONOMIC OVERVIEW

 

France was transitioning from an economy that has featured extensive government ownership and intervention to one that relies more on market mechanisms but is in the midst of a euro-zone crisis. The government has partially or fully privatized many large companies, banks, and insurers, and has ceded stakes in such leading firms as Air France, France Telecom, Renault, and Thales. It maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With at least 75 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that reduce income disparity and the impact of free markets on public health and welfare. France's real GDP contracted 2.6% in 2009, but recovered somewhat in 2010 and 2011. The unemployment rate increased from 7.4% in 2008 to 9.3% in 2010 and 9.1% in 2011. Lower-than-expected growth and increased unemployment have cut government revenues and increased borrowing costs, contributing to a deterioration of France's public finances. The government budget deficit rose sharply from 3.4% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 5.8% of GDP in 2011, while France's public debt rose from 68% of GDP to 86% over the same period. Under President SARKOZY, Paris implemented austerity measures that eliminated tax credits and froze most government spending in an effort to bring the budget deficit under the 3% euro-zone ceiling by 2013 and to highlight France's commitment to fiscal discipline at a time of intense financial market scrutiny of euro-zone debt levels. Socialist Francois HOLLANDE won the May 2012 presidential election, after advocating pro-growth economic policies, as well as measures such as forcing banks to separate their traditional deposit taking and lending activities from more speculative businesses, increasing taxes on bank profits, introducing a new top bracket on income taxes for people earning over €1 million ($1.3 million) a year, and hiring an additional 60,000 civil servants during his five-year term of office.

 

 

Source : CIA

 

 

 


 Company name and Summary

 


 

 

 

Name

RIB

R

SIRET

343 006 151 00033

 

Personal comment

company summary

 

 

 

 

 

EUR VAT Number

FR76343006151

 

 

Activity (APE)

Production of scientific and technical instruments (2651B)

Legal form

Plc with management board

 

 

Phone

01 39 47 68 51

RCS Registration

RCS Pontoise 0 343 006 151

 

 

Fax

 

Share capital

3,091,348 Euros

 

 

Address

RIBER
31 RUE CASIMIR PERIER
95870 BEZONS

Incorporated Date

12/1987

 

 

Nationality

France

Status

Economically active

 

 

 

 

 

Payment Information Summary - SafeTrade

 

Total number of Invoices available

15

 

Total number of Invoices paid within or up to 30 days after the due date

11

 

Total number of Invoices paid more than 30 days after the due date

1

 

Total number of Invoices currently outstanding where the due date has not yet been reached

1

 

Total number of Invoices currently outstanding beyond the due date

2

 

 

 

This company is not under monitoring

 

 

Ultimate Holding Company

 

Company Name

Safe Number

 

Company number

Click here to view the affiliation links

 

RIBER S.A

FR01914244

 

343006151

 

 

 

 

Current Directors

2

 

 

 

Trading to Date

12/31/2011

12/31/2009

12/31/2008

 

Turnover

28,067,151 €

17,799,592 €

18,829,741 €

 

Gross Operating Surplus

11,20 % Turnover

-2

% Turnover

-4,74 % Turnover

 

Shareholders’ equity

26,267,937 €

22,211,187 €

21,850,212 €

 

Net result

4,203,726 €

730,374 €

-1,222,481 €

 

Employees

50 to 99 employees

-

-

 

 

 

Trends

 

 

Profitability

 

Liquidity

 

Net worth

 

 

 

 

 

company details

 

 

 

Company details

 

 

 

 

Activity (APE)

Production of scientific and technical instruments (2651B)

 

RCS Registration

RCS Pontoise 0 343 006 151

Share capital

3,091,348 Euros

 

Registration Court

Pontoise (78)

Legal form

Plc with management board

 

Court Registry Number

20 0 6B031

EUR VAT Number

FR76343006151

 

Incorporation Date

12/1987

Formation Date

11/1987

 

Deregistration Date

 

Last account Date

31/12/2011

 

Nationality

France

 

 

 

 

Ultimate Parent

1 ultimate parent company for this company
>  RIBER  - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (2651B)  in BEZONS  (95870)

 

 

 

Establishment details

 

 

 

 

Activity (APE)

Production of scientific and technical instruments (2651B)

Business Pages FT®

 

 

Postal Address

RIBER
31 RUE CASIMIR PERIER
95870 BEZONS

Trading Address

31 RUE CASIMIR PERIER
95870 BEZONS

 

Telephone

01 39 47 68 51

 

Fax

 

 

 

 

 

Type

Head office

Status

Economically active

 

Formation Date

08/2006

Reason for formation

Formation

 

Closure Date

 

Reason for closure

 

 

Reactivation Date

 

Production Role

 

 

Activity Nature

 

Activity Location

 

 

Location surface

 

Seasonality

 

 

 

 

 

Department

Val-d'Oise (95)

Region

Ile-de-France

 

District

1

Area

04

 

City

BEZONS

Size of urban area

Paris conglomeration

 

 

 

Other establishments

 

 

 

 

Branches

1 branch entities in this company

 

 

 

Head office

 
> RIBER <<<  - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (2651B)  in BEZONS  (95870)
 

 

 

Secondary establishments

>  RIBER  - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (2651B)  in RUEIL MALMAISON  (92500)

 

 

 

 

Regionality

Legal unit with all establishments in same area

 

 

Mono-activity status

Legal unit having all establishments with the same main activity

 

 

 

 

Workforces

 

 

 

 

Workforce at address

50 to 99 employees

Company workforce

50 to 99 employees

 

 

 

 

accounts

 

Active Account |  Passive Account |  Account Results

 

Synthesized Accounts

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

Comparison mode

Average

Median

 

 

Annual Accounts

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

 

Account period (month)

12

 

12

 

12

 

 

Account Type

Normal

 

Normal

 

Normal

 

 

Deposit date

21/09/2012

 

06/08/2010

 

-

 

 

Activity Code

2651B

 

2651B

 

2651B

 

 

Employees

97

 

86

 

87

 

 


Active account

Annual Accounts

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2011

 

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

10 106 802

-0,4%

10 143 828

-10,0%

11 269 744

91 265,50

10974,1%

- Intangible assets

1 691 810

6,5%

1 589 174

-2,2%

1 624 496

7 036

23945,1%

- Tangible assets

7 504 532

-4,2%

7 835 679

-13,2%

9 026 678

32 316,50

23122,0%

- Financial assets

910 460

26,6%

718 975

16,2%

618 571

4 000

22661,5%

Net current assets

29 616 191

52,3%

19 445 985

-5,5%

20 570 969

654 446,50

4425,4%

- Stocks

11 314 196

84,4%

6 136 639

22,7%

5 000 526

130 096,50

8596,8%

- Advanced payments

58 710

52,3%

35 666

-56,0%

81 010

0

0%

- Receivables

6 714 826

-1,0%

6 780 670

-40,6%

11 413 870

304 182,50

2107,5%

- Securities and cash

11 528 459

77,6%

6 493 010

59,3%

4 075 563

122 887

9281,3%

- Prepaid expenses

-

-

-

-

-

456

-

Accounts of regularization

381 146

-24,0%

501 758

18,2%

424 437

0

0%

Total Assets

40 104 136

33,3%

30 091 569

-6,7%

32 265 150

828 113,50

4742,8%


Passive Account

Annual Accounts

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2011

 

Shareholders' equity

26 267 937

18,3%

22 211 187

1,7%

21 850 212

337 997,50

7671,6%

Share capital

3 091 349

0%

3 091 349

0,1%

3 089 672

79 600

3783,6%

Other capital resources

910 267

-4,2%

950 000

-2,1%

970 000

0

0%

Risk Provisions

1 820 262

46,3%

1 243 853

-45,5%

2 283 844

0

0%

Liabilities

11 080 677

94,9%

5 686 225

-20,3%

7 137 695

341 308

3146,5%

- Financial liabilities

0

0%

2 029

-98,2%

110 959

43 106,50

0%

- Advanced payments received

4 060 109

683,9%

517 906

182,9%

183 086

0

0%

- Trade account payables

3 228 378

35,2%

2 387 527

-26,3%

3 238 978

104 499

2989,4%

- Tax and social liabilities

3 111 903

78,4%

1 744 534

-5,0%

1 836 566

122 398

2442,4%

- Other debts and fixed assets liabilities

626 336

-33,3%

939 471

-42,7%

1 639 639

5 400,50

11497,7%

Account regularization

78 942

-17,0%

95 062

-37,4%

151 867

0

0%

Total liabilities

40 104 136

33,3%

30 091 568

-6,7%

32 265 150

828 114

4742,8%


Results

Annual Accounts

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2011

 

Sales of Goods

33 671 326

54,2%

21 834 717

11,9%

19 515 211

1 048 872,50

3110,2%

Net turnover

28 067 151

57,7%

17 799 592

-5,5%

18 829 741

968 958,50

2796,6%

- of which net export turnover

24 406 407

54,3%

15 820 611

-6,0%

16 837 441

13 673

178400,7%

Operating charges

29 387 741

34,5%

21 844 444

5,0%

20 812 757

983 110,50

2889,3%

Operating profit/loss

4 283 585

44138,1%

-9 727

99,3%

-1 297 546

37 352

11368,2%

Financial income

1 093 954

27,6%

857 666

-22,6%

1 107 480

843,50

129592,2%

Financial charges

1 074 010

48,6%

722 909

-52,1%

1 508 055

3 065

34941,1%

Financial profit/loss

19 944

-85,2%

134 757

133,6%

-400 575

-323

6274,6%

Pretax net operating income

4 303 529

3342,0%

125 030

107,4%

-1 698 121

37 568

11355,3%

Extraordinary income

82 114

-35,6%

127 604

1681,9%

7 161

834,50

9739,9%

Extraordinary charges

204 577

111,5%

96 719

-35,9%

150 909

714

28552,2%

Extraordinary profit/loss

-122 463

13510,9%

30 885

121,5%

-143 748

0

0%

Net result

4 203 726

475,6%

730 374

159,7%

-1 222 481

45 964,50

9045,6%


 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

 

Normal Account

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Months

 

12

 

12

 

12


Accounts - Active
Current Assets |  Equalization accounts |  Reference

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Grand Total (I to VI)

Net

40 104 136

33,3%

30 091 569

-6,7%

32 265 150

 

Gross

CO

53 343 893

10,5%

48 254 194

-4,8%

50 667 360

 

Amortisation

1A

13 239 757

-27,1%

18 162 625

-1,3%

18 402 210


Non declared distributed capital (I)

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AA

0

0%

0

-

0


Active fixed asset (II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total Active fixed asset (II)

Net

10 106 802

-0,4%

10 143 828

-10,0%

11 269 744

 

Gross

BJ

18 468 518

-6,8%

19 814 262

-0,3%

19 872 051

 

Amortisation

BK

8 361 716

-13,5%

9 670 434

12,4%

8 602 307


Intangilble fixed assets

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R & D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AE

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

166 676

147,2%

67 420

-36,9%

106 822

 

Gross

AF

1 075 240

2,1%

1 052 958

3,5%

1 017 586

 

Amortisation

AG

908 564

-7,8%

985 538

8,2%

910 764

Goodwill

Net

1 517 674

0%

1 517 674

0%

1 517 674

 

Gross

AH

1 517 674

0%

1 517 674

0%

1 517 674

 

Amortisation

AI

0

0%

0

0%

0

Other intangible fixed assets

Net

7 460

82,8%

4 080

0%

0

 

Gross

AJ

7 460

82,8%

4 080

0%

0

 

Amortisation

AK

0

0%

0

0%

0

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible Assets

Net

1 691 810

6,5%

1 589 174

-2,2%

1 624 496



Tangilble fixed assets

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Lands

Net

2 204 688

0%

2 204 688

0%

2 204 688

 

Gross

AN

2 204 688

0%

2 204 688

0%

2 204 688

 

Amortisation

AO

0

0%

0

0%

0

Buildings

Net

4 564 531

-10,8%

5 119 194

-6,8%

5 495 317

 

Gross

AP

6 620 375

3,7%

6 383 541

0,2%

6 373 179

 

Amortisation

AQ

2 055 844

62,6%

1 264 347

44,0%

877 862

Plant

Net

458 943

6,7%

430 167

-64,9%

1 224 714

 

Gross

AR

3 980 847

-33,7%

6 004 552

0,5%

5 975 936

 

Amortisation

AS

3 521 904

-36,8%

5 574 385

17,3%

4 751 222

Other tangible fixed assets

Net

110 073

34,8%

81 630

-19,9%

101 959

 

Gross

AT

690 016

17,1%

589 125

-16,3%

703 440

 

Amortisation

AU

579 943

14,3%

507 495

-15,6%

601 481

Fixed assets in construction

Net

166 297

0%

0

0%

0

 

Gross

AV

166 297

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AX

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Tangible asset

Net

7 504 532

 

7 835 679

 

9 026 678



Financial assets

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CU

986 318

108048,9%

912

-0,1%

913

 

Amortisation

CV

986 318

108048,9%

912

-0,1%

913

Inter-company receivables

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BB

309 143

-76,8%

1 330 487

-3,4%

1 377 236

 

Amortisation

BC

309 143

-76,8%

1 330 487

-3,4%

1 377 236

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

Loans

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BF

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BG

0

 

0

 

0

Other financial assets

Net

910 460

26,6%

718 975

16,2%

618 571

 

Gross

BH

910 460

25,4%

726 245

3,5%

701 399

 

Amortisation

BI

0

0%

7 270

-91,2%

82 828

 

Sub Total Financial Assets

 

910 460

 

718 975

 

618 571

 

Current Assets (III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total Assets

Net

29 616 191

52,3%

19 445 985

-5,5%

20 570 969

 

Gross

CJ

34 494 230

23,5%

27 938 176

-8,0%

30 370 872

 

Amortisation

CK

4 878 039

-42,6%

8 492 191

-13,3%

9 799 903



Stocks

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Raw materials

Net

3 712 584

20,9%

3 070 138

13,2%

2 712 390

 

Gross

BL

7 036 040

-19,7%

8 762 060

6,7%

8 213 399

 

Amortisation

BM

3 323 456

-41,6%

5 691 922

3,5%

5 501 009

Work in progress (goods)

Net

5 657 781

228,3%

1 723 099

7,6%

1 601 805

 

Gross

BN

5 758 107

157,2%

2 238 877

-10,9%

2 512 422

 

Amortisation

BO

100 326

-80,5%

515 778

-43,4%

910 617

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

1 943 831

44,7%

1 343 402

95,7%

686 331

 

Gross

BR

2 858 262

0,0%

2 857 270

9,8%

2 602 746

 

Amortisation

BS

914 431

-39,6%

1 513 868

-21,0%

1 916 415

Goods for resale

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BT

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BU

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Stocks

Net

11 314 196

84,4%

6 136 639

22,7%

5 000 526



Advance payments to suppliers

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Advance payments to suppliers

Net

58 710

64,6%

35 666

-56,0%

81 010

 

Gross

BV

95 282

31,9%

72 238

-38,6%

117 582

 

Amortisation

BW

36 572

0%

36 572

0%

36 572



Debtors

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Trade accounts receivable

Net

5 595 683

15,2%

4 855 677

-52,1%

10 137 448

 

Gross

BX

6 098 937

9,1%

5 589 728

-51,7%

11 572 738

 

Amortisation

BY

503 254

-31,4%

734 051

-48,9%

1 435 290

Other debtors

Net

1 037 320

-43,8%

1 845 472

52,0%

1 214 344

 

Gross

BZ

1 037 320

-43,8%

1 845 472

52,0%

1 214 344

 

Amortisation

CA

0

0%

0

0%

0

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Debtors

Net

6 633 003

-1,0%

6 701 149

-41,0%

11 351 792



Divers

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Investment securities

Net

9 295 438

71,4%

5 424 786

239,6%

1 597 176

 

Gross

CD

9 295 438

71,4%

5 424 786

239,6%

1 597 176

 

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

2 233 021

109,0%

1 068 224

-56,9%

2 478 387

 

Gross

CF

2 233 021

109,0%

1 068 224

-56,9%

2 478 387

 

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Divers

Net

11 528 459

77,6%

6 493 010

59,3%

4 075 563



Prepaid expenses

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Prepaid expenses

Net

81 823

2,9%

79 521

28,1%

62 078

 

Gross

CH

81 823

2,9%

79 521

28,1%

62 078

 

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts (IV to VI)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Multi-period charges

CW3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

-

-

 

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

-

-

 

Currency differential gain

CN3

381 146

-24,0%

501 758

18,2%

424 437

 

Gross

 

381 146

-24,0%

501 758

-

-

 

References

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

 

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Accounts - Passive
Other capital resources | Provisions for risks and charges | Liabilities | Translation loss | Equalization accounts | References

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Grand Total (I to V)

EE

40 104 136

33,3%

30 091 568

-6,7%

32 265 150


Shareholder Equity (I)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total shareholders' equity (Total I)

DL

26 267 937

18,3%

22 211 187

1,7%

21 850 212

 

Equity and shareholders' equity

DA

3 091 349

0%

3 091 349

0,1%

3 089 672

 

Issue and merger premiums

DB

23 979 991

-6,0%

25 515 839

0,0%

25 507 142

 

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

 

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

 

Legal reserve

DD

303 644

0%

303 644

0%

303 644

 

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

 

Special regulated reserves

DF

602 089

-37,0%

955 867

-28,3%

1 332 795

 

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

 

Other reserves

DG

0

0%

0

0%

0

 

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

 

0

0%

0

 

Profits or losses brought forward

DH

-5 912 942

29,5%

-8 391 688

-17,1%

-7 169 207

 

Profit or loss for the period

DI

4 203 726

475,6%

730 374

159,7%

-1 222 481

 

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

 

Special tax-allowable reserves

DK

80

-98,6%

5 802

-32,9%

8 648

 

Other capital resources (II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total other capital resources (Total II)

DO

910 267

-4,2%

950 000

-2,1%

970 000

 

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

 

Conditional loans

DN

910 267

-4,2%

950 000

-2,1%

970 000

 

Provisions for risks and charges (III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

1 820 262

46,3%

1 243 853

-45,5%

2 283 844

 

Risk provisions

DP

1 780 538

43,1%

1 243 853

-12,9%

1 427 984

 

Reserves for charges

DQ

39 724

0%

0

0%

855 860

 

Liabilities (IV)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total Liabilities (Total IV)

EC

11 080 677

94,9%

5 686 225

-20,3%

7 137 695

 

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

 

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

 

Bank loans and liabilities

DU

0

0%

2 029

-98,2%

110 959

 

Sundry loans and financial liabilities

DV

0

0%

0

0%

0

 

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

 

Advance payments received for current orders

DW

4 060 109

683,9%

517 906

182,9%

183 086

 

Trade accounts payables

DX

3 228 378

35,2%

2 387 527

-26,3%

3 238 978

 

Tax and social security liabilities

DY

3 111 903

78,4%

1 744 534

-5,0%

1 836 566

 

Fixed asset liabilities

DZ

173 164

-55,8%

391 903

-28,7%

550 000

 

Other debts

EA

428 181

-21,8%

547 264

-48,7%

1 066 241

 

Translation loss (V)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Translation loss (Total V)

ED

24 991

8120,7%

304

-98,7%

23 398

 

Equalization accounts

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Deferred income

EB

78 942

-17,0%

95 062

-37,4%

151 867

 

References

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

 

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

 

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Result account
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges | Financial income | Financial charges | Financial charges | Extraordinary charges | Employee profit sharing | Tax on profits | References

1- Operating result (I-II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Operating result (Total I-II)

GG

4 283 585

44138,1%

-9 727

99,3%

-1 297 546


2 - Financial result (V - VI)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Financial result (Total V-VI)

GV

19 944

-85,2%

134 757

133,6%

-400 575


3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

4 303 529

3342,0%

125 030

107,4%

-1 698 121


4 - Extraordinary result (VII-VIII)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

-122 463

-496,5%

30 885

121,5%

-143 748


Profit or loss

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Profit or loss

HN

4 203 726

475,6%

730 374

159,7%

-1 222 481


Total Income (I+III+V+VII)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total Income (I+III+V+VII)

HL

34 847 394

52,7%

22 819 987

10,6%

20 629 852


Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

30 643 669

38,7%

22 089 615

1,1%

21 852 332


Operating income (I)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total operating income (Total I)

FR

33 671 326

54,2%

21 834 717

11,9%

19 515 211


Operating income (details)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sale of goods for resale

FC

0

0%

0

0%

0

 

France

FA

0

0%

0

0%

0

 

Export

FB

0

0%

0

0%

0

Sale of goods produced

FF

27 869 136

63,0%

17 099 592

-4,7%

17 937 142

 

France

FD

3 642 365

84,1%

1 978 981

16,8%

1 694 885

 

Export

FE

24 226 771

60,2%

15 120 611

-6,9%

16 242 257

Sale of services

FI

198 015

-71,7%

700 000

-21,6%

892 599

 

France

FG

18 379

0%

0

0%

297 415

 

Export

FH

179 636

-74,3%

700 000

17,6%

595 184

Net turnover

FL

28 067 151

57,7%

17 799 592

-5,5%

18 829 741

 

France

FJ

3 660 744

85,0%

1 978 981

-0,7%

1 992 300

 

Export

FK

24 406 407

54,3%

15 820 611

-6,0%

16 837 441

 

Stocked production

FM

2 231 602

4286,4%

50 875

102,1%

-2 414 764

 

Self-constructed assets

FN

27 201

0%

0

0%

183 630

 

Operating grants

FO

50 269

-73,6%

190 095

268,9%

51 524

 

Release of reserves and provisions

FP

3 070 902

-18,5%

3 769 636

34,4%

2 803 880

 

Other income

FQ

224 201

814,4%

24 519

-59,9%

61 200


Operating charges (II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Total operating charges (Total II)

GF

29 387 741

34,5%

21 844 444

5,0%

20 812 757


Exploitation charges

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Purchase of goods for resale

FS

0

0%

2 733

0%

0

 

Change in stocks of goods for resale

FT

0

0%

0

0%

0

 

Purchase of raw materials

FU

14 105 721

79,0%

7 880 665

23,9%

6 358 055

 

Change in stocks of raw materials

FV

178 555

137,3%

-478 765

-188,9%

538 603

 

Other external purchases and charges

FW

4 316 177

-2,1%

4 408 849

-1,0%

4 454 134

 

Tax, duty and similar payments

FX

871 078

47,5%

590 558

7,5%

549 458

 

Payroll

FY

5 419 927

30,0%

4 167 736

7,5%

3 875 164

 

Social security costs

FZ

2 342 186

28,4%

1 824 259

3,2%

1 767 894


Depreciation

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Depreciation of fixed assets

GA

754 989

-43,4%

1 334 555

2,9%

1 297 004

 

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

0

 

Depreciation/amortisation of current assets

GC

510 152

-39,0%

835 887

-49,4%

1 650 531

 

Provisions for risks and charges

GD

133 236

-70,7%

455 297

42,1%

320 461


Other charges

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Other charges

GE

755 720

-8,1%

822 670

56518,7%

1 453

 

Operating charges (III-IV)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

 

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

 

Financial income (V)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total financial income (Total V)

GP

1 093 954

27,6%

857 666

-22,6%

1 107 480

 

Share financial income

GJ

0

0%

0

0%

0

 

Other investment income & capitalised receivables

GK

0

0%

0

0%

0

 

Other interest and similar income

GL

247 507

34,3%

184 247

21,4%

151 823

 

Released provisions and transferred charges

GM

568 983

4,0%

547 322

-11,6%

618 829

 

Exchange gains

GN

226 274

124,7%

100 693

-60,5%

254 894

 

Net income from disposal of investment securities

GO

51 190

101,5%

25 404

-69,0%

81 934

 

Financial Charge (VI)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total financial charge (Total VI)

GU

1 074 010

48,6%

722 909

-52,1%

1 508 055

 

Financial reserves and provisions

GQ

614 472

10,6%

555 765

-43,3%

980 184

 

Interest and similar charges

GR

197 015

1428,6%

12 889

-96,3%

347 265

 

Exchange losses

GS

262 523

70,2%

154 255

-14,6%

180 606

 

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary income (VII)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total extraordinary income (Total VII)

HD

82 114

-35,6%

127 604

1681,9%

7 161

 

Extraordinary operating income

HA

76 775

209,9%

24 777

330,1%

5 761

 

Extraordinary income from capital transactions

HB

4 544

-95,5%

99 982

0%

0

 

Released provisions and transferred charges

HC

795

-72,1%

2 845

103,2%

1 400

 

Extraordinary charges (VIII)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

204 577

111,5%

96 719

-35,9%

150 909

 

Extraordinary operating charges

HE

200 000

583,8%

29 250

-68,9%

94 115

 

Extraordinary charges from capital transactions

HF

4 537

-93,3%

67 469

54,6%

43 635

 

Extraordinary reserves and provisions

HG

40

0%

0

0%

13 159

 

Employee profit sharing (IX)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

0

0%

0

0%

0

 

Tax on profits (X)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Tax on profits (Total X)

HK

-22 659

96,1%

-574 457

7,3%

-619 389

 

References

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

 

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

 

Of which transferred charges

A1

0

0%

0

0%

0

 

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

 

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Other incomer tax return forms
Reserve for depreciation | Provisions included in balance sheet | State deadlines claims and debts at the end of period
Table allocation results and other information

Fixed Assets
Grand Total Fixed Assets (I to IV)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

22 651 503

 

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

2 655 754

 

Decreasess by budget item transfer

OK1

14 271

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

OK2

5 599 881

137,9%

2 353 504

-56,7%

5 435 207

 

Gross value at the end of period

OL

18 468 517

-6,8%

19 814 262

-0,3%

19 872 051


Research and development Charge (Total I)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

C01

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

C02

0

0%

0

0%

0

 

Gross value at the end of period

D0

0

0%

0

0%

0


Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

KD

2 687 910

6,0%

2 535 259

151,7%

1 007 094

 

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

129 796

229,0%

39 452

-97,5%

1 552 345

 

Decreasess by budget item transfer

LV1

14 271

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

LV2

203 063

0%

0

0%

24 181

 

Gross value at the end of period

LW

2 600 372

1,0%

2 574 711

1,6%

2 535 260


Tangible fixed assets (Total III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

LN

13 370 098

-12,4%

15 257 243

3,6%

14 726 468

 

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

339 096

383,4%

70 142

-87,2%

549 770

 

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NG2

46 971

-67,7%

145 480

665,9%

18 994

 

Gross value at the end of period

NH

13 662 223

-10,0%

15 181 905

-0,5%

15 257 244


Fiancial assets (Total IV)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

LQ

2 314 434

11,3%

2 079 547

-69,9%

6 917 942

 

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

5 241 334

139,8%

2 186 122

294,9%

553 639

 

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NJ2

5 349 847

142,3%

2 208 025

-59,1%

5 392 032

 

Gross value at the end of period

NK

2 205 921

7,2%

2 057 644

-1,1%

2 079 548

 

Reserve for depreciation
Situation and movement of reserve for depreciation
Grand total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

0N

0

0%

0

0%

5 748 678

Increases

0P

0

0%

0

0%

1 297 002

Decreasess

0Q

0

0%

0

0%

164 663

 

Reserve for depreciation value at the end of period

0R

0

0%

0

0%

7 141 329


Research and development charge (Total I)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0


Other intangible assets (Total II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

1 049 867

15,3%

910 764

4,6%

870 493

Increases

PF

61 760

-17,4%

74 774

34,0%

55 784

Decreasess

PG

203 062

0%

0

0%

15 513

 

Decreasess by budget item transfer

PH

908 565

-7,8%

985 538

8,2%

910 764


Total fixed assets amotisation (Total III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

5 519 878

-11,4%

6 230 566

27,7%

4 878 185

Increases

QV

693 229

-45,0%

1 259 560

1,5%

1 241 218

Decreases

QW

55 416

-61,5%

143 899

-3,5%

149 150

 

Decreasess by budget item transfer

QX

6 157 691

-16,2%

7 346 227

17,9%

6 230 565


Movements during period affecting charge allocated over several period
Charges à répartir ou frais d'émission d'emprunt

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0


Premium refund of obligations

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Net value at begining of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

 

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

 

Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

7C

10 218 707

-24,6%

13 553 372

-11,9%

15 384 096

Increases

UB

1 257 900

-31,9%

1 846 950

-38,7%

3 011 473

Decreases

UC

3 482 764

-19,4%

4 319 804

-10,6%

4 833 650

 

Value at the end of period

UD

7 993 843

-27,9%

11 080 518

-18,3%

13 561 920

Includes Total allocations

 

Operating

UE

0

0%

0

0%

0

 

Financial

UG

0

0%

0

0%

0

 

Exceptional

UJ

0

0%

0

0%

0

Includes Total Withdrawal

 

Operating

UF

0

0%

0

0%

0

 

Financial

UH

0

0%

0

0%

0

 

Exceptional

UK

0

0%

0

0%

0


Total regulated provisions (Total I)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

3Z

835

-90,3%

8 648

102,3%

4 274

Increases

TS

40

0%

0

0%

5 774

Decreases

TT

795

-72,1%

2 845

103,2%

1 400

 

Value at the end of period

TU

80

-98,6%

5 803

-32,9%

8 648


Total risk and charge provisions (Total II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

5Z

1 893 958

-17,1%

2 283 845

-32,4%

3 378 043

Increases

TV

704 656

-30,3%

1 010 484

30,1%

776 658

Decreases

TW

778 352

-62,0%

2 050 474

9,6%

1 870 858

 

Value at the end of period

TX

1 820 262

46,3%

1 243 855

-45,5%

2 283 843


Total Provision for depreciation (Total III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Value at begining of period

7B

8 323 915

-26,1%

11 260 880

-6,2%

12 001 779

Increases

TY

553 204

-33,9%

836 466

-62,5%

2 229 041

Decreases

TZ

2 703 618

19,3%

2 266 486

-23,5%

2 961 392

 

Value at the end of period

UA

6 173 501

-37,2%

9 830 860

-12,8%

11 269 428

 

State deadlines claims and debts at the end of period
State claims

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Gross value

VT

8 437 684

-11,8%

9 571 453

-36,4%

15 045 377

 

1 year at most

VU

7 356 129

-10,7%

8 240 966

-17,6%

9 995 170

 

More than one year

VV

1 081 555

-18,7%

1 330 487

-73,7%

5 050 207


State of loans

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Claims related to holdings (gross)

UL

309 143

-76,8%

1 330 487

-3,4%

1 377 236

 

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

154 572

0%

0

0%

0

 

Loans (gross)

UP

0

0%

0

0%

0

 

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

0

0%

0

 

Other financial assets (gross)

UT

910 460

25,4%

726 245

3,5%

701 399

 

Other financial assets (1 year at most)

UV

0

0%

726 245

568,2%

108 690


Receivables statement of assets

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Customers doubtful or disputed

VA

553 626

-35,5%

858 790

-40,2%

1 436 157

 

Other claims customer

UX

5 545 311

17,2%

4 730 938

-53,3%

10 136 581

 

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

 

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

 

Personnel and associated accounts

UY

17 865

219,1%

5 599

-0,2%

5 608

 

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

0

0%

2 208

 

Income taxes

VM

0

0%

1 097 876

0,5%

1 092 619

 

Value added tax

VB

649 731

453,4%

117 406

23,6%

94 970

 

Other taxes and payments assimilated

VN

316 602

-48,9%

619 677

7659,5%

7 986

 

State and other public - Miscellaneous

VP

8 229

0%

0

0%

0

 

Group and Associates

VC

0

0%

0

0%

0

 

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

44 893

813,6%

4 914

-55,1%

10 953


Prepaid

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Prepaid

VS

81 823

2,9%

79 521

28,1%

62 078


State Debt

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Total debt (gross)

VY

7 020 569

35,8%

5 168 318

-27,6%

7 137 697

1 year at most

VZ2

7 020 569

35,8%

5 168 318

-27,6%

7 137 695

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

VZ4

0

0%

0

0%

02


Details

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

0

0%

2 029

-98,2%

110 959

1 year at most

VG2

0

0%

2 029

-98,2%

110 959

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VH2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8A2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8A3

0

0%

0

0%

0

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

3 228 378

35,2%

2 387 527

-26,3%

3 238 978

1 year at most

8B2

3 228 378

35,2%

2 387 527

-26,3%

3 238 976

More than 1 year and 5 years at most

8B3

3 228 378

35,2%

2 387 527

0%

0

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

1 462 516

110,7%

694 118

42,1%

488 606

1 year at most

8C2

1 462 516

110,7%

694 118

42,1%

488 606

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

975 872

48,1%

659 011

13,5%

580 799

1 year at most

8D2

975 872

48,1%

659 011

13,5%

580 799

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

369 155

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

369 155

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (gross)

VW1

0

0%

06

-100,0%

390 573

1 year at most

VW2

0

0%

06

-100,0%

390 573

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

304 361

-22,2%

391 398

3,9%

376 588

1 year at most

VQ2

304 361

-22,2%

391 398

3,9%

376 588

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

173 164

-55,8%

391 903

-28,7%

550 000

1 year at most

8J2

173 164

-55,8%

391 903

-28,7%

550 000

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VI2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More 5 years

VI4

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

428 181

-21,8%

547 264

-56,2%

1 249 327

1 year at most

8K2

428 181

-21,8%

547 264

-56,2%

1 249 327

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

78 942

-17,0%

95 062

-37,4%

151 867

1 year at most

8L2

78 942

-17,0%

95 062

-37,4%

151 867

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0


References

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Loans made during the period

VJ

0

0%

0

0%

0

 

Debt repaid during the period

VK

0

0%

0

0%

0

 

Table allocation results and other information
Dividends distributed

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0


Commitments

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

 

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

 

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0


Other charges Externes

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

 

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

 

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

 

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

 

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

 

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

 

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0


Taxes and Fees

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

 

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0


VAT

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

 

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0


Average number of employees

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Average number of employees

YP

97

12,8%

86

-1,1%

87


Groups and Shareholders

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

 

Groups and Shareholders

ZR

0

-

0

-

-

 

 

 

Display parameter

Comparison mode

Average

Median


Ratios
Structure and liquidity | Management or rotation | Profitability of the business | Return on capital

Structure and Liquidity

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2011

 

Fixed Asset Financing

 

2,02

17,4%

1,72

1,2%

1,70

2,36

-14,4%

Global Debt

 

142 days

23,5%

115 days

-15,4%

136 days

130 days

9,2%

Working Capital Fund overall net

 

242 days

-16,0%

288 days

7,9%

267 days

140 days

72,9%

Financial independence

 

%

-

1094686,40%

5459,0%

19692,15%

1009,21%

-

Solvability

 

67,77%

-12,0%

76,97%

8,8%

70,73%

51,52%

31,5%

Capacity debt futures

 

%

-

1094686,40%

5459,0%

19692,15%

2648,05%

-

Coverage of current assets by net working capital overall

 

43,22%

0,9%

42,85%

-2,0%

43,71%

53,35%

-19,0%

General Liquidity

 

1,05

-34,0%

1,59

13,6%

1,40

0,95

10,5%

Restricted Liquidity

 

2,69

-5,6%

2,85

44,7%

1,97

1,51

78,1%


Management or rotation

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2011

 

Need background in operating working capital

 

90 days

-38,8%

147 days

-19,7%

183 days

67 days

34,3%

Treasury

 

148 days

13,0%

131 days

67,9%

78 days

35 days

322,9%

Inventory turnover of goods

 

days

-

0 days

-

days

16 days

-

Average length of credit granted to customers

 

78 days

-31,0%

113 days

-48,9%

221 days

79 days

-1,3%

Average length of credit obtained suppliers

 

62 days

-15,1%

73 days

-29,1%

103 days

67 days

-7,5%

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

 

180 days

-55,0%

400 days

-14,0%

465 days

107 days

68,2%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

 

205 days

75,2%

117 days

-4,9%

123 days

587 days

-65,1%

Rotation tangible assets

 

205,44%

75,2%

117,24%

-5,0%

123,42%

626,62%

-67,2%


Profitability of the business

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2011

 

Margin trading

 

0%

0%

-0,02%

0%

0

0%

0%

Profitability of the business

 

11,20

660,0%

-2

57,8%

-4,74

7,38%

51,8%

Net profit

 

14,98%

265,4%

4,10%

163,2%

-6,49%

5,24%

185,9%

Growth rate of turnover (excluding VAT)

 

0%

0%

-5,47%

-119,0%

28,73%

8,30%

0%

Rates integration

 

41,78%

23,2%

33,92%

21,7%

27,87%

45,52%

-8,2%

Rate leasing furniture

 

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Work Factor

 

66,20%

-33,3%

99,25%

-7,7%

107,53%

76,80%

-13,8%

Weight interests

 

3,83

-5,7%

4,06%

-49,3%

8,01%

0,36%

963,9%


Return on capital

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2011

 

Cash flow from the overall profitability

 

19,86%

36,6%

14,54%

146,4%

5,90%

7,24%

174,3%

Rates of economic profitability

 

12%

700%

-2%

50,0%

-4%

15%

-20,0%

Financial profitability

 

27178204%

17,3%

23161187%

1,5%

22820212%

338122%

7938,0%

Return on investment

 

19,42%

209,7%

6,27%

401,6%

1,25%

11,79%

64,7%

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

Comparison mode

Average

Median


Soldes Intermédiaires de Gestion

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

31/12/2008

Sector Median 2011

 

Turnover

28 067 151

57,7%

17 799 592

-5,5%

18 829 741

968 958 € 

2796,6% 

 

Sales of goods

0

0%

0

0%

0

 

 

- Purchase of goods

0

0%

2 733

0%

0

 

 

+/- Stock of goods variation

0

0%

0

0%

0

 

 

Trading margin

0 €

0%

-2 733 €

0%

0 €

0 € 

0% 

 

0,00 % CA

0%

-0,02 % CA

0%

0,00 % CA

0 % CA 

0% 

 

Sale

of goods produced

28 067 151

57,7%

17 799 592

-5,5%

18 829 741

 

 

+/- Stocked production

2 231 602

4286,4%

50 875

102,1%

-2 414 764

 

 

+ Self-constructed assets

27 201

0%

0

0%

183 630

 

 

Period production

30 325 954 €

69,9%

17 850 467 €

7,5%

16 598 607 €

718 020,50 € 

4123,5% 

 

108,05 % CA

7,7%

100,29 % CA

13,8%

88,15 % CA

99,76 % CA 

8,3% 

 

Trading margin

0

0%

-2 733

0%

0

0% 

+ Period Production

30 325 954

69,9%

17 850 467

7,5%

16 598 607

718 020,50 

4123,5% 

- Pur

hase of raw materials

14 105 721

79,0%

7 880 665

23,9%

6 358 055

 

 

+/- Change in stocks of raw materiels

178 555

137,3%

-478 765

-188,9%

538 603

 

 

- Other external purchases and charges

4 316 177

-2,1%

4 408 849

-1,0%

4 454 134

 

 

Added value

11 725 501 €

94,2%

6 036 985 €

15,0%

5 247 815 €

423 354 € 

2669,7% 

 

41,78 % CA

23,2%

33,92 % CA

21,7%

27,87 % CA

45,52 % CA 

-8,2% 

 

Added value

11 725 501 €

94,2%

6 036 985 €

15,0%

5 247 815 €

423 354 € 

2669,7% 

+ Operating grants

50 269

-73,6%

190 095

268,9%

51 524

 

 

- Tax, duty and similar payments

871 078

47,5%

590 558

7,5%

549 458

 

 

- Personal charges

7 762 113

29,5%

5 991 995

6,2%

5 643 058

 

 

Gross operating surplus

3 142 579 €

984,1%

-355 473 €

60,2%

-893 177 €

55 553 € 

5556,9% 

 

11,20 % CA

660,0%

-2,00 % CA

57,8%

-4,74 % CA

7,38 % CA 

51,8% 

 

Gross operating surplus

3 142 579 €

984,1%

-355 473 €

60,2%

-893 177 €

55 553 € 

5556,9% 

+ Release of reserves and provisions

3 070 902

-18,5%

3 769 636

34,4%

2 803 880

 

 

+ Other operating income

224 201

814,4%

24 519

-59,9%

61 200

 

 

- Depreciation/Amortisation

1 398 377

-46,7%

2 625 739

-19,7%

3 267 996

 

 

- Other charges

755 720

-8,1%

822 670

56518,7%

1 453

 

 

Operating result

4 283 585 €

44138,1%

-9 727 €

99,3%

-1 297 546 €

37 352 € 

11368,2% 

 

15,26 % CA

30620,0%

-0,05 % CA

99,3%

-6,89 % CA

5,08 % CA 

200,4% 

 

Operating result

4 283 585 €

44138,1%

-9 727 €

99,3%

-1 297 546 €

37 352 € 

11368,2% 

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Financial income

1 093 954

27,6%

857 666

-22,6%

1 107 480

 

 

- Financial charges

1 074 010

48,6%

722 909

-52,1%

1 508 055

 

 

Pre-tax result

4 303 529 €

3342,0%

125 030 €

107,4%

-1 698 121 €

37 568 € 

11355,3% 

 

15,33 % CA

2090,0%

0,70 % CA

107,8%

-9,02 % CA

4,79 % CA 

220,0% 

 

Extraordinary income

82 114

-35,6%

127 604

1681,9%

7 161

834,50 

9739,9% 

- Extraordinary charges

204 577

111,5%

96 719

-35,9%

150 909

 

 

Extraordinary result

-122 463 €

-496,5%

30 885 €

121,5%

-143 748 €

0 € 

0% 

 

-0,44 % CA

-358,8%

0,17 % CA

122,4%

-1 % CA

0 % CA 

0% 

 

Pre-tax result

4 303 529 €

3342,0%

125 030 €

107,4%

-1 698 121 €

37 568 € 

11355,3% 

Extraordinary result

-122 463 €

-496,5%

30 885 €

121,5%

-143 748 €

0 € 

0% 

- Employee profit sharing

0

0%

0

0%

0

 

 

- Tax on profits

-22 659

96,1%

-574 457

7,3%

-619 389

 

 

Net result

4 203 725 €

475,6%

730 372 €

159,7%

-1 222 480 €

45 966,50 € 

9045,2% 

 

14,98 % CA

265,4%

4,10 % CA

163,2%

-6,49 % CA

5,16 % CA 

190,3% 

 

 

Payment Information Summary - SafeTrade

 

Payment Information Summary - SafeTrade

 

Total number of Invoices available

15

 

Total number of Invoices paid within or up to 30 days after the due date

11

 

Total number of Invoices paid more than 30 days after the due date

1

 

Total number of Invoices currently outstanding where the due date has not yet been reached

1

 

Total number of Invoices currently outstanding beyond the due date

2

 

 

 

Have you got a payment experience on this or any other customers you could share with us? Contribute to our payment data programme to encourage best practice and expose poor performance. Click here for details and to find out what you will get back in return.

 

 

 

 

 

judgements

 

Collective procedures

 

 

No judgment information for the company

 

 

 

 

 

 

   Social security, pension funds preferential rights | Tax office preferential rights

Preferential rights details and history

Status of collection

This company is not under monitoring

 

 

Group data

 

Ultimate parent company

RIBER S.A

Direct parent

-

Group – Number of companies

2

Linkages – Number of companies

-

Number of countries

-

Company Name

 

SIREN

Parts

Last account published

 

RIBER

 

343006151

-

31/12/2011

 

RIBER INC

 

US46394436

100%

-

 

Linkages

Ultimate parent company

RIBER S.A

Direct parent

-

Group – Number of companies

2

Linkages – Number of companies

-

Number of countries

-

No linked companies

 

event history

 

 

Status history

 

 

 

Date

Description

No Status History

 

 

 

Recent publications in Gazettes

 

 

 

Publication date

Gazette Name

Description

 

29/08/2012

Bodacc C

Comptes annuels, consolidés et rapports

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

14134 - 343006151 RCS. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse : 31 rue Casimir Perier 95873 Bezons Cedex. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011.

21/08/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

14491 - 343006151 RCS. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse : 31 rue Casimir Perier 95873 Bezons Cedex. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011.

27/07/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

4322 - 343 006 151 RCS Pontoise. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Administration : Membre du directoire : PICAULT Michel modification le 17 Juin 2008 Vice président du conseil de surveillance : SPITZ Erich modification le 17 Juin 2008 Commissaire aux comptes suppléant : KUPERBERG Pierre Commissaire aux comptes titulaire : BOISSIERE EXPERTISE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : PETRONI Raymond Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD Membre du conseil de surveillance : RABOUTET Bernard en fonction le 18 Décembre 2007 Membre du conseil de surveillance : GOUTARD Noel modification le 04 Août 2010 Membre du directoire : BOUCHAIB Pierre en fonction le 17 Juin 2008 Président du directoire : GOUTARD Frédérick Noël en fonction le 11 Juin 2009 Membre du directoire : HANDSCHUMACHER Olivier Jean-Philippe en fonction le 11 Juin 2009 Membre du directoire : LEY Philippe en fonction le 27 Juillet 2010 Président du conseil de surveillance : NOELS Jacques en fonction le 27 Juillet 2010 Membre du conseil de surveillance : NICOU Gérard Louis en fonction le 21 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : BOUSCASSE Thierry Pierre en fonction le 21 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : DUMAINE Sylvie Martine Marie en fonction le 21 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : KIELWASSER Jacques René Joseph en fonction le 21 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : STIEVENART Guy Jean-Marc en fonction le 21 Juillet 2011. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant.

27/07/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

4324 - 343 006 151 RCS Pontoise. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Administration : Membre du directoire : PICAULT Michel modification le 17 Juin 2008 Commissaire aux comptes suppléant : KUPERBERG Pierre Commissaire aux comptes titulaire : BOISSIERE EXPERTISE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : PETRONI Raymond Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD Membre du conseil de surveillance : RABOUTET Bernard en fonction le 18 Décembre 2007 Membre du conseil de surveillance : GOUTARD Noel modification le 04 Août 2010 Membre du directoire : BOUCHAIB Pierre en fonction le 17 Juin 2008 Président du directoire : GOUTARD Frédérick Noël en fonction le 11 Juin 2009 Membre du directoire : HANDSCHUMACHER Olivier Jean-Philippe en fonction le 11 Juin 2009 Membre du directoire : LEY Philippe en fonction le 27 Juillet 2010 Président du conseil de surveillance : NOELS Jacques en fonction le 27 Juillet 2010 Membre du conseil de surveillance : NICOU Gérard Louis en fonction le 21 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : BOUSCASSE Thierry Pierre en fonction le 21 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : DUMAINE Sylvie Martine Marie en fonction le 21 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : KIELWASSER Jacques René Joseph en fonction le 21 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : STIEVENART Guy Jean-Marc en fonction le 21 Juillet 2011 Vice président : KIELWASSER Jacques René Joseph en fonction le 21 Juillet 2011. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant.

22/07/2011

JAL

Appointment of the social representative

 

 

Echo régional (L')


Société faisant l'objet d'une nomination : 343006151 - RIBER, 31 RUE CASIMIR PERIER, 95870 BEZONS
Nominé : Monsieur Jacques KIELWASSER
En la fonction de : Vice-Pdt du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Gérard NICOU, 94200 IVRY SUR SEINE
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Guy STIEVENART, 75016 PARIS 16
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Thierry BOUSCASSE, 74300 THYEZ
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Jacques KIELWASSER, 74300 CLUSES
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Madame Sylvie DUHAINE, 92200 NEUILLY SUR SEINE
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Date d'effet : 26/05/2011

22/07/2011

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

Echo régional (L')


Date de décision : 26/05/2011
La société 343006151 - RIBER, 31 RUE CASIMIR PERIER, 95870 BEZONS
Fait l'objet du départ de Date d'effet : 26/05/2011

30/08/2010

Bodacc C

Comptes annuels, consolidés et rapports

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

13809 - 343006151 RCS. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire. Adresse : 31 rue Casimir Perier 95873 Bezons Cedex. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

13/08/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

1095 - 343 006 151 RCS Pontoise. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire. Administration : Membre du directoire : PICAULT Michel modification le 17 Juin 2008 Vice président du conseil de surveillance : SPITZ Erich modification le 17 Juin 2008 Commissaire aux comptes suppléant : KUPERBERG Pierre Commissaire aux comptes titulaire : BOISSIERE EXPERTISE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : PETRONI Raymond Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD Membre du conseil de surveillance : RABOUTET Bernard en fonction le 18 Décembre 2007 Membre du conseil de surveillance : GOUTARD Noel modification le 04 Août 2010 Membre du directoire : BOUCHAIB Pierre en fonction le 17 Juin 2008 Président du directoire : GOUTARD Frédérick Noël en fonction le 11 Juin 2009 Membre du directoire : HANDSCHUMACHER Olivier Jean-Philippe en fonction le 11 Juin 2009 Membre du directoire : LEY Philippe en fonction le 27 Juillet 2010 Président du conseil de surveillance : NOELS Jacques en fonction le 27 Juillet 2010.
Commentaires : Modification de représentant.

05/08/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

2495 - 343 006 151 RCS Pontoise. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire. Administration : Membre du directoire : PICAULT Michel modification le 17 Juin 2008 Vice président du conseil de surveillance : SPITZ Erich modification le 17 Juin 2008 Commissaire aux comptes suppléant : KUPERBERG Pierre Commissaire aux comptes titulaire : BOISSIERE EXPERTISE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : PETRONI Raymond Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD Membre du conseil de surveillance : RABOUTET Bernard en fonction le 18 Décembre 2007 Président du conseil de surveillance : GOUTARD Noel en fonction le 17 Juin 2008 Membre du directoire : BOUCHAIB Pierre en fonction le 17 Juin 2008 Président du directoire : GOUTARD Frédérick Noël en fonction le 11 Juin 2009 Membre du directoire : HANDSCHUMACHER Olivier Jean-Philippe en fonction le 11 Juin 2009 Membre du directoire : LEY Philippe en fonction le 27 Juillet 2010.
Commentaires : Modification de représentant.

05/08/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

2496 - 343 006 151 RCS Pontoise. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire. Administration : Membre du directoire : PICAULT Michel modification le 17 Juin 2008 Vice président du conseil de surveillance : SPITZ Erich modification le 17 Juin 2008 Commissaire aux comptes suppléant : KUPERBERG Pierre Commissaire aux comptes titulaire : BOISSIERE EXPERTISE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : PETRONI Raymond Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD Membre du conseil de surveillance : RABOUTET Bernard en fonction le 18 Décembre 2007 Président du conseil de surveillance : GOUTARD Noel en fonction le 17 Juin 2008 Membre du directoire : BOUCHAIB Pierre en fonction le 17 Juin 2008 Président du directoire : GOUTARD Frédérick Noël en fonction le 11 Juin 2009 Membre du directoire : HANDSCHUMACHER Olivier Jean-Philippe en fonction le 11 Juin 2009 Membre du directoire : LEY Philippe en fonction le 27 Juillet 2010 Président du conseil de surveillance : NOELS Jacques en fonction le 27 Juillet 2010.
Commentaires : Modification de représentant.

09/07/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

L'ECHO - LE REGIONAL


Société faisant l'objet d'une nomination : 343006151 - RIBER, 31 RUE CASIMIR PERIER, 95870 BEZONS
Nominé : Monsieur Jacques NOELS, CHEMIN DES MAUVARES, 13840 ROGNES
En la fonction de : Président du Conseil de Surveillance
Pour une durée de 24 mois

09/07/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

L'ECHO - LE REGIONAL


Société faisant l'objet d'une nomination : 343006151 - RIBER, 31 RUE CASIMIR PERIER, 95870 BEZONS
Nominé : Monsieur Jacques NOELS, CHEMIN DES MAUVARES, 13840 ROGNES
En la fonction de : Membre du conseil de surveillance
Pour une durée de 24 mois

09/07/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

L'ECHO - LE REGIONAL


Société faisant l'objet d'une nomination : 343006151 - RIBER, 31 RUE CASIMIR PERIER, 95870 BEZONS
Nominé : Monsieur Philippe LEY, 3 RUE DE LA PORTE DE PARIS, 91470 LES MOLIERES
Pour une durée de 72 mois

09/07/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

L'ECHO - LE REGIONAL


Date de décision : 27/05/2010
La société 343006151 - RIBER, 31 RUE CASIMIR PERIER, 95870 BEZONS
Fait l'objet du départ de Monsieur Noël GOUTARD

26/01/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

1460 - 343 006 151 RCS Pontoise. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Capital : 3091348.96 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

01/01/2010

JAL

Modification of the share capital

 

 

L'ECHO - LE REGIONAL


Date de décision : 04/11/2009
La société : 343006151 - RIBER, 31 RUE CASIMIR PERIER, 95870 BEZONS a subi une augmentation de son capital social désormais de 3 091 349 €

01/07/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

12375 - 343006151 RCS. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse : 31 rue Casimir Perier 95873 Bezons Cedex. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

01/07/2009

Bodacc C

Comptes consolidés et rapports

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

12376 - 343006151 RCS. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse : 31 rue Casimir Perier 95873 Bezons Cedex. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

19/06/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

1975 - 343 006 151 RCS Pontoise. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Administration : Membre du directoire : PICAULT Michel modification le 17 Juin 2008. Vice président du conseil de surveillance : SPITZ Erich modification le 17 Juin 2008. Commissaire aux comptes suppléant : KUPERBERG Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : BOISSIERE EXPERTISE AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : PETRONI Raymond. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD. Membre du conseil de surveillance : RABOUTET Bernard en fonction le 18 Décembre 2007. Membre du conseil de surveillance : MONNIER Joel modification le 17 Juin 2008. Président du conseil de surveillance : GOUTARD Noel en fonction le 17 Juin 2008. Membre du directoire : BOUCHAIB Pierre en fonction le 17 Juin 2008. Président du directoire : GOUTARD Frédérick Noël en fonction le 11 Juin 2009.
Commentaires : Modification de représentant.

19/06/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

1978 - 343 006 151 RCS Pontoise. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Administration : Membre du directoire : PICAULT Michel modification le 17 Juin 2008. Vice président du conseil de surveillance : SPITZ Erich modification le 17 Juin 2008. Commissaire aux comptes suppléant : KUPERBERG Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : BOISSIERE EXPERTISE AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : PETRONI Raymond. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD. Membre du conseil de surveillance : RABOUTET Bernard en fonction le 18 Décembre 2007. Président du conseil de surveillance : GOUTARD Noel en fonction le 17 Juin 2008. Membre du directoire : BOUCHAIB Pierre en fonction le 17 Juin 2008. Président du directoire : GOUTARD Frédérick Noël en fonction le 11 Juin 2009. Membre du directoire : HANDSCHUMACHER Olivier Jean-Philippe en fonction le 11 Juin 2009.
Commentaires : Modification de représentant.

19/06/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

1976 - 343 006 151 RCS Pontoise. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Administration : Membre du directoire : PICAULT Michel modification le 17 Juin 2008. Vice président du conseil de surveillance : SPITZ Erich modification le 17 Juin 2008. Commissaire aux comptes suppléant : KUPERBERG Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : BOISSIERE EXPERTISE AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : PETRONI Raymond. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD. Membre du conseil de surveillance : RABOUTET Bernard en fonction le 18 Décembre 2007. Membre du conseil de surveillance : MONNIER Joel modification le 17 Juin 2008. Président du conseil de surveillance : GOUTARD Noel en fonction le 17 Juin 2008. Membre du directoire : BOUCHAIB Pierre en fonction le 17 Juin 2008. Président du directoire : GOUTARD Frédérick Noël en fonction le 11 Juin 2009. Membre du directoire : HANDSCHUMACHER Olivier Jean-Philippe en fonction le 11 Juin 2009.
Commentaires : Modification de représentant.

26/03/2009

Bodacc C

Comptes annuels, consolidés et rapports

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

10166 - 343006151 RCS. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse : 31 rue Casimir Perier 95873 Bezons Cedex. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

19/03/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

3203 - 343 006 151 RCS Pontoise. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Capital : 3089672.48 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

10/06/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

2058 - 343 006 151 RCS Pontoise. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Capital : 3036472.48 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

06/03/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

6157 - 343 006 151 RCS Pontoise. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Administration : Président du directoire : PICAULT Michel. Membre du directoire : CHAIX Catherine. Président du conseil de surveillance : SPITZ Erich. Membre du conseil de surveillance : BELIN Paul. Commissaire aux comptes suppléant : KUPERBERG Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : BOISSIERE EXPERTISE AUDIT. Membre du conseil de surveillance : LAVEDRINE Olivier. Membre du directoire : MARCHETTI Laurence. Commissaire aux comptes suppléant : PETRONI Raymond. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS& GUERARD. Membre du conseil de surveillance : RABOUTET Bernard en fonction le 18 Décembre 2007. Vice président du conseil de surveillance : MONNIER Joel en fonction le 18 Décembre 2007.
Commentaires : Modification de représentant.

06/03/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

6158 - 343 006 151 RCS Pontoise. RIBER. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Administration : Président du directoire : PICAULT Michel. Membre du directoire : CHAIX Catherine. Président du conseil de surveillance : SPITZ Erich. Membre du conseil de surveillance : BELIN Paul. Commissaire aux comptes suppléant : KUPERBERG Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : BOISSIERE EXPERTISE AUDIT. Membre du conseil de surveillance : LAVEDRINE Olivier. Membre du directoire : MARCHETTI Laurence. Commissaire aux comptes suppléant : PETRONI Raymond. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS& GUERARD. Membre du conseil de surveillance : RABOUTET Bernard en fonction le 18 Décembre 2007. Vice président du conseil de surveillance : MONNIER Joel en fonction le 18 Décembre 2007.
Commentaires : Modification de représentant.

13/09/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

8444 - 343 006 151. RCS Pontoise RIBER. Forme: Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse du siège social: 31 rue Casimir Perier 95873 Bezons Cedex. Comptes annuels, comptes consolidés et rapport de l'exercice cl os le: 31 décembre 2006.

21/03/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

3181 - RCS Pontoise B 343 006 151. RC 06-B 3124. RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Capital : 3 036 447,36 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

10/11/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1902 - RCS B 343 006 151. RC 06-B 3124. RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Capital : 3 035 523,20 euros. Adresse du siège social : 31 rue Casimir, 95873 Bezons Cedex. Administration : président du directoire : PICAULT (Michel). Membre du directoire : CHAIX (Catherine). Président du conseil de surveillance : SPITZ (Erich). Vice-président du conseil de surveillance : SMIT (Gjalt). Membre du conseil de surveillance : BELIN (Paul). Commissaire aux comptes suppléant : KUPERBERG (Pierre). Commissaire aux comptes titulaire : BOISSIERE EXPERTISE AUDIT. Membre du conseil de surveillance : LAVEDRINE (Olivier). Membre du directoire : MARCHETTI (Laurence) (Nom d'usage : MASSACCI). Commissaire aux comptes suppléant : PETRONI (Raymond). Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD. Etablissement principal - Activité : études, production, vente de systèmes et de composants fonctionnant sous ultra-vide. Adresse : 31 rue Casimir, 95873 Bezons Cedex. Commentaires : cette société transfère son siège du 133 boulevard National, 92500 Rueil-Maison. Modification survenue sur l'activité. Date d'effet : 1er août 2006.

21/10/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

6735 - RCS Nanterre B 343 006 151. RC 92-B 2490. RIBER. Forme: société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse du siège social: 133, boulevard National,92500 Rueil-Malmaison. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

21/10/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

6736 - RCS Nanterre B 343 006 151. RC 92-B 2490. RIBER. Forme: société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse du siège social: 133, boulevard National,92500 Rueil-Malmaison. Comptes consolidés et rapport de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

05/10/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1962 - RCS Nanterre B 343 006 151. RC 92-B 2490. RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : commissaire aux comptes suppléant partant : JOUAN (Michel). Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : PETRONI (Raymond). Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD.

20/08/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2399 - RCS Nanterre B 343 006 151. RC 92-B 2490. RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : membre du conseil de surveillance partant : AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE, représentée par JERPHAGNON (François).

20/08/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2400 - RCS Nanterre B 343 006 151. RC 92-B 2490. RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : membre du conseil de surveillance partant : IDI, représentée par CHARRIN (Paul).

25/08/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

497 - RCS Nanterre B 343 006 151. RC 92-B 2490. RIBER. Forme: société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse du siège social: 133, boulevard National,92500 Rueil-Malmaison. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

25/08/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

498 - RCS Nanterre B 343 006 151. RC 92-B 2490. RIBER. Forme: société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse du siège social: 133, boulevard National,92500 Rueil-Malmaison. Comptes consolidés et rapport de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

30/04/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 343006151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : nomination d'un membre du directoire : MARCHETTI (Laurence) ( Nom d'usage : MASSACCI).

17/03/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 343006151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : membre du directoire partant : GOBEAU (Agnès).

19/12/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 343006151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Capital : 3 035 523,20 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration. Administration : modification du président du directoire PICAULT (Michel).

05/11/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 343006151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : commissaire aux comptes titulaire partant : BEFEC-PRICE WATERHOUSE. Vice- président et membre du conseil de surveillance partant : BAUDRON (Michel). Modification d'un vice-président et membre du conseil de surveillance : SMIT (Gjalt). Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT.

08/04/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 343006151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Capital : 3 022 252,80 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

08/04/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 343006151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : nomination d'un membre du conseil de surveillance : AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE, représentée par JERPHAGNON (François).

24/12/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 343006151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Capital : 3 012 249,60 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

24/12/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 343006151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : membres du conseil de surveillance partants : HAYAT (Gilbert) S.I. FINANCE, représentée par SAADA (Corinne) BAMAS (Patrick). Membre du directoire partant LEVY (Mickael, Francis).

11/07/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 343006151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Capital : 3 011 870,40 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

11/07/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 343006151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : modification d'un membre du conseil de surveillance : S.I. FINANCE, représentée par SAADA (Corinne).

27/01/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 343006151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : membre du directoire partant : LAVEDRINE ( Olivier). Nomination d'un membre du directoire : GOBEAU (Agnès). Nomination d'un membre du conseil de surveillance : LAVREDINE (Olivier). Modification d'un membre du conseil de surveillance : S.I. FINANCE.

16/12/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 343006151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Capital : 3 010 353,60 euros. Adresse du siège social : 133 boulevard National, 92500 Rueil- Malmaison. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

29/11/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 343006151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Capital : 2 995 348,80 euros. Adresse du siège social : 133 boulevard National, 92500 Rueil- Malmaison. Administration : nomination d' un membre du directoire : LAVE (Drine, Olivier). Nomination des membres du conseil de surveillance : SMIT (Gjalt) BELIN (Paul) IDI. Nomination du commissaire aux comptes titulaire : BOISSIERE EXPERTISE AUDIT. Nomination du commissaire aux comptes suppléant : KUPERBERG (Pierre). Commentaires : modification survenue sur le capital ( augmentation) et l'administration.

08/06/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

*. RCS Nanterre B 343 006 151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Capital : 2 400 000 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

08/06/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

*. RCS Nanterre B 343 006 151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : modification : vice-président et membre du conseil de surveillance : BAUDRON ( Michel).

16/12/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

*. RCS Nanterre B 343 006 151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : modification : président : PICAULT ( Michel) Nomination en qualité de membre du directoire : LEVY (Mickael, Francis).

01/12/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 343006151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : membre du conseil de surveillance partant : FINOVELEC.

09/04/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Nanterre B 343 006 151 RC RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Administration : suppression : membre du directoire : GUILLET (Benoit). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

06/01/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 343 006 151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire. Capital : 15 000 000 de F. Commentaires : modification survenue sur le capital ( diminution) et l'administration. Administration : nomination du président du conseil de surveillance : SPITZ ( Erich).

06/01/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 343 006 151 RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur la forme juridique et l'administration. Administration : président du conseil d' administration partant : BAUDRON ( Michel, Louis, Auguste). Nomination du président : PICAULT (Michel). Nomination des membres du directoire : GUILLET (Benoit) CHAIX (Catherine). Nomination des membres du conseil de surveillance : BAUDRON (Michel) HAYAT (Gilbert) SUEZ INDUSTRIE S.A. FINOVELEC. Administrateurs partants : CULLERON (Michel, Jean, Edmond) BELIN (Paul).

06/09/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Nanterre B 343 006 151 RC RC 92-B 2490 RIBER. Forme : S.A. Administration : président du conseil d' administration : BAUDRON (Michel, Louis, Auguste) Administrateurs : CULLERON (Michel, Jean, Edmond) BELIN (Paul). Commissaire aux comptes titulaire : BEFEC-BRICE WATERHOUSE. Commissaire aux comptes suppléant : JOUAN (Michel). Commentaires : modification survenue sur l' administration.

 

Company events history

 

 

 

Date

Description

22/09/2012

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

29/08/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

21/08/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

04/05/2012

New shareholders detected

13/04/2012

Invalid balance sheet

06/04/2012

New shareholders detected

31/12/2011

New accounts available

02/09/2011

Update of participations in other companies

27/07/2011

Bodacc B: Various editing or changing

22/07/2011

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

21/07/2011

Minutes of general meeting of shareholders

21/07/2011

Appointment/resignation of company officers

21/07/2011

Invalid balance sheet

26/05/2011

Legal Gazette: Appointment of the social representative

12/11/2010

New shareholders detected

12/11/2010

New participations in other companies

30/08/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

13/08/2010

Bodacc B: Various editing or changing

05/08/2010

Bodacc B: Various editing or changing

27/07/2010

Appointment/resignation of company officers

27/07/2010

New chairman (CEO, CoB)

27/07/2010

Minutes of general meeting of shareholders

09/07/2010

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

27/05/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

17/02/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

26/01/2010

Bodacc B: Various editing or changing

13/01/2010

Minutes of general meeting of shareholders

13/01/2010

Capital increase

13/01/2010

Other modification of Establishment

13/01/2010

Updated articles of association

13/01/2010

Minutes of Board meeting

31/12/2009

New accounts available

04/11/2009

Other modification of Establishment

04/11/2009

Legal Gazette: Modification of the share capital

01/07/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

19/06/2009

Bodacc B: Various editing or changing

11/06/2009

Minutes of general meeting of shareholders

11/06/2009

Appointment/resignation of company officers

11/06/2009

Private document

11/06/2009

Changes to the Board of Directors

11/06/2009

New chairman (CEO, CoB)

26/03/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

19/03/2009

Bodacc B: Various editing or changing

25/02/2009

Capital increase

25/02/2009

Other modification of Establishment

25/02/2009

Minutes of general meeting of shareholders

25/02/2009

Updated articles of association

25/02/2009

Private document

31/12/2008

New accounts available

22/12/2008

Other modification of Establishment

17/06/2008

Nomination/démission des organes de gestion

17/06/2008

Appointment/resignation of company officers

17/06/2008

Private document

17/06/2008

Changes to the Board of Directors

17/06/2008

New chairman (CEO, CoB)

17/06/2008

Changement de Président (PDG, PCA)

17/06/2008

Minutes of general meeting of shareholders

17/06/2008

Minutes of Board meeting

17/06/2008

PV d'Assemblée

10/06/2008

New Bodacc B ads detected

10/06/2008

Bodacc B: Various editing or changing

29/05/2008

Updated articles of association

29/05/2008

PV d'Assemblée

29/05/2008

Private document

29/05/2008

Minutes of general meeting of shareholders

29/05/2008

Statuts mis à jour

29/05/2008

Capital increase

29/05/2008

Augmentation de Capital

06/03/2008

Bodacc B: Various editing or changing

06/03/2008

New Bodacc B ads detected

31/01/2008

Other modification of Establishment

31/12/2007

New accounts available

18/12/2007

Updated articles of association

18/12/2007

Statuts mis à jour

18/12/2007

Private document

18/12/2007

Nomination/démission des organes de gestion

18/12/2007

Appointment/resignation of company officers

18/12/2007

Minutes of general meeting of shareholders

18/12/2007

PV d'Assemblée

01/03/2007

Updated articles of association

01/03/2007

Private document

01/03/2007

Minutes of general meeting of shareholders

01/03/2007

Augmentation de Capital

01/03/2007

Statuts mis à jour

01/03/2007

PV d'Assemblée

01/03/2007

Capital increase

31/12/2006

New accounts available

25/10/2006

Private document

25/10/2006

Transfert du Siège hors du ressort du Tribunal de Commerce

25/10/2006

Updated articles of association

25/10/2006

Minutes of general meeting of shareholders

25/10/2006

PV d'Assemblée

25/10/2006

Immatriculation suite à transfert

25/10/2006

Registration after transfer

22/09/2006

New auditor

22/09/2006

Changement de Commissaire aux Comptes

22/09/2006

Minutes of general meeting of shareholders

22/09/2006

Appointment/resignation of company officers

22/09/2006

Private document

22/09/2006

PV d'Assemblée

31/08/2006

Private document

31/08/2006

PV d'Assemblée

31/08/2006

Minutes of general meeting of shareholders

31/08/2006

Statuts mis à jour

31/08/2006

Updated articles of association

24/07/2006

PV d'Assemblée

24/07/2006

Minutes of general meeting of shareholders

24/07/2006

Amendment

24/07/2006

Nomination/démission des organes de gestion

24/07/2006

Private document

24/07/2006

Modification du système d'administration des S.A.

31/12/2005

New accounts available

13/09/2005

Statuts mis à jour

13/09/2005

Updated articles of association

13/09/2005

Audit or Management Report

13/09/2005

Rapport des Commissaires ou du Gérant

13/09/2005

Capital reduction

13/09/2005

Réduction de Capital

13/09/2005

Acte sous seing privé

13/09/2005

Private document

13/09/2005

Minutes of general meeting of shareholders

13/09/2005

PV d'Assemblée

31/12/2004

New accounts available

01/12/2004

PV d'Assemblée

01/12/2004

Statuts mis à jour

01/12/2004

Updated articles of association

01/12/2004

Minutes of general meeting of shareholders

01/12/2004

Private document

01/12/2004

Acte sous seing privé

01/12/2004

Réduction de Capital

01/12/2004

Capital reduction

01/12/2004

Capital increase

01/12/2004

Augmentation de Capital

19/11/2004

Acte sous seing privé

19/11/2004

Private document

19/11/2004

Appointment/resignation of company officers

19/11/2004

Nomination/démission des organes de gestion

19/11/2004

PV d'Assemblée

19/11/2004

Minutes of general meeting of shareholders

15/04/2004

Acte sous seing privé

15/04/2004

PV d'Assemblée

15/04/2004

Nomination/démission des organes de gestion

15/03/2004

Acte modificatif

15/03/2004

Acte sous seing privé

15/03/2004

Nomination/démission des organes de gestion

03/03/2004

PV d'Assemblée

03/03/2004

Acte sous seing privé

03/03/2004

Nomination/démission des organes de gestion

31/12/2003

New accounts available

08/12/2003

PV d'Assemblée

08/12/2003

Statuts mis à jour

08/12/2003

Nomination/démission des organes de gestion

08/12/2003

Acte sous seing privé

08/12/2003

Augmentation de Capital

24/10/2003

Rapport des Commissaires ou du Gérant

24/10/2003

Acte sous seing privé

24/10/2003

PV d'Assemblée

24/10/2003

Nomination/démission des organes de gestion

27/03/2003

PV d'Assemblée

27/03/2003

Statuts mis à jour

27/03/2003

Nomination/démission des organes de gestion

27/03/2003

Augmentation de Capital

27/03/2003

Acte sous seing privé

11/12/2002

Augmentation de Capital

11/12/2002

Nomination/démission des organes de gestion

11/12/2002

Acte sous seing privé

11/12/2002

PV d'Assemblée

11/12/2002

Acte modificatif

11/12/2002

Statuts mis à jour

28/06/2002

Nomination/démission des organes de gestion

28/06/2002

Augmentation de Capital

28/06/2002

PV d'Assemblée

28/06/2002

Acte modificatif

28/06/2002

Acte sous seing privé

28/06/2002

Statuts mis à jour

04/12/2001

Statuts mis à jour

04/12/2001

Augmentation de Capital

04/12/2001

PV d'Assemblée

04/12/2001

Nomination/démission des organes de gestion

04/12/2001

Acte sous seing privé

14/11/2000

Augmentation de Capital

14/11/2000

Nomination/démission des organes de gestion

14/11/2000

Statuts mis à jour

14/11/2000

Acte sous seing privé

14/11/2000

Changement de Commissaire aux Comptes

14/11/2000

Modification du Conseil d'Administration

14/11/2000

PV d'Assemblée

23/05/2000

PV d'Assemblée

23/05/2000

Nomination/démission des organes de gestion

23/05/2000

Acte sous seing privé

23/05/2000

Augmentation de Capital

23/05/2000

Changement de Commissaire aux Comptes

23/05/2000

Statuts mis à jour

23/05/2000

Conversion du Capital Social en Euros

02/12/1999

Nomination/démission des organes de gestion

02/12/1999

PV d'Assemblée

02/12/1999

Acte sous seing privé

15/11/1999

PV d'Assemblée

15/11/1999

Nomination/démission des organes de gestion

15/11/1999

Acte sous seing privé

24/03/1999

PV d'Assemblée

24/03/1999

Statuts mis à jour

24/03/1999

Nomination/démission des organes de gestion

24/03/1999

Acte sous seing privé

24/03/1999

Acte modificatif

19/12/1997

PV d'Assemblée

19/12/1997

Nomination/démission des organes de gestion

19/12/1997

Reconstitution de l'Actif Net

19/12/1997

Changement de Président (PDG, PCA)

19/12/1997

Acte sous seing privé

19/12/1997

PV du Conseil d'Administration

19/12/1997

Statuts mis à jour

19/12/1997

Changement de Forme Juridique sans changement de catégorie

19/12/1997

Rapport des Commissaires ou du Gérant

19/12/1997

Augmentation de Capital

19/12/1997

Certificat de dépôt des fonds

19/12/1997

Réduction de Capital

26/12/1996

PV d'Assemblée

26/12/1996

Acte sous seing privé

26/12/1996

Continuation malgré perte supérieure à la moitié du capital

21/08/1995

PV du Conseil d'Administration

21/08/1995

PV d'Assemblée

21/08/1995

Acte modificatif

08/08/1994

Acte modificatif

08/08/1994

PV d'Assemblée

29/06/1993

Modification du Conseil d'Administration

29/06/1993

Acte modificatif

29/06/1993

Changement de Président (PDG, PCA)

29/06/1993

PV du Conseil d'Administration

29/06/1993

Nomination/démission des organes de gestion

05/03/1993

PV d'Assemblée

05/03/1993

Déclaration de conformité

05/03/1993

Changement de dénomination sociale

05/03/1993

Modification de l'objet social

05/03/1993

Augmentation de Capital

05/03/1993

Statuts mis à jour

24/12/1992

Acte modificatif

23/12/1992

Acte modificatif

23/12/1992

Rapport des Commissaires ou du Gérant

03/12/1992

PV d'Assemblée

03/12/1992

Continuation malgré perte supérieure à la moitié du capital

26/11/1992

Acte modificatif

26/11/1992

Requête et Ordonnance

26/05/1992

Déclaration de conformité

26/05/1992

PV d'Assemblée

26/05/1992

Statuts mis à jour

26/05/1992

PV du Conseil d'Administration

26/05/1992

Statuts

26/05/1992

Immatriculation suite à transfert

20/05/1992

Transfert du Siège hors du ressort du Tribunal de Commerce

20/05/1992

PV du Conseil d'Administration

20/05/1992

Acte modificatif

10/03/1992

PV du Conseil d'Administration

10/03/1992

Acte modificatif

 

 

 

Establishment events history

 

 

 

Date

Description

11/01/2013

Update of phone numbers

22/09/2012

Update Limit

22/09/2012

Update Rating

08/10/2011

Update Limit

03/09/2011

Update Rating

13/08/2010

Update Limit

13/08/2010

Update Rating

04/01/2010

Update Rating

29/12/2009

Update Rating

02/07/2009

Update Limit

19/03/2009

Update Limit

19/03/2009

Update Rating

25/02/2009

Modification of Head office

01/10/2008

Update Limit

03/09/2008

Update Rating

31/01/2008

Modification of Head office

16/12/2007

Update Limit

08/12/2007

Update Limit

13/06/2007

Update of phone numbers

01/08/2006

Formation of Establishment (after transfer)

 

 

directors

 

 

 

Name

M. GOUTARD FRÉDÉRICK NOËL

 

Manager position

Président du directoire

Date of birth

25/07/1968

 

Place of birth

PARIS

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. NOELS JACQUES

 

Manager position

Président du conseil de surveillance

Date of birth

19/11/1940

 

Place of birth

ORAN(ALGERIE)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Directors

 

 

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

 

Président du directoire

M FREDERICK GOUTARD

- - -

 

Président du directoire

M FREDERICK GOUTARD

25/07/1968 - PARIS 16

 

Président du directoire

M FRÉDÉRICK NOËL GOUTARD

25/07/1968 - PARIS

 

Président du directoire

M MICHEL PICAULT

08/02/1954 - PARIS 15

 

Président du directoire

M JEAN-PIERRE REGNER

27/02/1949 - RABAT

 

Président du directoire

M JEAN REGNER

27/02/1949 - RABAT

 

Président du conseil de surveillance

M NOEL GOUTARD

22/12/1931 - CASABLANCA(MAROC)

 

Président du conseil de surveillance

M NOEL GOUTARD

22/12/1931 - MAROC

 

Président du conseil de surveillance

M JACQUES NOELS

19/11/1940 - ORAN(ALGERIE)

 

Président du conseil de surveillance

M ERICH SPITZ

27/03/1931 - BRNO TCHECOSLOVAQUIE

 

 

 

 

 

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

Bottom of Form

 

 

 

 

 

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.53.29

UK Pound

1

Rs.83.96

Euro

1

Rs.71.88

 

INFORMATION DETAILS

 

Report Prepared by :

SDA

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

----

NB

New Business

----

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.