MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

04.03.2013

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

ARKEMA FRANCE

 

 

Registered Office :

420 Rue Estienne D Orves 92700 Colombes

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2011

 

 

Date of Incorporation :

February 1957

 

 

Com. Reg. No.:

RCS Nanterre 8 319 632 790

 

 

Legal Form :

Public limited company with board of directors

 

 

Line of Business :

Manufacture of other organic basic chemicals

 

 

No. of Employees :

5 000+ employees

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

B

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

Small

 

Status :

Moderate

Payment Behaviour :

No Complaints

Litigation :

Clear

 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail: infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – June 30th, 2012

 

Country Name

Previous Rating

(31.03.2011)

Current Rating

(30.06.2012)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 

 

FRANCE - ECONOMIC OVERVIEW

 

France was transitioning from an economy that has featured extensive government ownership and intervention to one that relies more on market mechanisms but is in the midst of a euro-zone crisis. The government has partially or fully privatized many large companies, banks, and insurers, and has ceded stakes in such leading firms as Air France, France Telecom, Renault, and Thales. It maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With at least 75 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that reduce income disparity and the impact of free markets on public health and welfare. France's real GDP contracted 2.6% in 2009, but recovered somewhat in 2010 and 2011. The unemployment rate increased from 7.4% in 2008 to 9.3% in 2010 and 9.1% in 2011. Lower-than-expected growth and increased unemployment have cut government revenues and increased borrowing costs, contributing to a deterioration of France's public finances. The government budget deficit rose sharply from 3.4% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 5.8% of GDP in 2011, while France's public debt rose from 68% of GDP to 86% over the same period. Under President SARKOZY, Paris implemented austerity measures that eliminated tax credits and froze most government spending in an effort to bring the budget deficit under the 3% euro-zone ceiling by 2013 and to highlight France's commitment to fiscal discipline at a time of intense financial market scrutiny of euro-zone debt levels. Socialist Francois HOLLANDE won the May 2012 presidential election, after advocating pro-growth economic policies, as well as measures such as forcing banks to separate their traditional deposit taking and lending activities from more speculative businesses, increasing taxes on bank profits, introducing a new top bracket on income taxes for people earning over €1 million ($1.3 million) a year, and hiring an additional 60,000 civil servants during his five-year term of office.

Source : CIA


REGISTERED NAME & COMPANY SUMMARY

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

ARKEMA FRANCE

SIRET

319 632 790 00857

 

Personal comment

Company details

 

 

 

 

Activity (APE)

Manufacture of other organic basic chemicals (2014Z)

 

RCS Registration

RCS Nanterre 8 319 632 790

Share capital

270,035,923 Euros

 

Registration Court

Nanterre (92)

Legal form

Public limited company with board of directors

 

Court Registry Number

19 8 1B003

EUR VAT Number

FR32319632790help1

 

Incorporation Date

02/1957

Formation Date

01/1980

 

Deregistration Date

 

Last account Date

31/12/2011

 

Nationality

France

 

 

 

 

DIRECTORS/MANAGEMENT

 

directors

 

 

 

Name

M. LE HENAFF THIERRY

 

Manager position

Président du conseil d'administration, Administrateur

Date of birth

04/05/1963

 

Place of birth

SAVIGNY SUR ORGE

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. DELABORDE MICHEL

 

Manager position

Directeur général, Administrateur

Date of birth

14/08/1956

 

Place of birth

SENLIS

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. LEMONNIER THIERRY

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

06/11/1953

 

Place of birth

MONTREUIL

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. SCHULLER MARC

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

11/12/1960

 

Place of birth

METZ

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. CHANOINE PIERRE

 

Manager position

Administrateur

Date of birth

10/05/1949

 

Place of birth

WORMS(ALLEMAGNE)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Directors

 

 

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

 

Président du conseil d'administration

M THIERRY LE HENAFF

04/05/1963 - SAVIGNY SUR ORGE

 

Directeur général

M MICHEL DELABORDE

14/08/1956 - SENLIS

 

Administrateur

M PIERRE CHANOINE

10/05/1949 - WORMS ALLEMAGNE

 

Administrateur

M PIERRE CHANOINE

10/05/1949 - WORMS(ALLEMAGNE)

 

Administrateur

M MICHEL DELABORDE

14/08/1956 - SENLIS

 

Administrateur

M THIERRY LE HENAFF

04/05/1963 - SAVIGNY SUR ORGE

 

Administrateur

M THIERRY LEMONNIER

06/11/1953 - MONTREUIL

 

Administrateur

M MARC SCHULLER

11/12/1960 - METZ

 

Administrateur

M OTTO TAKKEN

- - -

 

Administrateur

M OTTO TAKKEN

30/04/1951 - VEENENDAAL(PAYS-BAS)

 

Administrateur

M OTTO TAKKEN

30/04/1951 - VEENENDAAL PAYS BAS

 

Administrateur

M OTTO TAKKEN

30/04/1951 - VEENENDAAL(PAYS-BAS)

 

Administrateur

M MARC SCHULLER

11/12/1960 - METZ

 

 

 

NEGATIVE INFORMATION

 

judgements

Collective procedures

 

 

No judgment information for the company

 

 

 

 

 

 

Social security, pension funds preferential rights | Tax office preferential rights

Preferential rights details and history

Summary of preferential rights

Company monitored since

14/09/2007

 

 

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

Tax office preferential rights

Number of active preferential rights

0

Total amount

-

Due remaining amount

-

Date of last preferential right

-

 

Historical Data

Registration number

Registration date

Date of the planned end

Creditor

Amount of the debt

Due remaining amount

button_minusbutton_plus

41100541

25/05/2011

19/07/2011

DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

432 238 EUR

-

Reason for closure

Crossed Off

Court

Nanterre

Creditor

DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
8 RUE COURTOIS 93505, PANTIN CEDEX

Debtor

ARKEMA FRANCE
420 RUE Estienne d Orves 92700 COLOMBES, FR

button_minusbutton_plus

41300089

29/01/2013

11/02/2013

SERVICE DES IMPOTS DE PANTIN

908 213 EUR

-

Reason for closure

Crossed Off

Court

Nanterre

Creditor

SERVICE DES IMPOTS DE PANTIN
8 RUE COURTOIS 93505, PANTIN CEDEX

Debtor

ARKEMA FRANCE
420 RUE Estienne d Orves 92700 COLOMBES, FR

 

SHARE & SHARE CAPITAL INFORMATION

 

N/a

 

PAYMENT INFORMATION

 

Payment Information Summary - Trade Payment Data

 

Payment Information Summary - Trade Payment Data

 

Total number of Invoices available

18

 

Total number of Invoices paid within or up to 30 days after the due date

9

 

Total number of Invoices paid more than 30 days after the due date

0

 

Total number of Invoices currently outstanding where the due date has not yet been reached

1

 

Total number of Invoices currently outstanding beyond the due date

8

 

 

GROUP STRUCTURE & AFFILIATED COMPANIES

 

 

Ultimate Parent

1 ultimate parent company for this company
> ARKEMA - Activités des sociétés holding (6420Z) in COLOMBES (92700)

Group data

 

Ultimate parent company

ARKEMA

Direct parent

ARKEMA - 99.99 %

Group – Number of companies

123

Linkages – Number of companies

18

Number of countries

7

Go directly to the current company

Display only where participation % > 33 %

Display all participations

This company is a part of several groups, choose the group you wish to see the structure

Display the group

ARKEMA

preloader1loading data...

Company Name

 

SIREN

Parts

Last account published

tminusARKEMA

 

445074685

-

31/12/2010

TARKEMA EUROPE HOLDINGS B.V.

 

24326561

100%

31/12/2007

tminusARKEMA AMERIQUES SAS

 

451658470

99.46%

31/12/2011

TARKEMA CANADA INC.

 

-

40.80%

-

tminusARKEMA DELAWARE INC.

 

-

100%

-

tminusARKEMA INC

 

US07278639

100%

-

LAMERICAN ACRYL LP

 

US22286357

50%

-

tminusARKEMA ASIE SAS

 

418681029

59.40%

31/12/2011

tminusARKEMA K.K.

 

-

100%

-

TAKISHIMA CHEMICAL INDUSTRIES CO LTD

 

-

100%

-

TARKEMA YOSHITOMI LTD

 

-

49%

-

LSARTOMER JAPAN INC

 

-

100%

-

tminusARKEMA CHINA INVESTMENT CO LTD

 

-

100%

-

TARKEMA HYDROGEN PEROXIDE CO., LTD. SHANG...

 

-

66.67%

-

TARKEMA CHANGSHU FLUOROCHEMICAL CO., LTD

 

-

54.64%

-

TARKEMA BEIJING CHEMICALS CO LTD

 

-

100%

-

TCHANGSHU HAIKE CHEMICALS CO LTD

 

-

49%

-

TARKEMA CHANGSHU CHEMICALS CO LTD

 

-

100%

-

TARKEMA SHANGHAI DISTRIBUTION CO. LTD

 

-

100%

-

TSHANGHAI ARKEMA GAOYUAN CHEMICALS CO LTD

 

-

93.40%

-

LCHANGSHU RESICHINA ENGINEERING POLYMERS ...

 

-

100%

-

TARKEMA CHANGSHU FLUOROCHEMICAL CO., LTD

 

-

45.36%

-

TDAIKIN ARKEMA REFRIGERANTS ASIA LLD

 

-

40%

-

LARKEMA DAIKIN ADVANCED FLUOROCHEMICALS C...

 

-

50%

-

tminusARKEMA EUROPE

 

429608342

34.32%

31/12/2010

tminusARKEMA B.V.

 

24270059

100%

31/12/2011

LARKEMA HOLLAND HOLDING B.V.

 

33220762

100%

31/12/2007

TARKEMA GMBH

 

HRB 29373

80%

31/12/2011

TARKEMA LTD (UK)

 

-

100%

-

tminusARKEMA QUIMICA

 

117595

99.92%

31/12/2011

LPLASGOM

 

448413

99.92%

31/12/2010

TARKEMA SRL

 

-

100%

-

LALPHACAN DOO

 

-

100%

-

TARKEMA FINANCE NEDERLAND B.V.

 

27157026

100%

31/12/2007

tminusARKEMA FRANCE

 

319632790

99.99%

31/12/2011

TARKEMA VLISSINGEN B.V.

 

22016916

100%

-

TARKEMA CANADA INC.

 

-

59.20%

-

TALTUMAX DEUTSCHLAND GMBH

 

HRB 7404

100%

-

TMAQUILADORA GENERAL DE MATAMOROS SA DE C...

 

-

100%

-

TARKEMA ROTTERDAM B.V.

 

24183071

100%

-

TARKEMA PEROXIDES INDIA PRIVATE LTD

 

-

100%

-

TVETEK SA

 

-

60%

-

TARKEMA RE

 

418755096

100%

31/12/2010

tminusSOCIETE COATEX

 

971509070

100%

31/12/2011

TCOATEX NETHERLANDS BV

 

-

100%

-

TCOATEX, INC

 

US07540391

100%

-

TCOATEX KOREA

 

-

100%

-

TCOATEX CENTRAL EASTERN EUROPE SRO

 

-

100%

-

TCOATEX ASIA PACIFIC INC

 

-

100%

-

TCOATEX LATIN AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...

 

-

100%

-

LCHANGSHU COATEX ADDITIVES CO. LTD

 

-

100%

-

TALTUGLAS INTERNATIONAL LIMITED

 

-

100%

-

TALTUGLAS INTERNATIONAL SPA

 

-

100%

-

tminusARKEMA ASIE SAS

 

418681029

40.60%

31/12/2011

tminusARKEMA K.K.

 

-

100%

-

TAKISHIMA CHEMICAL INDUSTRIES CO LTD

 

-

100%

-

TARKEMA YOSHITOMI LTD

 

-

49%

-

LSARTOMER JAPAN INC

 

-

100%

-

ARKEMA CHINA INVESTMENT CO LTD

 

-

100%

-

ARKEMA HYDROGEN PEROXIDE CO., LTD. SHANG...

 

-

66.67%

-

ARKEMA CHANGSHU FLUOROCHEMICAL CO., LTD

 

-

54.64%

-

ARKEMA BEIJING CHEMICALS CO LTD

 

-

100%

-

CHANGSHU HAIKE CHEMICALS CO LTD

 

-

49%

-

ARKEMA CHANGSHU CHEMICALS CO LTD

 

-

100%

-

ARKEMA SHANGHAI DISTRIBUTION CO. LTD

 

-

100%

-

TSHANGHAI ARKEMA GAOYUAN CHEMICALS CO LTD

 

-

93.40%

-

LCHANGSHU RESICHINA ENGINEERING POLYMERS ...

 

-

100%

-

TARKEMA CHANGSHU FLUOROCHEMICAL CO., LTD

 

-

45.36%

-

TDAIKIN ARKEMA REFRIGERANTS ASIA LLD

 

-

40%

-

LARKEMA DAIKIN ADVANCED FLUOROCHEMICALS C...

 

-

50%

-

TMLPC INTERNATIONAL

 

986120186

100%

31/12/2011

TARKEMA QUIMICA LDA

 

-

100%

-

TALTUGLAS INTERNATIONAL SAS

 

388432171

100%

31/12/2010

TARKEMA INICIADORES SA DE CV

 

-

100%

-

tminusARKEMA EUROPE

 

429608342

65.68%

31/12/2010

tminusARKEMA B.V.

 

24270059

100%

31/12/2011

LARKEMA HOLLAND HOLDING B.V.

 

33220762

100%

31/12/2007

TARKEMA GMBH

 

HRB 29373

80%

31/12/2011

TARKEMA LTD (UK)

 

-

100%

-

tminusARKEMA QUIMICA

 

117595

99.92%

31/12/2011

LPLASGOM

 

448413

99.92%

31/12/2010

TARKEMA SRL

 

-

100%

-

LALPHACAN DOO

 

-

100%

-

TARKEMA LTD

 

-

100%

-

TSCI AGRICOLE PARAPON

 

428343826

100%

-

TARKEMA

 

-

100%

-

TRESINOPLAST

 

662037704

100%

31/12/2011

TOXOCHIMIE

 

662048883

50%

31/12/2011

tminusALPHACAN

 

309745891

100%

31/12/2011

TALPHACAN S.P.A.

 

-

100%

-

TALPHACAN B.V.

 

16028740

100%

31/12/2006

LALPHACAN ESPANA TRANSFORMADOS SAU

 

-

99.92%

-

TSOC ETUDE REALISAT FINANCIERES

 

712057165

100%

31/12/2011

TSOCIETE DES FLUIDES DIELECTRIQUES

 

552149353

50%

31/12/2011

TARKEMA QUIMICA LTDA

 

-

100%

-

tminusCECA SA

 

775728025

100%

31/12/2011

TFEBEX SA

 

9865

96.77%

-

TIRISH CECA LIMITED

 

IE021629

100%

31/12/2005

TCECA ITALIANA SRL

 

-

100%

-

LWINKELMANN MINERARIA

 

-

100%

-

TARKEMA PTY LTD

 

-

100%

-

TSUNCLEAR

 

330338013

100%

31/12/2011

TARKEMA COMPANY LTD

 

-

100%

-

TSEKI ARKEMA

 

-

51%

-

TARKEMA CATALYST INDIA LTD

 

-

100%

-

TARKEMA ENERGIE

 

493446603

100%

31/12/2011

TARKEMA AFRIQUE

 

493446645

100%

31/12/2010

LPIEZOTECH S.A.

 

391321122

99%

31/12/2011

TALTUGLAS INTL MEXICO INC

 

US25211960

100%

-

TAMERICAN ACRYL NA LLC

 

-

50%

-

TARKEMA GUANGZHOU CHEMICALS LTD

 

-

100%

-

TARKEMA HOLDINGS LTD.

 

01470171

100%

31/12/2009

TARKEMA PTE LTD

 

-

100%

-

TARKEMA RE LTD

 

-

100%

-

TARKEMA SP ZOO

 

-

100%

-

TDELAWARE CHEMICALS CORPORATION

 

-

100%

-

TLUPEROX INICIADORES SA DE CV

 

-

100%

-

TMICHELET FINANCE INC

 

-

100%

-

TOZARK MAHONING

 

US15529126

100%

-

TPLASTICOS ALTUMAX SA

 

-

99.92%

-

TRESIL BELGIUM NV

 

877366285

100%

31/12/2011

TRESILIA SRL

 

-

100%

-

TSTANNICA LLC

 

-

40%

-

TTURKISH PRODUCTS INC

 

-

100%

-

TVIKING CHEMICAL COMPANY

 

-

100%

-

TFOSFANIL SA

 

-

96.58%

-

TALTUGLAS POLIVAR SPA

 

-

100%

-

TALTUGLAS INTERNATIONAL SRL

 

-

100%

-

TALTUGLAS INTERNATIONAL DENMARK AS

 

-

100%

-

TARKEMA MAGYARORSZAG KFT

 

-

100%

-

TARKEMA PENSION FUND TRUSTEE COMPANY ...

 

02422536

100%

31/12/2007

TARKEMA SDN BHD

 

-

100%

-

TARKEMA A/S

 

-

100%

-

TOXFORD PERFORMANCE MATERIALS INC

 

-

84.50%

-

TARKEMA GAS ODORANTS LLC

 

-

100%

-

TARKEMA MEXICO S.A DE C.V

 

-

100%

-

TRESINOPLAST NORTH AMERICA SRL DE CV

 

-

100%

-

TODOR-TECH LLC

 

-

100%

-

TARKEMA SRO

 

-

100%

-

TARKEMA VE KIMYA SANAYI VE TICARET

 

-

100%

-

TATOFINA ARGENTINA S.A.

 

-

100%

-

TSUNCLEAR

 

256696

100%

31/12/2010

TSUNCLEAR SRL

 

-

100%

-

TARKEMA INTERNATIONAL SA

 

5079041

100%

-

TARKEMA COATINGS RESINS SRL

 

-

100%

-

THIPRO POLYMERS

 

-

Majority

-

LCASDA BIOMATERIALS

 

-

Majority

-

 

 

 

Linkages

Ultimate parent company

ARKEMA

Direct parent

ARKEMA - 99.99 %

Group – Number of companies

123

Linkages – Number of companies

18

Number of countries

7

Company Name

 

SIREN

Last account

Turnover

ARKEMA RE LIMITED

 

IE420011

31/12/2011

5 125 846 €

ARKEMA COATINGS RESINS LIMITED

 

07609424

31/12/2011

20 448 000 £

ALTUGLAS INTERNATIONAL LIMITED

 

02670507

31/12/2011

204 773 £

ARKEMA LTD.

 

00868680

31/12/2011

4 434 598 £

ARKEMA COATINGS RESINS B.V.

 

08102050

31/12/2010

-

ARKEMA S.A.

 

09973677

-

-

ALPHACAN OMNIPLAST GMBH

 

HRB 1182

-

-

ALPHACAN OMNIPLAST GMBH

 

HRB 6311

-

-

RESITECH GERMANY GMBH

 

HRB 28106

-

-

ARKEMA GMBH, NIEDERLASSUNG KIRCHHEIMBOLA...

 

HRB 11862

-

-

ARKEMA CHEMICALS INC

 

US01411268

-

0 $

ARKEMA RESEARCH CENTER

 

US31508436

-

0 $

ALTUGLAS INTERNATIONAL

 

US45891971

-

3 756 000 $

ARKEMA INC

 

US46440756

-

0 $

ARKEMA EUROPE SA

 

-

-

-

ARKEMA FRANCE

 

-

-

-

ARKEMA SA

 

-

-

-

MIMOSA SAS

 

-

-

-

 

FINANCIAL INFORMATION

 

accounts

Active Account | Passive Account | Account Results

 

Synthesized Accounts

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

Comparison mode

Average

Median

 

 

Annual Accounts

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

 

Account period (month)

12

 

12

 

12

 

 

Account Type

Normal

 

Normal

 

Normal

 

 

Deposit date

05/10/2012

 

06/07/2011

 

22/07/2010

 

 

Activity Code

2014Z

 

2014Z

 

2014Z

 

 

Employees

0

 

0

 

6357

 

 


Active account

Annual Accounts

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Sector Median 2011

 

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

2 333 200 000

9,0%

2 140 700 000

24,1%

1 725 100 000

652 958

357227,7%

- Intangible assets

113 800 000

261,3%

31 500 000

14,1%

27 600 000

12 195

933069,3%

- Tangible assets

717 800 000

6,8%

672 100 000

4,1%

645 700 000

361 112

198674,9%

- Financial assets

1 526 700 000

6,2%

1 437 100 000

36,6%

1 051 800 000

5 077

30070808,0%

Net current assets

1 539 600 000

-3,7%

1 599 100 000

30,3%

1 227 000 000

1 748 000

87977,8%

- Stocks

454 200 000

29,0%

352 200 000

9,0%

323 200 000

276 227

164330,0%

- Advanced payments

61 100 000

-3,7%

67 600 000

-8,3%

73 700 000

0

0%

- Receivables

926 900 000

30,3%

711 600 000

-13,0%

818 200 000

948 848

97586,9%

- Securities and cash

97 400 000

-79,2%

467 800 000

3831,1%

11 900 000

116 260

83677,7%

- Prepaid expenses

-

-

-

-

-

573

-

Accounts of regularization

26 400 000

-37,7%

42 400 000

223,7%

13 100 000

0

0%

Total Assets

3 899 500 000

3,1%

3 782 300 000

27,6%

2 964 900 000

3 419 727

113929,6%


Passive Account

Annual Accounts

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Sector Median 2011

 

Shareholders' equity

57 600 000

-84,5%

370 700 000

116,7%

171 100 000

868 357

6533,2%

Share capital

274 800 000

0%

274 800 000

300%

68 700 000

200 000

137300%

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

873 200 000

69,8%

514 400 000

11,0%

463 400 000

3 631

24048371,5%

Liabilities

2 956 900 000

2,2%

2 893 100 000

24,6%

2 321 100 000

996 170

296726,8%

- Financial liabilities

2 117 400 000

0,2%

2 113 800 000

31,0%

1 613 900 000

133 261

1588812,0%

- Advanced payments received

5 000 000

16,3%

4 300 000

-8,5%

4 700 000

0

0%

- Trade account payables

501 900 000

11,7%

449 500 000

15,7%

388 500 000

371 647

134947,5%

- Tax and social liabilities

207 500 000

1,0%

205 400 000

-17,8%

249 900 000

195 196

106203,4%

- Other debts and fixed assets liabilities

135 100 000

12,3%

120 300 000

68,3%

71 500 000

34 607

390283,4%

Account regularization

1 900 000

-50,0%

3 800 000

90,0%

2 000 000

0

0%

Total liabilities

3 899 500 000

3,1%

3 782 300 000

27,6%

2 964 900 000

3 419 727

113929,6%


Results

Annual Accounts

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Sector Median 2011

 

Sales of Goods

4 022 100 000

20,1%

3 347 600 000

26,7%

2 642 700 000

2 801 009

143494,7%

Net turnover

3 683 100 000

18,4%

3 112 000 000

24,8%

2 493 800 000

2 227 087

165277,5%

- of which net export turnover

0

0%

0

0%

0

0

0%

Operating charges

4 002 300 000

17,4%

3 408 300 000

17,3%

2 904 400 000

2 875 742

139074,5%

Operating profit/loss

19 800 000

132,6%

-60 700 000

76,8%

-261 700 000

41 668

47418,5%

Financial income

122 000 000

-1,4%

123 700 000

-28,3%

172 500 000

7 909

1542446,5%

Financial charges

95 900 000

8,2%

88 600 000

-34,8%

135 900 000

15 690

611117,3%

Financial profit/loss

26 100 000

-25,6%

35 100 000

-4,1%

36 600 000

-748

3489404,8%

Pretax net operating income

45 900 000

279,3%

-25 600 000

88,6%

-225 100 000

37 573

122062,2%

Extraordinary income

119 900 000

32,6%

90 400 000

-87,6%

729 200 000

9 000

1332122,2%

Extraordinary charges

501 900 000

509,8%

82 300 000

-89,3%

767 500 000

6 968

7202827,7%

Extraordinary profit/loss

-382 000 000

-4816,0%

8 100 000

121,1%

-38 300 000

0

0%

Net result

-318 300 000

-45371,4%

-700 000

99,7%

-244 500 000

42 066

-756768,1%



 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

 

Normal Account

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Months

 

12

 

12

 

12


Accounts - Active
Current Assets | Equalization accounts | Reference

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Grand Total (I to VI)

Net

3 899 500 000

3,1%

3 782 300 000

27,6%

2 964 900 000

 

Gross

CO

7 122 400 000

2,4%

6 954 600 000

15,0%

6 047 300 000

 

Amortisation

1A

3 222 900 000

1,6%

3 172 300 000

2,9%

3 082 400 000


Non declared distributed capital (I)

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AA

0

0%

0

0%

0


Active fixed asset (II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Total Active fixed asset (II)

Net

2 333 200 000

9,0%

2 140 700 000

24,1%

1 725 100 000

 

Gross

BJ

5 478 000 000

4,0%

5 266 800 000

10,7%

4 758 000 000

 

Amortisation

BK

3 144 800 000

0,6%

3 126 100 000

3,1%

3 032 900 000


Intangilble fixed assets

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

R & D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AE

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Distributorships, patents

Net

30 800 000

0%

0

0%

0

 

Gross

AF

242 400 000

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AG

211 600 000

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Goodwill

Net

28 600 000

0%

0

0%

0

 

Gross

AH

28 600 000

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AI

25 100 000

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Other intangible fixed assets

Net

54 400 000

72,7%

31 500 000

14,1%

27 600 000

 

Gross

AJ

54 900 000

-79,1%

263 100 000

4,3%

252 300 000

 

Amortisation

AK

500 000

-99,8%

231 600 000

3,1%

224 700 000

button_minusbutton_plus

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible Assets

Net

113 800 000

261,3%

31 500 000

14,1%

27 600 000



Tangilble fixed assets

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Lands

Net

30 300 000

0,7%

30 100 000

-3,2%

31 100 000

 

Gross

AN

45 200 000

0,2%

45 100 000

-0,4%

45 300 000

 

Amortisation

AO

14 900 000

-0,7%

15 000 000

5,6%

14 200 000

button_minusbutton_plus

Buildings

Net

98 400 000

9,5%

89 900 000

-2,4%

92 100 000

 

Gross

AP

625 800 000

0,3%

623 700 000

1,7%

613 100 000

 

Amortisation

AQ

527 400 000

-1,2%

533 800 000

2,5%

521 000 000

button_minusbutton_plus

Plant

Net

459 900 000

1,8%

451 600 000

-1,7%

459 400 000

 

Gross

AR

2 523 000 000

1,0%

2 497 900 000

2,6%

2 435 300 000

 

Amortisation

AS

2 063 100 000

0,8%

2 046 300 000

3,6%

1 975 900 000

button_minusbutton_plus

Other tangible fixed assets

Net

6 400 000

-9,9%

7 100 000

-20,2%

8 900 000

 

Gross

AT

55 700 000

2,4%

54 400 000

0,6%

54 100 000

 

Amortisation

AU

49 300 000

4,2%

47 300 000

4,6%

45 200 000

button_minusbutton_plus

Fixed assets in construction

Net

122 800 000

31,5%

93 400 000

72,3%

54 200 000

 

Gross

AV

123 800 000

32,1%

93 700 000

72,6%

54 300 000

 

Amortisation

AW

1 000 000

233,3%

300 000

200%

100 000

button_minusbutton_plus

Advances and payments on account

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AX

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Tangible asset

Net

717 800 000

 

672 100 000

 

645 700 000



Financial assets

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Other participations

Net

866 600 000

-2,6%

890 000 000

1,8%

874 500 000

 

Gross

CU

1 118 100 000

-2,0%

1 141 400 000

1,8%

1 121 700 000

 

Amortisation

CV

251 500 000

0,0%

251 400 000

1,7%

247 200 000

button_minusbutton_plus

Inter-company receivables

Net

498 800 000

62,2%

307 600 000

85,7%

165 600 000

 

Gross

BB

498 800 000

62,2%

307 600 000

85,7%

165 600 000

 

Amortisation

BC

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Loans

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BF

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BG

0

 

0

 

0

button_minusbutton_plus

Other financial assets

Net

161 300 000

-32,7%

239 500 000

1947,0%

11 700 000

 

Gross

BH

161 700 000

-32,6%

239 900 000

1371,8%

16 300 000

 

Amortisation

BI

400 000

0%

400 000

-91,3%

4 600 000

 

Sub Total Financial Assets

 

1 526 700 000

 

1 437 100 000

 

1 051 800 000



Current Assets (III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Total Assets

Net

1 539 600 000

-3,7%

1 599 100 000

30,3%

1 227 000 000

 

Gross

CJ

1 617 900 000

-1,7%

1 645 400 000

28,9%

1 276 400 000

 

Amortisation

CK

78 300 000

69,1%

46 300 000

-6,3%

49 400 000



Stocks

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Raw materials

Net

121 700 000

6,6%

114 200 000

-3,5%

118 400 000

 

Gross

BL

148 000 000

6,8%

138 600 000

-3,8%

144 100 000

 

Amortisation

BM

26 300 000

7,3%

24 500 000

-4,7%

25 700 000

button_minusbutton_plus

Work in progress (goods)

Net

22 500 000

0%

0

0%

0

 

Gross

BN

22 500 000

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Semi-finished and finished products

Net

310 000 000

30,3%

238 000 000

16,2%

204 800 000

 

Gross

BR

355 200 000

40,6%

252 600 000

15,7%

218 300 000

 

Amortisation

BS

45 200 000

209,6%

14 600 000

8,1%

13 500 000

button_minusbutton_plus

Goods for resale

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BT

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BU

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Stocks

Net

454 200 000

29,0%

352 200 000

9,0%

323 200 000



Advance payments to suppliers

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Advance payments to suppliers

Net

61 100 000

-9,6%

67 600 000

-8,3%

73 700 000

 

Gross

BV

61 100 000

-9,6%

67 600 000

-8,3%

73 700 000

 

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0



Debtors

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Trade accounts receivable

Net

511 800 000

10,0%

465 400 000

-0,4%

467 200 000

 

Gross

BX

517 700 000

9,8%

471 700 000

-1,0%

476 500 000

 

Amortisation

BY

5 900 000

-6,3%

6 300 000

-32,3%

9 300 000

button_minusbutton_plus

Other debtors

Net

413 200 000

69,0%

244 500 000

-30,0%

349 400 000

 

Gross

BZ

414 100 000

68,7%

245 400 000

-29,9%

350 300 000

 

Amortisation

CA

900 000

0%

900 000

0%

900 000

button_minusbutton_plus

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Debtors

Net

925 000 000

30,3%

709 900 000

-13,1%

816 600 000



Divers

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Investment securities

Net

88 700 000

-80,9%

464 000 000

0%

0

 

Gross

CD

88 700 000

-80,9%

464 000 000

0%

0

 

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Cash and cash equivalents

Net

8 700 000

128,9%

3 800 000

-68,1%

11 900 000

 

Gross

CF

8 700 000

128,9%

3 800 000

-68,1%

11 900 000

 

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Divers

Net

97 400 000

-79,2%

467 800 000

3831,1%

11 900 000



Prepaid expenses

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Prepaid expenses

Net

1 900 000

11,8%

1 700 000

6,2%

1 600 000

 

Gross

CH

1 900 000

11,8%

1 700 000

6,2%

1 600 000

 

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0



Equalization accounts (IV to VI)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Multi-period charges

CW3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

0%

0

 

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

0%

0

 

Currency differential gain

CN3

26 400 000

-37,7%

42 400 000

223,7%

13 100 000

 

Gross

 

26 400 000

-37,7%

42 400 000

223,7%

13 100 000



References

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

 

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Accounts - Passive
Other capital resources | Provisions for risks and charges | Liabilities | Translation loss | Equalization accounts | References

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Grand Total (I to V)

EE

3 899 500 000

3,1%

3 782 300 000

27,6%

2 964 900 000


Shareholder Equity (I)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Total shareholders' equity (Total I)

DL

57 600 000

-84,5%

370 700 000

116,7%

171 100 000

 

Equity and shareholders' equity

DA

274 800 000

0%

274 800 000

300%

68 700 000

 

Issue and merger premiums

DB

0

0%

0

0%

0

 

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

 

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

 

Legal reserve

DD

6 900 000

0%

6 900 000

0%

6 900 000

 

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

 

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

 

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

 

Other reserves

DG

0

0%

0

0%

0

 

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

 

0

0%

0

 

Profits or losses brought forward

DH

-85 600 000

-0,8%

-84 900 000

-153,2%

159 600 000

 

Profit or loss for the period

DI

-318 300 000

-45371,4%

-700 000

99,7%

-244 500 000

 

Investment grants

DJ

9 600 000

1820,0%

500 000

-28,6%

700 000

 

Special tax-allowable reserves

DK

170 200 000

-2,2%

174 100 000

-3,1%

179 700 000



Other capital resources (II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

 

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

 

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0



Provisions for risks and charges (III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

873 200 000

69,8%

514 400 000

11,0%

463 400 000

 

Risk provisions

DP

683 600 000

117,2%

314 700 000

15,2%

273 200 000

 

Reserves for charges

DQ

189 600 000

-5,1%

199 700 000

5,0%

190 100 000



Liabilities (IV)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Total Liabilities (Total IV)

EC

2 956 900 000

2,2%

2 893 100 000

24,6%

2 321 100 000

 

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

 

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

 

Bank loans and liabilities

DU

128 100 000

-6,7%

137 300 000

-56,8%

317 600 000

 

Sundry loans and financial liabilities

DV

1 989 300 000

0,6%

1 976 500 000

52,5%

1 296 300 000

 

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

 

Advance payments received for current orders

DW

5 000 000

16,3%

4 300 000

-8,5%

4 700 000

 

Trade accounts payables

DX

501 900 000

11,7%

449 500 000

15,7%

388 500 000

 

Tax and social security liabilities

DY

207 500 000

1,0%

205 400 000

-17,8%

249 900 000

 

Fixed asset liabilities

DZ

71 500 000

15,7%

61 800 000

124,7%

27 500 000

 

Other debts

EA

51 700 000

-5,1%

54 500 000

57,5%

34 600 000



Translation loss (V)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Translation loss (Total V)

ED

11 900 000

197,5%

4 000 000

-57,4%

9 400 000



Equalization accounts

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Deferred income

EB

1 900 000

-50,0%

3 800 000

90,0%

2 000 000



References

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

 

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

 

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Result account
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges | Financial income | Financial charges | Financial charges | Extraordinary charges | Employee profit sharing | Tax on profits | References

1- Operating result (I-II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Operating result (Total I-II)

GG

19 800 000

132,6%

-60 700 000

76,8%

-261 700 000


2 - Financial result (V - VI)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Financial result (Total V-VI)

GV

26 100 000

-25,6%

35 100 000

-4,1%

36 600 000


3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

45 900 000

279,3%

-25 600 000

88,6%

-225 100 000


4 - Extraordinary result (VII-VIII)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

-382 000 000

-4816,0%

8 100 000

121,1%

-38 300 000


Profit or loss

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Profit or loss

HN

-318 300 000

-45371,4%

-700 000

99,7%

-244 500 000


Total Income (I+III+V+VII)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Total Income (I+III+V+VII)

HL

4 264 000 000

19,7%

3 561 700 000

0,5%

3 544 300 000


Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

4 582 600 000

28,6%

3 562 400 000

-6,0%

3 788 800 000


Operating income (I)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Total operating income (Total I)

FR

4 022 100 000

20,1%

3 347 600 000

26,7%

2 642 700 000


Operating income (details)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Sale of goods for resale

FC

0

0%

0

0%

0

 

France

FA

0

0%

0

0%

0

 

Export

FB

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Sale of goods produced

FF

3 424 100 000

19,9%

2 855 700 000

26,4%

2 259 100 000

 

France

FD

3 424 100 000

19,9%

2 855 700 000

26,4%

2 259 100 000

 

Export

FE

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Sale of services

FI

259 000 000

1,1%

256 300 000

9,2%

234 700 000

 

France

FG

259 000 000

1,1%

256 300 000

9,2%

234 700 000

 

Export

FH

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Net turnover

FL

3 683 100 000

18,4%

3 112 000 000

24,8%

2 493 800 000

 

France

FJ

3 683 100 000

18,4%

3 112 000 000

24,8%

2 493 800 000

 

Export

FK

0

0%

0

0%

0

 

Stocked production

FM

125 000 000

264,4%

34 300 000

136,8%

-93 200 000

 

Self-constructed assets

FN

15 300 000

44,3%

10 600 000

2,9%

10 300 000

 

Operating grants

FO

8 600 000

50,9%

5 700 000

-8,1%

6 200 000

 

Release of reserves and provisions

FP

160 500 000

-2,3%

164 300 000

-21,1%

208 200 000

 

Other income

FQ

29 600 000

43,0%

20 700 000

20,3%

17 200 000


Operating charges (II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Total operating charges (Total II)

GF

4 002 300 000

17,4%

3 408 300 000

17,3%

2 904 400 000


Exploitation charges

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Purchase of goods for resale

FS

687 500 000

0%

0

0%

0

 

Change in stocks of goods for resale

FT

0

0%

0

0%

0

 

Purchase of raw materials

FU

1 692 500 000

-8,3%

1 845 900 000

33,9%

1 379 000 000

 

Change in stocks of raw materials

FV

-9 200 000

-270,4%

5 400 000

-86,2%

39 000 000

 

Other external purchases and charges

FW

818 200 000

4,0%

786 600 000

5,2%

747 500 000

 

Tax, duty and similar payments

FX

57 200 000

9,2%

52 400 000

-2,4%

53 700 000

 

Payroll

FY

299 200 000

0,7%

297 200 000

-0,4%

298 400 000

 

Social security costs

FZ

174 000 000

11,7%

155 800 000

3,5%

150 600 000


Depreciation

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Depreciation of fixed assets

GA

136 900 000

-0,4%

137 400 000

3,2%

133 100 000

 

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

0

 

Depreciation/amortisation of current assets

GC

81 800 000

88,0%

43 500 000

-17,5%

52 700 000

 

Provisions for risks and charges

GD

50 900 000

-31,1%

73 900 000

86,1%

39 700 000


Other charges

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Other charges

GE

13 300 000

30,4%

10 200 000

-5,6%

10 800 000



Operating charges (III-IV)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

 

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0



Financial income (V)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Total financial income (Total V)

GP

122 000 000

-1,4%

123 700 000

-28,3%

172 500 000

 

Share financial income

GJ

80 700 000

42,6%

56 600 000

-53,8%

122 400 000

 

Other investment income & capitalised receivables

GK

0

0%

0

0%

0

 

Other interest and similar income

GL

3 800 000

137,5%

1 600 000

-44,8%

2 900 000

 

Released provisions and transferred charges

GM

32 100 000

98,1%

16 200 000

-63,6%

44 500 000

 

Exchange gains

GN

2 100 000

-95,7%

49 000 000

1714,8%

2 700 000

 

Net income from disposal of investment securities

GO

3 300 000

1000%

300 000

0%

0



Financial Charge (VI)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Total financial charge (Total VI)

GU

95 900 000

8,2%

88 600 000

-34,8%

135 900 000

 

Financial reserves and provisions

GQ

30 600 000

-44,6%

55 200 000

-17,6%

67 000 000

 

Interest and similar charges

GR

44 700 000

111,8%

21 100 000

-22,7%

27 300 000

 

Exchange losses

GS

20 600 000

67,5%

12 300 000

0%

0

 

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

41 500 000



Extraordinary income (VII)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Total extraordinary income (Total VII)

HD

119 900 000

32,6%

90 400 000

-87,6%

729 200 000

 

Extraordinary operating income

HA

13 900 000

107,5%

6 700 000

235,0%

2 000 000

 

Extraordinary income from capital transactions

HB

69 400 000

308,2%

17 000 000

-97,3%

624 200 000

 

Released provisions and transferred charges

HC

36 600 000

-45,1%

66 700 000

-35,2%

103 000 000



Extraordinary charges (VIII)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

501 900 000

509,8%

82 300 000

-89,3%

767 500 000

 

Extraordinary operating charges

HE

4 700 000

-61,8%

12 300 000

-65,1%

35 200 000

 

Extraordinary charges from capital transactions

HF

33 200 000

260,9%

9 200 000

-98,5%

605 600 000

 

Extraordinary reserves and provisions

HG

464 000 000

663,2%

60 800 000

-52,0%

126 700 000



Employee profit sharing (IX)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

0

0%

0

0%

0



Tax on profits (X)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Tax on profits (Total X)

HK

-17 500 000

-4,2%

-16 800 000

11,6%

-19 000 000



References

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

 

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

 

Of which transferred charges

A1

0

0%

0

0%

0

 

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Other incomer tax return forms
Reserve for depreciation | Provisions included in balance sheet | State deadlines claims and debts at the end of period
Table allocation results and other information

Fixed Assets
Grand Total Fixed Assets (I to IV)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

OK2

337 100 000

20,1%

280 600 000

-65,0%

802 200 000

 

Gross value at the end of period

OL

5 478 100 000

4,0%

5 266 900 000

10,7%

4 758 000 000


Research and development Charge (Total I)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

C01

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

C02

0

0%

0

0%

0

 

Gross value at the end of period

D0

0

0%

0

0%

0


Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Gross value at begin of period

KD

263 100 000

4,3%

252 300 000

-0,6%

253 700 000

 

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

76 900 000

298,4%

19 300 000

46,2%

13 200 000

 

Decreasess by budget item transfer

LV1

-200 000

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

LV2

14 300 000

68,2%

8 500 000

-41,8%

14 600 000

 

Gross value at the end of period

LW

325 900 000

23,9%

263 100 000

4,3%

252 300 000


Tangible fixed assets (Total III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Gross value at begin of period

LN

3 314 900 000

3,5%

3 202 100 000

3,2%

3 103 800 000

 

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

214 700 000

-1,0%

216 800 000

86,3%

116 400 000

 

Decreasess by budget item transfer

NG1

200 000

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NG2

155 900 000

49,9%

104 000 000

474,6%

18 100 000

 

Gross value at the end of period

NH

3 373 500 000

1,8%

3 314 900 000

3,5%

3 202 100 000


Fiancial assets (Total IV)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Gross value at begin of period

LQ

1 688 900 000

29,6%

1 303 600 000

-34,7%

1 997 200 000

 

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

256 700 000

-53,6%

553 400 000

629,1%

75 900 000

 

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NJ2

166 900 000

-0,7%

168 100 000

-78,2%

769 500 000

 

Gross value at the end of period

NK

1 778 700 000

5,3%

1 688 900 000

29,6%

1 303 600 000



Reserve for depreciation
Situation and movement of reserve for depreciation
Grand total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Reserve for depreciation value at begin of period

0N

0

0%

0

0%

0

Increases

0P

0

0%

0

0%

0

Decreasess

0Q

0

0%

0

0%

0

 

Reserve for depreciation value at the end of period

0R

0

0%

0

0%

0


Research and development charge (Total I)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0


Other intangible assets (Total II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

206 700 000

3,5%

199 800 000

4,2%

191 700 000

Increases

PF

7 600 000

8,6%

7 000 000

-13,6%

8 100 000

Decreasess

PG

2 100 000

2000%

100 000

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PH

212 200 000

2,7%

206 700 000

3,5%

199 800 000


Total fixed assets amotisation (Total III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

2 579 600 000

5,0%

2 455 800 000

5,8%

2 321 500 000

Increases

QV

169 700 000

17,5%

144 400 000

-3,7%

149 900 000

Decreases

QW

154 500 000

650,0%

20 600 000

32,9%

15 500 000

 

Decreasess by budget item transfer

QX

2 594 800 000

0,6%

2 579 600 000

5,0%

2 455 800 000


Movements during period affecting charge allocated over several period
Charges à répartir ou frais d'émission d'emprunt

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0


Premium refund of obligations

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Net value at begining of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

 

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0



Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Value at begining of period

7C

1 074 800 000

0,4%

1 070 000 000

-4,6%

1 121 600 000

Increases

UB

637 100 000

178,0%

229 200 000

-12,3%

261 200 000

Decreases

UC

252 400 000

12,5%

224 400 000

-28,3%

312 800 000

 

Value at the end of period

UD

1 459 500 000

35,8%

1 074 800 000

0,4%

1 070 000 000

Includes Total allocations

 

Operating

UE

132 700 000

13,0%

117 400 000

27,1%

92 400 000

 

Financial

UG

30 600 000

-44,6%

55 200 000

-17,6%

67 000 000

 

Exceptional

UJ

462 300 000

756,1%

54 000 000

-47,0%

101 800 000

Includes Total Withdrawal

 

Operating

UF

158 700 000

14,3%

138 900 000

-22,4%

178 900 000

 

Financial

UH

32 100 000

98,1%

16 200 000

-63,6%

44 500 000

 

Exceptional

UK

36 600 000

-45,1%

66 700 000

-25,4%

89 400 000


Total regulated provisions (Total I)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Value at begining of period

3Z

174 100 000

-3,1%

179 700 000

-0,5%

180 600 000

Increases

TS

25 700 000

-10,5%

28 700 000

-21,4%

36 500 000

Decreases

TT

29 600 000

-13,7%

34 300 000

-8,3%

37 400 000

 

Value at the end of period

TU

170 200 000

-2,2%

174 100 000

-3,1%

179 700 000


Total risk and charge provisions (Total II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Value at begining of period

5Z

514 400 000

11,0%

463 400 000

-16,0%

551 700 000

Increases

TV

490 400 000

259,8%

136 300 000

47,0%

92 700 000

Decreases

TW

131 600 000

54,3%

85 300 000

-52,9%

181 000 000

 

Value at the end of period

TX

873 200 000

69,8%

514 400 000

11,0%

463 400 000


Total Provision for depreciation (Total III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Value at begining of period

7B

386 300 000

-9,5%

426 900 000

9,7%

389 300 000

Increases

TY

121 000 000

88,5%

64 200 000

-51,4%

132 000 000

Decreases

TZ

91 200 000

-13,0%

104 800 000

11,0%

94 400 000

 

Value at the end of period

UA

416 100 000

7,7%

386 300 000

-9,5%

426 900 000



State deadlines claims and debts at the end of period
State claims

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Gross value

VT

0

0%

1 266 300 000

25,1%

1 011 900 000

 

1 year at most

VU

0

0%

956 500 000

12,5%

850 200 000

 

More than one year

VV

0

0%

309 800 000

91,6%

161 700 000


State of loans

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Claims related to holdings (gross)

UL

0

0%

307 600 000

85,7%

165 600 000

 

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

0%

15 700 000

-20,3%

19 700 000

 

Loans (gross)

UP

0

0%

0

0%

0

 

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

0

0%

0

 

Other financial assets (gross)

UT

0

0%

239 900 000

1371,8%

16 300 000

 

Other financial assets (1 year at most)

UV

0

0%

222 000 000

44300%

500 000


Receivables statement of assets

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Customers doubtful or disputed

VA

0

0%

0

0%

0

 

Other claims customer

UX

0

0%

471 700 000

-1,0%

476 500 000

 

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

 

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

 

Personnel and associated accounts

UY

0

0%

0

0%

0

 

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

0

0%

0

 

Income taxes

VM

0

0%

0

0%

0

 

Value added tax

VB

0

0%

0

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

VN

0

0%

0

0%

0

 

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

0

0%

0

 

Group and Associates

VC

0

0%

0

0%

0

 

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

0

0%

247 100 000

-29,8%

351 900 000


Prepaid

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Prepaid

VS

0

0%

0

0%

1 600 000


State Debt

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Total debt (gross)

VY

2 956 900 000

279,4%

779 300 000

10,2%

707 200 000

1 year at most

VZ2

2 168 400 000

178,2%

779 300 000

10,2%

707 200 000

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

205 000 000

0%

0

0%

0

More than 5 years

VZ4

583 500 000

0%

0

0%

0


Details

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

button_minusbutton_plus

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VG2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

12 900 000

0%

0

0%

0

1 year at most

VH2

12 900 000

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

2 104 500 000

0%

0

0%

0

1 year at most

8A2

1 316 000 000

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8A3

205 000 000

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

501 900 000

11,7%

449 500 000

15,7%

388 500 000

1 year at most

8B2

501 900 000

11,7%

449 500 000

15,7%

388 500 000

More than 1 year and 5 years at most

8B3

501 900 000

11,7%

449 500 000

15,7%

388 500 000

button_minusbutton_plus

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8C2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

207 500 000

1,0%

205 400 000

-17,8%

249 900 000

1 year at most

8D2

207 500 000

1,0%

205 400 000

-17,8%

249 900 000

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

VAT (gross)

VW1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VW2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VQ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

71 500 000

15,7%

61 800 000

124,7%

27 500 000

1 year at most

8J2

71 500 000

15,7%

61 800 000

124,7%

27 500 000

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VI2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More 5 years

VI4

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Other liabilities (gross)

8K1

56 700 000

-3,6%

58 800 000

42,4%

41 300 000

1 year at most

8K2

56 700 000

-3,6%

58 800 000

42,4%

41 300 000

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

button_minusbutton_plus

Products in advance (gross)

8L1

1 900 000

-50,0%

3 800 000

0%

0

1 year at most

8L2

1 900 000

-50,0%

3 800 000

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0


References

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Loans made during the period

VJ

0

0%

0

0%

0

 

Debt repaid during the period

VK

0

0%

0

0%

0



Table allocation results and other information
Dividends distributed

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0


Commitments

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

 

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

 

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0


Other charges Externes

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

 

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

 

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

 

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

 

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

 

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

 

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0


Taxes and Fees

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

 

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0


VAT

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

 

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0


Average number of employees

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Average number of employees

YP

0

0%

0

0%

6 357


Groups and Shareholders

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Groups and Shareholders

ZR

0

-

0

-

-

 

 

Display parameter

Comparison mode

Average

Median


Ratios
Structure and liquidity | Management or rotation | Profitability of the business | Return on capital

Structure and Liquidity

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Sector Median 2011

 

Fixed Asset Financing

help1

1,13

-2,6%

1,16

4,5%

1,11

1,26

-10,3%

Global Debt

help1

289 days

-13,7%

335 days

0%

335 days

152 days

90,1%

Working Capital Fund overall net

help1

70 days

-29,3%

99 days

30,3%

76 days

91 days

-23,1%

Financial independence

44,96%

-83,3%

269,99%

401,2%

53,87%

683,02%

-93,4%

button_plusbutton_minusMore ratios

Solvability

help1

1,48%

-84,9%

9,80%

69,8%

5,77%

46,14%

-96,8%

Capacity debt futures

help1

446,51%

-

%

-

%

2492,73%

-82,1%

Coverage of current assets by net working capital overall

help1

41,94%

3,0%

40,72%

-0,8%

41,05%

48,24%

-13,1%

General Liquidity

help1

0

0%

1,23

2,5%

1,20

0,77

0%

Restricted Liquidity

help1

0,04

-97,8%

1,83

50,0%

1,22

1,15

-96,5%


Management or rotation

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Sector Median 2011

 

Need background in operating working capital

help1

59 days

43,9%

41 days

-43,8%

73 days

58 days

1,7%

Treasury

help1

10 days

-81,5%

54 days

2600%

2 days

10 days

0%

Inventory turnover of goods

help1

0 days

-

days

-

days

13 days

0%

Average length of credit granted to customers

help1

51 days

-7,3%

55 days

-20,3%

69 days

62 days

-17,7%

Average length of credit obtained suppliers

help1

57 days

-6,6%

61 days

-6,2%

65 days

64 days

-10,9%

button_plusbutton_minusMore ratios

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

help1

31 days

14,8%

27 days

-28,9%

38 days

51,50 days

-39,8%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

help1

109 days

16,0%

94 days

20,5%

78 days

138 days

-21,0%

Rotation tangible assets

help1

109,18%

16,3%

93,88%

20,5%

77,88%

122,20%

-10,7%


Profitability of the business

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Sector Median 2011

 

Margin trading

help1

-18,67%

0%

0%

0%

0

0%

0%

Profitability of the business

help1

3,06

393,5%

0,62

106,2%

-10,07

6,76%

-54,7%

Net profit

help1

-8,64%

-43100%

-0,02%

99,8%

-9,80%

3,36%

-357,1%

button_plusbutton_minusMore ratios

Growth rate of turnover (excluding VAT)

help1

18,35%

-26,0%

24,79%

200%

-24,79%

6,46%

184,1%

Rates integration

help1

17,22%

3,2%

16,68%

69,5%

9,84%

24,90%

-30,8%

Rate leasing furniture

help1

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Work Factor

help1

74,59%

-14,5%

87,28%

-52,3%

182,97%

51,63%

44,5%

Weight interests

help1

2,60

-8,8%

2,85%

-47,7%

5,45%

0,60%

333,3%


Return on capital

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Sector Median 2011

 

Cash flow from the overall profitability

help1

1,35%

82,4%

0,74%

107,4%

-9,99%

7,07%

-80,9%

Rates of economic profitability

help1

5%

400%

1%

107,1%

-14%

10%

-50,0%

Financial profitability

help1

57600000%

-84,5%

370700000%

116,7%

171100000%

868357%

6533,2%

Return on investment

help1

-10,23%

-389,0%

3,54%

158,2%

-6,08%

7,54%

-235,7%

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

Comparison mode

Average

Median


Soldes Intermédiaires de Gestion

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Sector Median 2011

 

Turnover

3 683 100 000

18,4%

3 112 000 000

24,8%

2 493 800 000

2 227 087 €

165277,5%

 

Sales of goods

0

0%

0

0%

0

 

 

- Purchase of goods

687 500 000

0%

0

0%

0

 

 

+/- Stock of goods variation

0

0%

0

0%

0

 

 

Trading margin

-687 500 000 €

0%

0 €

0%

0 €

0 €

0%

 

-18,67 % CA

0%

0,00 % CA

0%

0,00 % CA

0 % CA

0%

 

Sale of goods produced

3 683 100 000

18,4%

3 112 000 000

24,8%

2 493 800 000

 

 

+/- Stocked production

125 000 000

264,4%

34 300 000

136,8%

-93 200 000

 

 

+ Self-constructed assets

15 300 000

44,3%

10 600 000

2,9%

10 300 000

 

 

Period production

3 823 400 000 €

21,1%

3 156 900 000 €

30,9%

2 410 900 000 €

1 964 052 €

194569,0%

 

103,81 % CA

2,3%

101,44 % CA

4,9%

96,68 % CA

100 % CA

3,8%

 

Trading margin

-687 500 000

0%

0

0%

0

0

0%

+ Period Production

3 823 400 000

21,1%

3 156 900 000

30,9%

2 410 900 000

1 964 052

194569,0%

- Purchase of raw materials

1 692 500 000

-8,3%

1 845 900 000

33,9%

1 379 000 000

 

 

+/- Change in stocks of raw materiels

-9 200 000

-270,4%

5 400 000

-86,2%

39 000 000

 

 

- Other external purchases and charges

818 200 000

4,0%

786 600 000

5,2%

747 500 000

 

 

Added value

634 400 000 €

22,2%

519 000 000 €

111,5%

245 400 000 €

336 519 €

188418,3%

 

17,22 % CA

3,2%

16,68 % CA

69,5%

9,84 % CA

24,90 % CA

-30,8%

 

Added value

634 400 000 €

22,2%

519 000 000 €

111,5%

245 400 000 €

336 519 €

188418,3%

+ Operating grants

8 600 000

50,9%

5 700 000

-8,1%

6 200 000

 

 

- Tax, duty and similar payments

57 200 000

9,2%

52 400 000

-2,4%

53 700 000

 

 

- Personal charges

473 200 000

4,5%

453 000 000

0,9%

449 000 000

 

 

Gross operating surplus

112 600 000 €

483,4%

19 300 000 €

107,7%

-251 100 000 €

79 853 €

140909,1%

 

3,06 % CA

393,5%

0,62 % CA

106,2%

-10,07 % CA

6,76 % CA

-54,7%

 

Gross operating surplus

112 600 000 €

483,4%

19 300 000 €

107,7%

-251 100 000 €

79 853 €

140909,1%

+ Release of reserves and provisions

160 500 000

-2,3%

164 300 000

-21,1%

208 200 000

 

 

+ Other operating income

29 600 000

43,0%

20 700 000

20,3%

17 200 000

 

 

- Depreciation/Amortisation

269 600 000

5,8%

254 800 000

13,0%

225 500 000

 

 

- Other charges

13 300 000

30,4%

10 200 000

-5,6%

10 800 000

 

 

Operating result

19 800 000 €

132,6%

-60 700 000 €

76,8%

-262 000 000 €

41 669 €

47417,3%

 

0,54 % CA

127,7%

-1,95 % CA

81,4%

-10,51 % CA

3,05 % CA

-82,3%

 

Operating result

19 800 000 €

132,6%

-60 700 000 €

76,8%

-262 000 000 €

41 669 €

47417,3%

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Financial income

122 000 000

-1,4%

123 700 000

-28,3%

172 500 000

 

 

- Financial charges

95 900 000

8,2%

88 600 000

-34,8%

135 900 000

 

 

Pre-tax result

45 900 000 €

279,3%

-25 600 000 €

88,6%

-225 400 000 €

38 532 €

119021,8%

 

1,25 % CA

252,4%

-0,82 % CA

90,9%

-9,04 % CA

2,93 % CA

-57,3%

 

Extraordinary income

119 900 000

32,6%

90 400 000

-87,6%

729 200 000

9 000

1332122,2%

- Extraordinary charges

501 900 000

509,8%

82 300 000

-89,3%

767 500 000

 

 

Extraordinary result

-382 000 000 €

-4816,0%

8 100 000 €

121,1%

-38 300 000 €

0 €

0%

 

-10,37 % CA

-4088,5%

0,26 % CA

116,9%

-2 % CA

0 % CA

0%

 

Pre-tax result

45 900 000 €

279,3%

-25 600 000 €

88,6%

-225 400 000 €

38 532 €

119021,8%

Extraordinary result

-382 000 000 €

-4816,0%

8 100 000 €

121,1%

-38 300 000 €

0 €

0%

- Employee profit sharing

0

0%

0

0%

0

 

 

- Tax on profits

-17 500 000

-4,2%

-16 800 000

11,6%

-19 000 000

 

 

Net result

-318 600 000 €

-45414,3%

-700 000 €

99,7%

-244 700 000 €

50 647 €

-629160,0%

help1

-8,65 % CA

-43150,0%

-0,02 % CA

99,8%

-9,81 % CA

3,36 % CA

-357,4%

 

 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

N/a

 

ADDITIONAL INFORMATION

 

Establishment details

 

 

 

 

Activity (APE)

Activités des sièges sociaux (7010Z)

Business Pages FT®

 

 

Postal Address

ARKEMA FRANCE
420 RUE ESTIENNE D ORVES
92700 COLOMBES

Trading Address

420 RUE ESTIENNE D ORVES
92700 COLOMBES

 

Telephone

01 49 00 80 80

 

Fax

 

 

 

 

 

Type

Head office

Status

Economically active

 

Formation Date

06/2007

Reason for formation

Formation

 

Closure Date

 

Reason for closure

 

 

Reactivation Date

 

Production Role

 

 

Activity Nature

 

Activity Location

 

 

Location surface

 

Seasonality

 

 

 

 

 

Department

Hauts-de-Seine (92)

Region

Ile-de-France

 

District

2

Area

92

 

City

COLOMBES

Size of urban area

Paris conglomeration

 

 

 

Other establishments

 

 

 

 

Branches

43 branch entities in this company

 

 

 

Head office


> ARKEMA FRANCE <<< - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (2014Z) in COLOMBES (92700)

 

 

Secondary establishments

> ARKEMA FRANCE - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (2014Z) in MARSEILLE 8 (13008)
> ARKEMA FRANCE - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (2014Z) in VERNEUIL EN HALATTE (60550)
> ARKEMA FRANCE - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (2014Z) in VILLERS SAINT PAUL (60870)
> ARKEMA FRANCE - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (2014Z) in PIERRE BENITE (69310)
> ...

 

 

 

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas but no one grouping more than 50% of workforce

 

 

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which one activity grouping from 50 to 80% of workforce

 

 

 

Workforces

 

 

 

 

Workforce at address

500 to 999 employees

Company workforce

5 000+ employees

 

event history

 

 

 

 

 

Date

Description

No Status History

 

 

 

 

 

 

Publication date

Gazette Name

Description

 

18/01/2013

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

694 - . MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY. Forme : Société de droit étranger. Adresse : Chiyoda-Ku 2-5-2 Marunouchi 00000 Tokyo 100-8324
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 80000 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : un élément du fonds de commerce compose d'un portefeuille clientèle. complément de la rubrique capital de l'acquéreur : 41 970 000 000 000 yen. Adresse : 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. 319 632 790 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/12/2012. Publication légale : Les Petites Affiches du 07/01/2013. Oppositions : ARKEMA FRANCE 420 RUE D ESTIENNE D ORVES 92700 COLOMBES pour la validité et pour la correspondance. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

07/01/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Seller

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 22/11/2012
Cédant : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, 92700 COLOMBES
Cessionnaire : MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY,, 2-5 2 Marunouchi, Chiyoda-ku, 100-8324 TOKYO
Prix de vente : 80000 €
Date d’effet : 01/12/2012

28/12/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1729 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 270035923 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

18/12/2012

JAL

Modification of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 07/11/2012
La société : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, 92700 COLOMBES a subi une diminution de son capital social désormais de 270 035 923 €
Date d'effet : 07/11/2012

22/11/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1657 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 06 Septembre 2001 Président du conseil d'administration et administrateur : LE HENAFF Thierry modification le 26 Août 2008 Directeur général et administrateur : DELABORDE Michel modification le 14 Juin 2006 Administrateur : LEMONNIER Thierry en fonction le 28 Mars 2006 Administrateur : SCHULLER Marc en fonction le 28 Mars 2006 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 14 Juin 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 14 Juin 2006 Administrateur : CHANOINE Pierre en fonction le 25 Mars 2008 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 02 Juillet 2010. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant.

23/10/2012

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 19/10/2012
La société 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, 92700 COLOMBES
Fait l'objet du départ de Monsieur Takken Otto

14/10/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1263 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 274845346.04 EUR. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 79076945 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : avenant en date du 20 juillet 2012 d'un acte du 1er juillet 2011 relatif à la cession parue au Bodacc le 28/09/2012 - N°188a - aux termes dudit avenant, il a été procédé à l'ajustement du prix des différents éléments composant le prix d'acquisition, celui-ci s'élève ainsi à : 79 076 945 euros au lieu de 76 386 469 euros. Adresse : 16-32 rue Henri Régnault, - la Défense 6 -, 92400 Courbevoie.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 20/07/2012. Publication légale : La Loi du 07/09/2012. Oppositions : Société CRAY VALLEY SA - 16-32 rue Henri Régnault - La Défense 6 - 92400 Courbevoie pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

05/10/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

62 - PAS-DE-CALAIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS

291 - Réctificatif.
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : . Date de parution : 23 septembre 2012. Numéro d’annonce : 502. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant.
319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 274845346.04 EUR. Adresse : 420 rue Estienne d'orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 79076945 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Un fonds de commere de développement production et commercialisation de resine photoréticulable et des résines de revetement. Adresse : route d'Arras Drocourt, 62320 Rouvroy.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : la voix du nord du 11/09/2012. Oppositions : à ROUVROY Route d'arras drocourt pour la validité et au siège de la société CRAY VALLEY SA situé 16-32 rue Henri Regnault LA DEFENSE 6, 92400 COURBEVOIE pour la correspondance. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

29/09/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

60 - OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE

442 - 319 632 790 RCS Compiegne. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 79076945 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : avenant en date du 20 juillet 2012 d'un acte du 1er juillet 2011 relatif à la cession parue au Bodacc le 27 juillet 2011 N° 144 a - aux termes dudit avenant, il a été procédé à l'ajustement du prix des différents éléments composants le prix d'acquisition, celui-ci s'élève ainsi à : 79 076 945 euros au lieu de 76 386 469 euros;. Adresse : Zone Artisanale de Villers Saint-Paul, 60870 Villers-Saint-Paul.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : Le Parisien du 11/09/2012. Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance CRAY VALLAY SA 16-32 Rue Henri Regnault La Défense 6 92400 COURBEVOIE. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

28/09/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

580 - Réctificatif.
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : . Date de parution : 27 juillet 2011. Numéro d’annonce : 1635. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant.
319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 274845346.04 EUR. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 79 076 945 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : le fonds de commerce relatif a l'activité de développement, production et commercialisation de résines Photoreticulables et des résines de revêtement. Adresse : 16-32 rue Henri Regbault, la Défense 6, 92400 Courbevoie.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : La Loi du 15/07/2011. Oppositions : STE CRAY VALLEY SA A L ATTENTION DU DIRECTEUR GENERAL SITUE 16-32 RUE HENRI REGNAULT LA DEFENSE 6 - 92400 COURBEVOIE pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

23/09/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

62 - PAS-DE-CALAIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS

502 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 274845346.04 EUR. Adresse : 420 rue Estienne d'orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 79076945 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Un fonds de commere de développement production et commercialisation de resine photoréticulable et des résines de revetement. Adresse : route d'Arras Drocourt, 62320 Rouvroy.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : la voix du nord du 11/09/2012. Oppositions : à ROUVROY Route d'arras drocourt. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

19/09/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

60 - OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE

316 - 319 632 790 RCS Compiegne. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 79076945 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : avenant en date du 20 juillet 2012, d'un acte du 1er juillet 2011 relatif à la cession, Paur au Bodacc le 27 juillet 2011 N° 144 a aux termes dudit avenant, il a été procédé à l'ajustement du prix des différents éléments composant le prix d'acquisition. celui-ci s'élève ainsi à : 79 076 945 euros au lieu de 76 386 469 euros. Adresse : rue Taffanel, 60550 Verneuil-en-Halatte.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : Le Parisien du 11/09/2012. Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance CRAY VALLEY SA 16-32 Rue Henri Regnault La Défense 6 92400 COURBEVOIE. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

11/09/2012

JAL

Activity or goodwill cession

 

 

Parisien (Le)/Edition de l'Oise


Date de décision : 20/07/2012
Cédant : 340869353 - CRAY VALLEY SA, 16 RUE HENRI REGNAULT, LA DEFENSE 6 - 16 A 32, 92400 COURBEVOIE
Cessionnaire : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Prix de vente : 79076945 €

11/09/2012

JAL

Activity or goodwill cession

 

 

Voix du Nord (La)/édition CALAIS


Date de décision : 20/07/2011
Cédant : 340869353 - CRAY VALLEY SA, 16 RUE HENRI REGNAULT, LA DEFENSE 6 - 16 A 32, 92400 COURBEVOIE
Cessionnaire : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Prix de vente : 79076945 €

06/09/2012

JAL

Activity or goodwill cession

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 20/07/2012
Cédant : 340869353 - CRAY VALLEY SA, 16 RUE HENRI REGNAULT, LA DEFENSE 6 - 16 A 32, 92400 COURBEVOIE
Cessionnaire : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Prix de vente : 79076945 €
Date d’effet : 20/07/2012

29/08/2012

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

 

30 - GARD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

132 - 538 695 040 RCS Lyon. KEM ONE. Forme : Société par Actions Simplifiée. Adresse : 210 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon.
Origine du fonds : Apport partiel d'actif 1 EUR. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Exploitation d'un giseent de sel et transports de la saumure, production de sel. Adresse : Parrapon, 30600 Vauvert.
Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. 319 632 790 RCS Nîmes.
Date de commencement de l’activité : 02/07/2012. Publication légale : Medialex 35 Avenue des Peupliers 35515 CESSON-SEVIGNE du 25/07/2012. Déclarations des créances : Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

05/07/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

12952 - 319632790 RCS. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves 92700 Colombes. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011.

23/05/2012

JAL

Continuation of activity in spite of stockholders' equity become lower in the middle of the share capital

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 16/05/2012
Poursuite d'activité malgré des fonds propres devenus inférieurs à la moitié du capital social de la société 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Date d'effet : 16/05/2012

18/10/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

62 - PAS-DE-CALAIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS

903 - Réctificatif.
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : . Date de parution : 7 octobre 2011. Numéro d’annonce : 524. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant.
319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 76386469 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Fabrication et distillation de goudrons, développement, production et commercialisation des résines de revêtemets. Adresse : 121 route de Lille, 62218 Loison-sous-Lens.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : la voix du nord du 16/07/2011. Oppositions : au siège de la société CRAY VALLEY SA 16-32 rue Henry Régnault la défense 6, 92400 COURBEVOIE et pour la validité au lieu d'exploitation à ROUVROY Route d'Arras Drocourt. Descriptif : Montant du capital social de la soci¿t¿ ARKEMA FRANCE : 274 845 346.04 EUROS. Modification survenue sur l'activit¿. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

07/10/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

62 - PAS-DE-CALAIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS

524 - Réctificatif.
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : . Date de parution : 14 septembre 2011. Numéro d’annonce : 543. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant.
319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 76386269 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Fabrication et distillation de goudrons, développement, production et commercialistion des résines de revêtemetns. Adresse : 121 route de Lille, 62218 Loison-sous-Lens.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : la voix du nord du 16/07/2011. Oppositions : au siège de la société CRAY VALLEY SA 16-32 rue Henry Régnault la défense 6 92400 COURBEVOIE et pour la validité au lieu d exploitation à ROUVROY Route d'Arras Drocourt MERCI DE COMPLETER LE CAPITAL SOCIAL DE LA STE ARKEMA FRANCE SOIT / 274 845 346.04 EUROS. Descriptif : Modification survenue sur l'activit¿. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

14/09/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

62 - PAS-DE-CALAIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS

543 - Réctificatif.
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : . Date de parution : 2 août 2011. Numéro d’annonce : 720. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant.
319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 76386269 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Fabrication et distillation de goudrons, développement, production et commercialistion des résines de revêtemetns. Adresse : 121 route de Lille, 62218 Loison-sous-Lens.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : la voix du nord du 16/07/2011. Oppositions : au siège de la société CRAY VALLEY SA 16-32 rue Henry Régnault la défense 6 92400 COURBEVOIE et pour la validité au lieu d exploitation à ROUVROY Route d'Arras Drocourt. Descriptif : Modification survenue sur l'activit¿. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

02/08/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

62 - PAS-DE-CALAIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS

720 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Etablissement secondaire précédemment exploité en location-gérance acquis par apport au montant évalué à 7279029677 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Fabrication et distillation de goudrons . Développement production et commercialisation des résines de revêtements. Adresse : 121 route de Lille, 62218 Loison-sous-Lens. Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 76386269 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Fabrication et distillation de goudrons, développement, production et commercialistion des résines de revêtemetns. Adresse : 121 route de Lille, 62218 Loison-sous-Lens.
Précédent propriétaire : NORSOLOR. 301 459 525 RCS Arras. Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 31/07/1990. Publication légale : Publicateur légal du 03/08/1990. Oppositions : pas d'oppositions. Descriptif : Modification survenue sur l'activit¿. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

27/07/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

60 - OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE

844 - 319 632 790 RCS Compiegne. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 76386469 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : recherche et développement dans le domaine des résines Photoréticulables et des résines de revêtement. Adresse : rue Jacques Taffanel, 60550 Verneuil-en-Halatte.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : Le Parisien du 16/07/2011. Oppositions : ARKEMA FRANCE ZA de Villers St Paul BP 13 60870 VILLERS ST PAUL pour la validité et pour la correspondance CRAY VALLEY SA La Défense 6 16-32 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

27/07/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1635 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 274845346.04 EUR. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 76386469 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : le fonds de commerce relatif a l'activité de développement, production et commercialisation de résines Photoreticulables et des résines de revêtement. Adresse : 16-32 rue Henri Regbault, la Défense 6, 92400 Courbevoie.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : La Loi du 15/07/2011. Oppositions : STE CRAY VALLEY SA A L ATTENTION DU DIRECTEUR GENERAL SITUE 16-32 RUE HENRI REGNAULT LA DEFENSE 6 - 92400 COURBEVOIE pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

27/07/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

 

 

60 - OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE

845 - 319 632 790 RCS Compiegne. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 76386469 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : développement, production et commercialisation des résines Photoréticulables et des résines de revêtement. Adresse : Zone Artisanale de Villers Saint-Paul, Bp 13, 60870 Villers Saint-Paul.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : Le Parisien du 16/07/2011. Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance CRAY VALLEY La Défense 6 16-32 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

16/07/2011

JAL

Activity or goodwill cession

 

 

Voix du Nord (La)/édition CALAIS


Date de décision : 01/07/2011
Cédant : 340869353 - CRAY VALLEY SA, 16 RUE HENRI REGNAULT, LA DEFENSE 6 - 16 A 32, 92400 COURBEVOIE
Cessionnaire : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Prix de vente : 76386469 €
Date d’effet : 01/07/2011

16/07/2011

JAL

Activity or goodwill cession

 

 

Parisien (Le)/Edition de l'Oise


Date de décision : 01/07/2011
Cédant : 340869353 - CRAY VALLEY SA, 16 RUE HENRI REGNAULT, LA DEFENSE 6 - 16 A 32, 92400 COURBEVOIE
Cessionnaire : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Prix de vente : 34090200 €
Date d’effet : 01/07/2011

15/07/2011

JAL

Activity or goodwill cession

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 01/07/2011
Cédant : 340869353 - CRAY VALLEY SA, 16 RUE HENRI REGNAULT, LA DEFENSE 6 - 16 A 32, 92400 COURBEVOIE
Cessionnaire : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Prix de vente : 76386469 €
Date d’effet : 01/07/2011

31/07/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1196 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 274845346.04 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

16/07/2010

JAL

Modification of the share capital

 

 

LES PETITES AFFICHES


Date de décision : 28/06/2010
La société : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES a subi une augmentation de son capital social désormais de 274 845 300 €

13/07/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2801 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 06 Septembre 2001 Président du conseil d'administration et administrateur : LE HENAFF Thierry modification le 26 Août 2008 Directeur général et administrateur : DELABORDE Michel modification le 14 Juin 2006 Administrateur : LEMONNIER Thierry en fonction le 28 Mars 2006 Administrateur : SCHULLER Marc en fonction le 28 Mars 2006 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 14 Juin 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 14 Juin 2006 Administrateur : TAKKEN Otto en fonction le 12 Décembre 2006 Administrateur : CHANOINE Pierre en fonction le 25 Mars 2008 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 02 Juillet 2010.
Commentaires : Modification de représentant.

09/07/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

8816 - 319632790 RCS. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves 92700 Colombes. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

23/06/2010

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1463 - . BASF SE (SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DROIT ALLEMAND À CAPITAL VARIABLE). Forme : Société de droit étranger. Capital : 1175652728.32 EUR. Adresse : Carl - Bosch - Strasse 38, 99999 .
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : commercialisation d'acide méthacrylique. Adresse : 420 rue Estienne d' Orves, 92700 Colombes.
Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. 319 632 790 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : La Loi du 04/02/2010. Oppositions : Au fonds vendu et au siège du cessionnaire pour la correspondance pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 100000 Euros. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

26/03/2010

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1527 - . EVONIK RÖHM GMBH. Forme : Société de droit étranger. Capital : 52300000 EUR. Adresse : Kirschenallée 00000 64293 Darmstadt
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : commercialisation de Monomères d'Esthers Métacryliques de spécialités. Adresse : 420 rue d'Estienne d Orves, 92700 Colombes.
Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. 319 632 790 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : Le Parisien du 08/02/2010. Oppositions : ARKEMA FRANCE AU 420 RUE D ESTIENNE D ORVES 92700 COLOMBES pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 1700000 Euros. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

08/02/2010

JAL

Activity or goodwill cession

 

 

92


Date de décision : 04/02/2010
Cédant : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Cessionnaire : EVONIK ROHM GMBH,
Prix de vente : 1700000 €

04/02/2010

JAL

Activity or goodwill cession

 

 

LES PETITES AFFICHES


Date de décision : 02/02/2010
Cédant : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Cessionnaire : BASF SE, CARL BOSCH STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN
Prix de vente : 100000 €

02/08/2009

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

865 - . EW LIMITED PRIVATE LIMITED COMPANY. Forme : Société de droit étranger. Adresse : C/o Internationals Management Édith Cavell Street Limited - les Cascades Building - 00000 Port Louis
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : commercialisation de chlorure d'aluminium. Adresse : 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. 319 632 790 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : Gazette du palais du 23/07/2009. Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 200000 Euros. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

19/07/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

9398 - 319632790 RCS. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves 92700 Colombes. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

30/06/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

7881 - 319632790 RCS. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves 92700 Colombes. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

29/05/2008

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2119 - . SUMITOMO SEIKA EUROPE S. A. N. V. Forme : Société de droit étranger. Capital : 4000000 EUR. Adresse : 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : un élément de fonds de commerce relatif à l'activité de production et de commercialisation de différents super-absorbants acryliques. Adresse : 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. 319 632 790 RCS Nanterre.
Publication légale : Journal spécial des sociétés françaises du 15/05/2008. Oppositions : Au Mandataire FIDAL - ME JOSSET ET HARIRI - 14 BD DU GENERAL LECLERC - 92527 NEUILLY SUR SEINE CEDEX pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 5000000 Euros. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

23/03/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

3704 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 06 Septembre 2001. Commissaire aux comptes suppléant : BOUCHET Alain en fonction le 06 Septembre 2001. Président du conseil d'administration et administrateur : LE HENAFF Thierry modification le 14 Juin 2006. Directeur général et administrateur : DELABORDE Michel modification le 14 Juin 2006. Administrateur : LEMONNIER Thierry en fonction le 28 Mars 2006. Administrateur : SCHULLER Marc en fonction le 28 Mars 2006. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 14 Juin 2006. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 14 Juin 2006. Administrateur : TAKKEN Otto en fonction le 12 Décembre 2006. Administrateur : CHANOINE Pierre en fonction le 25 Mars 2008.
Commentaires : Modification de représentant.

29/11/2007

Bodacc A

Vente et cession

 

 

507 - RCS Lyon B 349 305 318. RC 07-B 5775. KEMIRA CHIMIE. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : route de Mothern Port du Rhin, 67630 Lauterbourg. Etablissement secondaire - Activité : fabrication de co-agulant pour le traitement de l'eau. Adresse : rue Henri Moisan, 69491 Pierre-Benite. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 496 000 euros . Date de début d'activité : 31 octobre 2007. Précédent propriétaire : RCS 319 632 790. ARKEMA FRANCE. Publication légale : Petites Affiches Lyonnaises du 19 novembre 2007 . Oppositions : à l'attention de Monsieur Denis Fromage, Directeur d'Usine Arkema France rue Henri Moisan 69491 Pierre-Benite.

25/11/2007

Bodacc A

Vente et cession

 

 

966 - RCS B 349 305 318. RC AP-B 42109. KEMIRA CHIMIE S.A.S. Forme : S.A.S. Capital : 5 700 000 euros. Adresse du siège social : route de Mothern, 67630 Lauterbourg. Etablissement principal - Activité : conception, fabrication, vente et livraisons d'appareils de traitement de l'eau. Adresse : 420 rue d'Estienne-d'Orves, 92700 Colombes. Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 496 000 euros. Date d'effet : 31 octobre 2007. Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. RCS 319 632 790. Publication légale : Le Publicateur légal du 12 novembre 2007. Oppositions : Arkema France, 420 rue d'Estienne-d'Orves, 92700 Colombes, pour la validité et Cabinet Carreras, Barsikian, Robertson et Associés, 32 avenue Raymond-Poincaré, 75116 Paris, pour la correspondance.

18/09/2007

Bodacc A

Vente et cession

 

 

2047 - RCS non encore inscrit. RC AP-B 42014. CAFFARO CHIMICA. Forme : société de droit étranger. Capital : 20 010 000 euros. Etablissement principal - Activité : activité de chlorite de sodium. Adresse : 420 rue d'Estiennes-d'Orves, 92700 Colombes. Cession de la propriété et de l'ensemble des droits et des intérêts, dépendant de l'établissement principal, acquis par achat au prix stipulé de 2 500 000 euros, à l'exclusion du bail commercial. Date d'effet : 7 août 2007. Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. RCS 319 632 790. Publication légale : La Gazette du Palais du 1er septembre 2007. Oppositions : au fonds, pour la validité et la correspondance.

25/07/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2306 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA FRANCE. Forme : S.A. Adresse du siège social : 420 rue Estienne-d'Orves,, 92700 Commentaires : modification survenue sur l'adresse du siège social et l'adresse de l'établissement principal. Etablissement principal - Adresse : 420 rue Estienne-d'Orves, 92700

10/07/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

8117 - 319 632 790. RCS Nanterre ARKEMA FRANCE. Forme: Société anonyme. Adresse du siège social: 4/8 Cours Michelet 92800 Puteaux. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

26/12/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2895 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA FRANCE. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : PERNOT (Philippe). Nomination d'un administrateur : TAKKEN (Otto).

11/08/2006

Bodacc A

Vente et cession

 

 

1717 - RCS non encore inscrit. RC AP-B 41427. FACT-FUTURE ADVANCED COMPOSITES & TECHNOLOGY. Forme : société de droit étranger. Capital : 82 200 euros. Etablissement principal - Activité : fabrication et commercialisation de produits de base thermoplastiques renforcés de fibres longues distribués tant en France, qu'en Allemagne ou qu'au Portugal sous la marque > Pryltex < . Adresse : La Défense 10, 4-8 cours Michelet, 92800 Puteaux. Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 600 000 euros. Date d'effet : 6 juillet 2006. Précédent propriétaire : ARKEMA (France). RCS 319 632 790. Publication légale : Les Petites affiches du 26 juillet 2006. Oppositions : au fonds vendu pour la validité et la correspondance.

11/07/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1569 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA FRANCE. Forme : S.A. Capital : 68 685 704,12 euros. Commentaires : modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation) et l'administration. Administration : modification du président du conseil d'administration et administrateur : LE HENAFF (Thierry). Modification d'un directeur général et administrateur : DELABORDE (Michel). Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT. Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.

20/06/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

2002 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA. Forme: S.A. Adresse du siège social: 4/8, cours Michelet,92800 Puteaux. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

23/04/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2776 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateurs partants : CASTAIGNE (Robert) LAFONT (Françoise) (Nom d'usage : LEROY) HOWAT (Ian). Nomination d'administrateurs : PERNOT (Philippe) GOEBEL (Philippe) LEMONNIER (Thierry) SCHULLER (Marc).

16/12/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1679 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA. Forme : S.A. Capital : 27 125 346,60 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (diminution).

24/08/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

5185 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA. Forme: S.A. Adresse du siège social: 4/8, cours Michelet,92800 Puteaux. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

06/01/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1776 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'administrateurs : HOWAT (Ian) DELABORDE (Michel).

01/12/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 319632790 RC 81-B 332 ARKEMA. Forme : S.A. Capital : 520 868 934, 51 euros. Activité : fabrication et vente de produits chimiques ou plastiques. Adresse du siège social : 48 cours Michelet, 92800 Puteaux. Commentaires : modification survenue sur le capital ( augmentation). Apport des sociétés BOSTIK HOLDINGS S.A. (ex-DAJA 33),. RCS Nanterre 445 074 461 et TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE S.A.,. RCS Nanterre 428 891 113. Date d'effet : 22 octobre 2004.

25/01/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 319632790 RC 81-B 332 ATOFINA. Forme : S.A. Capital : 501 240 321 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration. Administration : nomination du commissaire aux comptes titulaire : CABINET BARBIER FRINAULT ET AUTRES. Nomination du commissaire aux comptes suppléant : LEGER (Michel).

18/05/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

*. RCS Nanterre B 319 632 790 RC 81-B 332 ATOFINA. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur la dénomination.

29/08/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 319632790 RC 81-B 332 ELF ATOCHEM S.A. Forme : S.A. Capital : 494 868 500 euros. Adresse du siège social : 4-8 cours Michelet, 92800 Puteaux. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation). Fusion- absorption de la CIE FINANCIERE ATOCHEM, de la STE FINIRIS , de la STE MEDITERRANEENNE DU BROME et de la STE OXYSYNTHESE. Date d'effet : 30 juin 1999.

06/09/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nanterre B 319 632 790 RC 81-B 332 ELF ATOCHEM S.A. Forme : S.A. Capital : 3 246 123 500 F. Adresse du siège social : 4-8 cours Michelet 92800 Puteaux. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation). Apport pur et simple par la STE ELF AQUITAINE EXPLORATION PRODUCTION FRANCE (LACTAME ET THIOCHIMIE),. RCS Nanterre B 409 160 132. Date d'effet : 31 juillet 1998.

02/10/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Nanterre B 319 632 790 RC RC 81-B 332 ELF ATOCHEM S.A. Forme : S.A. Capital : 3 156 750 500 F. Administration : président du conseil d'administration : PUECHAL (Jacques) Administrateurs : DIDIER (François) RUTMAN (Gilbert) ISOARD (Frédéric) CASTILLON (Pierre) DE WISSOCQ (François) POLGE DE COMBERT (Bernard) WEYMULLER ( Stanislas) DESBIENDRAS (Daniel) ARTHAUD (Jean-Pierre). Commissaire aux comptes titulaire : ERNST AND YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : BAHON (Yves). Commentaires : modification survenue sur le capital et l'administration.

 

 

 

 

Date

Description

29/01/2013

New Filling of Tax Office preferential right

29/01/2013

Unfiling of a Tax Office preferential right

18/01/2013

Bodacc A : Sale and transfer

28/12/2012

Bodacc B: Various editing or changing

19/12/2012

Reconstitution of net assets

19/12/2012

Minutes of general meeting of shareholders

19/12/2012

Capital increase

19/12/2012

Updated articles of association

22/11/2012

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Seller

22/11/2012

Bodacc B: Various editing or changing

14/11/2012

Amendment

14/11/2012

Changes to the Board of Directors

07/11/2012

Other modification of Establishment

07/11/2012

Legal Gazette: Modification of the share capital

23/10/2012

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

14/10/2012

Bodacc A : Sale and transfer

06/10/2012

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

05/10/2012

Bodacc A : Sale and transfer

29/09/2012

Bodacc A : Sale and transfer

28/09/2012

Bodacc A : Sale and transfer

23/09/2012

Bodacc A : Sale and transfer

19/09/2012

Bodacc A : Sale and transfer

29/08/2012

Bodacc A : Sale and transfer

25/07/2012

Minutes of general meeting of shareholders

25/07/2012

Partial contribution

25/07/2012

Declaration of conformity

20/07/2012

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

05/07/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

11/06/2012

Amendment

11/06/2012

Continuation of business despite loss of equity

01/06/2012

Disengagement in other companies

01/06/2012

Partial contribution

16/05/2012

Legal Gazette: Continuation of activity

04/05/2012

Payment incident closed

03/02/2012

Disengagement in other companies

31/12/2011

New accounts available

18/10/2011

Bodacc A : Sale and transfer

07/10/2011

Bodacc A : Sale and transfer

14/09/2011

Bodacc A : Sale and transfer

02/09/2011

Update of participations in other companies

02/09/2011

Disengagement in other companies

02/09/2011

New subsidiarie(s) detected

02/08/2011

Bodacc A : Sale and transfer

27/07/2011

Bodacc A : Sale and transfer

20/07/2011

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

18/07/2011

Bodacc C : Deposit accounts notice

08/07/2011

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

01/07/2011

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

25/05/2011

New Filling of Tax Office preferential right

25/05/2011

Unfiling of a Tax Office preferential right

31/12/2010

New accounts available

29/11/2010

Payment incident closed

23/08/2010

Payment incident closed

13/08/2010

Update of participations in other companies

13/08/2010

Disengagement in other companies

13/08/2010

New participations in other companies

13/08/2010

New subsidiarie(s) detected

02/08/2010

Payment incident closed

31/07/2010

Bodacc B: Various editing or changing

21/07/2010

Amendment

21/07/2010

Updated articles of association

21/07/2010

Capital increase

21/07/2010

Fund deposit certificate

21/07/2010

Payment incident detected

13/07/2010

Bodacc B: Various editing or changing

09/07/2010

Update of participations in other companies

09/07/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

01/07/2010

New auditor

01/07/2010

Amendment

28/06/2010

Legal Gazette: Modification of the share capital

28/06/2010

Other modification of Establishment

23/06/2010

Bodacc A : Sale and transfer

21/06/2010

Payment incident detected

01/06/2010

Payment incident closed

26/03/2010

Bodacc A : Sale and transfer

08/02/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

04/02/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

26/01/2010

Payment incident detected

13/01/2010

Payment incident closed

08/01/2010

Payment incident closed

31/12/2009

New accounts available

16/10/2009

Payment incident closed

02/10/2009

Payment incident detected

31/08/2009

Payment incident detected

02/08/2009

Bodacc A : Sale and transfer

28/07/2009

Acte modificatif

28/07/2009

Updated articles of association

28/07/2009

Statuts mis à jour

28/07/2009

Minutes of general meeting of shareholders

28/07/2009

Private document

28/07/2009

Amendment

19/07/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

17/07/2009

Payment incident closed

26/06/2009

Payment incident closed

09/06/2009

Payment incident detected

19/03/2009

Payment incident detected

31/12/2008

New accounts available

15/10/2008

Payment incident closed

29/07/2008

Payment incident detected

30/06/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

29/05/2008

New Bodacc A ads detected

29/05/2008

Bodacc A : Sale and transfer

25/03/2008

Appointment/resignation of company officers

25/03/2008

Modification du Conseil d'Administration

25/03/2008

Minutes of Board meeting

25/03/2008

PV du Conseil d'Administration

25/03/2008

Acte modificatif

25/03/2008

Private document

25/03/2008

Changes to the Board of Directors

23/03/2008

New Bodacc B ads detected

23/03/2008

Bodacc B: Various editing or changing

31/12/2007

New accounts available

14/09/2007

Collection of preferential rights activated for this company

04/07/2007

Updated articles of association

04/07/2007

Statuts mis à jour

04/07/2007

Minutes of general meeting of shareholders

04/07/2007

PV d'Assemblée

04/07/2007

Private document

04/07/2007

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

04/07/2007

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

25/06/2007

PV d'Assemblée

25/06/2007

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

25/06/2007

Statuts mis à jour

15/06/2007

Modification to Establishment Address or Identifier

31/12/2006

New accounts available

12/12/2006

Appointment/resignation of company officers

12/12/2006

PV du Conseil d'Administration

12/12/2006

Private document

12/12/2006

Modification du Conseil d'Administration

12/12/2006

Acte modificatif

12/12/2006

Minutes of Board meeting

12/12/2006

Changes to the Board of Directors

14/06/2006

Acte modificatif

14/06/2006

Acte sous seing privé

14/06/2006

Private document

14/06/2006

Modification du Conseil d'Administration

14/06/2006

Changes to the Board of Directors

14/06/2006

Changement de Président (PDG, PCA)

14/06/2006

New company name

14/06/2006

Changement de dénomination sociale

14/06/2006

Réduction de Capital

14/06/2006

Statuts mis à jour

14/06/2006

Augmentation de Capital

14/06/2006

Capital increase

14/06/2006

Updated articles of association

14/06/2006

Changement de Commissaire aux Comptes

14/06/2006

PV du Conseil d'Administration

14/06/2006

Rapport des Commissaires ou du Gérant

14/06/2006

Appointment/resignation of company officers

14/06/2006

Nomination/démission des organes de gestion

14/06/2006

Audit or Management Report

14/06/2006

New auditor

14/06/2006

Minutes of general meeting of shareholders

14/06/2006

PV d'Assemblée

14/06/2006

Minutes of Board meeting

18/05/2006

Amendment

18/05/2006

Expédition acte notarié

18/05/2006

Office copy

18/05/2006

Acte modificatif

18/04/2006

Modification to Establishment Address or Identifier

28/03/2006

Nomination/démission des organes de gestion

28/03/2006

Appointment/resignation of company officers

28/03/2006

Private document

28/03/2006

Acte sous seing privé

28/03/2006

Updated articles of association

28/03/2006

Changes to the Board of Directors

28/03/2006

Minutes of general meeting of shareholders

28/03/2006

PV d'Assemblée

28/03/2006

Statuts mis à jour

28/03/2006

Modification du Conseil d'Administration

31/12/2005

New accounts available

01/12/2005

Réduction de Capital

01/12/2005

Acte sous seing privé

01/12/2005

Private document

01/12/2005

Minutes of general meeting of shareholders

01/12/2005

Statuts mis à jour

01/12/2005

Updated articles of association

01/12/2005

Audit or Management Report

01/12/2005

Rapport des Commissaires ou du Gérant

01/12/2005

Capital reduction

01/12/2005

PV d'Assemblée

22/11/2005

Acte sous seing privé

22/11/2005

Private document

22/11/2005

Audit or Management Report

22/11/2005

Rapport des Commissaires ou du Gérant

31/12/2004

New accounts available

17/12/2004

Rapport des Commissaires ou du Gérant

17/12/2004

Audit or Management Report

17/12/2004

Private document

17/12/2004

Acte sous seing privé

17/12/2004

Appointment/resignation of company officers

17/12/2004

PV d'Assemblée

17/12/2004

Modification du Conseil d'Administration

17/12/2004

Changes to the Board of Directors

17/12/2004

Minutes of general meeting of shareholders

17/12/2004

Nomination/démission des organes de gestion

15/11/2004

Déclaration de conformité

15/11/2004

Certificat de dépôt des fonds

15/11/2004

Declaration of conformity

15/11/2004

Private document

15/11/2004

Acte sous seing privé

15/11/2004

Reconstitution de l'Actif Net

15/11/2004

Fund deposit certificate

15/11/2004

Rapport des Commissaires ou du Gérant

15/11/2004

Audit or Management Report

15/11/2004

Updated articles of association

15/11/2004

Statuts mis à jour

15/11/2004

PV du Conseil d'Administration

15/11/2004

Minutes of Board meeting

15/11/2004

Acte modificatif

22/10/2004

PV d'Assemblée

22/10/2004

PV du Conseil d'Administration

22/10/2004

Statuts mis à jour

22/10/2004

Acte modificatif

22/10/2004

Changement de dénomination sociale

22/10/2004

Nomination/démission des organes de gestion

21/10/2004

Changement de dénomination sociale

21/10/2004

New company name

21/10/2004

Minutes of general meeting of shareholders

21/10/2004

Appointment/resignation of company officers

21/10/2004

Nomination/démission des organes de gestion

21/10/2004

Minutes of Board meeting

21/10/2004

PV du Conseil d'Administration

21/10/2004

Private document

21/10/2004

Statuts mis à jour

21/10/2004

Updated articles of association

21/10/2004

Acte sous seing privé

21/10/2004

Modification du Conseil d'Administration

21/10/2004

Changes to the Board of Directors

21/10/2004

New chairman (CEO, CoB)

21/10/2004

Changement de Président (PDG, PCA)

21/10/2004

PV d'Assemblée

01/10/2004

Réduction de Capital

01/10/2004

Capital reduction

01/10/2004

Capital increase

01/10/2004

Augmentation de Capital

01/10/2004

PV d'Assemblée

01/10/2004

Minutes of general meeting of shareholders

01/10/2004

Private document

01/10/2004

Acte sous seing privé

21/09/2004

Rapport des Commissaires ou du Gérant

25/08/2004

Apport Partiel

25/08/2004

Amendment

25/08/2004

Acte modificatif

25/08/2004

Acte sous seing privé

25/08/2004

Private document

25/08/2004

Scission

16/04/2004

Rapport des Commissaires ou du Gérant

16/04/2004

PV d'Assemblée

16/04/2004

Acte sous seing privé

16/04/2004

Statuts mis à jour

31/12/2003

New accounts available

12/12/2003

Nomination/démission des organes de gestion

12/12/2003

Acte sous seing privé

12/12/2003

Modification du Conseil d'Administration

28/08/2003

Acte modificatif

28/08/2003

PV d'Assemblée

28/08/2003

Modification du Conseil d'Administration

28/08/2003

Acte sous seing privé

28/08/2003

Rapport des Commissaires ou du Gérant

28/08/2003

Statuts mis à jour

28/08/2003

PV du Conseil d'Administration

14/09/2002

PV d'Assemblée

14/09/2002

Acte modificatif

14/09/2002

Acte sous seing privé

14/09/2002

Modification du Conseil d'Administration

14/09/2002

Nomination/démission des organes de gestion

14/09/2002

Changement de Commissaire aux Comptes

14/09/2002

PV du Conseil d'Administration

14/09/2002

Statuts mis à jour

04/06/2002

Acte modificatif

04/06/2002

Nomination/démission des organes de gestion

04/06/2002

Modification du Conseil d'Administration

04/06/2002

Acte sous seing privé

04/06/2002

PV du Conseil d'Administration

29/11/2001

Statuts mis à jour

29/11/2001

Acte sous seing privé

29/11/2001

Acte modificatif

06/09/2001

Nomination/démission des organes de gestion

06/09/2001

PV d'Assemblée

06/09/2001

Acte sous seing privé

06/09/2001

Changement de Commissaire aux Comptes

04/07/2001

Modification du Conseil d'Administration

04/07/2001

Changement de Président (PDG, PCA)

04/07/2001

Acte modificatif

04/07/2001

Nomination/démission des organes de gestion

04/07/2001

Acte sous seing privé

04/07/2001

PV du Conseil d'Administration

11/01/2001

Changement de Commissaire aux Comptes

11/01/2001

Nomination/démission des organes de gestion

11/01/2001

PV d'Assemblée

11/01/2001

Statuts mis à jour

11/01/2001

Augmentation de Capital

11/01/2001

Rapport des Commissaires ou du Gérant

11/01/2001

Acte sous seing privé

05/12/2000

Rapport des Commissaires ou du Gérant

05/12/2000

Acte sous seing privé

17/08/2000

Requête et Ordonnance

17/08/2000

Nomination/démission des organes de gestion

17/08/2000

Acte modificatif

02/05/2000

Statuts mis à jour

02/05/2000

PV d'Assemblée

02/05/2000

Changement de dénomination sociale

02/05/2000

Modification du Conseil d'Administration

02/05/2000

Rapport des Commissaires ou du Gérant

02/05/2000

Acte sous seing privé

14/04/2000

Nomination/démission des organes de gestion

14/04/2000

Acte sous seing privé

14/04/2000

Modification du Conseil d'Administration

14/04/2000

Changement de Président (PDG, PCA)

14/04/2000

Acte modificatif

14/04/2000

PV du Conseil d'Administration

11/10/1999

PV du Conseil d'Administration

11/10/1999

Nomination/démission des organes de gestion

11/10/1999

Acte sous seing privé

11/10/1999

Modification du Conseil d'Administration

11/10/1999

Acte modificatif

16/08/1999

Fusion

16/08/1999

PV d'Assemblée

16/08/1999

Déclaration de conformité

16/08/1999

Acte sous seing privé

16/08/1999

Augmentation de Capital

16/08/1999

Conversion du Capital Social en Euros

16/08/1999

Statuts mis à jour

22/06/1999

Rapport des Commissaires ou du Gérant

22/06/1999

Acte sous seing privé

28/05/1999

Projet de Fusion

28/05/1999

Acte sous seing privé

10/03/1999

Requête et Ordonnance

10/03/1999

Acte modificatif

10/03/1999

Nomination/démission des organes de gestion

09/12/1998

Rapport des Commissaires ou du Gérant

09/12/1998

Acte sous seing privé

02/12/1998

Acte sous seing privé

02/12/1998

Projet de Fusion

18/11/1998

Requête et Ordonnance

18/11/1998

Acte modificatif

18/11/1998

Nomination/démission des organes de gestion

17/11/1998

Acte sous seing privé

17/11/1998

Projet de Fusion

20/10/1998

Acte sous seing privé

20/10/1998

Nomination/démission des organes de gestion

20/10/1998

Acte modificatif

20/10/1998

PV du Conseil d'Administration

20/10/1998

Modification du Conseil d'Administration

24/08/1998

Statuts mis à jour

24/08/1998

PV d'Assemblée

24/08/1998

Augmentation de Capital

24/08/1998

Projet de Fusion

24/08/1998

Acte sous seing privé

23/07/1998

Rapport des Commissaires ou du Gérant

23/07/1998

Acte sous seing privé

19/05/1998

Requête et Ordonnance

19/05/1998

Nomination/démission des organes de gestion

19/05/1998

Acte modificatif

29/07/1997

Nomination/démission des organes de gestion

29/07/1997

Acte sous seing privé

29/07/1997

Changement de Commissaire aux Comptes

29/07/1997

PV d'Assemblée

18/09/1996

Augmentation de Capital

18/09/1996

Statuts mis à jour

18/09/1996

PV du Conseil d'Administration

18/09/1996

PV d'Assemblée

18/09/1996

Certificat de dépôt des fonds

18/09/1996

Acte sous seing privé

18/09/1996

Acte modificatif

04/08/1995

PV d'Assemblée

04/08/1995

Acte modificatif

14/09/1994

Modification du Conseil d'Administration

14/09/1994

Acte modificatif

14/09/1994

PV d'Assemblée

14/09/1994

PV du Conseil d'Administration

14/09/1994

Nomination/démission des organes de gestion

22/03/1994

Acte modificatif

22/03/1994

PV d'Assemblée

22/03/1994

Statuts mis à jour

22/03/1994

Déclaration de conformité

16/09/1993

PV d'Assemblée

16/09/1993

Déclaration de conformité

16/09/1993

Augmentation de Capital

16/09/1993

Acte modificatif

16/09/1993

Certificat de dépôt des fonds

16/09/1993

Statuts mis à jour

16/09/1993

PV du Conseil d'Administration

16/04/1993

Nomination/démission des organes de gestion

16/04/1993

PV du Conseil d'Administration

16/04/1993

Modification du Conseil d'Administration

16/04/1993

Acte modificatif

10/02/1992

Acte sous seing privé

10/02/1992

Acte modificatif

10/02/1992

Statuts mis à jour

10/02/1992

PV d'Assemblée

10/02/1992

Changement de dénomination sociale

10/02/1992

Fusion

 

 

 

 

 

 

Date

Description

12/01/2013

Update of phone numbers

14/11/2012

Update of phone numbers

13/10/2012

Update Limit

13/10/2012

Update Rating

01/10/2012

Update Limit

06/09/2012

Update Rating

25/04/2011

Update Rating

06/08/2010

Update Rating

23/07/2010

Update Rating

21/01/2010

Update of phone numbers

20/11/2009

Update of phone numbers

10/07/2009

Update Rating

22/10/2008

Update of phone numbers

08/07/2008

Update Rating

03/07/2008

Update Rating

12/06/2008

Update of phone numbers

09/12/2007

Update Limit

08/12/2007

Update Rating

06/12/2007

Update Rating

25/07/2007

Update of phone numbers

15/06/2007

Update of Establishment Address

15/06/2007

Modification of Head office Identification

18/04/2006

Update of Establishment Workforce

18/04/2006

Modification of Head office Identification

18/04/2006

Update of Establishment Address

 

 

 

NOTES & COMMENTS

 

N/a

 

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.54.48

UK Pound

1

Rs.82.72

Euro

1

Rs.71.27

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Report Prepared by :

PRL

 

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.