|
Report Date : |
07.03.2013 |
IDENTIFICATION DETAILS
|
Name : |
PCM |
|
|
|
|
Registered Office : |
P.C.M Pcm Pumps Delasco Foodys 6 Bd Bineau 92300 Levallois Perret |
|
|
|
|
Country : |
France |
|
|
|
|
Financials (as on) : |
31.12.2011 |
|
|
|
|
Date of Incorporation : |
November 1957 |
|
|
|
|
Com. Reg. No.: |
RCS Nanterre 8 572 180 198 |
|
|
|
|
Legal Form : |
Public limited company with board of directors |
|
|
|
|
Line of Business : |
Manufacture of other pumps and compressors |
|
|
|
|
No. of Employees : |
301 |
RATING & COMMENTS
|
MIRA’s Rating : |
Ba |
|
RATING |
STATUS |
PROPOSED CREDIT LINE |
|
|
41-55 |
Ba |
Overall operation is considered normal. Capable to meet normal
commitments. |
Satisfactory |
|
Status : |
Satisfactory |
|
Payment Behaviour : |
No Complaints |
|
Litigation : |
Clear |
NOTES :
Any query related to this report can be made
on e-mail: infodept@mirainform.com
while quoting report number, name and date.
ECGC Country Risk Classification List – June 30th, 2012
|
Country Name |
Previous Rating (31.03.2011) |
Current Rating (30.06.2012) |
|
France |
A1 |
A1 |
|
Risk Category |
ECGC
Classification |
|
Insignificant |
A1 |
|
Low |
A2 |
|
Moderate |
B1 |
|
High |
B2 |
|
Very High |
C1 |
|
Restricted |
C2 |
|
Off-credit |
D |
FRANCE - ECONOMIC OVERVIEW
France was transitioning from an economy that has featured extensive government ownership and intervention to one that relies more on market mechanisms but is in the midst of a euro-zone crisis. The government has partially or fully privatized many large companies, banks, and insurers, and has ceded stakes in such leading firms as Air France, France Telecom, Renault, and Thales. It maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With at least 75 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that reduce income disparity and the impact of free markets on public health and welfare. France's real GDP contracted 2.6% in 2009, but recovered somewhat in 2010 and 2011. The unemployment rate increased from 7.4% in 2008 to 9.3% in 2010 and 9.1% in 2011. Lower-than-expected growth and increased unemployment have cut government revenues and increased borrowing costs, contributing to a deterioration of France's public finances. The government budget deficit rose sharply from 3.4% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 5.8% of GDP in 2011, while France's public debt rose from 68% of GDP to 86% over the same period. Under President SARKOZY, Paris implemented austerity measures that eliminated tax credits and froze most government spending in an effort to bring the budget deficit under the 3% euro-zone ceiling by 2013 and to highlight France's commitment to fiscal discipline at a time of intense financial market scrutiny of euro-zone debt levels. Socialist Francois HOLLANDE won the May 2012 presidential election, after advocating pro-growth economic policies, as well as measures such as forcing banks to separate their traditional deposit taking and lending activities from more speculative businesses, increasing taxes on bank profits, introducing a new top bracket on income taxes for people earning over €1 million ($1.3 million) a year, and hiring an additional 60,000 civil servants during his five-year term of office.
Source
: CIA
company
summary
|
|
Acronym |
PCM |
|
||
|
|
|
|
EUR VAT Number |
FR88572180198 |
|
|
|
Activity (APE) |
Manufacture of other pumps and
compressors (2813Z) |
Legal form |
Public limited company with board of
directors |
|
|
|
Phone |
|
RCS Registration |
RCS Nanterre 8 572 180 198 |
|
|
|
Fax |
|
Share capital |
10,154,970 Euros |
|
|
|
Address |
PCM |
Incorporated Date |
11/1957 |
|
|
|
Nationality |
France |
Status |
Economically active |
|
|
|
Acronym |
PCM |
||
|
|
Activity (APE) |
Fabrication d'autres pompes et compresseurs
(2813Z) |
Business Pages FT® |
|
|
|
Postal Address |
PCM |
Trading Address |
6 BOULEVARD BINEAU |
|
|
Telephone |
|
||
|
|
Fax |
|
||
|
|
Current Directors |
9 |
|
|
|
Name |
GEVELOT |
||
|
|
Name of representative |
M MATIGNONI PAOLO |
||
|
|
Manager position |
Administrateur |
Date of birth |
06/11/1939 |
|
|
Place of birth |
GENES(ITALIE) |
|
|
|
|
Type |
Moral person |
Name at birth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name |
Mme. BIENAIME CLAUDINE SUZANNE MARGUERITE
MARIE |
||
|
|
Manager position |
Administrateur |
Date of birth |
23/11/1939 |
|
|
Place of birth |
SAINT ANDRE DE BRIOUZE (ORNE) |
|
|
|
|
Type |
Individual |
Name at birth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name |
Mme. MARTIGNONI ROSELYNE |
||
|
|
Manager position |
Administrateur |
Date of birth |
09/11/1943 |
|
|
Place of birth |
LAVAL |
|
|
|
|
Type |
Individual |
Name at birth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name |
M. BIENAIME GEOFFROY CHARLICK ROBERT |
||
|
|
Manager position |
Administrateur |
Date of birth |
21/05/1969 |
|
|
Place of birth |
LYON |
|
|
|
|
Type |
Individual |
Name at birth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name |
M. FAY JACQUES |
||
|
|
Manager position |
Administrateur |
Date of birth |
02/03/1949 |
|
|
Place of birth |
NIORT |
|
|
|
|
Type |
Individual |
Name at birth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name |
Mme. BIENAIME CLAUDINE SUZANNE MARGUERITE
MARIE |
||
|
|
Manager position |
Administrateur |
Date of birth |
23/11/1939 |
|
|
Place of birth |
SAINT ANDRE DE BRIOUZE (ORNE) |
|
|
|
|
Type |
Individual |
Name at birth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name |
Mme. MARTIGNONI ROSELYNE |
||
|
|
Manager position |
Administrateur |
Date of birth |
09/11/1943 |
|
|
Place of birth |
LAVAL |
|
|
|
|
Type |
Individual |
Name at birth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name |
M. BIENAIME GEOFFROY CHARLICK ROBERT |
||
|
|
Manager position |
Administrateur |
Date of birth |
21/05/1969 |
|
|
Place of birth |
LYON |
|
|
|
|
Type |
Individual |
Name at birth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name |
M. FAY JACQUES |
||
|
|
Manager position |
Administrateur |
Date of birth |
02/03/1949 |
|
|
Place of birth |
NIORT |
|
|
|
|
Type |
Individual |
Name at birth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name |
M. GARDE FRÉDÉRIC |
||
|
|
Manager position |
Directeur général délégué |
Date of birth |
04/05/1968 |
|
|
Place of birth |
PARIS |
|
|
|
|
Type |
Individual |
Name at birth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name |
M. BARBELANE PHILIPPE |
||
|
|
Manager position |
Administrateur |
Date of birth |
29/11/1946 |
|
|
Place of birth |
PARIS |
|
|
|
|
Type |
Individual |
Name at birth |
|
|
|
|
|
|
|
|
Previous Directors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
No social security and tax office
preferential right to date |
|
judgements |
|||||||||||||||||||
Social security, pension funds preferential
rights | Tax office preferential rights Preferential rights
details and history Summary of preferential rights
|
|||||||||||||||||||
Recent publications in
Gazettes
|
Bodacc B |
Modification et mutation diverse |
|
|
|
|
|||
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 1632 - 572 180 198 RCS Nanterre. PCM. Forme :
Société anonyme. Administration : Administrateur : BIENAIME CLAUDINE SUZANNE MARGUERITE
MARIE modification le 05 Septembre 2002 Administrateur : MARTIGNONI Roselyne
en fonction le 12 Août 1999 Administrateur : BIENAIME Geoffroy Charlick
Robert modification le 10 Février 2012 Administrateur : FAY Jacques
modification le 03 Janvier 2012 Administrateur : GEVELOT représenté par
MATIGNONI Paolo modification le 26 Juillet 2012 Administrateur : BARABINO
Roberto en fonction le 15 Septembre 2004 Président directeur général :
MARTIGNONI Mario modification le 03 Janvier 2012 Commissaire aux comptes
titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 15 Juillet 2008
Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 15 Juillet
2008 Directeur général délégué (non administrateur) : GARDE Frédéric en
fonction le 10 Février 2012 Commissaire aux comptes suppléant : BERGES
Catherine en fonction le 26 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire :
NSO Expertise et Audit en fonction le 26 Juillet 2012 Administrateur :
BARBELANE Philippe en fonction le 12 Septembre 2012. Activité : . |
|||
|
Bodacc C |
Comptes annuels et rapports |
|
|
|
|
|||
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 11229 - 572180198 RCS. PCM. Forme : Société
anonyme. Adresse : 6 boulevard Bineau 92300 Levallois-Perret. Commentaires :
Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011. |
|||
|
Bodacc B |
Modification et mutation diverse |
|
|
|
|
|||
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 1673 - 572 180 198 RCS Nanterre. PCM. Forme
: Société anonyme. Administration : Administrateur : BIENAIME CLAUDINE
SUZANNE MARGUERITE MARIE modification le 05 Septembre 2002 Administrateur :
DESTOURS Philippe Pierre Marie Ernest modification le 23 Janvier 2001
Administrateur : MARTIGNONI Roselyne en fonction le 12 Août 1999
Administrateur : BIENAIME Geoffroy Charlick Robert modification le 10 Février
2012 Administrateur : FAY Jacques modification le 03 Janvier 2012
Administrateur : GEVELOT représenté par MATIGNONI Paolo modification le 26
Juillet 2012 Administrateur : BARABINO Roberto en fonction le 15 Septembre
2004 Président directeur général : MARTIGNONI Mario modification le 03
Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
en fonction le 15 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS
Etienne en fonction le 15 Juillet 2008 Directeur général délégué (non
administrateur) : GARDE Frédéric en fonction le 10 Février 2012 Commissaire
aux comptes suppléant : BERGES Catherine en fonction le 26 Juillet 2012
Commissaire aux comptes titulaire : NSO Expertise et Audit en fonction le 26
Juillet 2012. Activité : . |
|||
|
Bodacc B |
Modification et mutation diverse |
|
|
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 1381 - 572 180 198 RCS Nanterre. PCM. Forme
: Société anonyme. Administration : Administrateur : BIENAIME CLAUDINE
SUZANNE MARGUERITE MARIE modification le 05 Septembre 2002 Administrateur :
DESTOURS Philippe Pierre Marie Ernest modification le 23 Janvier 2001
Administrateur : MARTIGNONI PAOLO RENATO Commissaire aux comptes suppléant :
BAILLIN PHILIPPE Administrateur : MARTIGNONI Roselyne en fonction le 12 Août
1999 Administrateur : BIENAIME Geoffroy Charlick Robert modification le 10
Février 2012 Administrateur : FAY Jacques modification le 03 Janvier 2012
Administrateur : GEVELOT représenté par BARBELANE Philippe modification le 10
Février 2012 Administrateur : BARABINO Roberto en fonction le 15 Septembre
2004 Président directeur général : MARTIGNONI Mario modification le 03
Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : BONTOUX Patrick en fonction
le 26 Juillet 2006 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT en fonction le 15 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant :
BORIS Etienne en fonction le 15 Juillet 2008 Directeur général délégué (non
administrateur) : GARDE Frédéric en fonction le 10 Février 2012. Activité
: . |
|||
|
JAL |
Appointment of the social representative |
|
|
|
Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien
juridique - archives commerciales de la France
|
|||
|
Bodacc B |
Modification et mutation diverse |
|
|
|
|
|||
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 4636 - 572 180 198 RCS Nanterre. PCM. Forme
: Société anonyme. Enseigne : PCM. Activité : . |
|||
|
Bodacc B |
Modification et mutation diverse |
|
|
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 4637 - 572 180 198 RCS Nanterre. PCM. Forme
: Société anonyme. Administration : Administrateur : BIENAIME
CLAUDINE SUZANNE MARGUERITE MARIE modification le 05 Septembre 2002 Administrateur
: DESTOURS Philippe Pierre Marie Ernest modification le 23 Janvier 2001
Administrateur : MARTIGNONI PAOLO RENATO Commissaire aux comptes suppléant :
BAILLIN PHILIPPE Administrateur : MARTIGNONI Roselyne en fonction le 12 Août
1999 Administrateur : BIENAIME Geoffroy Charlick Robert modification le 26
Juillet 2006 Administrateur : FAY Jacques modification le 03 Janvier 2012
Administrateur : GEVELOT représenté par BARBELANE Philippe modification le 07
Mai 2008 Administrateur : BARABINO Roberto en fonction le 15 Septembre 2004
Président directeur général : MARTIGNONI Mario modification le 03 Janvier
2012 Commissaire aux comptes titulaire : BONTOUX Patrick en fonction le 26
Juillet 2006 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
en fonction le 15 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS
Etienne en fonction le 15 Juillet 2008. Activité : . |
|||
|
JAL |
Appointment of the social representative |
|
|
|
Petites
affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de
la France |
|||
|
JAL |
Resignation / Revocation of the social
representative |
|
|
|
Petites affiches (Les) - La Loi - Le
Quotidien juridique - archives commerciales de la France
|
|||
|
JAL |
Head Office Transfer |
|
|
|
Petites affiches (Les) - La Loi - Le
Quotidien juridique - archives commerciales de la France
|
|||
|
Bodacc C |
Comptes annuels et rapports |
|
|
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 9108 - 572180198 RCS. PCM. Forme : Société
anonyme. Adresse : 17 rue Ernest Laval 92170 Vanves. Commentaires :
Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009. |
|||
|
Bodacc B |
Modification et mutation diverse |
|
|
|
|
|||
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 1467 - 572 180 198 RCS Nanterre. PCM. Forme
: Société anonyme. Administration : Administrateur : BIENAIME
CLAUDINE SUZANNE MARGUERITE MARIE modification le 05 Septembre 2002
Administrateur : DESTOURS Philippe Pierre Marie Ernest modification le 23
Janvier 2001 Administrateur : MARTIGNONI PAOLO RENATO Commissaire aux comptes
suppléant : BAILLIN PHILIPPE Administrateur : MARTIGNONI Roselyne en fonction
le 12 Août 1999 Administrateur : BIENAIME Geoffroy Charlick Robert
modification le 26 Juillet 2006 Président directeur général et administrateur
: FAY Jacques modification le 28 Novembre 2002 Administrateur : GEVELOT
représenté par BARBELANE Philippe modification le 07 Mai 2008 Administrateur
: BARABINO Roberto en fonction le 15 Septembre 2004 Directeur général délégué
et administrateur : MARTIGNONI Mario modification le 07 Mai 2010 Commissaire
aux comptes titulaire : BONTOUX Patrick en fonction le 26 Juillet 2006
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction
le 15 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en
fonction le 15 Juillet 2008. |
|||
|
JAL |
Appointment of the social representative |
|
|
|
|
|||
|
LES PETITES AFFICHES
|
|||
|
Bodacc C |
Comptes annuels et rapports |
|
|
|
|
|||
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 10254 - 572180198 RCS. PCM. Forme : Société
anonyme. Adresse : 17 rue Ernest Laval 92170 Vanves. Commentaires :
Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008. |
|||
|
Bodacc C |
Comptes annuels et rapports |
|
|
|
|
|||
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 9354 - 572180198 RCS. PCM. Forme : Société
anonyme. Adresse : 17 rue Ernest Laval 92170 Vanves. Commentaires :
Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007. |
|||
|
Bodacc B |
Modification et mutation diverse |
|
|
|
|
|||
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 3940 - 572 180 198 RCS Nanterre. PCM. Forme
: Société anonyme. Administration : Administrateur : BIENAIME
CLAUDINE SUZANNE MARGUERITE MARIE modification le 05 Septembre
2002Administrateur : DESTOURS Philippe Pierre Marie Ernest modification le 23
Janvier 2001. Administrateur : MARTIGNONI PAOLO RENATO. Commissaire aux
comptes suppléant : BAILLIN PHILIPPE. Administrateur : MARTIGNONI Roselyne en
fonction le 12 Août 1999. Administrateur : BIENAIME Geoffroy Charlick Robert
modification le 26 Juillet 2006. Président directeur général et
administrateur : FAY Jacques modification le 28 Novembre 2002. Administrateur
: GEVELOT représenté par BARBELANE Philippe modification le 07 Mai 2008.
Administrateur : BARABINO Roberto en fonction le 15 Septembre 2004.
Administrateur : MARTIGNONI Mario en fonction le 28 Juillet 2005. Commissaire
aux comptes titulaire : BONTOUX Patrick en fonction le 26 Juillet 2006.
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction
le 15 Juillet 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en
fonction le 15 Juillet 2008. |
|||
|
Bodacc C |
Avis de dépôt des comptes |
|
|
|
|
|||
|
6444 - 572 180 198. RCS Nanterre PCM.
Forme: Société anonyme. Adresse du siège social: 17 rue Ernest Laval 92170
Vanves. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006. |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
|
|||
|
0849 - RCS Nanterre B 572 180 198. RC 80-B
3689. PCM. Forme : S.A. Capital : 10 154 970 euros. Adresse du siège social :
17 rue Ernest-Laval,, 92170 Commentaires : modification survenue sur la dénomination,
le capital (augmentation), l'adresse du siège social et l'administration.
Administration : commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET MAZARS
& GUERARD. Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : BONTOUX
(Patrick). |
|||
|
Bodacc C |
Avis de dépôt des comptes |
|
|
|
|
|||
|
5116 - RCS Nanterre B 572 180 198. RC 80-B
3689. P C M POMPES. Forme: S.A. Adresse du siège social: 17/19, rue Ernest
Laval,92170 Vanves. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre
2005. |
|||
|
Bodacc C |
Avis de dépôt des comptes |
|
|
|
|
|||
|
5156 - RCS Nanterre B 572 180 198. RC 80-B
3689. P C M POMPES. Forme: S.A. Adresse du siège social: 17/19, rue Ernest Laval,92170
Vanves. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004. |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
|
|||
|
2248 - RCS Nanterre B 572 180 198. RC 80-B 3689.
P.C.M. POMPES. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur
l'administration. Administration : administrateur partant : HUBERTY (Claude).
Nomination d'un administrateur : MARTIGNONI (Mario). |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
|
|||
|
1755 - RCS Nanterre B 572 180 198. RC 80-B
3689. P.C.M. POMPES. Forme : S.A. Nom commercial : P.C.M. PCM Pumps Delasco
Foodys. Commentaires : modification survenue sur l'administration. |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
|
|||
|
2397 - RCS Nanterre B 572 180 198. RC 80-B
3689. P.C.M. POMPES. Forme : S.A. Nom commercial : P.C.M. PCM Pumps Delasco Foodys.
Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration :
modification d'un administrateur : GEVELOT, représentée par MARTIGNONI
(Paolo). |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
|
|||
|
RCS Nanterre B 572180198 RC 80-B 3689 P.
C.M. POMPES. Forme : S.A Nom commercial: P.C.M. P.C.M. Pumps Delasco Foodys.
Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration :
nomination d'un administrateur : BARABINO (Roberto). |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
|
|||
|
RCS Nanterre B 572180198 RC 80-B 3689 P.
C.M. POMPES. Forme : S.A Nom commercial: P.C.M. P.C.M. Pumps Delasco Foodys. Commentaires
: modification survenue sur l'administration. Administration : modification
du P.-D.G. et administrateur : FAY (Jacques). |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
|
|||
|
RCS Nanterre B 572180198 RC 80-B 3689 P.
C.M. POMPES. Forme : S.A Nom commercial: P.C.M. P.C.M. Pumps Delasco Foodys.
Commentaires : modification survenue sur le nom commercial. |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
|
|||
|
RCS Nanterre B 572180198 RC 80-B 3689 P.
C.M. POMPES. Forme : S.A. Capital : 3 384 990 euros Nom commercial: P.C.M.
P.C. M. Pumps Delasco. Commentaires : modification survenue sur le capital (
augmentation) et l'administration. Administration : nomination d'un
administrateur : GEVELOT. |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
|
|||
|
RCS Nanterre B 572180198 RC 80-B 3689 P.
C.M. POMPES. Forme : S.A Nom commercial: P.C.M. P.C.M. Pumps Delasco. Commentaires
: modification survenue sur le nom commercial. |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
|
|||
|
RCS Nanterre B 572180198 RC 80-B 3689 P. C.M.
POMPES. Forme : S.A Nom commercial: P.C.M. P.C.M. Pumps Delasco P.C.M. GmbH.
Commentaires : modification survenue sur le nom commercial. |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
|
|||
|
RCS Nanterre B 572180198 RC 80-B 3689 P.
C.M. POMPES. Forme : S.A Nom commercial: P.C.M. Commentaires : modification
survenue sur la dénomination, le nom commercial et l'administration.
Administration : modification du président du conseil d'administration : FAY
(Jacques). |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
|
|||
|
RCS Nanterre B 572180198 RC 80-B 3689 P.
C.M. POMPES. Forme : S.A Nom commercial: P.C.M. Commentaires : modification
survenue sur l'administration. Administration : modification du président du
conseil d'administration : FAY (Jacques). Modification d'un administrateur :
DESTOURS (Philippe, Pierre, Marie, Ernest). |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
|
|||
|
RCS Nanterre B 572180198 RC 80-B 3689 P.
C.M. POMPES. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'
administration. Administration : administrateur partant : BIENAIME ( Daniel, Lucien,
Charles, Maurice). Nomination d'un administrateur : BIENAIME (Geoffroy,
Charlick, Robert). |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
|
|||
|
RCS Nanterre B 572180198 RC 80-B 3689 P. C.M.
POMPES. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'
administration. Administration : nomination d'un administrateur : FAY (
Jacques). Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET VILLARY GUERARD
VIALA. Nomination du commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS ET
GUERARD. |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
|
|||
|
*. RCS Nanterre B 572 180 198 RC 80-B 3689
P.C.M. POMPES. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration.
Administration : nomination en qualité d'administrateur : MARTIGNONI
(Roselyne). |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
|
|||
|
*. RCS Nanterre B 572 180 198 RC 80-B 3689 P.C.M.
POMPES. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur
l'administration. Administration : suppression : administrateur : BLOCMAN (
Alain). Nomination en qualité d' administrateur : HUBERTY (Claude). |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
|
|||
|
RCS Nanterre B 572 180 198 RC 80-B 3689
P.C.M. POMPES. Forme : S.A. Administration : président du conseil
d'administration : DESTOURS (Philippe, Pierre, Marie, Ernest).
Administrateurs : BIENAIME ( Claudine, Suzanne, Marguerite, Marie) BIENAIME
(Daniel, Lucien, Charles, Maurice) BLOCMAN (Alain) MARTIGNONI (Paolo,
Renato). Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VILLARY GUERARD VIALA.
Commissaire aux comptes suppléant : BAILLIN (Philippe). Commentaires :
modification survenue sur l'administration. |
|||
Na
|
|
Payment Information Summary - Trade Payment
Data |
|
|
|
Total number of Invoices available |
1 |
|
|
Total number of Invoices paid within or up
to 30 days after the due date |
1 |
|
|
Total number of Invoices paid more than 30 days
after the due date |
0 |
|
|
Total number of Invoices currently
outstanding where the due date has not yet been reached |
0 |
|
|
Total number of Invoices currently
outstanding beyond the due date |
0 |
|
|
Ultimate Holding Company |
|||
|
|
Company Name |
|
Company number |
|
|
|
GEVELOT |
|
562088542 |
|
|
|
Ultimate Parent |
1 ultimate
parent company for this company |
|
Group data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This company is a part of several groups,
choose the group you wish to see the structure
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Linkages |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trading to Date |
12/31/2011 |
12/31/2010 |
12/31/2009 |
|
Turnover |
85,157,193 € |
68,919,834 € |
60,713,869 € |
|
Gross Operating Surplus |
16,56 % Turnover |
20,52 % Turnover |
11,49 % Turnover |
|
Shareholders’ equity |
55,006,903 € |
49,238,439 € |
43,231,388 € |
|
Net result |
6,516,893 € |
6,642,710 € |
2,705,734 € |
|
Employees |
250 to 499 employees |
- |
- |
|
accounts |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na
|
|
Trends |
|
|
|
Profitability |
|
|
|
Liquidity |
|
|
|
Net worth |
|
|
|
Activity (APE) |
Fabrication d'autres pompes et compresseurs
(2813Z) |
||
|
|
RCS Registration |
RCS Nanterre 8 572 180 198 |
Share capital |
10,154,970 Euros |
|
|
Registration Court |
Nanterre (92) |
Legal form |
Public limited company with board of
directors |
|
|
Court Registry Number |
19 8 0B036 |
EUR VAT Number |
FR88572180198 |
|
|
Incorporation Date |
11/1957 |
Formation Date |
11/1957 |
|
|
Deregistration Date |
|
Last account Date |
31/12/2011 |
|
|
Nationality |
France |
||
|
|
Type |
Head office |
Status |
Economically active |
|
|
Formation Date |
01/2011 |
Reason for formation |
Formation |
|
|
Closure Date |
|
Reason for closure |
|
|
|
Reactivation Date |
|
Production Role |
|
|
|
Activity Nature |
Services |
Activity Location |
Other |
|
|
Location surface |
|
Seasonality |
|
|
|
Department |
|
Region |
Ile-de-France |
|
|
District |
|
Area |
|
|
|
City |
LEVALLOIS PERRET |
Size of urban area |
|
|
|
Branches |
7 branch entities
in this company |
|
|
Head office |
|
|
|
Secondary establishments |
> PCM -
Fabrication d'autres pompes et compresseurs (2813Z) in SALON DE PROVENCE
(13300) |
|
|
Regionality |
Legal unit with multiple establishments in many
areas having at least 50% of workforce in same area |
|
|
Mono-activity status |
Legal unit with multiple establishments
having main activities in many divisions, which one activity grouping from 80
to 99% of workforce |
|
|
Workforce at address |
3 to 5 employees |
Company workforce |
250 to 499 employees |
|
Date |
Description |
|
01/01/2012 |
Economically active |
|
Date |
Description |
|
02/10/2012 |
Consideration of a balance sheet that has
led to a reassessment of this company's creditworthiness |
|
28/09/2012 |
Bodacc B: Various editing or changing |
|
20/09/2012 |
Amendment |
|
20/09/2012 |
Changes to the Board of Directors |
|
13/09/2012 |
Consideration of a balance sheet that has
led to a reassessment of this company's creditworthiness |
|
14/08/2012 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
03/08/2012 |
Bodacc B: Various editing or changing |
|
26/07/2012 |
Changes to the Board of Directors |
|
26/07/2012 |
Amendment |
|
26/07/2012 |
New auditor |
|
19/02/2012 |
Bodacc B: Various editing or changing |
|
10/02/2012 |
Changes to the Board of Directors |
|
10/02/2012 |
Minutes of Board meeting |
|
10/02/2012 |
Amendment |
|
19/01/2012 |
Legal Gazette: Appointment of the social
representative |
|
11/01/2012 |
Bodacc B: Various editing or changing |
|
03/01/2012 |
New chairman (CEO, CoB) |
|
03/01/2012 |
Updated articles of association |
|
03/01/2012 |
Registered office transferred inside jurisdiction
of the Commercial Court |
|
03/01/2012 |
Amendment |
|
01/01/2012 |
Update of Company Head Office Identifier |
|
01/01/2012 |
Transfer of Establishment |
|
01/01/2012 |
Modification to Establishment Address or
Identifier |
|
31/12/2011 |
New accounts available |
|
26/12/2011 |
Legal Gazette: Resignation / Revocation of
the social representative |
|
02/12/2011 |
Legal Gazette: Head Office Transfer |
|
13/10/2011 |
Legal Gazette: Appointment of the social
representative |
|
02/09/2011 |
Update of participations in other companies |
|
02/09/2011 |
New subsidiarie(s) detected |
|
26/07/2011 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
16/07/2011 |
Consideration of a balance sheet that has
led to a reassessment of this company's creditworthiness |
|
01/01/2011 |
Formation of Establishment |
|
31/12/2010 |
New accounts available |
|
15/10/2010 |
New subsidiarie(s) detected |
|
19/08/2010 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
21/05/2010 |
Bodacc B: Various editing or changing |
|
07/05/2010 |
Appointment/resignation of company officers |
|
07/05/2010 |
Minutes of Board meeting |
|
07/05/2010 |
Amendment |
|
07/05/2010 |
Change to the administration of a public
limited company |
|
15/04/2010 |
Legal Gazette: Appointment of the social
representative |
|
31/12/2009 |
New accounts available |
|
12/08/2009 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
31/12/2008 |
New accounts available |
|
05/08/2008 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
24/07/2008 |
Bodacc B: Various editing or changing |
|
24/07/2008 |
New Bodacc B ads detected |
|
15/07/2008 |
Acte modificatif |
|
15/07/2008 |
Changement de Commissaire aux Comptes |
|
15/07/2008 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
15/07/2008 |
Appointment/resignation of company officers |
|
15/07/2008 |
Private document |
|
31/12/2007 |
New accounts available |
|
14/09/2007 |
Collection of preferential rights activated
for this company |
|
31/12/2006 |
New accounts available |
|
26/07/2006 |
New auditor |
|
26/07/2006 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
26/07/2006 |
Private document |
|
26/07/2006 |
Appointment/resignation of company officers |
|
26/07/2006 |
Acte modificatif |
|
26/07/2006 |
Changement de Commissaire aux Comptes |
|
26/07/2006 |
Updated articles of association |
|
26/07/2006 |
PV d'Assemblée |
|
26/07/2006 |
Augmentation de Capital |
|
26/07/2006 |
Capital increase |
|
26/07/2006 |
Prorogation de durée |
|
26/07/2006 |
Extension of term |
|
26/07/2006 |
Transfert du Siège dans le ressort du
Tribunal de Commerce |
|
26/07/2006 |
Registered office transferred inside
jurisdiction of the Commercial Court |
|
26/07/2006 |
Changement de dénomination sociale |
|
26/07/2006 |
New company name |
|
26/07/2006 |
Statuts mis à jour |
|
31/12/2005 |
New accounts available |
|
28/07/2005 |
PV d'Assemblée |
|
28/07/2005 |
Modification du Conseil d'Administration |
|
28/07/2005 |
Changes to the Board of Directors |
|
28/07/2005 |
Nomination/démission des organes de gestion |
|
28/07/2005 |
Appointment/resignation of company officers |
|
28/07/2005 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
28/07/2005 |
Private document |
|
28/07/2005 |
Acte sous seing privé |
|
16/05/2005 |
Nomination/démission des organes de gestion |
|
16/05/2005 |
Private document |
|
16/05/2005 |
Acte sous seing privé |
|
16/05/2005 |
Acte modificatif |
|
16/05/2005 |
Amendment |
|
08/03/2005 |
Nomination/démission des organes de gestion |
|
08/03/2005 |
Private document |
|
08/03/2005 |
Acte sous seing privé |
|
08/03/2005 |
Acte modificatif |
|
08/03/2005 |
Amendment |
|
31/12/2004 |
New accounts available |
|
15/09/2004 |
PV d'Assemblée |
|
15/09/2004 |
Appointment/resignation of company officers |
|
15/09/2004 |
Private document |
|
15/09/2004 |
Nomination/démission des organes de gestion |
|
15/09/2004 |
Modification du Conseil d'Administration |
|
15/09/2004 |
Changes to the Board of Directors |
|
15/09/2004 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
15/09/2004 |
Acte sous seing privé |
|
31/12/2003 |
New accounts available |
|
28/11/2002 |
Acte modificatif |
|
28/11/2002 |
Acte sous seing privé |
|
28/11/2002 |
Nomination/démission des organes de gestion |
|
28/11/2002 |
PV du Conseil d'Administration |
|
05/09/2002 |
Statuts mis à jour |
|
05/09/2002 |
Acte sous seing privé |
|
05/09/2002 |
PV d'Assemblée |
|
13/07/2001 |
Statuts mis à jour |
|
13/07/2001 |
Augmentation de Capital |
|
13/07/2001 |
Acte sous seing privé |
|
13/07/2001 |
Modification du Conseil d'Administration |
|
13/07/2001 |
Nomination/démission des organes de gestion |
|
13/07/2001 |
PV d'Assemblée |
|
13/07/2001 |
Conversion du Capital Social en Euros |
|
23/01/2001 |
Acte modificatif |
|
23/01/2001 |
Acte sous seing privé |
|
23/01/2001 |
Modification du Conseil d'Administration |
|
23/01/2001 |
Changement de Président (PDG, PCA) |
|
23/01/2001 |
Nomination/démission des organes de gestion |
|
23/01/2001 |
PV du Conseil d'Administration |
|
26/09/2000 |
PV du Conseil d'Administration |
|
26/09/2000 |
Acte modificatif |
|
26/09/2000 |
Acte sous seing privé |
|
26/09/2000 |
Modification du Conseil d'Administration |
|
26/09/2000 |
Changement de Commissaire aux Comptes |
|
26/09/2000 |
Nomination/démission des organes de gestion |
|
26/09/2000 |
PV d'Assemblée |
|
12/08/1999 |
Acte modificatif |
|
12/08/1999 |
PV du Conseil d'Administration |
|
12/08/1999 |
PV d'Assemblée |
|
12/08/1999 |
Modification du Conseil d'Administration |
|
12/08/1999 |
Nomination/démission des organes de gestion |
|
12/08/1999 |
Acte sous seing privé |
|
25/01/1995 |
Acte modificatif |
|
25/01/1995 |
PV d'Assemblée |
|
30/08/1994 |
Acte modificatif |
|
30/08/1994 |
PV d'Assemblée |
|
30/08/1994 |
Augmentation de Capital |
|
30/08/1994 |
Fusion |
|
30/08/1994 |
Statuts mis à jour |
|
30/08/1994 |
Déclaration de conformité |
|
22/06/1994 |
Acte modificatif |
|
22/06/1994 |
Rapport des Commissaires ou du Gérant |
|
25/05/1994 |
Requête et Ordonnance |
|
25/05/1994 |
Acte modificatif |
|
28/04/1994 |
Acte sous seing privé |
|
28/04/1994 |
Projet de Fusion |
|
28/04/1994 |
Acte modificatif |
|
23/07/1993 |
PV d'Assemblée |
|
23/07/1993 |
Acte modificatif |
|
Date |
Description |
|
13/09/2012 |
Update Rating |
|
08/09/2012 |
Update Rating |
|
01/01/2012 |
Modification of Head office |
|
01/01/2012 |
Modification of Head office (after
transfer) |
|
01/01/2011 |
Formation of Establishment |
Na
FOREIGN EXCHANGE RATES
|
Currency |
Unit
|
Indian Rupees |
|
US Dollar |
1 |
Rs.54.71 |
|
|
1 |
Rs.82.79 |
|
Euro |
1 |
Rs.71.43 |
INFORMATION DETAILS
|
Report
Prepared by : |
PRL |
RATING EXPLANATIONS
|
RATING |
STATUS |
PROPOSED CREDIT LINE |
|
|
>86 |
Aaa |
Possesses an extremely sound financial base with the strongest
capability for timely payment of interest and principal sums |
Unlimited |
|
71-85 |
Aa |
Possesses adequate working capital. No caution needed for credit
transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest
and principal sums |
Large |
|
56-70 |
A |
Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable
factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of
interest and principal sums |
Fairly Large |
|
41-55 |
Ba |
Overall operation is considered normal. Capable to meet normal
commitments. |
Satisfactory |
|
26-40 |
B |
Capability to overcome financial difficulties seems comparatively
below average. |
Small |
|
11-25 |
Ca |
Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums
in default or expected to be in default upon maturity |
Limited with full
security |
|
<10 |
C |
Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised |
Credit not
recommended |
|
-- |
NB |
New Business |
-- |
This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and
to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite
of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The
assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as
follows:
Financial
condition (40%) Ownership
background (20%) Payment
record (10%)
Credit history
(10%) Market trend
(10%) Operational
size (10%)
This report is issued at your request without any
risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL)
or its officials.