MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

08.11.2013

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

SAS FRIAL

 

 

Registered Office :

6 Rte De Caen, 14400 Saint Martin Des Entrees

 

 

Country :

France

 

 

Date of Incorporation :

September 1980

 

 

Com. Reg. No.:

19 8 0B40021

 

 

Legal Form :

Simplified joint stock company

 

 

Line of Business :

Fabrication of the place prepares

 

 

No. of Employees :

50 to 99

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

B

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

Small

 

Status :

Moderate 

 

 

Payment Behaviour :

Unknown 

 

 

Litigation :

Clear

 


NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail: infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31st, 2013

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2012)

Current Rating

(31.03.2013)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 

FRANCE - ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With at least 79 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that reduce income disparity and the impact of free markets on public health and welfare. France's real GDP contracted 2.6% in 2009, but recovered somewhat in 2010 and 2011, before stagnating in 2012. The unemployment rate increased from 7.4% in 2008 to 10.3% in 2012. Youth unemployment shot up to 24.2% during the third quarter of 2012 in metropolitan France. Lower-than-expected growth and high unemployment costs have strained France's public finances. The budget deficit rose sharply from 3.4% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 4.8% of GDP in 2012, while France's public debt rose from 68% of GDP to 90% over the same period. Under President SARKOZY, Paris implemented some austerity measures to bring the budget deficit under the 3% euro-zone ceiling by 2013 and to highlight France's commitment to fiscal discipline at a time of intense financial market scrutiny of euro-zone debt. Socialist Party candidate Francois HOLLANDE won the May 2012 presidential election, after advocating pro-growth economic policies, the separation of banks' traditional deposit taking and lending activities from more speculative businesses, increasing the top corporate and personal tax rates, and hiring an additional 60,000 teachers during his five-year term. The government's attempt to introduce a 75% wealth tax on income over one million euros for two years was struck down by the French Constitutional Council in December 2012 because it applied to individuals rather than households. France ratified the EU fiscal stability treaty in October 2012 and HOLLANDE's government has maintained France's commitment to meeting the budget deficit target of 3% of GDP during 2013 even amid signs that economic growth will be lower than the government's forecast of 0.8%. Despite stagnant growth and fiscal challenges, France's borrowing costs declined during the second half of 2012 to euro-era lows

Source : CIA


REGISTERED NAME & COMPANY SUMMARY

 

company summary

 

 

 

EUR VAT Number

FR52319805974

 

 

Activity (APE)

Fabrication de plats préparés (1085Z) (Fabrication of the place prepares)

Legal form

Simplified joint stock company

 

 

Phone

02 31 51 48 48

RCS Registration

RCS Caen 8 319 805 974

 

 

Fax

 

Share capital

4,352,000 Euros

 

 

Address

SAS FRIAL
6 RTE DE CAEN
14400 SAINT MARTIN DES ENTREES

Incorporated Date

09/1980

 

 

Nationality

France

Status

Economically active

 

 

Company details

 

 

 

Activity (APE)

Fabrication de plats préparés (1085Z)

 

RCS Registration

RCS Caen 8 319 805 974

Share capital

4,352,000 Euros

 

Registration Court

Caen (14)

Legal form

Simplified joint stock company

 

Court Registry Number

19 8 0B40021

EUR VAT Number

FR52319805974

 

Incorporation Date

09/1980

Formation Date

08/1980

 

Deregistration Date

 

Last account Date

N/A

 

Nationality

France

 

 

Establishment details

 

 

 

Activity (APE)

Fabrication de plats préparés (1085Z) (Fabrication of the place prepares)

Business Pages FT®

 

 

Postal Address

SAS FRIAL
6 RTE DE CAEN
14400 SAINT MARTIN DES ENTREES

Trading Address

6 ROUTE DE CAEN
14400 SAINT MARTIN DES ENTREES

 

Telephone

02 31 51 48 48

 

Fax

 

 

 

 

Type

Head office

Status

Economically active

 

Formation Date

08/1980

Reason for formation

Formation

 

Closure Date

 

Reason for closure

 

 

Reactivation Date

 

Production Role

 

 

Activity Nature

-

Activity Location

Other

 

Location surface

 

Seasonality

 

 

 

 

Department

Calvados (14)

Region

Basse-Normandie

 

District

1

Area

03

 

City

SAINT MARTIN DES ENTREES

Size of urban area

 

 

 

Other establishments

 

 

Branches

2 branch entities in this company

 

Head office

 
> SAS FRIAL <<<  - Fabrication de plats préparés (1085Z)  in SAINT MARTIN DES ENTREES  (14400)
 

 

Secondary establishments

>  SAS FRIAL  - Fabrication de plats préparés (1085Z)  in BAYEUX  (14400)

 

 

 

 

Regionality

Legal unit with all establishments in same area

 

Mono-activity status

Legal unit having all establishments with the same main activity

 

 

Workforces

 

 

Workforce at address

50 to 99 employees

Company workforce

50 to 99 employees

 

 

DIRECTORS/MANAGEMENT

 

Current Directors

2

 

 

directors

 

Name

M. PIRANDA JEAN-MARIE

 

Manager position

President of the supervisory council

Date of birth

06/04/1954

 

Place of birth

LAVIRON (25)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. RUSTICHELLI PHILIPPE

 

Manager position

President, President of the management board

Date of birth

07/01/1960

 

Place of birth

MARSEILLE 06 (13)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Directors

 

View the directors history for this company
If you want to view the directors history, please click on the link view details.

 

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

 

President

M PIERRE ESNEE

23/05/1966 - BAYEUX

 

President

M JEAN-MARIE PIRANDA

06/04/1954 - LAVIRON

 

President

M JEAN-MARIE PIRANDA

06/04/1954 - LAVIRON (25)

 

Managing director

M THIERRY DUPONT

16/12/1956 - BAYEUX

 

Managing director

M JEAN-MARIE PIRANDA

06/04/1954 - LAVIRON

 

Managing director

M JEAN-LUC PUECH

- - -

 

 

 

NEGATIVE INFORMATION

 

judgements

Collective procedures

 

No judgment information for the company

   Social security, pension funds preferential rights | Tax office preferential rights

Preferential rights details and history

Summary of preferential rights

Company monitored since

30/07/2008

 

 

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

 

 

SHARE & SHARE CAPITAL INFORMATION

 

Share capital

4,352,000 Euros

 

 

PAYMENT INFORMATION

 

Na

 

 

GROUP STRUCTURE & AFFILIATED COMPANIES

 

Ultimate Holding Company

 

Company Name

Safe Number

 

Company number

Click here to view the affiliation links

 

FROZEN HOLDING

LU00182975

 

B136588

 

 

 

Group data

Ultimate parent company

FROZEN HOLDING

Direct parent

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET PRODUCTION EN AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION - 95 %

Group – Number of companies

7

Linkages – Number of companies

-

Number of countries

-

Group Structure

Go directly to the current company

Display only where participation % > 33 %

 

Linkages

Ultimate parent company

FROZEN HOLDING

Direct parent

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET PRODUCTION EN AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION - 95 %

Group – Number of companies

7

Linkages – Number of companies

-

Number of countries

-

Linkages

No Linkages information available for the company

 

 

FINANCIAL INFORMATION

 

Na

 

 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Na

 

 

ADDITIONAL INFORMATION

 

No social security and tax office preferential right to date

Commentary

The comments are ordered according to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative for another or can change depending on its value. This is a purely statistical decision.

 

 

Financial statements overdue. The latest Creditsafe risk score has taken this into account, please contact Creditsafe with your latest financial statements if you want the risk score to be recalculated

 

High risk workforce size

 

The company is 33 years old

 

Industry code with low risk rating

Rating and Limit history

There is no rating and limit history available for this company

Linkages

Company Name

 

Safe Number

SIREN

Parts

Rating

Limit

Last account published

FROZEN HOLDING S.A.

 

LU00182975

B136588

-

NC

-

-

GLACIES HOLDING

 

FR08665056

485376479

100%

99

7 500 €

31/01/2007

DEVEL PROD AGRO ALIMENT RESTAUR

 

FR07872360

477890388

100%

NC

-

31/12/2006

SAS FRIAL

 

FR00956341

319805974

95%

20

0 €

-

ERIMER

 

FR14108741

408515286

85%

55

180 000 €

31/03/2009

SARL SAINT GUEFROID

 

FR02409116

353485428

99%

67

50 000 €

31/03/2011

COFA

 

FR01895168

342661535

100%

80

765 000 €

31/03/2012

 

event history

Status history

 

 

No Status History

 

 

Recent publications in Gazettes

 

 

Publication date

Gazette Name

Description

 

30/10/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

14 - CALVADOS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

302 - 319 805 974 RCS Caen. FRIAL. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président, Président du directoire : RUSTICHELLI Philippe Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : PIRANDA Jean-Marie Membre du conseil de surveillance : VER HULST Nicolas Membre du conseil de surveillance : HERMAN Patrick Membre du conseil de surveillance : KORDES Olaf Membre du conseil de surveillance : VAISSIE Paul Commissaire aux comptes titulaire : SA CABINET KRIBS (SA) Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : KRIBS Roger Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves. Activité : .
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

12/10/2013

JAL

Appointment of the social representative

 

 

Manche libre (La)


Date de décision : 30/09/2013
Société faisant l'objet d'une nomination : 319805974 - SAS FRIAL, 6 RTE DE CAEN, 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Nominé : Monsieur Jean-Marie PIRANDA, 14400 BAYEUX
En la fonction de : Président du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Philippe RUSTICHELLI, 14390 CABOURG
En la fonction de : Président du Directoire
Nominé : Monsieur Paul VAISSIÉ, 75015 PARIS 15
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Olaf KORDES, 92400 COURBEVOIE
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Patrick Herman, 1000 BRUXELLES
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Nicolas VER HULST, 75009 PARIS 09
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Jean-Marie PIRANDA, 14400 BAYEUX
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance

12/10/2013

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

Manche libre (La)


Date de décision : 30/09/2013
La société 319805974 - SAS FRIAL, 6 RTE DE CAEN, 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Fait l'objet du départ de Monsieur Jean-Marie PIRANDA

13/11/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

14 - CALVADOS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

310 - 319 805 974 RCS Caen. FRIAL. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président : PIRANDA Jean-Marie Commissaire aux comptes titulaire : SA CABINET KRIBS (SA) Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : KRIBS Roger Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves.
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

28/05/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

14 - CALVADOS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYEUX

427 - 319 805 974 RCS Bayeux. FRIAL. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président : PIRANDA Jean-MarieCommissaire aux comptes titulaire : SA CABINET KRIBS (SA). Commissaire aux comptes suppléant : KRIBS Roger.
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

23/10/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

648 - RCS Bayeux B 319 805 974. RC 80-B 21. FRIAL. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : route de Caen,, 14400 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président : ESNEE (Pierre) (Nom d'usage : ESNEE). Directeurs généraux : DUPONT (Thierry) (Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean-Marie) (Nom d'usage : PIRANDA). Commissaire aux comptes titulaire : S.A. CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : SCHMITT (Pierre) (Nom d'usage : SCHMITT). Date d'effet : 23 juillet 2007.

20/03/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

150 - RCS Bayeux B 319 805 974. RC 80-B 21. FRIAL. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : route de Caen,, 14400 Commentaires : modification survenue sur la forme juridique et l'administration. Ancienne forme juridique : S.A. Administration : nouveau président : ESNEE (Pierre) (Nom d'usage : ESNEE), ancien président directeur général. Nomination en qualité de directeurs généraux : DUPONT (Thierry) (Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean-Marie) (Nom d'usage : PIRANDA) PUECH (Jean-Luc) (Nom d'usage : PUECH). Commissaire aux comptes titulaire maintenu : S.A. CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : SCHMITT (Pierre) (Nom d'usage : SCHMITT). Anciens administrateurs : ESNEE (Pierre) ESNEE (Jacques) SOCIETE SCDHH DUPONT (Thierry) PIRANDA (Jean-Marie) PUECH (Jean-Luc). Ancien commissaire aux comptes suppléant : GANDON (Gérard). Date d'effet : 16 décembre 2004.

25/11/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : route de Caen, 14400 Saint-Martin-des- Entrées. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président directeur général : ESNEE (Pierre) ( Nom d'usage : ESNEE). Directeurs généraux délégués et administrateurs : ESNEE (Jacques) ( Nom d'usage : ESNEE) DUPONT (Thierry) ( Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean, Marie) ( Nom d'usage : PIRANDA). Administrateurs : PUECH (Jean-Luc) ( Nom d'usage : PUECH). Nouvel administrateur : S.C. DE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET HOSPITALIER-S.C.D.H., représentée par ESNEE (Pierre) ( Nom d' usage : ESNEE). Commissaire aux comptes : S.A. CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : GANDON (Gérard) ( Nom d'usage : GANDON). Date d'effet : 22 juillet 2004.

25/07/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 4 352 000 euros. Adresse du siège social : route de Caen, 14400 Saint-Martin-des-Entrées. Commentaires : modification survenue sur le capital (diminution). Date d'effet : 3 mai 2004.

08/08/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées, 14400 Bayeux. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président directeur général : ESNEE (Pierre) ( Nom d'usage : ESNEE). Directeurs généraux délégués et administrateurs : ESNEE (Jacques) ( Nom d'usage : ESNEE) DUPONT (Thierry) ( Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean, Marie) ( Nom d'usage : PIRANDA). Administrateurs : ESNEE (Nathalie) ( Nom d'usage : ESCLAPEZ) PUECH (Jean- Luc) ( Nom d'usage : PUECH). Commissaire aux comptes : S.A. CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : GANDON (Gérard) ( Nom d' usage : GANDON). Date d'effet : 23 mai 2003.

16/03/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées, 14400 Bayeux. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : Président directeur général : ESNEE (Jacques) ( Nom d'usage ESNEE) directeurs généraux délégués : DUPONT (Thierry) ( Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean, Marie) ( Nom d' usage : PIRANDA). Administrateurs : ESNEE (Nathalie) ( Nom d'usage : ESCLAPEZ) ESNEE (Pierre) ( Nom d' usage : ESNEE) PUECH (Jean-Luc) ( Nom d'usage : PUECH). Commissaire aux comptes : S.A. CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : GANDON (Gérard) ( Nom d'usage : GANDON). Date d'effet : 21 juin 2002.

14/11/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 4 599 040 euros. Adresse du siège social : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées, 14400 Bayeux. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation et conversion en euros). Date d'effet : 22 juin 2001.

06/08/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 13 423 448 F. Activité : achat, vente de tous produits alimentaires surgelés, congelés et de conserves, pour une consommation humaine ou animale gestion de participations. Adresse du siège social : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées, 14400 Bayeux. Commentaires : modification survenue sur l'activité. Date d'effet : 9 juin 2000.

31/10/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Bayeux B 319 805 974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 13 423 448 F. Adresse du siège social : route de Caen Saint-Martin-des-Entrées 14400 Bayeux. Administration : ancien commissaire aux comptes titulaire : KRIBS (Roger). Nouveau commissaire aux comptes titulaire : S.A. CABINET KRIBS. Date d'effet : 19 juin 1998.

26/11/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

Ancienne situation du siège social. RCS Bayeux B 319 805 974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 5 389 500 F. Adresse : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées 14400 Bayeux Nouvelle situation du siège social. Capital : 13 423 448 F. Date d'effet : 28 juin 1996.

10/10/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Bayeux B 319 805 974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 5 389 500. Adresse du siège social : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées 14400 Bayeux. Administration : renouvellement des mandats des administrateurs : ESNEE ( Jacques) DUPONT (Thierry) ESCLAPEZ ( Nathalie). Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration : ESNEE (Jacques). Renouvellement des mandats des directeurs généraux : DUPONT (Thierry) et PIRANDA (Jean-Marie) à compter du:19 juin 1995 Nouvel administrateur : PIRANDA (Jean-Marie). Date d'effet : 17 juillet 1995.

Company events history

 

 

Date

Description

30/10/2013

Bodacc B: Various editing or changing

16/10/2013

Updated articles of association

16/10/2013

Amendment

12/10/2013

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

30/09/2013

Legal Gazette: Appointment of the social representative

25/02/2013

Minutes of general meeting of shareholders

25/02/2013

Updated articles of association

15/10/2010

New shareholders detected

15/10/2010

New subsidiarie(s) detected

15/10/2010

New ultimate parent

15/10/2010

New parent detected

13/11/2009

Bodacc B: Various editing or changing

27/10/2009

Minutes of general meeting of shareholders

27/10/2009

PV d'Assemblée

30/07/2008

Collection of preferential rights activated for this company

28/05/2008

Bodacc B: Various editing or changing

28/05/2008

New Bodacc B ads detected

15/05/2008

Statuts mis à jour

15/05/2008

Appointment/resignation of company officers

15/05/2008

Updated articles of association

15/05/2008

Private document

15/05/2008

PV d'Assemblée

15/05/2008

Minutes of general meeting of shareholders

15/05/2008

Changement de Commissaire aux Comptes

18/10/2007

PV d'Assemblée

18/10/2007

Private document

18/10/2007

Amendment

18/10/2007

Minutes of general meeting of shareholders

19/09/2007

Appointment/resignation of company officers

19/09/2007

PV d'Assemblée

19/09/2007

Private document

19/09/2007

Minutes of general meeting of shareholders

24/10/2005

Acte sous seing privé

24/10/2005

Private document

24/10/2005

Private document

24/10/2005

Minutes of general meeting of shareholders

24/10/2005

PV d'Assemblée

24/10/2005

Minutes of general meeting of shareholders

24/10/2005

Acte modificatif

24/10/2005

Amendment

24/10/2005

Amendment

14/01/2005

New legal form – no new category

14/01/2005

Private document

14/01/2005

Minutes of general meeting of shareholders

14/01/2005

PV d'Assemblée

14/01/2005

Minutes of general meeting of shareholders

14/01/2005

Appointment/resignation of company officers

14/01/2005

Nomination/démission des organes de gestion

14/01/2005

Appointment/resignation of company officers

14/01/2005

Changement de Forme Juridique sans changement de catégorie

14/01/2005

Changement de Forme Juridique avec changement de catégorie

14/01/2005

Acte modificatif

14/01/2005

Private document

14/01/2005

Updated articles of association

14/01/2005

Updated articles of association

14/01/2005

Changement de Commissaire aux Comptes

14/01/2005

New auditor

14/01/2005

New auditor

14/01/2005

Statuts mis à jour

14/01/2005

Acte sous seing privé

14/01/2005

New legal form – no new category

14/10/2004

PV du Conseil d'Administration

14/10/2004

Minutes of Board meeting

14/10/2004

Appointment/resignation of company officers

14/10/2004

Nomination/démission des organes de gestion

14/10/2004

Appointment/resignation of company officers

14/10/2004

Private document

14/10/2004

Minutes of Board meeting

14/10/2004

Acte sous seing privé

14/10/2004

Changes to the Board of Directors

14/10/2004

Modification du Conseil d'Administration

14/10/2004

Changes to the Board of Directors

14/10/2004

Acte modificatif

14/10/2004

Private document

24/06/2004

Updated articles of association

24/06/2004

Acte modificatif

24/06/2004

Capital reduction

24/06/2004

Réduction de Capital

24/06/2004

Capital reduction

24/06/2004

Acte sous seing privé

24/06/2004

Private document

24/06/2004

Private document

24/06/2004

PV d'Assemblée

24/06/2004

Minutes of Board meeting

24/06/2004

PV du Conseil d'Administration

24/06/2004

Minutes of Board meeting

24/06/2004

Statuts mis à jour

24/06/2004

Updated articles of association

16/03/2004

Capital reduction

16/03/2004

Private document

16/03/2004

Acte sous seing privé

16/03/2004

Minutes of general meeting of shareholders

16/03/2004

Réduction de Capital

16/03/2004

Acte modificatif

16/03/2004

PV d'Assemblée

01/07/2003

Nomination/démission des organes de gestion

01/07/2003

Changement de Président (PDG, PCA)

01/07/2003

Acte modificatif

01/07/2003

PV du Conseil d'Administration

01/07/2003

Modification du Conseil d'Administration

01/07/2003

Acte sous seing privé

05/02/2003

Acte modificatif

05/02/2003

Statuts mis à jour

05/02/2003

PV du Conseil d'Administration

05/02/2003

Nomination/démission des organes de gestion

05/02/2003

Acte sous seing privé

05/02/2003

PV d'Assemblée

05/02/2003

Modification du Conseil d'Administration

20/12/2002

Acte modificatif

20/12/2002

Requête et Ordonnance

02/10/2001

PV d'Assemblée

02/10/2001

Conversion du Capital Social en Euros

02/10/2001

Augmentation de Capital

02/10/2001

Acte modificatif

02/10/2001

Acte sous seing privé

02/10/2001

Statuts mis à jour

02/10/2001

PV du Conseil d'Administration

13/07/2000

Modification de l'objet social

13/07/2000

Acte modificatif

13/07/2000

Statuts mis à jour

13/07/2000

Acte sous seing privé

13/07/2000

PV d'Assemblée

10/09/1999

PV d'Assemblée

10/09/1999

Nomination/démission des organes de gestion

10/09/1999

Acte sous seing privé

10/09/1999

Acte modificatif

02/09/1998

Acte modificatif

02/09/1998

PV d'Assemblée

02/09/1998

Nomination/démission des organes de gestion

02/09/1998

Acte sous seing privé

29/08/1996

Augmentation de Capital

29/08/1996

Acte modificatif

29/08/1996

PV d'Assemblée

29/08/1996

Statuts mis à jour

24/08/1995

Acte modificatif

24/08/1995

PV du Conseil d'Administration

24/08/1995

PV d'Assemblée

24/08/1995

Nomination/démission des organes de gestion

27/01/1995

Acte modificatif

27/01/1995

Cession de parts

27/01/1995

Expédition acte notarié

28/12/1993

PV d'Assemblée

28/12/1993

Acte modificatif

05/03/1993

Déclaration de conformité

05/03/1993

Statuts mis à jour

05/03/1993

PV du Conseil d'Administration

05/03/1993

PV d'Assemblée

05/03/1993

Acte modificatif

05/03/1993

Augmentation de Capital

23/01/1993

Statuts mis à jour

23/01/1993

PV du Conseil d'Administration

23/01/1993

Déclaration de conformité

23/01/1993

PV d'Assemblée

23/01/1993

Augmentation de Capital

23/01/1993

Acte modificatif

09/09/1992

Nomination/démission des organes de gestion

09/09/1992

PV du Conseil d'Administration

09/09/1992

PV d'Assemblée

09/09/1992

Changement de Président (PDG, PCA)

09/09/1992

Acte modificatif

09/09/1992

Modification du Conseil d'Administration

27/11/1991

Cession de parts

27/11/1991

Expédition acte notarié

 

 

 

 

 

 

 

NOTES & COMMENTS

 

Na

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.62.57

UK Pound

1

Rs.100.62

Euro

1

Rs.84.62

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Report Prepared by :

PDT

 

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Maket trend (10%)                                 Operational size (10%)

MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

08.11.2013

 

 

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

SAS FRIAL

 

 

Registered Office :

6 Rte De Caen, 14400 Saint Martin Des Entrees

 

 

Country :

France

 

 

Date of Incorporation :

September 1980

 

 

Com. Reg. No.:

19 8 0B40021

 

 

Legal Form :

Simplified joint stock company

 

 

Line of Business :

Fabrication of the place prepares

 

 

No. of Employees :

50 to 99

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

B

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

Small

 

Status :

Moderate 

 

 

Payment Behaviour :

Unknown 

 

 

Litigation :

Clear

 


NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail: infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31st, 2013

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2012)

Current Rating

(31.03.2013)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 

FRANCE - ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With at least 79 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that reduce income disparity and the impact of free markets on public health and welfare. France's real GDP contracted 2.6% in 2009, but recovered somewhat in 2010 and 2011, before stagnating in 2012. The unemployment rate increased from 7.4% in 2008 to 10.3% in 2012. Youth unemployment shot up to 24.2% during the third quarter of 2012 in metropolitan France. Lower-than-expected growth and high unemployment costs have strained France's public finances. The budget deficit rose sharply from 3.4% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 4.8% of GDP in 2012, while France's public debt rose from 68% of GDP to 90% over the same period. Under President SARKOZY, Paris implemented some austerity measures to bring the budget deficit under the 3% euro-zone ceiling by 2013 and to highlight France's commitment to fiscal discipline at a time of intense financial market scrutiny of euro-zone debt. Socialist Party candidate Francois HOLLANDE won the May 2012 presidential election, after advocating pro-growth economic policies, the separation of banks' traditional deposit taking and lending activities from more speculative businesses, increasing the top corporate and personal tax rates, and hiring an additional 60,000 teachers during his five-year term. The government's attempt to introduce a 75% wealth tax on income over one million euros for two years was struck down by the French Constitutional Council in December 2012 because it applied to individuals rather than households. France ratified the EU fiscal stability treaty in October 2012 and HOLLANDE's government has maintained France's commitment to meeting the budget deficit target of 3% of GDP during 2013 even amid signs that economic growth will be lower than the government's forecast of 0.8%. Despite stagnant growth and fiscal challenges, France's borrowing costs declined during the second half of 2012 to euro-era lows

Source : CIA


REGISTERED NAME & COMPANY SUMMARY

 

company summary

 

 

 

EUR VAT Number

FR52319805974

 

 

Activity (APE)

Fabrication de plats préparés (1085Z) (Fabrication of the place prepares)

Legal form

Simplified joint stock company

 

 

Phone

02 31 51 48 48

RCS Registration

RCS Caen 8 319 805 974

 

 

Fax

 

Share capital

4,352,000 Euros

 

 

Address

SAS FRIAL
6 RTE DE CAEN
14400 SAINT MARTIN DES ENTREES

Incorporated Date

09/1980

 

 

Nationality

France

Status

Economically active

 

 

Company details

 

 

 

Activity (APE)

Fabrication de plats préparés (1085Z)

 

RCS Registration

RCS Caen 8 319 805 974

Share capital

4,352,000 Euros

 

Registration Court

Caen (14)

Legal form

Simplified joint stock company

 

Court Registry Number

19 8 0B40021

EUR VAT Number

FR52319805974

 

Incorporation Date

09/1980

Formation Date

08/1980

 

Deregistration Date

 

Last account Date

N/A

 

Nationality

France

 

 

Establishment details

 

 

 

Activity (APE)

Fabrication de plats préparés (1085Z) (Fabrication of the place prepares)

Business Pages FT®

 

 

Postal Address

SAS FRIAL
6 RTE DE CAEN
14400 SAINT MARTIN DES ENTREES

Trading Address

6 ROUTE DE CAEN
14400 SAINT MARTIN DES ENTREES

 

Telephone

02 31 51 48 48

 

Fax

 

 

 

 

Type

Head office

Status

Economically active

 

Formation Date

08/1980

Reason for formation

Formation

 

Closure Date

 

Reason for closure

 

 

Reactivation Date

 

Production Role

 

 

Activity Nature

-

Activity Location

Other

 

Location surface

 

Seasonality

 

 

 

 

Department

Calvados (14)

Region

Basse-Normandie

 

District

1

Area

03

 

City

SAINT MARTIN DES ENTREES

Size of urban area

 

 

 

Other establishments

 

 

Branches

2 branch entities in this company

 

Head office

 
> SAS FRIAL <<<  - Fabrication de plats préparés (1085Z)  in SAINT MARTIN DES ENTREES  (14400)
 

 

Secondary establishments

>  SAS FRIAL  - Fabrication de plats préparés (1085Z)  in BAYEUX  (14400)

 

 

 

 

Regionality

Legal unit with all establishments in same area

 

Mono-activity status

Legal unit having all establishments with the same main activity

 

 

Workforces

 

 

Workforce at address

50 to 99 employees

Company workforce

50 to 99 employees

 

 

DIRECTORS/MANAGEMENT

 

Current Directors

2

 

 

directors

 

Name

M. PIRANDA JEAN-MARIE

 

Manager position

President of the supervisory council

Date of birth

06/04/1954

 

Place of birth

LAVIRON (25)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. RUSTICHELLI PHILIPPE

 

Manager position

President, President of the management board

Date of birth

07/01/1960

 

Place of birth

MARSEILLE 06 (13)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Directors

 

View the directors history for this company
If you want to view the directors history, please click on the link view details.

 

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

 

President

M PIERRE ESNEE

23/05/1966 - BAYEUX

 

President

M JEAN-MARIE PIRANDA

06/04/1954 - LAVIRON

 

President

M JEAN-MARIE PIRANDA

06/04/1954 - LAVIRON (25)

 

Managing director

M THIERRY DUPONT

16/12/1956 - BAYEUX

 

Managing director

M JEAN-MARIE PIRANDA

06/04/1954 - LAVIRON

 

Managing director

M JEAN-LUC PUECH

- - -

 

 

 

NEGATIVE INFORMATION

 

judgements

Collective procedures

 

No judgment information for the company

   Social security, pension funds preferential rights | Tax office preferential rights

Preferential rights details and history

Summary of preferential rights

Company monitored since

30/07/2008

 

 

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

 

 

SHARE & SHARE CAPITAL INFORMATION

 

Share capital

4,352,000 Euros

 

 

PAYMENT INFORMATION

 

Na

 

 

GROUP STRUCTURE & AFFILIATED COMPANIES

 

Ultimate Holding Company

 

Company Name

Safe Number

 

Company number

Click here to view the affiliation links

 

FROZEN HOLDING

LU00182975

 

B136588

 

 

 

Group data

Ultimate parent company

FROZEN HOLDING

Direct parent

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET PRODUCTION EN AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION - 95 %

Group – Number of companies

7

Linkages – Number of companies

-

Number of countries

-

Group Structure

Go directly to the current company

Display only where participation % > 33 %

 

Linkages

Ultimate parent company

FROZEN HOLDING

Direct parent

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET PRODUCTION EN AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION - 95 %

Group – Number of companies

7

Linkages – Number of companies

-

Number of countries

-

Linkages

No Linkages information available for the company

 

 

FINANCIAL INFORMATION

 

Na

 

 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Na

 

 

ADDITIONAL INFORMATION

 

No social security and tax office preferential right to date

Commentary

The comments are ordered according to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative for another or can change depending on its value. This is a purely statistical decision.

 

 

Financial statements overdue. The latest Creditsafe risk score has taken this into account, please contact Creditsafe with your latest financial statements if you want the risk score to be recalculated

 

High risk workforce size

 

The company is 33 years old

 

Industry code with low risk rating

Rating and Limit history

There is no rating and limit history available for this company

Linkages

Company Name

 

Safe Number

SIREN

Parts

Rating

Limit

Last account published

FROZEN HOLDING S.A.

 

LU00182975

B136588

-

NC

-

-

GLACIES HOLDING

 

FR08665056

485376479

100%

99

7 500 €

31/01/2007

DEVEL PROD AGRO ALIMENT RESTAUR

 

FR07872360

477890388

100%

NC

-

31/12/2006

SAS FRIAL

 

FR00956341

319805974

95%

20

0 €

-

ERIMER

 

FR14108741

408515286

85%

55

180 000 €

31/03/2009

SARL SAINT GUEFROID

 

FR02409116

353485428

99%

67

50 000 €

31/03/2011

COFA

 

FR01895168

342661535

100%

80

765 000 €

31/03/2012

 

event history

Status history

 

 

No Status History

 

 

Recent publications in Gazettes

 

 

Publication date

Gazette Name

Description

 

30/10/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

14 - CALVADOS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

302 - 319 805 974 RCS Caen. FRIAL. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président, Président du directoire : RUSTICHELLI Philippe Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : PIRANDA Jean-Marie Membre du conseil de surveillance : VER HULST Nicolas Membre du conseil de surveillance : HERMAN Patrick Membre du conseil de surveillance : KORDES Olaf Membre du conseil de surveillance : VAISSIE Paul Commissaire aux comptes titulaire : SA CABINET KRIBS (SA) Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : KRIBS Roger Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves. Activité : .
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

12/10/2013

JAL

Appointment of the social representative

 

 

Manche libre (La)


Date de décision : 30/09/2013
Société faisant l'objet d'une nomination : 319805974 - SAS FRIAL, 6 RTE DE CAEN, 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Nominé : Monsieur Jean-Marie PIRANDA, 14400 BAYEUX
En la fonction de : Président du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Philippe RUSTICHELLI, 14390 CABOURG
En la fonction de : Président du Directoire
Nominé : Monsieur Paul VAISSIÉ, 75015 PARIS 15
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Olaf KORDES, 92400 COURBEVOIE
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Patrick Herman, 1000 BRUXELLES
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Nicolas VER HULST, 75009 PARIS 09
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Jean-Marie PIRANDA, 14400 BAYEUX
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance

12/10/2013

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

Manche libre (La)


Date de décision : 30/09/2013
La société 319805974 - SAS FRIAL, 6 RTE DE CAEN, 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Fait l'objet du départ de Monsieur Jean-Marie PIRANDA

13/11/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

14 - CALVADOS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

310 - 319 805 974 RCS Caen. FRIAL. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président : PIRANDA Jean-Marie Commissaire aux comptes titulaire : SA CABINET KRIBS (SA) Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : KRIBS Roger Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves.
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

28/05/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

14 - CALVADOS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYEUX

427 - 319 805 974 RCS Bayeux. FRIAL. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président : PIRANDA Jean-MarieCommissaire aux comptes titulaire : SA CABINET KRIBS (SA). Commissaire aux comptes suppléant : KRIBS Roger.
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

23/10/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

648 - RCS Bayeux B 319 805 974. RC 80-B 21. FRIAL. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : route de Caen,, 14400 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président : ESNEE (Pierre) (Nom d'usage : ESNEE). Directeurs généraux : DUPONT (Thierry) (Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean-Marie) (Nom d'usage : PIRANDA). Commissaire aux comptes titulaire : S.A. CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : SCHMITT (Pierre) (Nom d'usage : SCHMITT). Date d'effet : 23 juillet 2007.

20/03/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

150 - RCS Bayeux B 319 805 974. RC 80-B 21. FRIAL. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : route de Caen,, 14400 Commentaires : modification survenue sur la forme juridique et l'administration. Ancienne forme juridique : S.A. Administration : nouveau président : ESNEE (Pierre) (Nom d'usage : ESNEE), ancien président directeur général. Nomination en qualité de directeurs généraux : DUPONT (Thierry) (Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean-Marie) (Nom d'usage : PIRANDA) PUECH (Jean-Luc) (Nom d'usage : PUECH). Commissaire aux comptes titulaire maintenu : S.A. CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : SCHMITT (Pierre) (Nom d'usage : SCHMITT). Anciens administrateurs : ESNEE (Pierre) ESNEE (Jacques) SOCIETE SCDHH DUPONT (Thierry) PIRANDA (Jean-Marie) PUECH (Jean-Luc). Ancien commissaire aux comptes suppléant : GANDON (Gérard). Date d'effet : 16 décembre 2004.

25/11/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : route de Caen, 14400 Saint-Martin-des- Entrées. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président directeur général : ESNEE (Pierre) ( Nom d'usage : ESNEE). Directeurs généraux délégués et administrateurs : ESNEE (Jacques) ( Nom d'usage : ESNEE) DUPONT (Thierry) ( Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean, Marie) ( Nom d'usage : PIRANDA). Administrateurs : PUECH (Jean-Luc) ( Nom d'usage : PUECH). Nouvel administrateur : S.C. DE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET HOSPITALIER-S.C.D.H., représentée par ESNEE (Pierre) ( Nom d' usage : ESNEE). Commissaire aux comptes : S.A. CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : GANDON (Gérard) ( Nom d'usage : GANDON). Date d'effet : 22 juillet 2004.

25/07/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 4 352 000 euros. Adresse du siège social : route de Caen, 14400 Saint-Martin-des-Entrées. Commentaires : modification survenue sur le capital (diminution). Date d'effet : 3 mai 2004.

08/08/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées, 14400 Bayeux. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président directeur général : ESNEE (Pierre) ( Nom d'usage : ESNEE). Directeurs généraux délégués et administrateurs : ESNEE (Jacques) ( Nom d'usage : ESNEE) DUPONT (Thierry) ( Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean, Marie) ( Nom d'usage : PIRANDA). Administrateurs : ESNEE (Nathalie) ( Nom d'usage : ESCLAPEZ) PUECH (Jean- Luc) ( Nom d'usage : PUECH). Commissaire aux comptes : S.A. CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : GANDON (Gérard) ( Nom d' usage : GANDON). Date d'effet : 23 mai 2003.

16/03/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées, 14400 Bayeux. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : Président directeur général : ESNEE (Jacques) ( Nom d'usage ESNEE) directeurs généraux délégués : DUPONT (Thierry) ( Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean, Marie) ( Nom d' usage : PIRANDA). Administrateurs : ESNEE (Nathalie) ( Nom d'usage : ESCLAPEZ) ESNEE (Pierre) ( Nom d' usage : ESNEE) PUECH (Jean-Luc) ( Nom d'usage : PUECH). Commissaire aux comptes : S.A. CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : GANDON (Gérard) ( Nom d'usage : GANDON). Date d'effet : 21 juin 2002.

14/11/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 4 599 040 euros. Adresse du siège social : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées, 14400 Bayeux. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation et conversion en euros). Date d'effet : 22 juin 2001.

06/08/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 13 423 448 F. Activité : achat, vente de tous produits alimentaires surgelés, congelés et de conserves, pour une consommation humaine ou animale gestion de participations. Adresse du siège social : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées, 14400 Bayeux. Commentaires : modification survenue sur l'activité. Date d'effet : 9 juin 2000.

31/10/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Bayeux B 319 805 974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 13 423 448 F. Adresse du siège social : route de Caen Saint-Martin-des-Entrées 14400 Bayeux. Administration : ancien commissaire aux comptes titulaire : KRIBS (Roger). Nouveau commissaire aux comptes titulaire : S.A. CABINET KRIBS. Date d'effet : 19 juin 1998.

26/11/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

Ancienne situation du siège social. RCS Bayeux B 319 805 974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 5 389 500 F. Adresse : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées 14400 Bayeux Nouvelle situation du siège social. Capital : 13 423 448 F. Date d'effet : 28 juin 1996.

10/10/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Bayeux B 319 805 974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 5 389 500. Adresse du siège social : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées 14400 Bayeux. Administration : renouvellement des mandats des administrateurs : ESNEE ( Jacques) DUPONT (Thierry) ESCLAPEZ ( Nathalie). Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration : ESNEE (Jacques). Renouvellement des mandats des directeurs généraux : DUPONT (Thierry) et PIRANDA (Jean-Marie) à compter du:19 juin 1995 Nouvel administrateur : PIRANDA (Jean-Marie). Date d'effet : 17 juillet 1995.

Company events history

 

 

Date

Description

30/10/2013

Bodacc B: Various editing or changing

16/10/2013

Updated articles of association

16/10/2013

Amendment

12/10/2013

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

30/09/2013

Legal Gazette: Appointment of the social representative

25/02/2013

Minutes of general meeting of shareholders

25/02/2013

Updated articles of association

15/10/2010

New shareholders detected

15/10/2010

New subsidiarie(s) detected

15/10/2010

New ultimate parent

15/10/2010

New parent detected

13/11/2009

Bodacc B: Various editing or changing

27/10/2009

Minutes of general meeting of shareholders

27/10/2009

PV d'Assemblée

30/07/2008

Collection of preferential rights activated for this company

28/05/2008

Bodacc B: Various editing or changing

28/05/2008

New Bodacc B ads detected

15/05/2008

Statuts mis à jour

15/05/2008

Appointment/resignation of company officers

15/05/2008

Updated articles of association

15/05/2008

Private document

15/05/2008

PV d'Assemblée

15/05/2008

Minutes of general meeting of shareholders

15/05/2008

Changement de Commissaire aux Comptes

18/10/2007

PV d'Assemblée

18/10/2007

Private document

18/10/2007

Amendment

18/10/2007

Minutes of general meeting of shareholders

19/09/2007

Appointment/resignation of company officers

19/09/2007

PV d'Assemblée

19/09/2007

Private document

19/09/2007

Minutes of general meeting of shareholders

24/10/2005

Acte sous seing privé

24/10/2005

Private document

24/10/2005

Private document

24/10/2005

Minutes of general meeting of shareholders

24/10/2005

PV d'Assemblée

24/10/2005

Minutes of general meeting of shareholders

24/10/2005

Acte modificatif

24/10/2005

Amendment

24/10/2005

Amendment

14/01/2005

New legal form – no new category

14/01/2005

Private document

14/01/2005

Minutes of general meeting of shareholders

14/01/2005

PV d'Assemblée

14/01/2005

Minutes of general meeting of shareholders

14/01/2005

Appointment/resignation of company officers

14/01/2005

Nomination/démission des organes de gestion

14/01/2005

Appointment/resignation of company officers

14/01/2005

Changement de Forme Juridique sans changement de catégorie

14/01/2005

Changement de Forme Juridique avec changement de catégorie

14/01/2005

Acte modificatif

14/01/2005

Private document

14/01/2005

Updated articles of association

14/01/2005

Updated articles of association

14/01/2005

Changement de Commissaire aux Comptes

14/01/2005

New auditor

14/01/2005

New auditor

14/01/2005

Statuts mis à jour

14/01/2005

Acte sous seing privé

14/01/2005

New legal form – no new category

14/10/2004

PV du Conseil d'Administration

14/10/2004

Minutes of Board meeting

14/10/2004

Appointment/resignation of company officers

14/10/2004

Nomination/démission des organes de gestion

14/10/2004

Appointment/resignation of company officers

14/10/2004

Private document

14/10/2004

Minutes of Board meeting

14/10/2004

Acte sous seing privé

14/10/2004

Changes to the Board of Directors

14/10/2004

Modification du Conseil d'Administration

14/10/2004

Changes to the Board of Directors

14/10/2004

Acte modificatif

14/10/2004

Private document

24/06/2004

Updated articles of association

24/06/2004

Acte modificatif

24/06/2004

Capital reduction

24/06/2004

Réduction de Capital

24/06/2004

Capital reduction

24/06/2004

Acte sous seing privé

24/06/2004

Private document

24/06/2004

Private document

24/06/2004

PV d'Assemblée

24/06/2004

Minutes of Board meeting

24/06/2004

PV du Conseil d'Administration

24/06/2004

Minutes of Board meeting

24/06/2004

Statuts mis à jour

24/06/2004

Updated articles of association

16/03/2004

Capital reduction

16/03/2004

Private document

16/03/2004

Acte sous seing privé

16/03/2004

Minutes of general meeting of shareholders

16/03/2004

Réduction de Capital

16/03/2004

Acte modificatif

16/03/2004

PV d'Assemblée

01/07/2003

Nomination/démission des organes de gestion

01/07/2003

Changement de Président (PDG, PCA)

01/07/2003

Acte modificatif

01/07/2003

PV du Conseil d'Administration

01/07/2003

Modification du Conseil d'Administration

01/07/2003

Acte sous seing privé

05/02/2003

Acte modificatif

05/02/2003

Statuts mis à jour

05/02/2003

PV du Conseil d'Administration

05/02/2003

Nomination/démission des organes de gestion

05/02/2003

Acte sous seing privé

05/02/2003

PV d'Assemblée

05/02/2003

Modification du Conseil d'Administration

20/12/2002

Acte modificatif

20/12/2002

Requête et Ordonnance

02/10/2001

PV d'Assemblée

02/10/2001

Conversion du Capital Social en Euros

02/10/2001

Augmentation de Capital

02/10/2001

Acte modificatif

02/10/2001

Acte sous seing privé

02/10/2001

Statuts mis à jour

02/10/2001

PV du Conseil d'Administration

13/07/2000

Modification de l'objet social

13/07/2000

Acte modificatif

13/07/2000

Statuts mis à jour

13/07/2000

Acte sous seing privé

13/07/2000

PV d'Assemblée

10/09/1999

PV d'Assemblée

10/09/1999

Nomination/démission des organes de gestion

10/09/1999

Acte sous seing privé

10/09/1999

Acte modificatif

02/09/1998

Acte modificatif

02/09/1998

PV d'Assemblée

02/09/1998

Nomination/démission des organes de gestion

02/09/1998

Acte sous seing privé

29/08/1996

Augmentation de Capital

29/08/1996

Acte modificatif

29/08/1996

PV d'Assemblée

29/08/1996

Statuts mis à jour

24/08/1995

Acte modificatif

24/08/1995

PV du Conseil d'Administration

24/08/1995

PV d'Assemblée

24/08/1995

Nomination/démission des organes de gestion

27/01/1995

Acte modificatif

27/01/1995

Cession de parts

27/01/1995

Expédition acte notarié

28/12/1993

PV d'Assemblée

28/12/1993

Acte modificatif

05/03/1993

Déclaration de conformité

05/03/1993

Statuts mis à jour

05/03/1993

PV du Conseil d'Administration

05/03/1993

PV d'Assemblée

05/03/1993

Acte modificatif

05/03/1993

Augmentation de Capital

23/01/1993

Statuts mis à jour

23/01/1993

PV du Conseil d'Administration

23/01/1993

Déclaration de conformité

23/01/1993

PV d'Assemblée

23/01/1993

Augmentation de Capital

23/01/1993

Acte modificatif

09/09/1992

Nomination/démission des organes de gestion

09/09/1992

PV du Conseil d'Administration

09/09/1992

PV d'Assemblée

09/09/1992

Changement de Président (PDG, PCA)

09/09/1992

Acte modificatif

09/09/1992

Modification du Conseil d'Administration

27/11/1991

Cession de parts

27/11/1991

Expédition acte notarié

 

 

 

 

 

 

 

NOTES & COMMENTS

 

Na

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.62.57

UK Pound

1

Rs.100.62

Euro

1

Rs.84.62

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Report Prepared by :

PDT

 

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.