Capability to overcome financial difficulties seems comparatively
below average.
Small
Status :
Moderate
Payment Behaviour :
Unknown
Litigation :
Clear
NOTES :
Any query related to this report can be made on
e-mail: infodept@mirainform.com
while quoting report number, name and date.
ECGC Country Risk Classification List – March 31st, 2013
Country Name
Previous Rating
(31.12.2012)
Current Rating
(31.03.2013)
France
A1
A1
Risk Category
ECGC
Classification
Insignificant
A1
Low
A2
Moderate
B1
High
B2
Very High
C1
Restricted
C2
Off-credit
D
FRANCE - ECONOMIC
OVERVIEW
The French economy is
diversified across all sectors. The government has partially or fully
privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault,
and Thales. However, the government maintains a strong presence in some
sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With at
least 79 million foreign tourists per year, France is the most visited country
in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's
leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity
by means of laws, tax policies, and social spending that reduce income
disparity and the impact of free markets on public health and welfare. France's
real GDP contracted 2.6% in 2009, but recovered somewhat in 2010 and 2011,
before stagnating in 2012. The unemployment rate increased from 7.4% in 2008 to
10.3% in 2012. Youth unemployment shot up to 24.2% during the third quarter of
2012 in metropolitan France.
Lower-than-expected growth and high unemployment costs have strained France's
public finances. The budget deficit rose sharply from 3.4% of GDP in 2008 to
7.5% of GDP in 2009 before improving to 4.8% of GDP in 2012, while France's public
debt rose from 68% of GDP to 90% over the same period. Under President SARKOZY,
Paris implemented some austerity measures to
bring the budget deficit under the 3% euro-zone ceiling by 2013 and to
highlight France's
commitment to fiscal discipline at a time of intense financial market scrutiny
of euro-zone debt. Socialist Party candidate Francois HOLLANDE won the May 2012
presidential election, after advocating pro-growth economic policies, the
separation of banks' traditional deposit taking and lending activities from
more speculative businesses, increasing the top corporate and personal tax
rates, and hiring an additional 60,000 teachers during his five-year term. The
government's attempt to introduce a 75% wealth tax on income over one million
euros for two years was struck down by the French Constitutional Council in
December 2012 because it applied to individuals rather than households. France ratified the EU fiscal stability treaty
in October 2012 and HOLLANDE's government has maintained France's
commitment to meeting the budget deficit target of 3% of GDP during 2013 even
amid signs that economic growth will be lower than the government's forecast of
0.8%. Despite stagnant growth and fiscal challenges, France's borrowing costs declined
during the second half of 2012 to euro-era lows
Source : CIA
REGISTERED NAME & COMPANY
SUMMARY
company summary
EUR VAT Number
FR52319805974
Activity (APE)
Fabrication
de plats préparés (1085Z) (Fabrication of the place prepares)
Legal
form
Simplified
joint stock company
Phone
02 31
51 48 48
RCS
Registration
RCS Caen 8 319 805
974
Fax
Share
capital
4,352,000 Euros
Address
SAS
FRIAL 6 RTE DE CAEN 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Incorporated
Date
09/1980
Nationality
France
Status
Economically
active
Company details
Activity (APE)
Fabrication de plats
préparés (1085Z)
RCS Registration
RCS Caen 8 319 805 974
Share capital
4,352,000 Euros
Registration Court
Caen (14)
Legal form
Simplified joint stock company
Court Registry Number
19 8 0B40021
EUR VAT Number
FR52319805974
Incorporation Date
09/1980
Formation Date
08/1980
Deregistration Date
Last account Date
N/A
Nationality
France
Establishment details
Activity (APE)
Fabrication de plats
préparés (1085Z) (Fabrication of the place prepares)
Business Pages FT®
Postal Address
SAS
FRIAL
6 RTE DE CAEN
14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Trading Address
6 ROUTE DE CAEN
14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Telephone
02 31 51 48 48
Fax
Type
Head office
Status
Economically active
Formation Date
08/1980
Reason for formation
Formation
Closure Date
Reason for closure
Reactivation Date
Production Role
Activity Nature
-
Activity Location
Other
Location surface
Seasonality
Department
Calvados (14)
Region
Basse-Normandie
District
1
Area
03
City
SAINT MARTIN DES ENTREES
Size of urban area
Other establishments
Branches
2 branch entities in this
company
Head office
> SAS FRIAL <<< - Fabrication de plats
préparés (1085Z) in SAINT MARTIN DES ENTREES (14400)
Secondary establishments
> SAS FRIAL
- Fabrication de plats préparés (1085Z) in BAYEUX (14400)
Regionality
Legal unit with all establishments
in same area
Mono-activity status
Legal unit having all
establishments with the same main activity
Workforces
Workforce at address
50 to 99 employees
Company workforce
50 to 99 employees
DIRECTORS/MANAGEMENT
Current Directors
2
directors
Name
M. PIRANDA JEAN-MARIE
Manager position
President of the
supervisory council
Date of birth
06/04/1954
Place of birth
LAVIRON (25)
Type
Individual
Name at birth
Name
M.
RUSTICHELLI PHILIPPE
Manager position
President, President of
the management board
Date of birth
07/01/1960
Place of birth
MARSEILLE 06 (13)
Type
Individual
Name at birth
Previous
Directors
View the directors history for this company
If you want to view the directors history, please click on the link view
details.
Manager position
Title and name
Date of Birth/Place of Birth
President
M PIERRE ESNEE
23/05/1966 - BAYEUX
President
M JEAN-MARIE PIRANDA
06/04/1954 - LAVIRON
President
M JEAN-MARIE PIRANDA
06/04/1954 - LAVIRON (25)
Managing director
M THIERRY DUPONT
16/12/1956 - BAYEUX
Managing director
M JEAN-MARIE PIRANDA
06/04/1954 - LAVIRON
Managing director
M JEAN-LUC PUECH
- - -
NEGATIVE INFORMATION
judgements
Collective
procedures
No judgment information for
the company
Social security,
pension funds preferential rights | Tax office preferential rights
Preferential rights details and
history
Summary
of preferential rights
Company monitored since
30/07/2008
Status of Monitoring
No social security and tax
office preferential right to date
SHARE & SHARE CAPITAL
INFORMATION
Share
capital
4,352,000 Euros
PAYMENT INFORMATION
Na
GROUP STRUCTURE & AFFILIATED
COMPANIES
Ultimate Holding Company
Company Name
Safe Number
Company number
Click here to view the
affiliation links
FROZEN HOLDING
LU00182975
B136588
Group data
Ultimate parent company
FROZEN HOLDING
Direct parent
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET
PRODUCTION EN AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION - 95 %
Group – Number of companies
7
Linkages – Number of companies
-
Number of countries
-
Group Structure
Go directly to the current
company
Display
only where participation % > 33 %
Linkages
Ultimate parent company
FROZEN HOLDING
Direct parent
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET
PRODUCTION EN AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION - 95 %
Group – Number of companies
7
Linkages – Number of companies
-
Number of countries
-
Linkages
No
Linkages information available for the company
FINANCIAL INFORMATION
Na
FOREIGN EXCHANGE RATES
Na
ADDITIONAL INFORMATION
No
social security and tax office preferential right to date
Commentary
The comments are ordered according
to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies
of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative
for another or can change depending on its value. This is a purely
statistical decision.
Financial
statements overdue. The latest Creditsafe risk score has taken this into
account, please contact Creditsafe with your latest financial statements if
you want the risk score to be recalculated
High risk
workforce size
The company
is 33 years old
Industry
code with low risk rating
Rating and Limit history
There is no rating and limit history available for
this company
Linkages
Company Name
Safe Number
SIREN
Parts
Rating
Limit
Last account published
FROZEN
HOLDING S.A.
LU00182975
B136588
-
NC
-
-
GLACIES
HOLDING
FR08665056
485376479
100%
99
7 500 €
31/01/2007
DEVEL
PROD AGRO ALIMENT RESTAUR
FR07872360
477890388
100%
NC
-
31/12/2006
SAS
FRIAL
FR00956341
319805974
95%
20
0 €
-
ERIMER
FR14108741
408515286
85%
55
180 000 €
31/03/2009
SARL
SAINT GUEFROID
FR02409116
353485428
99%
67
50 000 €
31/03/2011
COFA
FR01895168
342661535
100%
80
765 000 €
31/03/2012
event history
Status history
No Status History
Recent publications in Gazettes
Publication
date
Gazette
Name
Description
30/10/2013
Bodacc B
Modification et mutation diverse
14 - CALVADOS
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
302 - 319 805 974 RCS Caen. FRIAL. Forme : Société par
actions simplifiée. Administration : Président, Président du directoire
: RUSTICHELLI Philippe Président du conseil de surveillance, Membre du
conseil de surveillance : PIRANDA Jean-Marie Membre du conseil de
surveillance : VER HULST Nicolas Membre du conseil de surveillance :
HERMAN Patrick Membre du conseil de surveillance : KORDES Olaf Membre
du conseil de surveillance : VAISSIE Paul Commissaire aux comptes
titulaire : SA CABINET KRIBS (SA) Commissaire aux comptes titulaire :
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant :
KRIBS Roger Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves. Activité
: .
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.
12/10/2013
JAL
Appointment of the social representative
Manche libre (La)
Date de décision : 30/09/2013
Société faisant l'objet d'une nomination : 319805974 - SAS FRIAL, 6 RTE
DE CAEN, 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Nominé : Monsieur Jean-Marie PIRANDA, 14400 BAYEUX
En la fonction de : Président du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Philippe RUSTICHELLI, 14390 CABOURG
En la fonction de : Président du Directoire
Nominé : Monsieur Paul VAISSIÉ, 75015 PARIS 15
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Olaf KORDES, 92400 COURBEVOIE
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Patrick Herman, 1000 BRUXELLES
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Nicolas VER HULST, 75009 PARIS 09
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Jean-Marie PIRANDA, 14400 BAYEUX
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
12/10/2013
JAL
Resignation / Revocation of the social
representative
Manche libre (La)
Date de décision : 30/09/2013
La société 319805974 - SAS FRIAL, 6 RTE DE CAEN, 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Fait l'objet du départ de Monsieur Jean-Marie PIRANDA
13/11/2009
Bodacc B
Modification et mutation diverse
14 - CALVADOS
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
310 - 319 805 974 RCS Caen. FRIAL. Forme : Société par
actions simplifiée. Administration : Président : PIRANDA Jean-Marie
Commissaire aux comptes titulaire : SA CABINET KRIBS (SA) Commissaire
aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) Commissaire
aux comptes suppléant : KRIBS Roger Commissaire aux comptes suppléant :
NICOLAS Yves.
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.
28/05/2008
Bodacc B
Modification et mutation diverse
14 - CALVADOS
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYEUX
427 - 319 805 974 RCS Bayeux. FRIAL. Forme : Société par
actions simplifiée. Administration : Président : PIRANDA Jean-MarieCommissaire
aux comptes titulaire : SA CABINET KRIBS (SA). Commissaire aux comptes
suppléant : KRIBS Roger.
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.
23/10/2007
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
648 - RCS Bayeux B 319 805 974. RC 80-B 21.
FRIAL. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : route de Caen,, 14400
Commentaires : modification survenue sur l'administration.
Administration : président : ESNEE (Pierre) (Nom d'usage : ESNEE). Directeurs
généraux : DUPONT (Thierry) (Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean-Marie)
(Nom d'usage : PIRANDA). Commissaire aux comptes titulaire : S.A.
CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : SCHMITT (Pierre)
(Nom d'usage : SCHMITT). Date d'effet : 23 juillet 2007.
20/03/2005
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
150 - RCS Bayeux B 319 805 974. RC 80-B 21.
FRIAL. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : route de Caen,, 14400
Commentaires : modification survenue sur la forme juridique et
l'administration. Ancienne forme juridique : S.A. Administration :
nouveau président : ESNEE (Pierre) (Nom d'usage : ESNEE), ancien
président directeur général. Nomination en qualité de directeurs
généraux : DUPONT (Thierry) (Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean-Marie)
(Nom d'usage : PIRANDA) PUECH (Jean-Luc) (Nom d'usage : PUECH).
Commissaire aux comptes titulaire maintenu : S.A. CABINET KRIBS.
Commissaire aux comptes suppléant : SCHMITT (Pierre) (Nom d'usage :
SCHMITT). Anciens administrateurs : ESNEE (Pierre) ESNEE (Jacques)
SOCIETE SCDHH DUPONT (Thierry) PIRANDA (Jean-Marie) PUECH (Jean-Luc).
Ancien commissaire aux comptes suppléant : GANDON (Gérard). Date
d'effet : 16 décembre 2004.
25/11/2004
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
RCS Bayeux
B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A.
Adresse du siège social : route de
Caen, 14400
Saint-Martin-des- Entrées. Commentaires : modification survenue sur l'administration.
Administration : président directeur général : ESNEE (Pierre) ( Nom
d'usage : ESNEE). Directeurs généraux délégués et administrateurs :
ESNEE (Jacques) ( Nom d'usage : ESNEE) DUPONT (Thierry) ( Nom d'usage :
DUPONT) PIRANDA (Jean, Marie) ( Nom d'usage : PIRANDA). Administrateurs
: PUECH (Jean-Luc) ( Nom d'usage : PUECH). Nouvel administrateur : S.C.
DE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET HOSPITALIER-S.C.D.H., représentée par
ESNEE (Pierre) ( Nom d' usage : ESNEE). Commissaire aux comptes : S.A.
CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : GANDON (Gérard) (
Nom d'usage : GANDON). Date d'effet : 22 juillet 2004.
25/07/2004
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
RCS Bayeux
B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 4 352 000
euros. Adresse du siège social : route de Caen, 14400
Saint-Martin-des-Entrées. Commentaires : modification survenue sur le
capital (diminution). Date d'effet : 3 mai 2004.
08/08/2003
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
RCS Bayeux
B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A.
Adresse du siège social : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées,
14400 Bayeux.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.
Administration : président directeur général : ESNEE (Pierre) ( Nom
d'usage : ESNEE). Directeurs généraux délégués et administrateurs :
ESNEE (Jacques) ( Nom d'usage : ESNEE) DUPONT (Thierry) ( Nom d'usage :
DUPONT) PIRANDA (Jean, Marie) ( Nom d'usage : PIRANDA). Administrateurs
: ESNEE (Nathalie) ( Nom d'usage : ESCLAPEZ) PUECH (Jean- Luc) ( Nom
d'usage : PUECH). Commissaire aux comptes : S.A. CABINET KRIBS.
Commissaire aux comptes suppléant : GANDON (Gérard) ( Nom d' usage :
GANDON). Date d'effet : 23 mai 2003.
16/03/2003
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL.
Forme : S.A. Adresse du siège social : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées,
14400 Bayeux. Commentaires : modification survenue sur
l'administration. Administration : Président directeur général : ESNEE
(Jacques) ( Nom d'usage ESNEE) directeurs généraux délégués : DUPONT
(Thierry) ( Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean, Marie) ( Nom d' usage
: PIRANDA). Administrateurs : ESNEE (Nathalie) ( Nom d'usage :
ESCLAPEZ) ESNEE (Pierre) ( Nom d' usage : ESNEE) PUECH (Jean-Luc) ( Nom
d'usage : PUECH). Commissaire aux comptes : S.A. CABINET KRIBS.
Commissaire aux comptes suppléant : GANDON (Gérard) ( Nom d'usage :
GANDON). Date d'effet : 21 juin 2002.
14/11/2001
Bodacc B
Modifications et mutations
diverses
RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme
: S.A. Capital : 4 599 040 euros. Adresse du siège social : route de
Caen, Saint-Martin-des-Entrées, 14400 Bayeux. Commentaires :
modification survenue sur le capital (augmentation et conversion en
euros). Date d'effet : 22 juin 2001.
06/08/2000
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL.
Forme : S.A. Capital : 13 423 448 F. Activité : achat, vente de tous
produits alimentaires surgelés, congelés et de conserves, pour une consommation
humaine ou animale gestion de participations. Adresse du siège social :
route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées, 14400 Bayeux. Commentaires :
modification survenue sur l'activité. Date d'effet : 9 juin 2000.
31/10/1998
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
RCS Bayeux B 319 805 974 RC 80-B 21 FRIAL.
Forme : S.A. Capital : 13 423 448 F. Adresse du siège social : route de
Caen Saint-Martin-des-Entrées 14400 Bayeux. Administration : ancien
commissaire aux comptes titulaire : KRIBS (Roger). Nouveau commissaire
aux comptes titulaire : S.A. CABINET KRIBS. Date d'effet : 19 juin
1998.
26/11/1996
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
Ancienne situation du siège social. RCS Bayeux
B 319 805 974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 5 389 500 F.
Adresse : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées 14400 Bayeux Nouvelle
situation du siège social. Capital : 13 423 448 F. Date d'effet : 28
juin 1996.
10/10/1995
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
RCS Bayeux B 319 805 974 RC 80-B 21 FRIAL.
Forme : S.A. Capital : 5 389 500. Adresse du siège social : route de
Caen, Saint-Martin-des-Entrées 14400 Bayeux. Administration : renouvellement
des mandats des administrateurs : ESNEE ( Jacques) DUPONT (Thierry)
ESCLAPEZ ( Nathalie). Renouvellement du mandat du président du conseil
d'administration : ESNEE (Jacques). Renouvellement des mandats des
directeurs généraux : DUPONT (Thierry) et PIRANDA (Jean-Marie) à
compter du:19 juin 1995 Nouvel administrateur : PIRANDA (Jean-Marie).
Date d'effet : 17 juillet 1995.
Company events history
Date
Description
30/10/2013
Bodacc B: Various editing
or changing
16/10/2013
Updated articles of
association
16/10/2013
Amendment
12/10/2013
Legal Gazette: Resignation
/ Revocation of the social representative
30/09/2013
Legal Gazette: Appointment
of the social representative
25/02/2013
Minutes of general meeting
of shareholders
25/02/2013
Updated articles of
association
15/10/2010
New shareholders detected
15/10/2010
New subsidiarie(s)
detected
15/10/2010
New ultimate parent
15/10/2010
New parent detected
13/11/2009
Bodacc B: Various editing
or changing
27/10/2009
Minutes of general meeting
of shareholders
27/10/2009
PV d'Assemblée
30/07/2008
Collection of preferential
rights activated for this company
28/05/2008
Bodacc B: Various editing
or changing
28/05/2008
New Bodacc B ads detected
15/05/2008
Statuts mis à jour
15/05/2008
Appointment/resignation of
company officers
15/05/2008
Updated articles of
association
15/05/2008
Private document
15/05/2008
PV d'Assemblée
15/05/2008
Minutes of general meeting
of shareholders
15/05/2008
Changement de Commissaire
aux Comptes
18/10/2007
PV d'Assemblée
18/10/2007
Private document
18/10/2007
Amendment
18/10/2007
Minutes of general meeting
of shareholders
19/09/2007
Appointment/resignation of
company officers
19/09/2007
PV d'Assemblée
19/09/2007
Private document
19/09/2007
Minutes of general meeting
of shareholders
24/10/2005
Acte sous seing privé
24/10/2005
Private document
24/10/2005
Private document
24/10/2005
Minutes of general meeting
of shareholders
24/10/2005
PV d'Assemblée
24/10/2005
Minutes of general meeting
of shareholders
24/10/2005
Acte modificatif
24/10/2005
Amendment
24/10/2005
Amendment
14/01/2005
New legal form – no new
category
14/01/2005
Private document
14/01/2005
Minutes of general meeting
of shareholders
14/01/2005
PV d'Assemblée
14/01/2005
Minutes of general meeting
of shareholders
14/01/2005
Appointment/resignation of
company officers
14/01/2005
Nomination/démission des
organes de gestion
14/01/2005
Appointment/resignation of
company officers
14/01/2005
Changement de Forme
Juridique sans changement de catégorie
14/01/2005
Changement de Forme
Juridique avec changement de catégorie
14/01/2005
Acte modificatif
14/01/2005
Private document
14/01/2005
Updated articles of
association
14/01/2005
Updated articles of
association
14/01/2005
Changement de Commissaire
aux Comptes
14/01/2005
New auditor
14/01/2005
New auditor
14/01/2005
Statuts mis à jour
14/01/2005
Acte sous seing privé
14/01/2005
New legal form – no new
category
14/10/2004
PV du Conseil
d'Administration
14/10/2004
Minutes of Board meeting
14/10/2004
Appointment/resignation of
company officers
14/10/2004
Nomination/démission des
organes de gestion
14/10/2004
Appointment/resignation of
company officers
14/10/2004
Private document
14/10/2004
Minutes of Board meeting
14/10/2004
Acte sous seing privé
14/10/2004
Changes to the Board of
Directors
14/10/2004
Modification du Conseil
d'Administration
14/10/2004
Changes to the Board of
Directors
14/10/2004
Acte modificatif
14/10/2004
Private document
24/06/2004
Updated articles of
association
24/06/2004
Acte modificatif
24/06/2004
Capital reduction
24/06/2004
Réduction de Capital
24/06/2004
Capital reduction
24/06/2004
Acte sous seing privé
24/06/2004
Private document
24/06/2004
Private document
24/06/2004
PV d'Assemblée
24/06/2004
Minutes of Board meeting
24/06/2004
PV du Conseil
d'Administration
24/06/2004
Minutes of Board meeting
24/06/2004
Statuts mis à jour
24/06/2004
Updated articles of
association
16/03/2004
Capital reduction
16/03/2004
Private document
16/03/2004
Acte sous seing privé
16/03/2004
Minutes of general meeting
of shareholders
16/03/2004
Réduction de Capital
16/03/2004
Acte modificatif
16/03/2004
PV d'Assemblée
01/07/2003
Nomination/démission des
organes de gestion
01/07/2003
Changement de Président
(PDG, PCA)
01/07/2003
Acte modificatif
01/07/2003
PV du Conseil
d'Administration
01/07/2003
Modification du Conseil
d'Administration
01/07/2003
Acte sous seing privé
05/02/2003
Acte modificatif
05/02/2003
Statuts mis à jour
05/02/2003
PV du Conseil
d'Administration
05/02/2003
Nomination/démission des
organes de gestion
05/02/2003
Acte sous seing privé
05/02/2003
PV d'Assemblée
05/02/2003
Modification du Conseil
d'Administration
20/12/2002
Acte modificatif
20/12/2002
Requête et Ordonnance
02/10/2001
PV d'Assemblée
02/10/2001
Conversion du Capital
Social en Euros
02/10/2001
Augmentation de Capital
02/10/2001
Acte modificatif
02/10/2001
Acte sous seing privé
02/10/2001
Statuts mis à jour
02/10/2001
PV du Conseil
d'Administration
13/07/2000
Modification de l'objet
social
13/07/2000
Acte modificatif
13/07/2000
Statuts mis à jour
13/07/2000
Acte sous seing privé
13/07/2000
PV d'Assemblée
10/09/1999
PV d'Assemblée
10/09/1999
Nomination/démission des
organes de gestion
10/09/1999
Acte sous seing privé
10/09/1999
Acte modificatif
02/09/1998
Acte modificatif
02/09/1998
PV d'Assemblée
02/09/1998
Nomination/démission des
organes de gestion
02/09/1998
Acte sous seing privé
29/08/1996
Augmentation de Capital
29/08/1996
Acte modificatif
29/08/1996
PV d'Assemblée
29/08/1996
Statuts mis à jour
24/08/1995
Acte modificatif
24/08/1995
PV du Conseil
d'Administration
24/08/1995
PV d'Assemblée
24/08/1995
Nomination/démission des
organes de gestion
27/01/1995
Acte modificatif
27/01/1995
Cession de parts
27/01/1995
Expédition acte notarié
28/12/1993
PV d'Assemblée
28/12/1993
Acte modificatif
05/03/1993
Déclaration de conformité
05/03/1993
Statuts mis à jour
05/03/1993
PV du Conseil
d'Administration
05/03/1993
PV d'Assemblée
05/03/1993
Acte modificatif
05/03/1993
Augmentation de Capital
23/01/1993
Statuts mis à jour
23/01/1993
PV du Conseil
d'Administration
23/01/1993
Déclaration de conformité
23/01/1993
PV d'Assemblée
23/01/1993
Augmentation de Capital
23/01/1993
Acte modificatif
09/09/1992
Nomination/démission des
organes de gestion
09/09/1992
PV du Conseil
d'Administration
09/09/1992
PV d'Assemblée
09/09/1992
Changement de Président
(PDG, PCA)
09/09/1992
Acte modificatif
09/09/1992
Modification du Conseil
d'Administration
27/11/1991
Cession de parts
27/11/1991
Expédition acte notarié
NOTES & COMMENTS
Na
FOREIGN EXCHANGE RATES
Currency
Unit
Indian Rupees
US Dollar
1
Rs.62.57
UK Pound
1
Rs.100.62
Euro
1
Rs.84.62
INFORMATION DETAILS
Report Prepared
by :
PDT
RATING EXPLANATIONS
RATING
STATUS
PROPOSED CREDIT LINE
>86
Aaa
Possesses an extremely sound financial base with the strongest
capability for timely payment of interest and principal sums
Unlimited
71-85
Aa
Possesses adequate working capital. No caution needed for credit
transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest
and principal sums
Large
56-70
A
Financial & operational base are regarded healthy. General
unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for
payment of interest and principal sums
Fairly Large
41-55
Ba
Overall operation is considered normal. Capable to meet normal
commitments.
Satisfactory
26-40
B
Capability to overcome
financial difficulties seems comparatively below average.
Small
11-25
Ca
Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums
in default or expected to be in default upon maturity
Limited with
full security
<10
C
Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised
Credit not
recommended
--
NB
New
Business
--
This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and
to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite
of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The
assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as
follows:
Financial
condition (40%)Ownership
background (20%)Payment
record (10%)
Credit history
(10%)Maket trend (10%)Operational
size (10%)
MIRA
INFORM REPORT
Report Date :
08.11.2013
IDENTIFICATION DETAILS
Name :
SAS
FRIAL
Registered Office :
6 Rte De Caen, 14400
Saint Martin Des Entrees
Country :
France
Date of Incorporation :
September 1980
Com. Reg. No.:
19 8 0B40021
Legal Form :
Simplified joint stock company
Line of Business :
Fabrication of the place prepares
No. of Employees :
50 to 99
RATING & COMMENTS
MIRA’s Rating :
B
RATING
STATUS
PROPOSED CREDIT LINE
26-40
B
Capability to overcome financial difficulties seems comparatively
below average.
Small
Status :
Moderate
Payment Behaviour :
Unknown
Litigation :
Clear
NOTES :
Any query related to this report can be made on
e-mail: infodept@mirainform.com
while quoting report number, name and date.
ECGC Country Risk Classification List – March 31st, 2013
Country Name
Previous Rating
(31.12.2012)
Current Rating
(31.03.2013)
France
A1
A1
Risk Category
ECGC
Classification
Insignificant
A1
Low
A2
Moderate
B1
High
B2
Very High
C1
Restricted
C2
Off-credit
D
FRANCE - ECONOMIC
OVERVIEW
The French economy is
diversified across all sectors. The government has partially or fully
privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault,
and Thales. However, the government maintains a strong presence in some
sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With at
least 79 million foreign tourists per year, France is the most visited country
in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's
leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity
by means of laws, tax policies, and social spending that reduce income
disparity and the impact of free markets on public health and welfare. France's real
GDP contracted 2.6% in 2009, but recovered somewhat in 2010 and 2011, before
stagnating in 2012. The unemployment rate increased from 7.4% in 2008 to 10.3%
in 2012. Youth unemployment shot up to 24.2% during the third quarter of 2012
in metropolitan France.
Lower-than-expected growth and high unemployment costs have strained France's public
finances. The budget deficit rose sharply from 3.4% of GDP in 2008 to 7.5% of
GDP in 2009 before improving to 4.8% of GDP in 2012, while France's public debt
rose from 68% of GDP to 90% over the same period. Under President SARKOZY,
Paris implemented some austerity measures to bring the budget deficit under the
3% euro-zone ceiling by 2013 and to highlight France's commitment to fiscal
discipline at a time of intense financial market scrutiny of euro-zone debt. Socialist
Party candidate Francois HOLLANDE won the May 2012 presidential election, after
advocating pro-growth economic policies, the separation of banks' traditional
deposit taking and lending activities from more speculative businesses,
increasing the top corporate and personal tax rates, and hiring an additional
60,000 teachers during his five-year term. The government's attempt to
introduce a 75% wealth tax on income over one million euros for two years was
struck down by the French Constitutional Council in December 2012 because it
applied to individuals rather than households. France ratified the EU fiscal
stability treaty in October 2012 and HOLLANDE's government has maintained
France's commitment to meeting the budget deficit target of 3% of GDP during
2013 even amid signs that economic growth will be lower than the government's
forecast of 0.8%. Despite stagnant growth and fiscal challenges, France's
borrowing costs declined during the second half of 2012 to euro-era lows
Source : CIA
REGISTERED NAME & COMPANY SUMMARY
company summary
EUR VAT Number
FR52319805974
Activity (APE)
Fabrication
de plats préparés (1085Z) (Fabrication of the place prepares)
Legal
form
Simplified
joint stock company
Phone
02 31
51 48 48
RCS
Registration
RCS
Caen 8 319 805 974
Fax
Share
capital
4,352,000 Euros
Address
SAS
FRIAL 6 RTE DE CAEN 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Incorporated
Date
09/1980
Nationality
France
Status
Economically
active
Company details
Activity (APE)
Fabrication de plats
préparés (1085Z)
RCS Registration
RCS Caen 8 319 805 974
Share capital
4,352,000 Euros
Registration Court
Caen (14)
Legal form
Simplified joint stock company
Court Registry Number
19 8 0B40021
EUR VAT Number
FR52319805974
Incorporation Date
09/1980
Formation Date
08/1980
Deregistration Date
Last account Date
N/A
Nationality
France
Establishment details
Activity (APE)
Fabrication de plats
préparés (1085Z) (Fabrication of the place prepares)
Business Pages FT®
Postal Address
SAS
FRIAL
6 RTE DE CAEN
14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Trading Address
6 ROUTE DE CAEN
14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Telephone
02 31 51 48 48
Fax
Type
Head office
Status
Economically active
Formation Date
08/1980
Reason for formation
Formation
Closure Date
Reason for closure
Reactivation Date
Production Role
Activity Nature
-
Activity Location
Other
Location surface
Seasonality
Department
Calvados (14)
Region
Basse-Normandie
District
1
Area
03
City
SAINT MARTIN DES ENTREES
Size of urban area
Other establishments
Branches
2 branch entities in this
company
Head office
> SAS FRIAL <<< - Fabrication de plats
préparés (1085Z) in SAINT MARTIN DES ENTREES (14400)
Secondary establishments
> SAS FRIAL
- Fabrication de plats préparés (1085Z) in BAYEUX
(14400)
Regionality
Legal unit with all establishments
in same area
Mono-activity status
Legal unit having all
establishments with the same main activity
Workforces
Workforce at address
50 to 99 employees
Company workforce
50 to 99 employees
DIRECTORS/MANAGEMENT
Current Directors
2
directors
Name
M. PIRANDA JEAN-MARIE
Manager position
President of the
supervisory council
Date of birth
06/04/1954
Place of birth
LAVIRON (25)
Type
Individual
Name at birth
Name
M.
RUSTICHELLI PHILIPPE
Manager position
President, President of
the management board
Date of birth
07/01/1960
Place of birth
MARSEILLE 06 (13)
Type
Individual
Name at birth
Previous
Directors
View the directors history for this company
If you want to view the directors history, please click on the link view
details.
Manager position
Title and name
Date of Birth/Place of Birth
President
M PIERRE ESNEE
23/05/1966 - BAYEUX
President
M JEAN-MARIE PIRANDA
06/04/1954 - LAVIRON
President
M JEAN-MARIE PIRANDA
06/04/1954 - LAVIRON (25)
Managing director
M THIERRY DUPONT
16/12/1956 - BAYEUX
Managing director
M JEAN-MARIE PIRANDA
06/04/1954 - LAVIRON
Managing director
M JEAN-LUC PUECH
- - -
NEGATIVE INFORMATION
judgements
Collective
procedures
No judgment information for
the company
Social security,
pension funds preferential rights | Tax office preferential rights
Preferential rights details and
history
Summary
of preferential rights
Company monitored since
30/07/2008
Status of Monitoring
No social security and tax
office preferential right to date
SHARE & SHARE CAPITAL
INFORMATION
Share
capital
4,352,000 Euros
PAYMENT INFORMATION
Na
GROUP STRUCTURE & AFFILIATED
COMPANIES
Ultimate Holding Company
Company Name
Safe Number
Company number
Click here to view the
affiliation links
FROZEN HOLDING
LU00182975
B136588
Group data
Ultimate parent company
FROZEN HOLDING
Direct parent
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET
PRODUCTION EN AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION - 95 %
Group – Number of companies
7
Linkages – Number of companies
-
Number of countries
-
Group Structure
Go directly to the current
company
Display
only where participation % > 33 %
Linkages
Ultimate parent company
FROZEN HOLDING
Direct parent
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET
PRODUCTION EN AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION - 95 %
Group – Number of companies
7
Linkages – Number of companies
-
Number of countries
-
Linkages
No
Linkages information available for the company
FINANCIAL INFORMATION
Na
FOREIGN EXCHANGE RATES
Na
ADDITIONAL INFORMATION
No
social security and tax office preferential right to date
Commentary
The comments are ordered according
to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies
of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative
for another or can change depending on its value. This is a purely
statistical decision.
Financial
statements overdue. The latest Creditsafe risk score has taken this into
account, please contact Creditsafe with your latest financial statements if
you want the risk score to be recalculated
High risk
workforce size
The company
is 33 years old
Industry
code with low risk rating
Rating and Limit history
There is no rating and limit history available for
this company
Linkages
Company Name
Safe Number
SIREN
Parts
Rating
Limit
Last account published
FROZEN
HOLDING S.A.
LU00182975
B136588
-
NC
-
-
GLACIES
HOLDING
FR08665056
485376479
100%
99
7 500 €
31/01/2007
DEVEL
PROD AGRO ALIMENT RESTAUR
FR07872360
477890388
100%
NC
-
31/12/2006
SAS
FRIAL
FR00956341
319805974
95%
20
0 €
-
ERIMER
FR14108741
408515286
85%
55
180 000 €
31/03/2009
SARL
SAINT GUEFROID
FR02409116
353485428
99%
67
50 000 €
31/03/2011
COFA
FR01895168
342661535
100%
80
765 000 €
31/03/2012
event history
Status history
No Status History
Recent publications in Gazettes
Publication
date
Gazette
Name
Description
30/10/2013
Bodacc B
Modification et mutation diverse
14 - CALVADOS
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
302 - 319 805 974 RCS Caen. FRIAL. Forme : Société
par actions simplifiée. Administration : Président, Président du
directoire : RUSTICHELLI Philippe Président du conseil de surveillance,
Membre du conseil de surveillance : PIRANDA Jean-Marie Membre du
conseil de surveillance : VER HULST Nicolas Membre du conseil de
surveillance : HERMAN Patrick Membre du conseil de surveillance :
KORDES Olaf Membre du conseil de surveillance : VAISSIE Paul
Commissaire aux comptes titulaire : SA CABINET KRIBS (SA) Commissaire
aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) Commissaire
aux comptes suppléant : KRIBS Roger Commissaire aux comptes suppléant :
NICOLAS Yves. Activité : .
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.
12/10/2013
JAL
Appointment of the social representative
Manche libre (La)
Date de décision : 30/09/2013
Société faisant l'objet d'une nomination : 319805974 - SAS FRIAL, 6 RTE
DE CAEN, 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Nominé : Monsieur Jean-Marie PIRANDA, 14400 BAYEUX
En la fonction de : Président du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Philippe RUSTICHELLI, 14390 CABOURG
En la fonction de : Président du Directoire
Nominé : Monsieur Paul VAISSIÉ, 75015 PARIS 15
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Olaf KORDES, 92400 COURBEVOIE
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Patrick Herman, 1000 BRUXELLES
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Nicolas VER HULST, 75009 PARIS 09
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Jean-Marie PIRANDA, 14400 BAYEUX
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
12/10/2013
JAL
Resignation / Revocation of the social
representative
Manche libre (La)
Date de décision : 30/09/2013
La société 319805974 - SAS FRIAL, 6 RTE DE CAEN, 14400 SAINT MARTIN DES
ENTREES
Fait l'objet du départ de Monsieur Jean-Marie PIRANDA
13/11/2009
Bodacc B
Modification et mutation diverse
14 - CALVADOS
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
310 - 319 805 974 RCS Caen. FRIAL. Forme :
Société par actions simplifiée. Administration : Président : PIRANDA
Jean-Marie Commissaire aux comptes titulaire : SA CABINET KRIBS (SA)
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA)
Commissaire aux comptes suppléant : KRIBS Roger Commissaire aux comptes
suppléant : NICOLAS Yves.
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.
28/05/2008
Bodacc B
Modification et mutation diverse
14 - CALVADOS
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYEUX
427 - 319 805 974 RCS Bayeux. FRIAL. Forme :
Société par actions simplifiée. Administration : Président : PIRANDA Jean-MarieCommissaire
aux comptes titulaire : SA CABINET KRIBS (SA). Commissaire aux comptes
suppléant : KRIBS Roger.
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.
23/10/2007
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
648 - RCS Bayeux B 319 805 974. RC 80-B 21.
FRIAL. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : route de Caen,, 14400
Commentaires : modification survenue sur l'administration.
Administration : président : ESNEE (Pierre) (Nom d'usage : ESNEE). Directeurs
généraux : DUPONT (Thierry) (Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean-Marie)
(Nom d'usage : PIRANDA). Commissaire aux comptes titulaire : S.A.
CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : SCHMITT (Pierre)
(Nom d'usage : SCHMITT). Date d'effet : 23 juillet 2007.
20/03/2005
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
150 - RCS Bayeux B 319 805 974. RC 80-B 21.
FRIAL. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : route de Caen,, 14400 Commentaires
: modification survenue sur la forme juridique et l'administration.
Ancienne forme juridique : S.A. Administration : nouveau président :
ESNEE (Pierre) (Nom d'usage : ESNEE), ancien président directeur
général. Nomination en qualité de directeurs généraux : DUPONT
(Thierry) (Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean-Marie) (Nom d'usage :
PIRANDA) PUECH (Jean-Luc) (Nom d'usage : PUECH). Commissaire aux
comptes titulaire maintenu : S.A. CABINET KRIBS. Commissaire aux
comptes suppléant : SCHMITT (Pierre) (Nom d'usage : SCHMITT). Anciens
administrateurs : ESNEE (Pierre) ESNEE (Jacques) SOCIETE SCDHH DUPONT
(Thierry) PIRANDA (Jean-Marie) PUECH (Jean-Luc). Ancien commissaire aux
comptes suppléant : GANDON (Gérard). Date d'effet : 16 décembre 2004.
25/11/2004
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL.
Forme : S.A. Adresse du siège social : route de Caen, 14400
Saint-Martin-des- Entrées. Commentaires : modification survenue sur l'administration.
Administration : président directeur général : ESNEE (Pierre) ( Nom
d'usage : ESNEE). Directeurs généraux délégués et administrateurs :
ESNEE (Jacques) ( Nom d'usage : ESNEE) DUPONT (Thierry) ( Nom d'usage :
DUPONT) PIRANDA (Jean, Marie) ( Nom d'usage : PIRANDA). Administrateurs
: PUECH (Jean-Luc) ( Nom d'usage : PUECH). Nouvel administrateur : S.C.
DE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET HOSPITALIER-S.C.D.H., représentée par
ESNEE (Pierre) ( Nom d' usage : ESNEE). Commissaire aux comptes : S.A.
CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : GANDON (Gérard) (
Nom d'usage : GANDON). Date d'effet : 22 juillet 2004.
25/07/2004
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme
: S.A. Capital : 4 352 000 euros. Adresse du siège social : route de
Caen, 14400 Saint-Martin-des-Entrées. Commentaires : modification
survenue sur le capital (diminution). Date d'effet : 3 mai 2004.
08/08/2003
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL.
Forme : S.A. Adresse du siège social : route de Caen,
Saint-Martin-des-Entrées, 14400 Bayeux. Commentaires : modification
survenue sur l'administration. Administration : président directeur
général : ESNEE (Pierre) ( Nom d'usage : ESNEE). Directeurs généraux
délégués et administrateurs : ESNEE (Jacques) ( Nom d'usage : ESNEE)
DUPONT (Thierry) ( Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean, Marie) ( Nom
d'usage : PIRANDA). Administrateurs : ESNEE (Nathalie) ( Nom d'usage :
ESCLAPEZ) PUECH (Jean- Luc) ( Nom d'usage : PUECH). Commissaire aux
comptes : S.A. CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant :
GANDON (Gérard) ( Nom d' usage : GANDON). Date d'effet : 23 mai 2003.
16/03/2003
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL.
Forme : S.A. Adresse du siège social : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées,
14400 Bayeux. Commentaires : modification survenue sur
l'administration. Administration : Président directeur général : ESNEE
(Jacques) ( Nom d'usage ESNEE) directeurs généraux délégués : DUPONT
(Thierry) ( Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean, Marie) ( Nom d' usage
: PIRANDA). Administrateurs : ESNEE (Nathalie) ( Nom d'usage :
ESCLAPEZ) ESNEE (Pierre) ( Nom d' usage : ESNEE) PUECH (Jean-Luc) ( Nom
d'usage : PUECH). Commissaire aux comptes : S.A. CABINET KRIBS.
Commissaire aux comptes suppléant : GANDON (Gérard) ( Nom d'usage :
GANDON). Date d'effet : 21 juin 2002.
14/11/2001
Bodacc B
Modifications et mutations
diverses
RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme
: S.A. Capital : 4 599 040 euros. Adresse du siège social : route de
Caen, Saint-Martin-des-Entrées, 14400 Bayeux. Commentaires :
modification survenue sur le capital (augmentation et conversion en
euros). Date d'effet : 22 juin 2001.
06/08/2000
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL.
Forme : S.A. Capital : 13 423 448 F. Activité : achat, vente de tous
produits alimentaires surgelés, congelés et de conserves, pour une consommation
humaine ou animale gestion de participations. Adresse du siège social :
route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées, 14400 Bayeux. Commentaires :
modification survenue sur l'activité. Date d'effet : 9 juin 2000.
31/10/1998
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
RCS Bayeux B 319 805 974 RC 80-B 21 FRIAL.
Forme : S.A. Capital : 13 423 448 F. Adresse du siège social : route de
Caen Saint-Martin-des-Entrées 14400 Bayeux. Administration : ancien
commissaire aux comptes titulaire : KRIBS (Roger). Nouveau commissaire
aux comptes titulaire : S.A. CABINET KRIBS. Date d'effet : 19 juin
1998.
26/11/1996
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
Ancienne situation du siège social. RCS Bayeux
B 319 805 974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 5 389 500 F.
Adresse : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées 14400 Bayeux Nouvelle
situation du siège social. Capital : 13 423 448 F. Date d'effet : 28
juin 1996.
10/10/1995
Bodacc B
Modifications et mutations diverses
RCS Bayeux B 319 805 974 RC 80-B 21 FRIAL.
Forme : S.A. Capital : 5 389 500. Adresse du siège social : route de
Caen, Saint-Martin-des-Entrées 14400 Bayeux. Administration : renouvellement
des mandats des administrateurs : ESNEE ( Jacques) DUPONT (Thierry)
ESCLAPEZ ( Nathalie). Renouvellement du mandat du président du conseil
d'administration : ESNEE (Jacques). Renouvellement des mandats des
directeurs généraux : DUPONT (Thierry) et PIRANDA (Jean-Marie) à
compter du:19 juin 1995 Nouvel administrateur : PIRANDA (Jean-Marie).
Date d'effet : 17 juillet 1995.
Company events history
Date
Description
30/10/2013
Bodacc B: Various editing
or changing
16/10/2013
Updated articles of
association
16/10/2013
Amendment
12/10/2013
Legal Gazette: Resignation
/ Revocation of the social representative
30/09/2013
Legal Gazette: Appointment
of the social representative
25/02/2013
Minutes of general meeting
of shareholders
25/02/2013
Updated articles of
association
15/10/2010
New shareholders detected
15/10/2010
New subsidiarie(s)
detected
15/10/2010
New ultimate parent
15/10/2010
New parent detected
13/11/2009
Bodacc B: Various editing
or changing
27/10/2009
Minutes of general meeting
of shareholders
27/10/2009
PV d'Assemblée
30/07/2008
Collection of preferential
rights activated for this company
28/05/2008
Bodacc B: Various editing
or changing
28/05/2008
New Bodacc B ads detected
15/05/2008
Statuts mis à jour
15/05/2008
Appointment/resignation of
company officers
15/05/2008
Updated articles of
association
15/05/2008
Private document
15/05/2008
PV d'Assemblée
15/05/2008
Minutes of general meeting
of shareholders
15/05/2008
Changement de Commissaire
aux Comptes
18/10/2007
PV d'Assemblée
18/10/2007
Private document
18/10/2007
Amendment
18/10/2007
Minutes of general meeting
of shareholders
19/09/2007
Appointment/resignation of
company officers
19/09/2007
PV d'Assemblée
19/09/2007
Private document
19/09/2007
Minutes of general meeting
of shareholders
24/10/2005
Acte sous seing privé
24/10/2005
Private document
24/10/2005
Private document
24/10/2005
Minutes of general meeting
of shareholders
24/10/2005
PV d'Assemblée
24/10/2005
Minutes of general meeting
of shareholders
24/10/2005
Acte modificatif
24/10/2005
Amendment
24/10/2005
Amendment
14/01/2005
New legal form – no new
category
14/01/2005
Private document
14/01/2005
Minutes of general meeting
of shareholders
14/01/2005
PV d'Assemblée
14/01/2005
Minutes of general meeting
of shareholders
14/01/2005
Appointment/resignation of
company officers
14/01/2005
Nomination/démission des
organes de gestion
14/01/2005
Appointment/resignation of
company officers
14/01/2005
Changement de Forme
Juridique sans changement de catégorie
14/01/2005
Changement de Forme
Juridique avec changement de catégorie
14/01/2005
Acte modificatif
14/01/2005
Private document
14/01/2005
Updated articles of
association
14/01/2005
Updated articles of
association
14/01/2005
Changement de Commissaire
aux Comptes
14/01/2005
New auditor
14/01/2005
New auditor
14/01/2005
Statuts mis à jour
14/01/2005
Acte sous seing privé
14/01/2005
New legal form – no new
category
14/10/2004
PV du Conseil
d'Administration
14/10/2004
Minutes of Board meeting
14/10/2004
Appointment/resignation of
company officers
14/10/2004
Nomination/démission des
organes de gestion
14/10/2004
Appointment/resignation of
company officers
14/10/2004
Private document
14/10/2004
Minutes of Board meeting
14/10/2004
Acte sous seing privé
14/10/2004
Changes to the Board of
Directors
14/10/2004
Modification du Conseil
d'Administration
14/10/2004
Changes to the Board of
Directors
14/10/2004
Acte modificatif
14/10/2004
Private document
24/06/2004
Updated articles of
association
24/06/2004
Acte modificatif
24/06/2004
Capital reduction
24/06/2004
Réduction de Capital
24/06/2004
Capital reduction
24/06/2004
Acte sous seing privé
24/06/2004
Private document
24/06/2004
Private document
24/06/2004
PV d'Assemblée
24/06/2004
Minutes of Board meeting
24/06/2004
PV du Conseil
d'Administration
24/06/2004
Minutes of Board meeting
24/06/2004
Statuts mis à jour
24/06/2004
Updated articles of
association
16/03/2004
Capital reduction
16/03/2004
Private document
16/03/2004
Acte sous seing privé
16/03/2004
Minutes of general meeting
of shareholders
16/03/2004
Réduction de Capital
16/03/2004
Acte modificatif
16/03/2004
PV d'Assemblée
01/07/2003
Nomination/démission des
organes de gestion
01/07/2003
Changement de Président
(PDG, PCA)
01/07/2003
Acte modificatif
01/07/2003
PV du Conseil
d'Administration
01/07/2003
Modification du Conseil
d'Administration
01/07/2003
Acte sous seing privé
05/02/2003
Acte modificatif
05/02/2003
Statuts mis à jour
05/02/2003
PV du Conseil
d'Administration
05/02/2003
Nomination/démission des
organes de gestion
05/02/2003
Acte sous seing privé
05/02/2003
PV d'Assemblée
05/02/2003
Modification du Conseil
d'Administration
20/12/2002
Acte modificatif
20/12/2002
Requête et Ordonnance
02/10/2001
PV d'Assemblée
02/10/2001
Conversion du Capital
Social en Euros
02/10/2001
Augmentation de Capital
02/10/2001
Acte modificatif
02/10/2001
Acte sous seing privé
02/10/2001
Statuts mis à jour
02/10/2001
PV du Conseil
d'Administration
13/07/2000
Modification de l'objet
social
13/07/2000
Acte modificatif
13/07/2000
Statuts mis à jour
13/07/2000
Acte sous seing privé
13/07/2000
PV d'Assemblée
10/09/1999
PV d'Assemblée
10/09/1999
Nomination/démission des
organes de gestion
10/09/1999
Acte sous seing privé
10/09/1999
Acte modificatif
02/09/1998
Acte modificatif
02/09/1998
PV d'Assemblée
02/09/1998
Nomination/démission des
organes de gestion
02/09/1998
Acte sous seing privé
29/08/1996
Augmentation de Capital
29/08/1996
Acte modificatif
29/08/1996
PV d'Assemblée
29/08/1996
Statuts mis à jour
24/08/1995
Acte modificatif
24/08/1995
PV du Conseil
d'Administration
24/08/1995
PV d'Assemblée
24/08/1995
Nomination/démission des
organes de gestion
27/01/1995
Acte modificatif
27/01/1995
Cession de parts
27/01/1995
Expédition acte notarié
28/12/1993
PV d'Assemblée
28/12/1993
Acte modificatif
05/03/1993
Déclaration de conformité
05/03/1993
Statuts mis à jour
05/03/1993
PV du Conseil
d'Administration
05/03/1993
PV d'Assemblée
05/03/1993
Acte modificatif
05/03/1993
Augmentation de Capital
23/01/1993
Statuts mis à jour
23/01/1993
PV du Conseil
d'Administration
23/01/1993
Déclaration de conformité
23/01/1993
PV d'Assemblée
23/01/1993
Augmentation de Capital
23/01/1993
Acte modificatif
09/09/1992
Nomination/démission des
organes de gestion
09/09/1992
PV du Conseil
d'Administration
09/09/1992
PV d'Assemblée
09/09/1992
Changement de Président
(PDG, PCA)
09/09/1992
Acte modificatif
09/09/1992
Modification du Conseil
d'Administration
27/11/1991
Cession de parts
27/11/1991
Expédition acte notarié
NOTES & COMMENTS
Na
FOREIGN EXCHANGE RATES
Currency
Unit
Indian Rupees
US Dollar
1
Rs.62.57
UK Pound
1
Rs.100.62
Euro
1
Rs.84.62
INFORMATION DETAILS
Report Prepared
by :
PDT
RATING EXPLANATIONS
RATING
STATUS
PROPOSED CREDIT LINE
>86
Aaa
Possesses an extremely sound financial base with the strongest
capability for timely payment of interest and principal sums
Unlimited
71-85
Aa
Possesses adequate working capital. No caution needed for credit
transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest
and principal sums
Large
56-70
A
Financial & operational base are regarded healthy. General
unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for
payment of interest and principal sums
Fairly Large
41-55
Ba
Overall operation is considered normal. Capable to meet normal
commitments.
Satisfactory
26-40
B
Capability to overcome
financial difficulties seems comparatively below average.
Small
11-25
Ca
Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums
in default or expected to be in default upon maturity
Limited with
full security
<10
C
Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised
Credit not
recommended
--
NB
New
Business
--
This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and
to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite
of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The
assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as
follows:
Financial
condition (40%)Ownership
background (20%)Payment
record (10%)
Credit history
(10%)Market trend
(10%)Operational
size (10%)
PRIVATE
& CONFIDENTIAL : This information is provided to you at
your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the
information as aid only in determining the propriety of giving credit and
generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold
the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known
to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not
warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability
whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or
expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of
these conditions
This report is issued at your request without any
risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL)
or its officials.