MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

10.09.2013

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

RHI AG

 

 

Registered Office :

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

31.12.2012

 

 

Date of Incorporation :

1976

 

 

Legal Form :

Joint Stock Company

 

 

Line of Business :

Manufacture of refractory products

 

 

No. of Employees :

660

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory

 

 

Payment Behaviour :

No Complaints

 

 

Litigation :

Clear

 

 

NOTES:

Any query related to this report can be made on e-mail: infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – March, 31st, 2013

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2012)

Current Rating

(31.03.2013)

Austria

A2

A2

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 

AUSTRIA - ECONOMIC OVERVIEW

 

Austria, with its well-developed market economy, skilled labor force, and high standard of living, is closely tied to other EU economies, especially Germany's. Its economy features a large service sector, a sound industrial sector, and a small, but highly developed agricultural sector. Following several years of solid foreign demand for Austrian exports and record employment growth, the international financial crisis of 2008 and subsequent global economic downturn led to a sharp but brief recession. Austrian GDP contracted 3.8% in 2009 but saw positive growth of about 2% in 2010 and 2.7% in 2011. Growth fell to 0.6% in 2012. Unemployment did not rise as steeply in Austria as elsewhere in Europe, partly because the government subsidized reduced working hour schemes to allow companies to retain employees. The 2012 unemployment rate of 4.3% was the lowest within the EU. Stabilization measures, stimulus spending, and an income tax reform pushed the budget deficit to 4.5% in 2010 and 2.6% in 2011, from only about 0.9% in 2008. The international financial crisis of 2008 caused difficulties for Austria's largest banks whose extensive operations in central, eastern, and southeastern Europe faced large losses. The government provided bank support - including in some instances, nationalization - to support aggregate demand and stabilize the banking system. Austria's fiscal position compares favorably with other euro-zone countries, but it faces external risks, such as Austrian banks' continued exposure to Central and Eastern Europe as well as political and economic uncertainties caused by the European sovereign debt crisis. In 2011 the government attempted to pass a constitutional amendment limiting public debt to 60% of GDP by 2020, but it was unable to obtain sufficient support in parliament and instead passed the measure as a simple law. In March 2012, the Austrian parliament approved an austerity package consisting of a mix of expenditure cuts and new revenues that will bring public finances into balance by 2016. In 2012, the budget deficit rose to 3.1% of GDP.

 

Source : CIA

 


Basic company information

 

Company name:

RHI AG

Status:

active company

Locations:

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

Phone:

0043 (5) 0213

Fax:

0043 (5) 0213 - 6213

E-mail:

info@rhi-ag.com

Internet:

http://www.rhi-ag.com

Activities:

Önace 23200 90% Manufacture of refractory products

 

Önace 82990 5% Other business support service activities n.e.c.

 

Önace 64200 5% Activities of holding companies

 

comparison:

The of this company is better than industry average.

Recommendation:

In respect to solvency reasons, there is nothing to say against an establishment of a business relationship.

 

Detail Assessment:

Payment 300

As a rule payments are made on time according to conditions, in some cases there have been delays and reminders.

 

Assessment 300

Financial situation is average.

 

 

Additional company information

 

Year of incorporation:

1976

 

Activities:

 

 

Type of company:

Manufacturing

 

Legal form:

joint stock company since 1979-11-16

 

companies' house number:

FN 103123 b Wien 1979-12-18

 

VAT number:

ATU 14187609

 

number - Austrian National Bank:

62871

 

 

 

 

Import 

Country 

 

 

 

Import

world-wide

 

2013

 

 

 

Export 

Country 

 

 

 

Export

world-wide

 

2013

 

 

 

Financial data

 

total turnover (total sales)

2012

EUR  1.256.323.063,49

(exact)

total turnover (total sales)

2011

EUR  1.217.291.767,95

(exact)

total turnover (total sales)

2010

EUR  1.102.033.564,70

(exact)

total turnover (total sales)

2009

EUR  846.518.343,55

(exact)

total turnover (total sales)

2008

EUR  1.121.483.998,91

(exact)

turnover (sales) - group

2012

EUR  1.835.700.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2011

EUR  1.758.600.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2010

EUR  1.522.900.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2009

EUR  1.236.900.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2008

EUR  1.596.700.000,00

(exact)

total employees

2013

660

(approx.)

white collar workers

2013

660

(approx.)

total investments

2012

EUR  167.900.000,00

(exact)

 

 

Extraxt from the Companies' House

 

firm (style):

   22      RHI AG

legal form:

    1      Aktiengesellschaft

registered office:

    1      politischer Gemeinde Wien

business adress:

  137      Wienerbergstraße 9
           1100 Wien

capital:

  129      EUR 289.376.212,84

reference date annual accounts:

    1      31. Dezember

annual accounts:

  153      zum 31.12.2012 eingereicht am 05.06.2013

consolidated accounts:

  153      zum 31.12.2012 eingereicht am 05.06.2013

power of representation:

    1      Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder
           bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder
           durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen
           vertreten.
           Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
           selbständige Vertretungsbefugnis erteilen.

other provisions:

    3      Der Vorstand besteht aus 2, 3, 4 oder 5 Personen.

board of directors:

        CN   Mag. Barbara Potisk-Eibensteiner, geb. 09.09.1968
  147        Mitglied
             vertritt seit 01.04.2012 gemeinsam mit
             einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
        DC   DI Franz Buxbaum, geb. 22.02.1956
  154        vertritt seit 01.07.2013 gemeinsam mit
             einer Vorständin/einem Vorstand oder einer Prokuristin/einem
             Prokuristen
        DE   Dkfm. Franz Struzl, geb. 03.07.1942
  144        Vorsitzender
             vertritt seit 08.09.2011 gemeinsam mit
             einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
        DM   DI Reinhold Steiner, geb. 06.10.1964
  154        vertritt seit 01.07.2013 gemeinsam mit
             einer Vorständin/einem Vorstand oder einer Prokuristin/einem
             Prokuristen

proxy:

        BP   Dipl.Ing. Ingo Gruber, geb. 19.04.1962
   58        vertritt seit 18.03.2002 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        BT   Mag. Michael Csebits, geb. 05.01.1965
   68        vertritt seit 07.04.2003 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        BZ   Bernhard Goliasch, geb. 19.05.1964
   91        vertritt seit 01.01.2006 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        CO   Mag. Gabriele Becker-Pichler, geb. 24.05.1975
  115        vertritt seit 19.12.2007 gemeinsam mit
             einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
        CU   Mag. Bernd Buchberger, geb. 19.08.1965
  123        vertritt seit 30.03.2009 gemeinsam mit
             einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
        CY   Dipl.Ing. Thomas Jakowiak, geb. 08.04.1972
  126        vertritt seit 25.05.2009 gemeinsam mit
             einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
        DA   Dipl.Ing. Holger Woltron, geb. 19.12.1964
  126        vertritt seit 25.05.2009 gemeinsam mit
             einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
        DF   Mag. Felix Warmuth, geb. 30.03.1981
  147        vertritt seit 03.05.2012 gemeinsam mit
             einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
        DJ   DI Erik Hagander, geb. 29.06.1956
  151        vertritt seit 04.02.2013 gemeinsam mit
             einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
        DK   Mag. Robert Ranftler, geb. 25.11.1971
  152        vertritt seit 22.04.2013 gemeinsam mit
             einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied

supervisory board:

        AX   Dipl.Bw. Gerd Peskes, geb. 26.12.1944
  111        Mitglied
        BJ   Stanislaus Prinz zu Sayn-Wittgenstein
             -Berleburg, geb. 15.09.1965
   47        Mitglied
        CI   Dipl.-Ing.Dr. Helmut Draxler, geb. 25.04.1950
  111        Stellvertreter des Vorsitzenden
        CJ   Dr. Herbert Cordt, geb. 12.01.1947
  133        Vorsitzender
        CL   Hubert Gorbach, geb. 27.07.1956
  109        Mitglied
        CQ   Franz Reiter, geb. 25.01.1962
  116        Mitglied
        CV   Roland Rabensteiner, geb. 27.01.1971
  124        Mitglied
        DD   David Schlaff, geb. 08.10.1978
  133        Mitglied
        DG   Dr. Wolfgang Ruttenstorfer, geb. 15.10.1950
  153        Stellvertreter des Vorsitzenden
        DH   Ing. Christian Hütter, geb. 24.02.1957
  150        Mitglied
        DI   Ing. Walter Geier, geb. 19.04.1957
  150        Mitglied
        DL   Dr. Alfred Gusenbauer, geb. 08.02.1960
  153        Mitglied

general table:

 Handelsgericht Wien
   1 datenersterfaßt am 17.06.1994              Geschäftsfall 920 Fr  1462/94 s
       Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
   3 eingetragen am 01.07.1994                  Geschäftsfall 703 Fr  6865/94 s
       Berichtigung - Antrag  eingelangt am 29.06.1994
  12 eingetragen am 12.12.1995                  Geschäftsfall 702 Fr 12830/95 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.12.1995
  13 eingetragen am 13.12.1995                  Geschäftsfall 702 Fr 12831/95 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.12.1995
  22 eingetragen am 08.01.1998                  Geschäftsfall  72 Fr 12900/97 b
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.12.1997
  33 eingetragen am 22.07.1999                  Geschäftsfall  72 Fr  8698/99 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.07.1999
  34 eingetragen am 06.08.1999                  Geschäftsfall  72 Fr  8701/99 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.07.1999
  35 eingetragen am 07.09.1999                  Geschäftsfall  72 Fr  9670/99 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.07.1999
  36 eingetragen am 15.10.1999                  Geschäftsfall  73 Fr  1989/99 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.10.1999
  42 eingetragen am 19.05.2001                  Geschäftsfall  73 Fr  5484/01 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.04.2001
  47 eingetragen am 06.07.2001                  Geschäftsfall  73 Fr  8859/01 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.07.2001
  58 eingetragen am 06.04.2002                  Geschäftsfall  73 Fr  3820/02 v
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.04.2002
  68 eingetragen am 09.05.2003                  Geschäftsfall  73 Fr  4762/03 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.04.2003
  69 eingetragen am 05.08.2003                  Geschäftsfall  73 Fr  8065/03 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 15.07.2003
  70 eingetragen am 25.09.2003                  Geschäftsfall  73 Fr 10680/03 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.09.2003
  72 eingetragen am 24.12.2003                  Geschäftsfall  73 Fr 14627/03 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.12.2003
  74 eingetragen am 24.03.2004                  Geschäftsfall  73 Fr  3326/04 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.03.2004
  75 eingetragen am 24.06.2004                  Geschäftsfall  73 Fr  6931/04 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.06.2004
  78 eingetragen am 28.09.2004                  Geschäftsfall  73 Fr 11101/04 v
       Berichtigung - Antrag  eingelangt am 27.09.2004
  80 eingetragen am 18.12.2004                  Geschäftsfall  73 Fr 15541/04 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.12.2004
  83 eingetragen am 19.03.2005                  Geschäftsfall  73 Fr  3641/05 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.03.2005
  84 eingetragen am 28.06.2005                  Geschäftsfall  73 Fr  7870/05 a
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.06.2005
  87 eingetragen am 09.09.2005                  Geschäftsfall  73 Fr  9194/05 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.07.2005
  88 eingetragen am 24.09.2005                  Geschäftsfall  73 Fr 11472/05 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.09.2005
  90 eingetragen am 21.12.2005                  Geschäftsfall  73 Fr 15872/05 v
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.12.2005
  91 eingetragen am 27.01.2006                  Geschäftsfall  73 Fr   816/06 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.01.2006
  93 eingetragen am 25.03.2006                  Geschäftsfall  71 Fr  2706/06 a
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.03.2006
  94 eingetragen am 30.06.2006                  Geschäftsfall  71 Fr  6101/06 v
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.06.2006
  97 eingetragen am 14.07.2006                  Geschäftsfall  71 Fr  6725/06 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.07.2006
  98 eingetragen am 22.09.2006                  Geschäftsfall  71 Fr  9393/06 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.09.2006
  99 eingetragen am 21.12.2006                  Geschäftsfall  71 Fr 13417/06 b
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.12.2006
 102 eingetragen am 07.02.2007                  Geschäftsfall  71 Fr  1466/07 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 01.02.2007
 103 eingetragen am 28.03.2007                  Geschäftsfall  71 Fr  3756/07 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.03.2007
 104 eingetragen am 30.03.2007                  Geschäftsfall  71 Fr  3911/07 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.03.2007
 106 eingetragen am 26.06.2007                  Geschäftsfall  71 Fr  7189/07 b
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.06.2007
 107 eingetragen am 27.06.2007                  Geschäftsfall  71 Fr  7379/07 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.06.2007
 109 eingetragen am 31.07.2007                  Geschäftsfall  71 Fr  7486/07 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.06.2007
 110 eingetragen am 15.09.2007                  Geschäftsfall  71 Fr 10678/07 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.09.2007
 111 eingetragen am 03.10.2007                  Geschäftsfall  71 Fr 11666/07 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.09.2007
 114 eingetragen am 22.12.2007                  Geschäftsfall  71 Fr 15179/07 b
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.12.2007
 115 eingetragen am 17.01.2008                  Geschäftsfall  71 Fr   555/08 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.01.2008
 116 eingetragen am 06.02.2008                  Geschäftsfall  71 Fr  1394/08 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.01.2008
 118 eingetragen am 17.05.2008                  Geschäftsfall  75 Fr  4804/08 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.05.2008
 119 eingetragen am 11.09.2008                  Geschäftsfall  75 Fr  9111/08 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.08.2008
 120 eingetragen am 24.09.2008                  Geschäftsfall  75 Fr 10547/08 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.09.2008
 121 eingetragen am 09.01.2009                  Geschäftsfall  75 Fr 15828/08 w
       Urkundenvorlage  eingelangt am 23.12.2008
 123 eingetragen am 07.04.2009                  Geschäftsfall  71 Fr  4335/09 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.04.2009
 124 eingetragen am 16.05.2009                  Geschäftsfall  71 Fr  6076/09 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.05.2009
 126 eingetragen am 03.07.2009                  Geschäftsfall  71 Fr  8155/09 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.06.2009
 127 eingetragen am 11.07.2009                  Geschäftsfall  71 Fr  8561/09 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.07.2009
 128 eingetragen am 22.09.2009                  Geschäftsfall  71 Fr 11849/09 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.09.2009
 129 eingetragen am 23.12.2009                  Geschäftsfall  71 Fr 16770/09 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.12.2009
 130 eingetragen am 30.01.2010                  Geschäftsfall  71 Fr   930/10 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.01.2010
 133 eingetragen am 03.06.2010                  Geschäftsfall  71 Fr  5509/10 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.05.2010
 137 eingetragen am 11.11.2010                  Geschäftsfall  71 Fr 11954/10 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.11.2010
 140 eingetragen am 23.06.2011                  Geschäftsfall  75 Fr 10438/11 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 10.06.2011
 144 eingetragen am 10.11.2011                  Geschäftsfall  75 Fr 21319/11 x
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.11.2011
 145 eingetragen am 16.12.2011                  Geschäftsfall  75 Fr 22832/11 x
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.12.2011
 146 eingetragen am 27.06.2012                  Geschäftsfall  75 Fr  8069/12 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.06.2012
 147 eingetragen am 06.07.2012                  Geschäftsfall  75 Fr  8285/12 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.06.2012
 148 eingetragen am 20.07.2012                  Geschäftsfall  75 Fr  9452/12 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 27.06.2012
 150 eingetragen am 19.01.2013                  Geschäftsfall  75 Fr   461/13 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.01.2013
 151 eingetragen am 20.02.2013                  Geschäftsfall  75 Fr  1624/13 a
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.02.2013
 152 eingetragen am 07.05.2013                  Geschäftsfall  75 Fr  4623/13 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.05.2013
 153 eingetragen am 11.06.2013                  Geschäftsfall  75 Fr  5756/13 b
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.06.2013
 154 eingetragen am 05.07.2013                  Geschäftsfall  75 Fr  7742/13 y
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.07.2013
 155 eingetragen am 03.09.2013                  Geschäftsfall  75 Fr 10466/13 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.08.2013

 

 

Real estate

 

Real estate :

No real estate property registered

 

 

Private data

 

 

Surname

 

 

Date of birth

 

 

Address

 

 

Executive positions

 

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Mag.  Bernd Dieter Buchberger

1965-08-19 

 

8700 Leoben Magnesitstraße 2

 

joint signing clerk

 

3

 

Mag.  Michael Csebits

 

1960-01-05 

 

2405 Bad Deutsch Altenburg Altenburgerstraße 2A

joint signing clerk

 

1

 

Bernhard Goliasch

1964-05-19 

1100 Wien Palisagasse 20

joint signing clerk

0

Dipl-Ing.  Ingo Gruber

1962-04-19 

9300 St. Veit Glan Rainweg 18

joint signing clerk

1

Dipl-Ing.  Erik Hagander

1956-06-29 

 

1040 Wien Graf Starhemberggasse 1A

joint signing clerk

 

0

 

Dipl-Ing.  Thomas Jakowiak

1972-04-08 

 

1100 Wien Wienerbergstraße 11(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Mag.  Gabriele Pichler

1975-05-24 

3240 Mank Plainachergasse 7

joint signing clerk

1

Mag.  Robert Ranftler

1971-11-25 

1100 Wien Alxingergasse 57-59

joint signing clerk

5

Mag.  Felix Warmuth

 

1981-03-30 

 

2483 Ebreichsdorf Gutshofzeile 1

joint signing clerk

 

0

 

Dipl-Ing.  Holger Woltron

1964-12-19 

 

2630 Ternitz Döpplingerstraße 24

joint signing clerk

 

1

 

Dkfm.  Franz Struzl

 

1942-07-03 

 

8650 Kindberg Kreutzerstraße 65

chairman of the executive board

 

3

 

Dipl-Ing.  Franz Buxbaum

1956-02-22 

 

2540 Bad Vöslau Anzengruberstraße 10

member of the executive board

 

1

 

Mag.  Barbara Potisk-Eibensteiner

1968-09-09 

 

1030 Wien Modecenterstraße 14

 

member of the executive board

 

1

 

Dipl-Ing.  Reinhold Steiner

1964-10-06 

 

8793 Trofaiach Edling 24d

 

member of the executive board

 

2

 

Dr.  Herbert Cordt

1947-01-12 

1010 Wien Am Parkring 12

chairman of the supervisory board

10

Dipl-Ing.Dr.  Helmut Draxler

1950-04-25 

 

1100 Wien Wienerbergstraße 11

 

deputy chairman of the supervisory board

 

4

 

 

Vorsitzender des Vorstandes

Dr.  Wolfgang Ruttenstorfer

1950-10-15 

 

1010 Wien Schottenring 30

 

deputy chairman of the supervisory board

 

9

 

Ing.  Walter Geier

1957-04-19 

8700 Leoben Magnesitgasse 6

member of the supervisory board

0

Hubert Gorbach

1956-07-27 

6820 Frastanz Obere Lände 1

member of the supervisory board

2

Dr.  Alfred Gusenbauer

1960-02-08 

1070 Wien Sankt Ulrichsplatz 4

member of the supervisory board

10

Ing.  Christian Hütter

1957-02-24 

1050 Wien Högelmüllerstraße 3

member of the supervisory board

0

Dipl-Betriebsw.  Gerd Peskes

1944-12-26 

 

40479 Düsseldorf Inselstraße 20

member of the supervisory board

 

1

 

Roland Rabensteiner

1971-01-27 

8663 Veitsch Köhlersiedlung 3

member of the supervisory board

0

Franz Reiter

 

1962-01-25 

 

6020 Innsbruck Universitätsstraße 15(c/o)

member of the supervisory board

 

0

 

Prinz  Stanislaus Sayn-Wittgenstein Berleburg

1965-09-15 

 

81672 München Rosenheimerstraße 146 b(c/o)

member of the supervisory board

 

0

 

David Schlaff

 

1978-10-08 

 

1100 Wien Wienerbergstraße 11(c/o)

member of the supervisory board

 

0

 

Dipl-Betriebsw.  Peter Luef

  

 

1100 Wien Wienerbergstraße 9(c/o)

head of accounting

 

0

 

Ing.  Karl Astecker

 

  

 

1100 Wien Wienerbergstraße 11(c/o)

head of EDP

 

0

 

Dkfm.  Michael Merzbach

 

  

 

1100 Wien Wienerbergstraße 9(c/o)

head of personnel

 

0

 

 

 

 

Balance Sheet (absolute) 

 

all amounts in EUR 

 

 

2012-12-31 

 

 

 

 

Franchises, patents, licences, trademarks and similar rights and advantages

5.405.382,96

 

 

 

 

Sum intangible assets

5.405.382,96

 

 

 

 

 

Other operating and business equipment

2.343.877,00

 

 

 

 

Technical plants and machines

6.674.096,00

 

 

 

 

Advanced payments and constructions in progress

1.828.132,22

 

 

 

 

Sum tangible assets

10.846.105,22

 

 

 

 

 

Shares on related firms

878.188.564,25

 

 

 

 

Other financial assets, values and securities of fixed assets

16.593.696,18

 

 

 

 

Sum financial assets

894.782.260,43

 

 

 

 

 

Sum fixed assets

911.033.748,61

 

 

 

 

 

Raw-, auxiliary materials and supplies

5.934.632,35

 

 

 

 

Finished products

35.471.499,24

 

 

 

 

Outstanding service claims

1.468.818,11

 

 

 

 

Sum stock

42.874.949,70

 

 

 

 

 

Claims from delivered goods and performed services

90.791.403,78

 

 

 

 

Claims against companies with shareholding relationship

15.436,80

 

 

 

 

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

597.701.861,28

 

 

 

 

Other claims and assets

39.232.842,26

 

 

 

 

Sum claims

727.741.544,12

 

 

 

 

 

Cash on hand, cheques and bank deposits

129.571.848,75

 

 

 

 

Sum cash and bank

129.571.848,75

 

 

 

 

 

Sum current assets

900.188.342,57

 

 

 

 

 

Deferred charges

68.316,17

 

 

 

 

Sum deferred charges

68.316,17

 

 

 

 

Assets

1.811.290.407,35

 

 

 

 

 

Subscribed/declared capital

289.376.212,84

 

 

 

 

Committed capital reserves

39.142.056,75

 

 

 

 

Balance sheet profit/balance sheet loss

566.184.459,22

 

 

 

 

Thereof profit/loss carried forward

447.234.360,41

 

 

 

 

Sum equity capital

894.702.728,81

 

 

 

 

 

Reservesfor severance pays

18.179.546,00

 

 

 

 

Reserves for pensions

27.089.364,00

 

 

 

 

Tax reserves

10.245.916,97

 

 

 

 

Other reserves

76.589.846,43

 

 

 

 

Sum reserves

132.104.673,40

 

 

 

 

 

Liabilities against credit institutes

503.434.236,60

 

 

 

 

Received advanced payments for orders

10.997.193,01

 

 

 

 

Liabilities from delivered goods and performed services from the acceptance of drafts and emission of promissory notes

16.651.002,10

 

 

 

 

Liabilities against related firms

241.115.744,63

 

 

 

 

Other liabilities

12.284.828,80

 

 

 

 

Sum liabilities

784.483.005,14

 

 

 

 

 

Liabilities

1.811.290.407,35

 

 

 

 

 

Contingent liabilities

96.843.185,84

 

 

 

 

Balance sheet sum

1.811.290.407,35

 

 

 

 

 

P / L Account (absolute) 

 

all amounts in EUR 

 

2012-12-31 

 

 

 

 

Gross sales 

1.256.323.063,49

 

 

 

 

Increase or decrease in finished and unfinished goods and in service claims 

-110.171,66

 

 

 

 

Sum turnover or sum gross profit 

1.256.212.891,83

 

 

 

 

 

Profits from retirement of fixed assets, except financial assets 

6.726,00

 

 

 

 

Income from dissolution of reserves 

6.332.400,71

 

 

 

 

Other operating profits 

40.694.337,61

 

 

 

 

Other operating profits totally 

47.033.464,32

 

 

 

 

 

Costs for obtained services 

-51.190,76

 

 

 

 

Special account material costs 

-925.075.383,98

 

 

 

 

Costs for obtained services totally 

-925.126.574,74

 

 

 

 

 

Salaries 

-56.397.847,05

 

 

 

 

Costs for severance pays 

-4.510.246,93

 

 

 

 

Costs for old age pension 

-4.777.705,36

 

 

 

 

Legal fringe benefits and other payments depending on salaries 

-12.349.464,83

 

 

 

 

Other social fringe benefits 

-1.449.680,98

 

 

 

 

Personnel expenses totally 

-79.484.945,15

 

 

 

 

 

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation 

-3.942.646,06

 

 

 

 

Depreciation tangible assets / intangible assets totally 

-3.942.646,06

 

 

 

 

 

Different operating costs 

-206.181.163,32

 

 

 

 

Other taxes 

-65.280,97

 

 

 

 

Other operating costs totally 

-206.246.444,29

 

 

 

 

 

Operating result totally 

88.445.745,91

 

 

 

 

 

Profits from shareholdings 

21.341.854,58

 

 

 

 

Income from other securities and loans of financial assets 

158.299,84

 

 

 

 

Interest income, securties income and similar income 

14.104.590,27

 

 

 

 

Profits from the retirement of and investment in financial assets 

20.125.041,08

 

 

 

 

Interest and similar disbursements 

-16.706.598,82

 

 

 

 

Financial profits totally 

39.023.186,95

 

 

 

 

 

Results from usual business activity totally 

127.468.932,86

 

 

 

 

 

Taxes on income and profits 

-8.518.834,05

 

 

 

 

Taxes on income and profits totally 

-8.518.834,05

 

 

 

 

Annual surplus/annual deficit totally 

118.950.098,81

 

 

 

 

 

Annual profit/annual loss totally 

118.950.098,81

 

 

 

 

 

Profit and loss carried forward from previous year 

447.234.360,41

 

 

 

 

Transfer of profits totally 

447.234.360,41

 

 

 

 

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account 

566.184.459,22

 

 

 

 

 

Key ratios

 

 

2012  

 

 

 

 

 

Cash flow II

  122.892.744,87

 

 

 

 

 

Debt amortisation period

  6,31

 

 

 

 

 

Bank indebtedness

  27,79

 

 

 

 

 

Equity capital share

  49,69

 

 

 

 

 

Social capital share

  2,49

 

 

 

 

 

Fixed assets coverage

  103,17

 

 

 

 

 

Net profit ratio

  10,14

 

 

 

 

 

Capital turnover

  0,69

 

 

 

 

 

Return on investment

  7,95

 

 

 

 

 

Cash flow in % of operating performance

  9,78

 

 

 

 

 

Cash flow I

  131.411.578,92

 

 

 

 

 

Gross productivity

  15,80

 

 

 

 

 

Net productivity

  4,16

 

 

 

 

 

Operating performance

  1.256.212.891,83

 

 

 

 

 

Inventories in % of operating performance

  3,41

 

 

 

 

 

Gross profit

  331.086.317,09

 

 

 

 

 

 

 

Locations

 

Type

Locations

Description

 

 

E-mail 

operational 

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

registered office, rented premises 

 

 

 

operational 

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

registered headquarters, rented premises 

 

 

info@rhi-ag.com

operational 

P.O. Box  143, A-1011 Wien

postbox 

 

 

 

operational 

Schoberpassbundesstraße  57, A-8784 Trieben, Werk Veitsch Radex

branch office 

 

 

 

operational 

Magnesitstrasse  2, A-8700 Leoben, Technologiezentrum

branch office, rented premises 

 

 

 

former 

Wienerbergstraße  11, A-1100 Wien

registered office 

 

 

 

former 

Mommsengasse  35, A-1040 Wien

registered office 

 

 

 

former 

Wienerbergstraße  11, A-1100 Wien

registered headquarters 

 

 

 

former 

Opernring  1, A-1010 Wien

office 

 

 

 

former 

Millstätterstraße  25, A-9545 Radenthein

office 

 

 

 

 

 

related companies

 

Company name

 

Postal code

 

Stake in %

 

KSV-number

Companies House

 

Shares in this company are held by:

Chestnut Beteiligungsgesell- schaft mbH

Am Holzmaierfeld  1, D-82064 Straßlach Dingharting

 

 

7.172.750

 

 

Silver Beteiligungsgesell- schaft mbH

Am Holzmaierfeld  1, D-82064 Straßlach Dingharting

 

 

7.172.751

 

 

MS Privatstiftung

 

An der Hülben  4, A-1010 Wien

 

 

1.091.624

 

FN 194908 f

 

FEWI Beteiligungsgesellschaft mbH

Am Holzmaierfeld  1, D-82064 Straßlach-Dingharting

 

 

7.156.721

 

 

 

This company holds 100% of the shares in:

Refractory Intellectual Property GmbH

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

100 % 2002-01-31

 

1.195.043

 

FN 218190 v

 

Veitscher Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

100 % 2002-05-01

 

531.734

 

FN 127094 d

 

"VEITSCH-RADEX" Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

100 % 2002-05-09

 

939.717

 

FN 168287 g

 

Veitsch-Radex GmbH

 

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

100 % 2002-03-13

 

1.199.471

 

FN 219532 t

 

 

This company holds 50% to 99% of the shares in:

RHI Refractories Raw Material GmbH

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

99.8 % 1999-04-10

 

720.797

 

FN 138973 y

 

 

This company holds less than 50% of the shares in:

Kompetenz- und Informationszentrum für Humanvermögen und interdisziplinäre Arbeits- und Unternehmensforschung GmbH

Kierlingerstraße  87, A-3400 Klosterneuburg

8.89 % 2003-10-10

 

1.305.209

 

FN 240485 f

 

 

Affiliated companies and further participations:

Radex Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Magnesitstraße  2, A-8700 Leoben

 

 

939.530

 

FN 168288 h

 

MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH

Magnesitstraße  40, A-8614 Breitenau Hochlantsch

 

 

1.246.782

 

FN 228996 i

 

MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH & Co KG

Magnesitstraße  40, A-8614 Breitenau Hochlantsch

 

 

1.256.435

 

FN 229831 m

 

Veitsch-Radex GmbH & Co OG

 

Wienerbergstraße  9, A-1100 Wien

2002-05-08

 

1.211.872

 

FN 221994 m

 

Refractory Intellectual Property GmbH & Co KG

Wienerbergstraße  11, A-1100 Wien

2002-03-15

 

1.202.762

 

FN 219265 z

 

 

 

Bankers

 

 

 

 

Banker

Bank sort code

Type of banking connection

The Royal Bank of Scotland N.V., 1011 Wien

 

19985

 

main bank connection

 

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, 1011 Wien

 

20111

 

main bank connection

 

UniCredit Bank Austria AG, 1011 Wien

 

20151

 

main bank connection

 

BKS Bank AG, 9010 Klagenfurt

 

17000

 

secondary banking connection

 

Raiffeisen Bank International AG, 1011 Wien

 

31000

 

secondary banking connection

 

 

 

Historical development

 

Year of incorporation:

1976

Date of registration:

1979-12-18

 

Change in share capital:

From

To

Capital

  2005-03-19

  2005-06-28

EUR  166.947.951,72

  2005-06-28

  2005-09-24

EUR  167.387.622,16

   

  1999-08-09

ATS  1.392.003.900,00

  1999-08-09

  1999-10-18

EUR  101.160.868,59

  1999-10-18

  2003-09-25

EUR  144.764.569,09

  2003-09-25

  2003-12-24

EUR  145.364.119,97

  2003-12-24

  2004-03-24

EUR  145.723.850,50

  2004-03-24

  2004-06-24

EUR  145.803.790,62

  2004-06-24

  2004-09-24

EUR  146.523.251,68

  2004-09-24

  2004-12-18

EUR  158.873.999,85

  2004-12-18

  2005-03-19

EUR  159.753.341,14

  2005-09-24

  2005-12-21

EUR  188.491.803,28

  2005-12-21

  2006-03-25

EUR  189.531.024,32

  2006-03-25

  2006-06-30

EUR  193.328.178,12

  2006-06-30

  2006-09-22

EUR  195.646.440,44

  2006-09-22

  2006-12-21

EUR  196.805.571,60

  2006-12-21

  2007-03-28

EUR  212.074.126,88

  2007-03-28

  2007-03-30

EUR  235.976.219,65

  2007-03-30

  2007-06-26

EUR  237.295.231,46

  2007-06-26

  2007-06-27

EUR  271.909.298,91

  2007-06-27

  2007-09-15

EUR  271.989.239,02

  2007-09-15

  2007-12-20

EUR  272.109.149,18

  2007-12-20

  2007-12-22

EUR  272.189.089,29

  2007-12-22

  2008-05-19

EUR  272.348.969,51

  2008-05-19

  2008-09-24

EUR  272.548.819,78

  2008-09-24

  2009-01-09

EUR  274.827.112,90

  2009-01-09

  2009-09-22

EUR  275.626.514,00

  2009-09-22

  2009-12-23

EUR  276.665.735,42

  2009-12-23

   

EUR  289.376.212,84

 

Former executives:

From

To

Function

Name

  2003-01-21

  2013-05-07

joint signing clerk 

Mag. Gerlinde Celia Konrad 

  2010-01-30

  2013-07-05

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Franz Buxbaum 

   

  1999-07-22

chairman of the executive board 

Dr. Walter Ressler 

  1999-07-22

  2002-01-16

chairman of the executive board 

Dr. Georg Obermeier 

  2002-01-14

  2007-01-20

chairman of the executive board 

Dipl-Ing.Dr. Helmut Draxler 

  2007-01-20

  2009-01-17

chairman of the executive board 

Dipl-Ing.Dr. Andreas Meier 

  2009-01-17

  2010-10-23

chairman of the executive board 

Dipl-Betriebsw. Thomas Michael Fahnemann 

  2011-03-31

  2011-11-10

chairman of the executive board 

Henning Jensen 

  2002-01-18

  2007-01-20

deputy chairman of the executive board 

Dipl-Ing.Dr. Andreas Meier 

  2007-01-20

  2007-07-04

deputy chairman of the executive board 

Dr. Eduard Zehetner 

  2007-07-04

  2009-06-17

deputy chairman of the executive board 

Dr. Stefano Colombo 

   

  1998-01-30

member of the executive board 

Mag. Hans Jörg Kaltenbrunner 

   

  1999-02-09

member of the executive board 

Dipl-Ing.Dr. Günther Mörtl 

   

  2000-01-21

member of the executive board 

Rudolf Kanzi 

  1999-02-09

  2001-05-31

member of the executive board 

Dipl-Ing. Jakob Aurel Mosser 

  1999-02-09

  2002-01-16

member of the executive board 

Dipl-Ing.Dr. Andreas Meier 

  2002-01-18

  2002-04-08

member of the executive board 

Dipl-Ing.Dr. Andreas Meier 

   

  1997-04-25

joint signing clerk 

Dr. Franz Aust 

   

  1998-08-07

joint signing clerk 

Günther Pacher 

   

  1998-11-24

joint signing clerk 

Ing.Mag. Johannes Elsner 

   

  1999-02-09

joint signing clerk 

Mag. Roland Platzer 

   

  1999-05-06

joint signing clerk 

Rosa Maria Lesacher 

  1999-02-09

  2000-01-28

joint signing clerk 

DDipl-Ing. Gerd Ingo Janitschek 

  1998-01-30

  2000-12-29

joint signing clerk 

Mag. Peter Hofmann 

  1999-02-09

  2000-12-29

joint signing clerk 

Dr. Peter Podesser 

  1999-02-09

  2001-06-22

joint signing clerk 

Mag. Gabriel Faimann 

  1999-02-09

  2001-06-22

joint signing clerk 

Dr. Günter Karhut 

  2000-05-17

  2009-04-07

joint signing clerk 

Dr. Robin Schmidt Whitley 

  2001-05-24

  2009-07-03

joint signing clerk 

Juan Alvarez 

  2008-05-16

  2009-07-03

joint signing clerk 

Mag. Martin Bartmann 

  2001-06-22

  2009-07-03

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Klaus Dösinger 

  2001-05-24

  2009-07-03

joint signing clerk 

Mag. Josef Leitgeb 

  2006-07-08

  2009-07-03

joint signing clerk 

Dr. Dieter Siegel 

  2005-01-21

  2009-07-03

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Max Taferner 

  2008-01-17

  2009-12-23

joint signing clerk 

Mag. Johann Diwald 

  2004-01-21

  2010-04-27

joint signing clerk 

Mag. Andreas Berger 

  2009-07-03

  2010-09-08

joint signing clerk 

Dipl-Betriebsw. Robert Gregan 

  2009-07-03

  2010-09-08

joint signing clerk 

Dipl-Betriebsw. Ernst Stoelzel 

  2006-07-08

  2011-07-20

joint signing clerk 

Dipl-Ing.Mag.Dr. Gerald Klenner 

  2006-07-08

  2011-07-20

joint signing clerk 

Mag. Rainhard Mayer 

  2002-07-26

  2011-11-12

joint signing clerk 

Gottfried Hofreither 

  2007-10-03

  2012-07-06

joint signing clerk 

Mag. Barbara Potisk Eibensteiner 

  2009-07-03

  2013-01-19

joint signing clerk 

Ulf Andersson 

  2002-06-06

  2007-10-03

deputy chairman of the supervisory board 

Dipl-Betriebsw. Gerd Peskes 

  2007-11-03

  2008-09-11

deputy chairman of the supervisory board 

Dr. Herbert Cordt 

  2007-10-03

  2010-06-03

deputy chairman of the supervisory board 

Dr. Herbert Cordt 

  2010-06-03

  2013-06-11

deputy chairman of the supervisory board 

Dkfm. Michael Gröller 

  1997-07-04

  1997-11-05

member of the supervisory board 

Ferdinand Lacina 

   

  1998-01-30

member of the supervisory board 

Dr. Andreas Foglar Deinhardstein 

   

  1999-05-06

member of the supervisory board 

Dkfm. Gerhard Randa 

   

  1999-07-22

member of the supervisory board 

Andreas Huiskamp 

   

  1999-07-22

member of the supervisory board 

Hellmuth Wandschneider 

   

  2001-07-06

member of the supervisory board 

Max Deitcher 

  1999-07-22

  2001-09-12

member of the supervisory board 

Dr. Erich Hampel 

  1999-07-22

  2001-10-19

member of the supervisory board 

DDr. Erhard Schaschl 

  1998-06-25

  2001-10-26

member of the supervisory board 

Mag. Andreas Treichl 

  1999-07-22

  2002-03-01

member of the supervisory board 

Dipl-Betriebsw. Gerd Peskes 

  2002-03-01

  2002-10-03

member of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Friedrich Nemec 

  2002-03-01

  2004-07-03

member of the supervisory board 

Dr. Walter Ressler 

  2004-07-03

  2005-08-23

member of the supervisory board 

August Francois von Finck 

  1995-08-22

  2005-09-03

member of the supervisory board 

Dipl-Ing. Maximilian Ardelt 

  2004-12-07

  2005-10-04

member of the supervisory board 

Ing. Günther Lippitsch 

  2001-11-27

  2007-07-31

member of the supervisory board 

DDr. Erhard Schaschl 

  2006-07-14

  2007-07-31

member of the supervisory board 

Dr. Kurt Waniek 

  2002-10-03

  2007-10-03

member of the supervisory board 

Dr.jur. Cornelius Alexander Grupp 

  2002-03-01

  2007-11-03

member of the supervisory board 

Ing. Gerd Klaus Gregor 

  2007-07-31

  2008-05-19

member of the supervisory board 

Dr. Herbert Cordt 

  2007-07-31

  2008-05-19

member of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Helmut Draxler 

  2007-07-31

  2008-09-11

member of the supervisory board 

Mark Eckhout 

  2001-09-12

  2009-05-16

member of the supervisory board 

Karl Wetzelhütter 

  2008-09-11

  2010-06-03

member of the supervisory board 

Dr. Ulrich Glaunach 

  2006-07-13

  2013-01-19

member of the supervisory board 

Mag. Martin Kowatsch 

  1999-03-17

  2013-01-19

member of the supervisory board 

Dipl-Ing. Leopold Miedl 

   

  2013-06-11

member of the supervisory board 

Dr. Wolfgang Ruttenstorfer 

   

  1999-03-17

employee's representative on the supervisory board 

Helga Klement 

   

  2001-09-12

employee's representative on the supervisory board 

Karl Prettner 

  1993-07-03

  2004-12-07

employee's representative on the supervisory board 

Georg Eder 

  1993-12-01

  2008-02-06

employee's representative on the supervisory board 

Josef Horn 

  2001-05-24

  2001-08-01

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Edmar Allitsch 

  2001-05-24

  2001-08-01

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Viktor Fischer 

  1999-02-09

  2001-10-18

joint signing clerk 

Mag. Norbert Wittmann 

  1999-02-09

  2002-07-26

joint signing clerk 

Mag. Ronald Elgert 

  1999-02-09

  2002-07-26

joint signing clerk 

Fritz Friedrich 

  2002-07-30

  2002-11-12

joint signing clerk 

Mag. Norbert Wittmann 

  1994-12-02

  2003-02-08

joint signing clerk 

Dr. Georg Gerhardt 

  1999-02-09

  2003-11-08

joint signing clerk 

Dr. Gerhard Kantusch 

  2001-06-22

  2005-01-25

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Stefan Wallner 

  2005-01-21

  2006-01-27

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Björn Karlsson 

  2001-05-24

  2007-02-07

joint signing clerk 

Dr. Giorgio Cappelli 

  2001-05-24

  2007-02-07

joint signing clerk 

Dr. Manfred Hödl 

  2000-12-29

  2007-06-16

joint signing clerk 

Dkfm. Markus Richter 

  1999-02-09

  2007-07-04

joint signing clerk 

Mag. Rudolf Payer 

  1998-01-30

  2008-05-16

joint signing clerk 

Mag. Andreas Bier 

  2006-07-08

  2009-04-07

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Claus Braunhuber 

  2001-06-22

  2009-04-07

joint signing clerk 

Dipl-Ing.Dr. Stefan Pirker 

  1999-02-16

  2003-05-06

member of the executive board 

Mag. Roland Platzer 

  2002-01-16

  2007-01-20

member of the executive board 

Dr. Eduard Zehetner 

  2007-07-04

  2010-04-01

member of the executive board 

Mag. Rudolf Payer 

  2010-01-30

  2011-03-31

member of the executive board 

Henning Jensen 

  2011-03-31

  2012-07-06

member of the executive board 

Mark Eckhout 

  2007-01-04

  2013-07-05

member of the executive board 

Dr. Giorgio Cappelli 

  2007-01-04

  2013-07-05

member of the executive board 

Dr. Manfred Hödl 

   

  1997-07-04

chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing. Hellmut Friedrich Longin 

  1995-08-22

  1999-07-22

chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Friedrich Nemec 

  1999-07-22

  2002-03-01

chairman of the supervisory board 

Dr. Walter Ressler 

  2002-03-01

  2002-06-06

chairman of the supervisory board 

Dipl-Betriebsw. Gerd Peskes 

  2002-06-06

  2010-06-03

chairman of the supervisory board 

Dkfm. Michael Gröller 

   

  1997-07-04

deputy chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Friedrich Nemec 

  1998-01-30

  1999-07-22

deputy chairman of the supervisory board 

Dr. Andreas Foglar Deinhardstein 

  2001-10-19

  2001-11-27

deputy chairman of the supervisory board 

DDr. Erhard Schaschl 

  1999-07-22

  2002-03-01

deputy chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Friedrich Nemec 

  2002-03-01

  2002-06-06

deputy chairman of the supervisory board 

Dkfm. Michael Gröller 

 

Former shareholdings:

From

To

Name

   

 

Refractories Consulting & Engineering Gesellschaft m.b.H. in Liqu. 

  1998-04-22

  1999-02-26

Knauf Insulation GmbH 

  1995-12-22

  2001-03-27

VIAG Telecom Connect zweite Beteiligungs-GmbH 

  1999-03-05

  2001-05-19

VRD Asia Pacific Feuerfestbeteiligungen GmbH 

  2002-04-10

  2002-05-08

Veitsch-Radex Betriebs GmbH 

  2002-04-30

  2003-12-11

Radex Vertriebsgesellschaft m.b.H. 

  2002-05-03

  2005-07-30

Radex Vertriebsgesellschaft m.b.H. 

  2002-02-28

  2002-12-20

MAGNIFIN Magnesiaprodukte Gesellschaft m.b.H. 

  2002-11-23

  2010-09-18

MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH 

  1999-10-15

  2003-02-06

Knauf Insulation GmbH 

  2002-12-20

  2010-10-19

MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH & Co KG 

   

 

Österreichische Magnesit Aktiengesellschaft in Liquidation 

   

 

RHI Refractories Raw Material GmbH 

   

 

Heraklith AG 

 

Mergers:

Date

Function

Name

  2001-05-28

merged with 

VRD Asia Pacific Feuerfestbeteiligungen GmbH 

  2000-12-01

merged with 

Heraklith AG 

  2013-07-10

merged with 

Heraklith Holding Aktiengesellschaft 

  2005-03-22

merged with 

Veitsch-Radex Aktiengesellschaft für feuerfeste Erzeugnisse 

 

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.65.96

UK Pound

1

Rs.102.91

Euro

1

Rs.86.58

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Report Prepared by :

SDA

 

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

----

NB

New Business

----

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.