MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

10.12.2014

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

SANDOZ GMBH

 

 

Formerly Known As :

BIOCHEMIE GMBH 

 

 

Registered Office :

Biochemiestraße  10, A-6250 Kundl

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

31.12.2013

 

 

Year of Establishment :

1965

 

 

Legal Form :

Limited Liability Company

 

 

Line of Business :

Manufacture of Pharmaceutical Preparations.

 

 

No. of Employees :

3628 (Approximately)

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

 

Status :

Satisfactory

 

 

Payment Behaviour :

No Complaints

 

 

Litigation :

Clear

 

 

NOTES:

Any query related to this report can be made on e-mail: infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – September 30, 2014

 

Country Name

Previous Rating

(30.06.2014)

Current Rating

(30.09.2014)

Austria

A2

A2

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 

AUSTRIA - ECONOMIC OVERVIEW

 

Austria, with its well-developed market economy, skilled labor force, and high standard of living, is closely tied to other EU economies, especially Germany's. Its economy features a large service sector, a sound industrial sector, and a small, but highly developed agricultural sector. Following several years of solid foreign demand for Austrian exports and record employment growth, the international Financial crisis of 2008 and subsequent global economic downturn led to a sharp but brief recession. Austrian GDP contracted 3.8% in 2009 but saw positive growth of about 2% in 2010 and 2.7% in 2011. Growth fell to 0.6% in 2012. Unemployment did not rise as steeply in Austria as elsewhere in Europe, partly because the government subsidized reduced working hour schemes to allow companies to retain employees. The 2012 unemployment rate of 4.3% was the lowest within the EU. Stabilization measures, stimulus spending, and an income tax reform pushed the budget deficit to 4.5% in 2010 and 2.6% in 2011, from only about 0.9% in 2008. The international financial crisis of 2008 caused difficulties for Austria's largest banks whose extensive operations in central, eastern, and southeastern Europe faced large losses. The government provided bank support - including in some instances, nationalization - to support aggregate demand and stabilize the banking system. Austria's fiscal position compares favorably with other euro-zone countries, but it faces external risks, such as Austrian banks' continued exposure to Central and Eastern Europe as well as political and economic uncertainties caused by the European sovereign debt crisis. In 2011 the government attempted to pass a constitutional amendment limiting public debt to 60% of GDP by 2020, but it was unable to obtain sufficient support in parliament and instead passed the measure as a simple law. In March 2012, the Austrian parliament approved an austerity package consisting of a mix of expenditure cuts and new revenues that will bring public finances into balance by 2016. In 2012, the budget deficit rose to 3.1% of GDP.

 

Source : CIA


Basic company information

 

Company name:

Sandoz GmbH

Status:

active company

Locations:

Biochemiestraße  10, A-6250 Kundl

Phone:

0043 (5338) 200

Fax:

0043 (5338) 200 - 415

E-mail:

kundl.austria@sandoz.com

Internet:

http://www.sandoz.com

Internet:

http://www.sandoz.at

Activities:

Önace 21200 100% Manufacture of pharmaceutical preparations

 

Detail Assessment:

Payments are made within net agreements.

 

Financial situation is good.

 

 

Collections

 

Date of collection order

Amount presently due

Amount presently paid

Collection status quo

since

2013-05-16

EUR 0,00

EUR 578,31

Payment after debt collection

2013-06-17

2012-11-08

EUR 0,00

EUR 348,96

Payment after debt collection

2012-12-04

Sums

EUR  0,00

EUR  927,27

 

 

 

 

Additional company information

 

Year of incorporation:

1965

 

Activities:

--

 

Type of company:

Manufacturing

 

Legal form:

limited liability company since 1965-11-18

 

companies' house number:

FN 50587 v Innsbruck 1965-11-26

 

VAT number:

ATU 32425809

 

ARA-number:

3462

 

number - Austrian National Bank:

4812

 

 

Export 

Country 

 

 

 

Export

world-wide

 

2014

 

 

 

Financial data

 

total turnover (total sales)

2013

EUR  1.496.118.876,88

(exact)

total turnover (total sales)

2012

EUR  1.449.492.227,45

(exact)

total turnover (total sales)

2011

EUR  1.480.566.195,12

(exact)

total turnover (total sales)

2010

EUR  1.428.954.760,56

(exact)

total turnover (total sales)

2009

EUR  1.315.733.905,62

(exact)

total employees

2014

3628

(approx.)

total investments

2013

EUR  159.715.369,74

(exact)

 

 

Extraxt from the Companies' House

 

firm (style):

   63      Sandoz GmbH

legal form:

    1      Gesellschaft mit beschränkter Haftung

registered office:

    1      politischer Gemeinde Kundl

business adress:

   15      Biochemiestraße 10
           6250 Kundl

capital:

   52      EUR 32.703.000

reference date annual accounts:

    1      31. Dezember

annual accounts:

  139      zum 31.12.2013 eingereicht am 11.09.2014

power of representation:

    1      Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer
           bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
           durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen
           vertreten.

other provisions:

    8      Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.
    1   Gesellschaftsvertrag  vom 18.11.1965                                001
    1   Der Gesellschaftsvertrag wurde mehrfach geändert, zuletzt           002
          mit Beschluss der Generalversammlung  vom 23.05.1986
    1   Verschmelzungsvertrag  vom 30.05.1972                               003
    1   Generalversammlungsbeschluss  vom 19.06.1972                        004
          Die Biochemie Kundl Gesellschaft m.b.H., Kundl wurde mit
          dieser Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen.
    8   Generalversammlungsbeschluss vom 27.06.1994 bzw.                    005
          vom 19.07.1994
          Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
   22   Generalversammlungsbeschluss  vom 30.04.1997                        006
          Änderung des Gesellschaftsvertrages im Artikel 1.
   32   Verschmelzungsvertrag  vom 01.09.1998                               007
   32   Generalversammlungsbeschluss  vom 01.09.1998                        008
          Diese Gesellschaft wurde als
          übernehmende Gesellschaft mit der
          Novartis Handelsgesellschaft m.b.H.
          (FN 143149 p)
          als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
          Sitz der übertragenden Gesellschaft in Wien.
   52   Gesellschaftsvertrag mit Generalversammlungsbeschluss               009
          vom 25.09.2001
          gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.
          Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 224,62.
          Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Artikeln 6, 7, 9,
          10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 und 19.
   63   Generalversammlungsbeschluss  vom 24.04.2003                        010
          Änderung des Gesellschaftsvertrages im Artikel 1.
   79   Verschmelzungsvertrag  vom 28.09.2005                               011
   79   Generalversammlungsbeschluss  vom 28.09.2005                        012
          Diese Gesellschaft wurde als
          übernehmende Gesellschaft mit der
          Grandis Handel mit pharmazeutischen
          Produkten Gesellschaft mbH
          (FN 158417 t)
          als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
          Sitz der übertragenden Gesellschaft in Kundl.
   80   Verschmelzungsvertrag  vom 22.12.2005                               013
   80   Generalversammlungsbeschluss  vom 22.12.2005                        014
          Diese Gesellschaft wurde als
          übernehmende Gesellschaft mit der
          Sandoz GmbH
          (FN 233373 x)
          als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
          Sitz der übertragenden Gesellschaft in Wien.
   87   Einbringungsvertrag  vom 30.01.2006                                 015
          Einbringung eines Teilbetriebes in die
          Nabriva Therapeutics Forschungs GmbH
          (FN 269261 y)
          Teilbetrieb: Antibiotic Research Institute
   98   Generalversammlungsbeschluss  vom 15.12.2008                        016
          Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Artikeln 6, 8, 9,
          11, 12, 15 und 19.
  102   Einbringungsvertrag  vom 21.09.2009                                 017
          Einbringung eines Teilbetriebes der
          Novartis Institutes for BioMedical
          Research GmbH & Co KG
          (FN 253505 b)
          Teilbetrieb: "TopDerm"
  103   Generalversammlungsbeschluss  vom 21.09.2009                        018
          Spaltung
  103   zur Aufnahme in die                                                 019
          Novartis Pharma GmbH
          (FN 41622 i)
          durch Übertragung
          des Teilbetriebes "TopDerm"
          gemäß Spaltungs- und Übernahmsvertrag vom 21.09.2009
  141   Verschmelzungsvertrag  vom 12.09.2014                               020
  141   Generalversammlungsbeschluss  vom 12.09.2014  der                   021
          Novartis Animal Health GmbH
          (FN 152616 k)
          als übertragender Gesellschaft. Verschmelzung mit dieser
          Gesellschaft als übernehmender Gesellschaft.
          Sitz der übertragenden Gesellschaft in Kundl.

proxy:

        CT   Sibylla Härtel, geb. 21.10.1962
   26        vertritt seit 01.01.1998 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        CW   Mag. Ingrid Schwarzenberger, geb. 20.03.1958
   26        vertritt seit 01.01.1998 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        EC   Mag. Hans-Peter Amon, geb. 19.01.1975
  100        vertritt seit 01.02.2009 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        EK   Dipl.-Chem. Michael Kocher, geb. 12.04.1967
  122        vertritt seit 23.02.2012 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        EL   Dr. Nikolaus Kofler, geb. 05.12.1968
  124        vertritt seit 10.04.2012 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        EM   Dkfm. Michael Friedhofen, geb. 27.08.1967
  125        vertritt seit 12.06.2012 gemeinsam mit
             einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
        ES   Dr. Christopher Manuel Mader, geb. 10.04.1973
  134        vertritt seit 19.02.2014 gemeinsam mit
             einem/einer Geschäftsführer/in oder
             einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen
        EU   Rodrigo Goarmon Pedroso Santos
             Ferreira, geb. 10.11.1978
  137        vertritt seit 01.06.2014 gemeinsam mit
             einem/einer Geschäftsführer/in oder
             einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

supervisory board:

        CX   Helmut Pancheri, geb. 05.07.1961
   25        Mitglied
        DF   Dr. Josef Egerbacher, geb. 20.11.1958
  138        Vorsitzende/r
        EA   Barbara Nerad, geb. 30.12.1962
   96        Mitglied
        EP   Felix Senn, geb. 26.05.1959
  132        Mitglied
        EQ   Dr. Andreas Brutsche, geb. 17.09.1962
  138        Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
        EV   Sandrine Charlotte Philippe Piret-
             Gerard, geb. 17.10.1975
  138        Mitglied

managing director:

        BD   Mag. Hubert Hirzinger, geb. 10.05.1957
   90        vertritt seit 01.06.2007 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
        DU   Ernst Meijnders, geb. 14.12.1956
   82        vertritt seit 01.06.2006 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen
        ER   Dipl.Kfm. Klaus Neumayer, geb. 17.07.1964
  133        vertritt seit 01.12.2013 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
        ET   Dr. Jens Scheibner, geb. 15.11.1968
  136        vertritt seit 01.04.2014 gemeinsam mit
             einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
        EW   Dr. Thomas Nothegger, geb. 11.07.1967
  140        vertritt seit 10.09.2014 gemeinsam mit
             einem/einer weiteren Geschäftsführer/in oder
             einer/einem Prokuristin/Prokuristen

shareholder:

        CM   Novartis Holding AG
   85        ........................  EUR 3.000
   85        ...................................................  EUR 3.000
        DW   Novartis Austria GmbH
   85        ...................  EUR 32.700.000
   85        ..............................................  EUR 32.700.000
                        -------------------------------------------------------
                 Summen:          EUR 32.703.000             EUR 32.703.000

general table:

 Landesgericht Innsbruck
   1 datenersterfaßt am 23.09.1993              Geschäftsfall 915 Fr  3046/93 i
       Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
   8 eingetragen am 04.08.1994                  Geschäftsfall  19 Fr  3050/94 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.07.1994
  15 eingetragen am 31.07.1996                  Geschäftsfall  50 Fr  3421/96 b
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 10.07.1996
  18 eingetragen am 22.02.1997                  Geschäftsfall  50 Fr   480/97 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.01.1997
  22 eingetragen am 14.06.1997                  Geschäftsfall  50 Fr  3183/97 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.06.1997
  25 eingetragen am 24.01.1998                  Geschäftsfall  50 Fr   503/98 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.01.1998
  26 eingetragen am 27.01.1998                  Geschäftsfall  50 Fr   356/98 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.01.1998
  32 eingetragen am 24.11.1998                  Geschäftsfall  50 Fr  7458/98 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.09.1998
  40 eingetragen am 12.01.2000                  Geschäftsfall  50 Fr 15588/99 x
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.12.1999
  52 eingetragen am 05.10.2001                  Geschäftsfall  62 Fr  1934/01 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.09.2001
  63 eingetragen am 01.05.2003                  Geschäftsfall  62 Fr   914/03 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.04.2003
  66 eingetragen am 01.10.2003                  Geschäftsfall  62 Fr  1753/03 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.09.2003
  79 eingetragen am 06.10.2005                  Geschäftsfall  62 Fr  1652/05 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.09.2005
  80 eingetragen am 11.02.2006                  Geschäftsfall  62 Fr  2534/05 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.12.2005
  82 eingetragen am 03.06.2006                  Geschäftsfall  62 Fr   809/06 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.05.2006
  85 eingetragen am 27.07.2006                  Geschäftsfall  62 Fr  1055/06 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.07.2006
  86 eingetragen am 31.08.2006                  Geschäftsfall  62 Fr  1258/06 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.08.2006
  87 eingetragen am 10.10.2006                  Geschäftsfall  62 Fr  1543/06 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.09.2006
  88 eingetragen am 09.02.2007                  Geschäftsfall  62 Fr   236/07 x
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.02.2007
  90 eingetragen am 06.06.2007                  Geschäftsfall  62 Fr   777/07 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.05.2007
  96 eingetragen am 01.08.2008                  Geschäftsfall  62 Fr  1428/08 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.07.2008
  98 eingetragen am 19.12.2008                  Geschäftsfall  62 Fr  3130/08 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.12.2008
 100 eingetragen am 19.02.2009                  Geschäftsfall  62 Fr   265/09 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.02.2009
 102 eingetragen am 29.10.2009                  Geschäftsfall  62 Fr  2202/09 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.09.2009
 103 eingetragen am 30.10.2009                  Geschäftsfall  62 Fr  2201/09 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.09.2009
 114 eingetragen am 12.10.2010                  Geschäftsfall  62 Fr  2478/10 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.10.2010
 122 eingetragen am 16.03.2012                  Geschäftsfall  60 Fr   618/12 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.03.2012
 123 eingetragen am 26.04.2012                  Geschäftsfall  60 Fr   963/12 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.04.2012
 124 eingetragen am 01.05.2012                  Geschäftsfall  60 Fr  1009/12 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.04.2012
 125 eingetragen am 11.07.2012                  Geschäftsfall  60 Fr  1826/12 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.07.2012
 132 eingetragen am 05.10.2013                  Geschäftsfall  60 Fr  3714/13 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.09.2013
 133 eingetragen am 22.01.2014                  Geschäftsfall  60 Fr  5161/13 b
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.11.2013
 134 eingetragen am 05.03.2014                  Geschäftsfall  60 Fr   705/14 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.02.2014
 136 eingetragen am 15.05.2014                  Geschäftsfall  60 Fr  1195/14 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.04.2014
 137 eingetragen am 11.07.2014                  Geschäftsfall  60 Fr  2187/14 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.07.2014
 138 eingetragen am 16.07.2014                  Geschäftsfall  60 Fr  2246/14 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.07.2014
 139 eingetragen am 13.09.2014                  Geschäftsfall  60 Fr  3500/14 v
       Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 11.09.2014
 140 eingetragen am 03.10.2014                  Geschäftsfall  60 Fr  3933/14 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.09.2014
 141 eingetragen am 08.10.2014                  Geschäftsfall  60 Fr  3725/14 z
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.09.2014

 

 

Real estate

 

Registration number of real estate  100  Cadastral register  83108  Kundl T  Number and date of entry  2460/2011  Status of  2013-10-11 

Part A - type of real estate  :

    GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
     32/1     GST-Fläche               877
              Bauf.(Gebäude)           240
              Gärten                   637  Biochemiestraße 4
     43/2     GST-Fläche              3405
              Bauf.(Gebäude)          1498
              Sonst(Betriebsf.)       1907  Biochemiestraße 11
                                            Biochemiestraße 5
                                            Biochemiestraße 9
    478/2   G Gärten            *     5848
    478/3   G Sonst(Straßen)    *      152
    481/1     Landw(Feld/Wiese)        344
    484     G GST-Fläche        *   108797
              Bauf.(Gebäude)         45898
              Sonst(Betriebsf.)      62899  Biochemiestraße 10
                                            Biochemiestraße 6
    GESAMTFLAECHE                   119423
    1  a Stand 1923 Miteigentumsrecht zu 1/3 Anteil an EZ 57
    2  a 354/1951 Miteigentumsrecht zu 1/2 Anteil an EZ 56
   11  a 2346/1989 2463/2009 Recht der Führung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen auf gst 478/1 478/4 29 in EZ 90030
   16  a 3065/1990 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von 2
           Leitungen auf Gst 1449 in EZ 90040
   17  a 3117/1990 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von 2
           Leitungen auf Gst 1428/1 in EZ 186
   18  a 3122/1990 2862/2000 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und
           Erhaltung von 2 Leitungen auf Gst 1448 in EZ 333
   19  a 676/1991 Recht der Fürhung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1459 in EZ 979
   20  a 790/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 462 in EZ 710
   21  a 791/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1430 in EZ 90023
   22  a 792/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1425 in EZ 90011
   23  a 793/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1431 in EZ 25
   24  a 794/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 466/2 1424 in EZ 90025
   25  a 795/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1426 in EZ 90027
   26  a 796/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1423 in EZ 90033
   27  a 797/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1428/1 in EZ 186
   28  a 798/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 452/2 in EZ 90031
   29  a 799/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1433 in EZ 90003
   30  a 800/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 463 in EZ 90028
   31  a 801/1991 2307/2003 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und
           Erhaltung von Leitungen und Bauwerken auf Gst 1427 in EZ 90066
   32  a 802/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1429 in EZ 982
   33  a 803/1991 2460/2011 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und
           Erhaltung von Leitungen und Bauwerken auf
           Gst 1458/1 in EZ 166
           Gst 1458/2 in EZ 996
   34  a 1088/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
           Leitungen und Bauwerken auf Gst 1432 in EZ 204
   36  a 2325/1996 Wasserschutzgebiet auf Gst 489 gem § 34 Abs 5 WRG
   40  a 528/2004 Kaufvertrag 2003-11-25 Zuschreibung Gst 481/1 aus EZ
           90043
   42  a 2463/2009 Kaufvertrag und Urkunde 2009-10-29 Zuschreibung Gst 478/2
           478/3 aus EZ 90030
   43  a 2463/2009 RECHT des Gehens und Fahrens auf Gst 478/4 in EZ
           90030
           für Gst 478/2 478/3 484
   44  a 2463/2009 RECHT der Unterlassung der Errichtung eines Mistlagers, einer
           Bioabfall-Anlage oder einer Fäulnisanlage sowie der Ausbringung von
           Gülle, Mist oder anderen geruchsintensiven Düngemitteln auf Gst
           477/1 478/1 1293 in EZ 90030 für Gst 478/2
   45  a 2463/2009 Kaufvertrag und Urkunde 2009-10-29 Zuschreibung Teilfläche(n)
           Gst 1294/1 aus EZ 56, Einbeziehung in Gst 478/2 484
   46  a 1053/2011 RECHT der unterirdischen Führung, Verlegung, Benützung und
           Erhaltung von Leitungen in Gst 1428/1 in EZ 186 für Gst 484
   47  a 1053/2011 RECHT der unterirdischen Führung, Verlegung, Benützung und
           Erhaltung von Leitungen in Gst 1428/1 in EZ 186 für Gst 484
   48  a gelöscht
 

Part B - ownership details  :

    1 ANTEIL: 1/1
      Sandoz GmbH
      ADR: Biochemiestraße 10, Kundl   6250
       a 561/1956 Urkunde und Übergabsvertrag 1956-08-13
           Eigentumsrecht
       b 1660/2003 Namensänderung
 

Part C - registered charges  :

    3  a 1589/1993
           DIENSTBARKEIT der Verlegung, des Betriebes, der Erhaltund
           und Erneuerung einer Leitung auf Gst 481/1 gem
           Dienstbarkeitsvertrag 1993-04-30 für
           Tiroler Ferngas Gesellschaft mbH
       b 528/2004 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ
           90043
    4  a 2463/2009
           DIENSTBARKEIT des Gehens und Fahrens auf Gst 478/2 478/3
           484 gemäß Punkt VI. Ziffer 1. Kauf- und
           Dienstbarkeitsvertrag 2009-10-29
           für Gst 477/1 478/1 478/4 1293 in EZ 90030
    5  a 672/2011
           DIENSTBARKEIT zur Führung, Benützung und Erhaltung von
           sechs unterirdischen Niederspannungsleitungen nach Maßgabe
           des Punktes II. des Dienstbarkeitsvertrages vom 15.03.2011
           in Gst 484 für Gst 59/1 in EZ 275
            Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS
 

 

 

Private data

 

 

Surname

 

 

Date of birth

 

 

Address

 

 

Executive positions

 

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Mag.  Hubert Hirzinger

 

1957-05-10

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10 (p/A Sandoz GmbH)

manager

 

4

 

Dipl-Ing.  Ernst Meijinders

1956-12-14

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10

 

manager

 

0

 

Dkfm.  Klaus Neumayer

1964-07-17

6250 Kundl Biochemiestraße 10

manager

0

Dr.  Thomas Nothegger

 

1967-07-11

 

6250 Kundl c/o Sandoz GmbH Biochemiestraß 10

manager

 

0

 

Dr.  Jens Scheibner

 

1968-11-15

 

6250 Kundl c/o Sandoz GmbH Biochemiestraß 10

manager

 

0

 

Mag.  Hans Peter Amon

 

1975-01-19

 

1020 Wien Stella Klein Löwweg 17

joint signing clerk,

head of accounting

 

4

 

Dkfm.  Michael Friedhofen

1967-08-27

 

1020 Wien Stella Klein Löwweg 17

joint signing clerk

 

1

 

Sibylla Härtel

 

1962-10-21

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Dip.-Chem.  Michael Kocher

1967-04-12

 

6250 Kundl c/o Sandoz GmbH Biochemiestraß 10

joint signing clerk

 

0

 

Dr.  Nikolaus Kofler

 

1968-12-05

 

6250 Kundl c/o Sandoz GmbH Biochemiestraß 10

joint signing clerk

 

0

 

Dr.  Christopher Manuel Mader

1973-04-10

 

6250 Kundl c/o Sandoz GmbH Biochemiestraß 10

joint signing clerk

 

0

 

Rodrigo Goarmon Pedroso Santos-Ferreira

1978-11-10

 

1020 Wien Stella Klein Löwweg 17

joint signing clerk

 

2

 

 

Ferreira

Mag.  Ingrid Schwarzenberger

1958-03-20

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

joint signing clerk

 

0

 

Dr.  Josef Egerbacher

 

1958-11-20

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

chairman of the supervisory board,

member of the supervisory board

 

0

 

Dr.  Andreas Brutsche

 

1962-09-17

 

83607 Holzkirchen Industriestraße 25

deputy chairman of the supervisory board

 

0

 

Barbara Nerad

1962-12-30

6250 Kundl Biochemiestraße 10

member of the supervisory board

0

Helmut Pancheri

 

1961-07-05

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

member of the supervisory board

 

0

 

Sandrine Charlotte Philippe Piret-Gerard

1975-10-17

 

83607 Holzkirchen c/o HEXAL AG Industriestraße 25

member of the supervisory board

 

0

 

Felix Senn

 

1959-05-26

 

4056 Basel Novartis Campus Forum 1

member of the supervisory board

 

0

 

Mag.  Max Leitinger

 

 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

head of EDP

 

0

 

Josef Postl

 

 

 

6250 Kundl Biochemiestraße 10(c/o)

technical director

 

0

 

 

 

Balance Sheet (absolute) all amounts in EUR 

 

 

2013-12-31 

 

 

 

 

Franchises, patents, licences, trademarks and similar rights and advantages

10.517.586,87

 

 

 

 

Sum intangible assets

10.517.586,87

 

 

 

 

 

Land and leasehold rights with buildings thereon including building on land owned by third parties

272.157.348,76

 

 

 

 

Other operating and business equipment

19.349.235,85

 

 

 

 

Technical plants and machines

147.003.610,97

 

 

 

 

Advanced payments and constructions in progress

85.077.459,40

 

 

 

 

Sum tangible assets

523.587.654,98

 

 

 

 

 

Shares on related firms

56.831.602,18

 

 

 

 

Other shareholdings

1.751.901,77

 

 

 

 

Other financial assets, values and securities of fixed assets

18.051.774,04

 

 

 

 

Sum financial assets

76.635.277,99

 

 

 

 

 

Sum fixed assets

610.740.519,84

 

 

 

 

 

Raw-, auxiliary materials and supplies

80.531.973,71

 

 

 

 

Unfinished products

154.198.842,07

 

 

 

 

Finished products

37.655.853,59

 

 

 

 

Sum stock

272.386.669,37

 

 

 

 

 

Claims from delivered goods and performed services

130.329.080,94

 

 

 

 

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

141.547.017,72

 

 

 

 

Other claims and assets

54.046.409,90

 

 

 

 

Sum claims

325.922.508,56

 

 

 

 

 

Cash on hand, cheques and bank deposits

4.781.773,95

 

 

 

 

Sum cash and bank

4.781.773,95

 

 

 

 

 

Sum current assets

603.090.951,88

 

 

 

 

 

Deferred charges

949.397,27

 

 

 

 

Sum deferred charges

949.397,27

 

 

 

 

Assets

1.214.780.868,99

 

 

 

 

 

Subscribed/declared capital

32.703.000,00

 

 

 

 

Legal reserves

3.270.300,00

 

 

 

 

Free reserves

99.991.891,44

 

 

 

 

Balance sheet profit/balance sheet loss

0,00

 

 

 

 

Sum equity capital

135.965.191,44

 

 

 

 

 

Other reserves before taxes

24.061.760,15

 

 

 

 

Sum reserves before taxes

24.061.760,15

 

 

 

 

 

Investment contributions

557.404,46

 

 

 

 

Sum floor capital

557.404,46

 

 

 

 

 

Reserves for severance pays

47.244.982,00

 

 

 

 

Reserves for pensions

62.223.887,00

 

 

 

 

Other reserves

75.068.795,26

 

 

 

 

Sum reserves

184.537.664,26

 

 

 

 

 

Liabilities against credit institutes

4.416.356,48

 

 

 

 

Received advanced payments for orders

6.711.020,99

 

 

 

 

Liabilities from delivered goods and performed services

121.144.856,15

 

 

 

 

Liabilities against related firms

718.491.287,70

 

 

 

 

Liabilities against firm with shareholding relationship

2.476.066,96

 

 

 

 

Other liabilities

7.970.213,28

 

 

 

 

Other loans

1.474.413,00

 

 

 

 

Sum liabilities

862.684.214,56

 

 

 

 

 

Deferred income

6.974.634,12

 

 

 

 

Sum deferred income

6.974.634,12

 

 

 

 

Liabilities

1.214.780.868,99

 

 

 

 

 

Contingent liabilities

1.700.000,00

 

 

 

 

Balance sheet sum

1.214.780.868,99

 

 

 

 

 

 

P/L Account (absolute) all amounts in EUR 

 

 

2013-12-31 

 

 

 

 

Gross sales 

1.496.118.876,88

 

 

 

 

Increase or decrease in finished and unfinished goods and in service claims 

-3.688.594,78

 

 

 

 

Other manufacturing costs capitalized 

4.943.709,32

 

 

 

 

Total turnover or gross profit 

1.497.373.991,42

 

 

 

 

 

Profits from retirement of fixed assets, except financial assets 

52.284,01

 

 

 

 

Other operating profits 

25.610.882,10

 

 

 

 

Other operating profits totally 

25.663.166,11

 

 

 

 

 

Costs for obtained services 

-35.905.614,21

 

 

 

 

Material costs 

-812.029.603,51

 

 

 

 

Costs for obtained services totally 

-847.935.217,72

 

 

 

 

 

Wages 

-27.252.938,16

 

 

 

 

Salaries 

-159.084.034,37

 

 

 

 

Costs for severance pays 

-3.639.921,46

 

 

 

 

Costs for old age pension 

-6.652.421,94

 

 

 

 

Legal fringe benefits and other payments depending on salaries 

-48.815.704,62

 

 

 

 

Other social fringe benefits 

-6.969.046,50

 

 

 

 

Personnel expenses totally 

-252.414.067,05

 

 

 

 

 

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation 

-67.475.792,73

 

 

 

 

Depreciation tangible assets / intangible assets totally 

-67.475.792,73

 

 

 

 

 

Other operating costs 

-314.828.351,82

 

 

 

 

Other taxes 

-582.752,31

 

 

 

 

Total costs 

-315.411.104,13

 

 

 

 

 

Operating result totally 

39.800.975,90

 

 

 

 

 

Profits from shareholdings 

11.027.987,22

 

 

 

 

Income from other securities and loans of financial assets 

551.302,92

 

 

 

 

Interest income, securties income and similar income 

99,97

 

 

 

 

Interest and similar disbursements 

-11.860.973,78

 

 

 

 

Financial profits totally 

-281.583,67

 

 

 

 

 

Results from usual business activity totally 

39.519.392,23

 

 

 

 

 

Taxes on income and profits 

-8.044,52

 

 

 

 

Taxes on income and profits totally 

-8.044,52

 

 

 

 

Annual surplus/annual deficit totally 

39.511.347,71

 

 

 

 

 

Dissolution reserves before taxes 

824.117,96

 

 

 

 

Transfer to profit reserves 

-40.335.465,67

 

 

 

 

Reserves movements totally 

-39.511.347,71

 

 

 

 

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account 

0,00

 

 

 

 

 

 

Key ratios

 

 

2013  

 

 

 

 

 

Cash flow II

  106.987.140,44

 

 

 

 

 

Debt amortisation period

  9,68

 

 

 

 

 

Bank indebtedness

  0,48

 

 

 

 

 

Equity capital share

  13,29

 

 

 

 

 

Social capital share

  9,01

 

 

 

 

 

Fixed assets coverage

  44,21

 

 

 

 

 

Net profit ratio

  2,63

 

 

 

 

 

Capital turnover

  1,23

 

 

 

 

 

Return on investment

  4,22

 

 

 

 

 

Cash flow in % of operating performance

  7,14

 

 

 

 

 

Cash flow I

  106.995.184,96

 

 

 

 

 

Gross productivity

  5,93

 

 

 

 

 

Net productivity

  2,57

 

 

 

 

 

Operating performance

  1.497.373.991,42

 

 

 

 

 

Inventories in % of operating performance

  18,19

 

 

 

 

 

Gross profit

  649.438.773,70

 

 

 

 

 

 

 

Locations

 

Type

Locations

Description

 

 

E-mail 

operational 

Biochemiestraße  10, A-6250 Kundl

registered office 

 

 

 

operational 

Biochemiestraße  10, A-6250 Kundl

registered headquarters, owned property 

 

 

kundl.austria@sandoz.com

operational 

Brunnerstraße  59, A-1230 Wien

branch office, rented premises 

 

 

 

operational 

Schaftenau Biochemiestraße  10, A-6330 Kufstein

factory, owned property 

 

 

 

operational 

Dr. Hans Bachmannstraße  7, A-6250 Kundl, (umben.auf Biochemiestraße 10)

registered headquarters 

 

 

 

former 

Wagramerstraße  19, A-1220 Wien

branch office 

 

 

related companies

 

Company name

 

Postal code

 

Stake in %

 

 

Companies House

 

Shares in this company are held by:

Novartis Austria GmbH

 

Stella Klein Löwweg  17, A-1020 Wien

99.99 % 2006-07-27

 

 

FN 274620 d

 

Novartis Holding AG

 

Lichtstraße  35, CH-4056 Basel

0.01 % 1997-02-22

 

 

 

 

This company holds 100% of the shares in:

HEXAL PHARMA GmbH

 

Stella Klein Löwweg  17, A-1020 Wien

100 % 2005-12-17

 

 

FN 44896 z

 

Novartis Institutes for Biomedical Research GmbH

Biochemiestraße  10, A-6250 Kundl

100 % 1993-08-13

 

 

FN 43251 f

 

 

Affiliated companies and further participations:

HBHG Pharma Ges.m.b.H.

 

Mondseestraße  11, A-4866 Unterach Attersee

 

 

 

FN 215663 b

 

Novartis Pharma GmbH

 

Stella Klein Löwweg  17, A-1020 Wien

 

 

 

FN 41622 i

 

EBEWE Spezial-Pharma Holding GmbH

Stella Klein Löwweg  17, A-1020 Wien

 

 

 

FN 331193 z

 

Novartis Institutes for BioMedical Research GmbH & Co KG

Brunnerstraße  59, A-1235 Wien

2004-10-23

 

 

FN 253505 b

 

Austrian Center of Biopharmaceutical Technology

Muthgasse  18, A-1190 Wien

 

 

 

 

Nabriva Therapeutics AG

 

Leberstraße  20, A-1112 Wien

 

 

 

FN 269261 y

 

 

 

Bankers

 

Banker

Bank sort code

Type of banking connection

UniCredit Bank Austria AG, 1011 Wien

 

12000

 

main bank connection

 

 

 

Historical development

 

Year of incorporation:

1965

Date of registration:

1965-11-26

 

Change of company name:

From

To

Company name

   

  2003-05-02

Biochemie GmbH 

  2003-05-02

   

Sandoz GmbH 

 

Change in share capital:

From

To

Capital

   

  2001-10-05

ATS  450.000.000,00

  2001-10-05

   

EUR  32.703.000,00

 

Former executives:

From

To

Function

Name

   

  1999-04-13

manager 

Dipl-Ing.Dr. Oswald Sellemond 

   

  2003-04-29

manager 

Werner Meßner 

  2003-04-29

  2004-09-01

manager 

Mag.Dr. Franz Stumpf 

  2003-04-29

  2005-07-28

manager 

Mag. Hubert Hirzinger 

  2003-04-29

  2005-07-28

manager 

Dr. Patrick Vink 

   

  2006-06-03

manager 

Dipl-Ing.Dr. Heinrich Scherfler 

  1998-10-20

  1999-04-15

joint signing clerk 

Eric Gorka 

  1999-04-15

  2003-03-19

joint signing clerk 

Mag. Gerhard Hörl 

  1999-08-17

  2003-04-29

joint signing clerk 

Mag.Dr. Franz Stumpf 

  1993-09-23

  2000-10-11

joint signing clerk 

Mag. Hubert Hirzinger 

  1993-09-23

  2001-10-02

joint signing clerk 

Dr. Walter Killiches 

  2006-06-23

  2007-06-15

joint signing clerk 

Lorraine Lynne Christina Perry 

  2000-01-12

  2010-01-09

joint signing clerk 

Dr. Josef Egerbacher 

  1999-10-12

  2001-10-02

chairman of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Oswald Sellemond 

  2001-10-02

  2002-05-30

chairman of the supervisory board 

Mag. Christian Seiwald 

  2002-05-30

  2005-04-19

chairman of the supervisory board 

Mag. Christian Seiwald 

  2010-07-29

  2013-10-05

chairman of the supervisory board 

Mag. Christian Seiwald 

  2005-04-19

  2010-07-29

deputy chairman of the supervisory board 

Mag. Christian Seiwald 

   

  2014-07-16

deputy chairman of the supervisory board 

Dr. Josef Egerbacher 

  1999-08-06

  1999-10-12

member of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Oswald Sellemond 

  1999-08-06

  2001-10-02

member of the supervisory board 

Mag. Christian Seiwald 

  2001-10-02

  2002-05-30

member of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Oswald Sellemond 

  2007-03-16

  2011-06-30

member of the supervisory board 

Dipl-Ing.Dr. Heinrich Scherfler 

   

  2013-10-05

member of the supervisory board 

Dr. Josef Egerbacher 

   

  2014-07-16

member of the supervisory board 

Dr. Andreas Brutsche 

   

  2013-10-05

deputy chairman of the supervisory board 

Peter Goldschmidt 

  2003-04-29

  2008-02-21

manager 

Mag. Bernhard Sigl 

  2010-11-13

  2012-12-18

manager 

Mag. Richard Kronbichler 

  2010-02-20

  2014-01-22

manager 

Dr. Peter Gasteiger 

  2010-01-09

  2014-05-15

manager 

Dr. Günter Stempfer 

  1993-09-23

  1999-02-16

joint signing clerk 

Dr. Paul Inama Sternegg 

  1993-09-23

  2000-09-13

joint signing clerk 

Dr. Otto Streichsbier 

  1998-01-27

  2002-04-25

joint signing clerk 

Mag. Vinzenz Plörer 

  1997-11-07

  2002-10-01

joint signing clerk 

Dr. Helmut Deimel 

  1993-09-23

  2003-04-29

joint signing clerk 

Mag. Bernhard Sigl 

  2001-10-02

  2003-12-18

joint signing clerk 

MMag.Dr. Johannes Gerstenbauer 

  1998-01-27

  2003-12-18

joint signing clerk 

Mag. Gottfried Rieser 

  1993-09-23

  2005-03-08

joint signing clerk 

Dr. Ernst Leitner 

  1998-02-02

  2005-03-08

joint signing clerk 

Peter Haselböck 

  1993-09-23

  2001-03-13

joint signing clerk 

Dr. Eberhard Pirich 

  1998-01-27

  2006-05-16

joint signing clerk 

Dr. Santiago Alonso Ciriza 

  2004-08-10

  2006-05-16

joint signing clerk 

Knut Ulrich Mager 

  2000-03-14

  2006-05-16

joint signing clerk 

Hans Schaller 

  1993-09-23

  2007-02-09

joint signing clerk 

Mag. Rupert Labner 

  2003-10-01

  2007-06-15

joint signing clerk 

Mag.Dr. Otto Scheidl 

  2002-07-17

  2007-06-15

joint signing clerk 

Dr. Elisabeth Schneider Scherzer 

  2000-01-12

  2007-06-15

joint signing clerk 

Mag. Barbara Weigl Aman 

  1998-04-02

  2007-06-15

joint signing clerk 

Dr. Bruno Wallnöfer 

  2004-10-06

  2008-05-29

joint signing clerk 

MBA. Elgar Schnegg 

  2000-05-31

  2009-02-19

joint signing clerk 

Kurt Unterkircher 

  1993-09-23

  2010-03-19

joint signing clerk 

Mag. Friedrich Fuchs 

  2006-06-23

  2011-02-10

joint signing clerk 

Mag. Helmuth Hofer 

  2001-12-19

  2012-05-01

joint signing clerk 

Dr. Maria Schmalzl 

  1998-01-27

  2012-10-17

joint signing clerk 

Dr. Elmar Dolejsi 

   

  2014-03-18

joint signing clerk 

Dr. Friedrich Sernetz 

  1993-05-10

  1997-05-16

chairman of the supervisory board 

Dr. Urs Bärlocher 

  2002-03-12

  2005-07-14

member of the supervisory board 

Dr. Urs Bärlocher 

  1997-05-16

  1998-04-18

chairman of the supervisory board 

Pierre Douaze 

  1998-04-18

  1999-10-12

chairman of the supervisory board 

Dr. Argeric Karabelas 

  1999-10-12

  2000-11-30

deputy chairman of the supervisory board 

Dr. Argeric Karabelas 

  2005-04-19

  2009-02-19

chairman of the supervisory board 

Dr. Andreas Rummelt 

  2009-03-11

  2010-04-20

member of the supervisory board 

Dr. Andreas Rummelt 

  1997-05-16

  2002-03-12

deputy chairman of the supervisory board 

Dr. Jörg Reinhardt 

  2000-11-30

  2002-05-30

deputy chairman of the supervisory board 

Thomas Ebeling 

  2002-05-30

  2005-04-19

deputy chairman of the supervisory board 

Paul Choffat 

  2010-07-29

  2012-09-26

deputy chairman of the supervisory board 

Christina Ackermann Swistara 

  2010-04-20

  2010-07-29

member of the supervisory board 

Christina Ackermann Swistara 

   

  1998-04-18

member of the supervisory board 

Daniel Wagniere 

  1998-04-18

  1999-08-06

member of the supervisory board 

Dr. Hans Kindler 

  1997-05-16

  1999-08-06

member of the supervisory board 

Dr. Erwin Schillinger 

  2002-05-30

  2007-06-28

member of the supervisory board 

Dr. Erwin Schillinger 

  2005-07-14

  2007-03-16

member of the supervisory board 

Kevin Plummer 

  1999-08-06

  2008-08-01

member of the supervisory board 

Hermann Egger 

  2007-06-28

  2008-08-01

member of the supervisory board 

Dr. Peter Jager 

  2008-08-01

  2009-03-11

member of the supervisory board 

Knut Mager 

  2010-09-22

  2012-03-09

member of the supervisory board 

Dr. Gerhard Schaefer 

   

  1998-01-24

employee's representative on the supervisory board 

Johann Auer 

   

  1999-08-06

employee's representative on the supervisory board 

Helmuth Stubenvoll 

  2004-09-01

  2007-06-06

manager 

Mag. Johannes Schwertner 

  2010-01-09

  2012-02-03

manager 

Mag. Hannes Teißl 

   

  2014-07-16

chairman of the supervisory board 

Hans Helmut Michael Fabry 

  2011-06-30

  2013-10-05

member of the supervisory board 

Hans Helmut Michael Fabry 

   

  1997-05-16

member of the supervisory board 

Dr. Raymund Breu 

  2008-02-21

  2010-02-20

manager 

Dipl-Ing. Bianca Stöhr 

  2003-05-06

  2004-11-03

joint signing clerk 

Mag. Siegfried Johann Leitner 

  2008-05-29

  2010-06-18

joint signing clerk 

Dipl-Betriebsw. Björn Komischke 

  2010-06-18

  2012-09-21

joint signing clerk 

Dr. Gerhard van der Meij 

  2009-02-19

  2010-07-29

chairman of the supervisory board 

Dr. Horst Uwe Groh 

  2010-07-29

  2010-09-22

member of the supervisory board 

Dr. Horst Uwe Groh 

  1995-06-21

  1997-05-16

deputy chairman of the supervisory board 

Dr. Daniel Vasella 

 

Former shareholders:

From

To

Function

Name

   

  1997-02-22

partner 

Sandoz Holding AG 

  1997-02-22

  2000-08-26

partner 

Novartis AG 

 

Former shareholdings:

From

To

Name

  1996-05-08

  1998-11-24

Novartis Handelsgesellschaft m.b.H. 

  2004-09-16

  2004-10-23

Novartis Forschungsinstitut GmbH 

  2005-01-27

  2005-10-06

Grandis Handel mit pharmazeutischen Produkten Gesellschaft mbH 

  2006-01-24

  2007-11-10

Nabriva Therapeutics AG 

  1996-12-03

  2014-10-08

Novartis Animal Health GmbH 

  1993-12-17

  2014-05-09

Biozym GmbH in Liqu. 

 

Mergers:

Date

Function

Name

  2014-10-08

merged with 

Novartis Animal Health GmbH 

  2006-12-14

merged with 

Sandoz GmbH 

  2005-10-06

merged with 

Grandis Handel mit pharmazeutischen Produkten Gesellschaft mbH 

  2000-11-24

merged with 

Novartis Handelsgesellschaft m.b.H. 

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.61.88

UK Pound

1

Rs.96.90

Euro

1

Rs.76.29

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

DIV

 

 

Report Prepared by :

NIT

 

               

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

 

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

 

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

 

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

 

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

 

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

 

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

 

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

Credit not recommended

 

--

NB

New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.