MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

11.12.2014

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

AUCHAN FRANCE

 

 

Registered Office :

200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve D'ascq

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2013

 

 

Date of Incorporation :

January 1997

 

 

Com. Reg. No.:

RCS 9 410 409 460

 

 

Legal Form :

Public Limited Company With Board Of Directors

 

 

Line of Business :

Hypermarkets

 

 

No of Employees :

51411 (31.12.2011)

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory

Payment Behaviour :

Slow but Correct

Litigation :

Clear 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – September 30, 2014

 

Country Name

Previous Rating

(30.06.2014)

Current Rating

(30.09.2014)

France

a1

a1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 

France ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With at least 82 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that mitigate economic inequality. France's real GDP stagnated in 2012 and 2013. The unemployment rate (including overseas territories) increased from 7.8% in 2008 to 10.2% in 2013. Youth unemployment in metropolitan France decreased from a high of 25.4% in the fourth quarter of 2012 to 22.8% in the fourth quarter of 2013. Lower-than-expected growth and high spending have strained France's public finances. The budget deficit rose sharply from 3.3% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 4.1% of GDP in 2013, while France's public debt rose from 68% of GDP to nearly 94% over the same period. In accordance with its EU obligations, France is targeting a deficit of 3.6% of GDP in 2014 and 2.8% in 2015. The administration of President Francois HOLLANDE has implemented greater state support for employment, the separation of banks' traditional deposit taking and lending activities from more speculative businesses, increasing the top corporate and personal tax rates, including a temporary 75% tax on wages over one million euros, and hiring an additional 60,000 teachers during his five-year term. In January 2014 HOLLANDE proposed a “Responsibility Pact” aimed primarily at lowering labor costs in return for businesses’ commitment to create jobs. Despite stagnant growth and fiscal challenges, France's borrowing costs have declined in recent years because investors remain attracted to the liquidity of France’s bonds.

 

Source : CIA

 

 

 

 


company summary

 

Name

AUCHAN FRANCE

SIRET

410 409 460 00756

 

 

Trade name

AUCHAN DRIVE

 

 

EUR VAT Number

FR20410409460

Activity (APE)

Hypermarkets

Legal form

Public limited company with board of directors

Phone

03 28 77 78 00

RCS Registration

RCS 9 410 409 460

Fax

 

Share capital

56,882,160 Euros

Address

AUCHAN FRANCE
200 RUE DE LA RECHERCHE
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Incorporated Date

01/1997

Nationality

France

Status

Economically active

 

 

Payment Information Summary - Trade Payment Data

 

 

Total number of Invoices available

334

 

Total number of Invoices paid within or up to 30 days after the due date

266

 

Total number of Invoices paid more than 30 days after the due date

58

 

Total number of Invoices currently outstanding where the due date has not yet been reached

9

 

Total number of Invoices currently outstanding beyond the due date

0

 

 

 Last published preferential right

10/8/2014

 

 

This company is under monitoring with at least one active preferential right

 

 

Ultimate Holding Company

 

 

Company Name

 

 

Company number

 

GROUPE AUCHAN

 

 

476180625

 

 

Current Directors

6

 

 

Trading to Date

12/31/2013

12/31/2011

12/31/2009

 

Turnover

13,752,000,000 €

13,988,738,535 €

13,819,000,000 €

 

Gross Operating Surplus

4.37 % Turnover

5.32 % Turnover

14.34 % Turnover

 

Shareholders ’ equity

701,000,000 €

597,040,840 €

967,000,000 €

 

Net result

148,000,000 €

163,471,776 €

224,000,000 €

 

Employees

51411 (31.12.2011)

-

-

 


 

Trends    

 

Profitability

Liquidity

Net worth

 

 

Company details

 

 

 

 

 

Activity (APE)

Hypermarkets

 

 

 

RCS Registration

RCS 9 410 409 460

Share capital

56,882,160 Euros

 

Registration Court

(59)

Legal form

Public limited company with board of directors

 

Court Registry Number

19 9 9B00405

EUR VAT Number

FR20410409460

 

Incorporation Date

01/1997

Formation Date

01/1997

 

Deregistration Date

 

Last account Date

31/12/2013

 

Nationality

France

 

 

 

 

Ultimate Parent

1 ultimate parent company for this company 
 GROUPE AUCHAN  - ActivitEs des sièges sociaux (7010Z)  in CROIX  (59170)

 

 

Establishment details

 

 

 

 

 

Trade name

AUCHAN DRIVE

 

Activity (APE)

Hypermarkets

Business Pages FT®

 

 

Postal Address

AUCHAN FRANCE 
200 RUE DE LA RECHERCHE 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Trading Address

200 RUE DE LA RECHERCHE 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

 

Telephone

03 28 77 78 00

 

Fax

 

 

 

 

 

Type

Head office

Status

Economically active

 

Formation Date

12/1997

Reason for formation

Contribution

 

Closure Date

 

Reason for closure

 

 

Reactivation Date

 

Production Role

 

 

Activity Nature

Other

Activity Location

Other

 

Location surface

 

Seasonality

 

 

 

 

 

Department

Nord (59)

Region

Nord-Pas-de-Calais

 

District

5

Area

84

 

City

VILLENEUVE D'ASCQ

Size of urban area

Urban unit with 200 000 to 1 999 999 inhabitants

 

 

Other establishments

 

 

 

Branches

210 branch entities in this company

 

 

 

Head office

 
> AUCHAN FRANCE <<<  - HypermarchEs (4711F)  in VILLENEUVE D'ASCQ  (59650) 
 

 

 

Secondary establishments

 AUCHAN FRANCE  - HypermarchEs (4711F)  in NEUILLY SUR MARNE  (93330) 
 AUCHAN FRANCE  - HypermarchEs (4711F)  in MOUANS SARTOUX  (06370) 
 AUCHAN FRANCE  - HypermarchEs (4711F)  in SAVONNIERES DEVANT BAR  (55000) 
 AUCHAN FRANCE  - HypermarchEs (4711F)  in PUTEAUX  (92800) 
> ...

 

 

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas but no one grouping more than 50% of workforce

 

 

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which one activity grouping from 80 to 99% of workforce

 

 

 

 

Workforces

 

Workforce at address  

2 000 to 4 999 employees          

 

Company workforce

51411 (31.12.2011)

 

 


accounts

 

Active Account |  Passive Account |  Account Results

 

Synthesized Accounts 

Display parameter

Currency

 Euro

 Kilo Euro

 

Comparison mode

 Average

 Median

 

 

 Annual Accounts

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

 

Account period (month)

12

 

12

 

12

 

 

Account Type

Normal

 

Normal

 

Normal

 

 

Date of capture

28/08/2014

 

16/11/2012

 

03/02/2011

 

 

Activity Code

4711F

 

4711F

 

4711F

 

 

Employees

0

 

51411

 

49373

 

 

 

Active account

Annual Accounts

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Sector Median 2013

 

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

2,447,000,000

-3.6%

2,538,329,050

-9.2%

2,797,000,000

4,704,343

51915.8%

- Intangible assets

319,000,000

-81.1%

1,691,008,498

165.9%

636,000,000

75,213

424028.8%

- Tangible assets

2,028,000,000

-0.8%

2,043,798,344

0.3%

2,038,000,000

1,937,694

104560.5%

- Financial assets

100,000,000

478.1%

17,297,974

-85.9%

123,000,000

773,649

12825.8%

Net current assets

2,002,000,000

-7.1%

2,155,303,154

7.9%

1,998,000,000

4,964,074

40229.8%

- Stocks

1,042,000,000

-2.7%

1,071,349,847

2.9%

1,041,000,000

2,111,271

49254.2%

- Advanced payments

0

-7.1%

1,878,952

0%

0

0

0%

- Receivables

764,000,000

-10.2%

850,478,422

7.0%

795,000,000

1,138,384

67012.7%

- Securities and cash

196,000,000

-15.4%

231,595,933

43.0%

162,000,000

936,777

20822.8%

- Prepaid expenses

-

-

-

-

-

2,463

-

Accounts of regularization

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total Assets

4,449,000,000

-7.0%

4,785,838,697

-0.2%

4,795,000,000

10,066,842

44094.6%

Passive Account

Annual Accounts

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Sector Median 2013

 

Shareholders' equity

701,000,000

17.4%

597,040,840

-38.3%

967,000,000

2,852,162

24477.8%

Share capital

553,000,000

872.2%

56,882,160

-0.2%

57,000,000

141,000

392098.6%

Other capital resources

118,000,000

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

0

0%

154,372,430

-20.4%

194,000,000

18,758

0%

Liabilities

3,779,000,000

-6.3%

4,034,415,427

11.0%

3,634,000,000

6,602,988

57131.7%

- Financial liabilities

783,000,000

58.6%

493,570,425

2803.4%

17,000,000

2,342,528

33325.4%

- Advanced payments received

0

0%

12,448,528

-45.9%

23,000,000

0

0%

- Trade account payables

0

0%

2,060,940,724

-24.7%

2,737,000,000

2,483,429

0%

- Tax and social liabilities

0

0%

658,578,490

0%

0

999,602

0%

- Other debts and fixed assets liabilities

2,996,000,000

315.0%

721,852,999

-7.5%

780,000,000

93,481

3204829.3%

Account regularization

0

0%

87,024,262

13.0%

77,000,000

0

0%

Total liabilities

4,598,000,000

-3.9%

4,785,828,696

-0.2%

4,795,000,000

10,094,528

45449.4%

 

 

Results

Annual Accounts

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Sector Median 2013

 

Sales of Goods

13,752,000,000

-3.1%

14,189,905,095

2.7%

13,819,000,000

35,592,938

38536.9%

Net turnover

13,752,000,000

-1.7%

13,988,738,535

1.2%

13,819,000,000

35,225,219

38940.2%

- of which net export turnover

0

0%

63,513,567

0%

0

0

0%

Operating charges

13,480,000,000

-2.3%

13,801,264,670

4.0%

13,270,000,000

34,752,874

38688.2%

Operating profit/loss

272,000,000

-30.0%

388,640,425

-29.2%

549,000,000

777,987

34862.0%

Financial income

0

0%

41,000,565

115.8%

19,000,000

45,930

0%

Financial charges

23,000,000

-52.1%

47,972,014

128.4%

21,000,000

68,090

33678.8%

Financial profit/loss

-23,000,000

-229.9%

-6,971,449

-248.6%

-2,000,000

-11,396

-201725.2%

Pretax net operating income

254,000,000

-34.8%

389,741,803

-29.6%

554,000,000

774,184

32708.7%

Extraordinary income

25,000,000

-86.7%

187,397,085

0%

0

44,923

55550.8%

Extraordinary charges

0

0%

192,557,707

369.7%

41,000,000

40,644

0%

Extraordinary profit/loss

25,000,000

584.4%

-5,160,622

87.4%

-41,000,000

01

2499999900%

Net result

148,000,000

-9.5%

163,471,776

-27.0%

224,000,000

517,475

28500.4%

 

 

Display parameter

Currency

 Euro

 Kilo Euro

 

 

Normal Account

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Months

 

12

 

12

 

12

 

Accounts - Active 
Current Assets |  Equalization accounts |  Reference 

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Grand Total (I to VI)

Net

4,449,000,000

-7.0%

4,785,838,697

-0.2%

4,795,000,000

 

Gross

CO

8,529,000,000

1.7%

8,386,188,848

5.3%

7,963,000,000

 

Amortisation

1A

4,080,000,000

13.3%

3,600,350,151

13.6%

3,168,000,000

 

Non declared distributed capital (I)

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AA

0

0%

0

0%

0

 

Active fixed asset (II)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Total Active fixed asset (II)

Net

2,447,000,000

-3.6%

2,538,329,050

-9.2%

2,797,000,000

 

Gross

BJ

6,451,000,000

6.2%

6,075,447,408

3.0%

5,899,000,000

 

Amortisation

BK

4,004,000,000

13.2%

3,537,118,358

14.0%

3,102,000,000

 


 

Intangible fixed assets

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Start-up cost

Net

0

0%

827

0%

0

 

Gross

AB

0

0%

827

0%

0

 

Amortisation

AC

0

0%

827

0%

0

R & D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AE

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

0

0%

180,308

0%

0

 

Gross

AF

0

0%

180,308

0%

0

 

Amortisation

AG

0

0%

0

0%

0

Goodwill

Net

0

0%

1,676,517,424

0%

0

 

Gross

AH

0

0%

1,676,517,424

0%

0

 

Amortisation

AI

0

0%

1,213,774,939

0%

0

Other intangible fixed assets

Net

319,000,000

2129.2%

14,309,939

-97.8%

636,000,000

 

Gross

AJ

1,753,000,000

3046.7%

55,708,762

-96.8%

1,718,000,000

 

Amortisation

AK

1,434,000,000

3363.9%

41,398,823

-96.2%

1,082,000,000

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible Assets

Net

319,000,000

-81.1%

1,691,008,498

165.9%

636,000,000

 

 

Tangible fixed assets

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Lands

Net

0

0%

710,984,712

0%

0

 

Gross

AN

0

0%

714,071,774

0%

0

 

Amortisation

AO

0

0%

3,087,062

0%

0

Buildings

Net

0

0%

1,069,758,744

0%

0

 

Gross

AP

0

0%

2,821,284,164

0%

0

 

Amortisation

AQ

0

0%

1,751,525,420

0%

0

Plant

Net

0

0%

157,215,775

0%

0

 

Gross

AR

0

0%

504,489,381

0%

0

 

Amortisation

AS

0

0%

347,273,606

0%

0

Other tangible fixed assets

Net

2,028,000,000

4069.2%

48,642,091

-97.6%

2,038,000,000

 

Gross

AT

4,561,000,000

1938.7%

223,715,669

-94.5%

4,056,000,000

 

Amortisation

AU

2,533,000,000

1346.8%

175,073,578

-91.3%

2,018,000,000

Fixed assets in construction

Net

0

0%

49,364,591

0%

0

 

Gross

AV

0

0%

49,364,591

0%

0

 

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

0

0%

7,832,431

0%

0

 

Gross

AX

0

0%

7,832,431

0%

0

 

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Tangible asset

Net

2,028,000,000

 

2,043,798,344

 

2,038,000,000

 

 

Financial assets

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

0

0%

5,732,954

-94.9%

113,000,000

 

Gross

CU

0

0%

10,244,052

-90.9%

113,000,000

 

Amortisation

CV

0

0%

4,511,098

0%

0

Inter-company receivables

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BC

0

0%

0

0%

0

Other investment securities

Net

0

0%

153,273

0%

0

 

Gross

BD

0

0%

168,930

0%

0

 

Amortisation

BE

0

0%

15,657

0%

0

Loans

Net

0

0%

2,276,190

-77.2%

10,000,000

 

Gross

BF

0

0%

2,504,864

-88.6%

12,000,000

 

Amortisation

BG

0

 

228,674

 

2,000,000

Other financial assets

Net

100,000,000

994.6%

9,135,557

0%

0

 

Gross

BH

137,000,000

1363.0%

9,364,231

0%

0

 

Amortisation

BI

37,000,000

16080.2%

228,674

0%

0

 

Sub Total Financial Assets

 

100,000,000

 

17,297,974

 

123,000,000

  

 

Current Assets (III)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Total Assets

Net

2,002,000,000

-7.1%

2,155,303,154

7.9%

1,998,000,000

 

Gross

CJ

2,078,000,000

-6.3%

2,218,544,949

7.5%

2,064,000,000

 

Amortisation

CK

76,000,000

20.2%

63,241,795

-4.2%

66,000,000

 


 

Stocks

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Raw materials

Net

1,042,000,000

107187.3%

971,224

0%

0

 

Gross

BL

1,089,000,000

112026.6%

971,224

0%

0

 

Amortisation

BM

47,000,000

0%

0

0%

0

Work in progress (goods)

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BN

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BR

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BS

0

0%

0

0%

0

Goods for resale

Net

0

0%

1,070,378,623

2.8%

1,041,000,000

 

Gross

BT

0

0%

1,109,598,063

2.1%

1,087,000,000

 

Amortisation

BU

0

0%

39,219,440

-14.7%

46,000,000

 

Sub Total Stocks

Net

1,042,000,000

-2.7%

1,071,349,847

2.9%

1,041,000,000

 

Advance payments to suppliers

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Advance payments to suppliers

Net

0

0%

1,878,952

0%

0

 

Gross

BV

0

0%

1,878,952

0%

0

 

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0

 

Debtors

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Trade accounts receivable

Net

745,000,000

532.6%

117,762,476

-61.5%

306,000,000

 

Gross

BX

774,000,000

481.5%

133,103,609

-58.1%

318,000,000

 

Amortisation

BY

29,000,000

89.0%

15,341,133

27.8%

12,000,000

Other debtors

Net

0

0%

717,672,540

51.7%

473,000,000

 

Gross

BZ

0

0%

726,349,570

51.0%

481,000,000

 

Amortisation

CA

0

0%

8,677,030

8.5%

8,000,000

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Debtors

Net

745,000,000

-10.8%

835,435,016

7.2%

779,000,000

 


Divers

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Investment securities

Net

0

0%

580

0%

0

 

Gross

CD

0

0%

4,772

0%

0

 

Amortisation

CE

0

0%

4,192

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

196,000,000

-15.4%

231,595,353

43.0%

162,000,000

 

Gross

CF

196,000,000

-15.4%

231,595,353

43.0%

162,000,000

 

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Divers

Net

196,000,000

-15.4%

231,595,933

43.0%

162,000,000

 

 

Prepaid expenses

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Prepaid expenses

Net

19,000,000

26.3%

15,043,406

-6.0%

16,000,000

 

Gross

CH

19,000,000

26.3%

15,043,406

-6.0%

16,000,000

 

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

  

Equalization accounts (IV to VI)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Multi-period charges

CW3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

0%

0

 

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

0%

0

 

Currency differential gain

CN3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

0%

0

  

References

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

 

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

 

 

Display parameter

Currency

 Euro

 Kilo Euro

 

Accounts - Passive 
Other capital resources | Provisions for risks and charges | Liabilities | Translation loss | Equalization accounts | References 


Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Grand Total (I to V)

EE

4,598,000,000

-3.9%

4,785,828,696

-0.2%

4,795,000,000

 


 

Shareholder Equity (I)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Total shareholders' equity (Total I)

DL

701,000,000

17.4%

597,040,840

-38.3%

967,000,000

 

Equity and shareholders' equity

DA

553,000,000

872.2%

56,882,160

-0.2%

57,000,000

 

Issue and merger premiums

DB

0

0%

0

0%

0

 

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

 

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

 

Legal reserve

DD

0

0%

5,688,216

0%

0

 

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

 

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

 

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

 

Other reserves

DG

0

0%

0

0%

0

 

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

 

0

0%

0

 

Profits or losses brought forward

DH

0

0%

0

0%

0

 

Profit or loss for the period

DI

148,000,000

-9.5%

163,471,776

-27.3%

225,000,000

 

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

 

Special tax-allowable reserves

DK

0

0%

370,998,688

0%

0

  

Other capital resources (II)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Total other capital resources (Total II)

DO

118,000,000

0%

0

0%

0

 

Income from participating securities

DM

118,000,000

0%

0

0%

0

 

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

  


Provisions for risks and charges (III)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

0

0%

154,372,430

-20.4%

194,000,000

 

Risk provisions

DP

0

0%

70,203,149

-63.8%

194,000,000

 

Reserves for charges

DQ

0

0%

84,169,281

0%

0

  

Liabilities (IV)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Total Liabilities (Total IV)

EC

3,779,000,000

-6.3%

4,034,415,427

11.0%

3,634,000,000

 

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

 

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

 

Bank loans and liabilities

DU

0

0%

0

0%

0

 

Sundry loans and financial liabilities

DV

783,000,000

58.6%

493,570,425

2803.4%

17,000,000

 

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

 

Advance payments received for current orders

DW

0

0%

12,448,528

-45.9%

23,000,000

 

Trade accounts payables

DX

0

0%

2,060,940,724

-24.7%

2,737,000,000

 

Tax and social security liabilities

DY

0

0%

658,578,490

0%

0

 

Fixed asset liabilities

DZ

0

0%

53,158,177

0%

0

 

Other debts

EA

2,996,000,000

348.0%

668,694,822

-14.3%

780,000,000

  

Translation loss (V)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Translation loss (Total V)

ED

0

0%

0

0%

0

  

Equalization accounts

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Deferred income

EB

0

0%

87,024,262

13.0%

77,000,000

  
References

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

 

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

3,492,041,597

0%

0

 

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

 

Display parameter

Currency

 Euro

 Kilo Euro


Result account 
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges | Financial income | Financial charges | Financial charges | Extraordinary charges | Employee profit sharing | Tax on profits |References 


1- Operating result (I-II)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Operating result (Total I-II)

GG

272,000,000

-30.0%

388,640,425

-29.2%

549,000,000

 

2 - Financial result (V - VI)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Financial result (Total V-VI)

GV

-23,000,000

-229.9%

-6,971,449

-248.6%

-2,000,000

 

3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

254,000,000

-34.8%

389,741,803

-29.6%

554,000,000

 

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

25,000,000

584.4%

-5,160,622

87.4%

-41,000,000

 

Profit or loss

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Profit or loss

HN

148,000,000

-9.5%

163,471,776

-27.0%

224,000,000

 

Total Income (I+III+V+VII)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Total Income (I+III+V+VII)

HL

13,782,000,000

-4.5%

14,426,536,758

4.2%

13,845,000,000

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

13,634,000,000

-4.4%

14,263,064,983

4.7%

13,621,000,000

 

Operating income (I)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Total operating income (Total I)

FR

13,752,000,000

-3.1%

14,189,905,095

2.7%

13,819,000,000

 

 

Operating income (details)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Sale of goods for resale

FC

13,752,000,000

13.3%

12,140,997,139

0%

0

 

France

FA

13,752,000,000

13.9%

12,077,539,873

0%

0

 

Export

FB

0

0%

63,457,266

0%

0

Sale of goods produced

FF

0

0%

1,040,948,147

-92.5%

13,819,000,000

 

France

FD

0

0%

1,040,948,147

-92.5%

13,819,000,000

 

Export

FE

0

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

0

0%

806,793,249

0%

0

 

France

FG

0

0%

806,736,948

0%

0

 

Export

FH

0

0%

56,301

0%

0

Net turnover

FL

13,752,000,000

-1.7%

13,988,738,535

1.2%

13,819,000,000

 

France

FJ

13,752,000,000

-1.2%

13,925,224,968

0.8%

13,819,000,000

 

Export

FK

0

0%

63,513,567

0%

0

 

Stocked production

FM

0

0%

0

0%

0

 

Self-constructed assets

FN

0

0%

9,055,480

0%

0

 

Operating grants

FO

0

0%

6,983,459

0%

0

 

Release of reserves and provisions

FP

0

0%

173,840,201

0%

0

 

Other income

FQ

0

0%

11,287,420

0%

0

 

Operating charges (II)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Total operating charges (Total II)

GF

13,480,000,000

-2.3%

13,801,264,670

4.0%

13,270,000,000

 

Exploitation charges

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Purchase of goods for resale

FS

9,864,000,000

5.0%

9,395,690,359

0%

0

 

Change in stocks of goods for resale

FT

0

0%

-1,699,187

0%

0

 

Purchase of raw materials

FU

0

0%

638,658,957

-93.5%

9,847,000,000

 

Change in stocks of raw materials

FV

0

0%

-29,344

-100.1%

32,000,000

 

Other external purchases and charges

FW

3,287,000,000

190.9%

1,129,936,201

0%

0

 

Tax, duty and similar payments

FX

0

0%

250,246,488

9.3%

229,000,000

 

Payroll

FY

0

0%

1,342,223,318

-22.4%

1,730,000,000

 

Social security costs

FZ

0

0%

506,195,007

0%

0

 

Depreciation

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Depreciation of fixed assets

GA

329,000,000

5.1%

313,064,138

3.0%

304,000,000

 

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

2,133,819

0%

0

 

Depreciation/amortisation of current assets

GC

0

0%

46,951,870

261.2%

13,000,000

 

Provisions for risks and charges

GD

0

0%

108,609,821

0%

0

 

Other charges

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Other charges

GE

0

0%

69,283,223

-93.8%

1,115,000,000

  

Operating charges (III-IV)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

5,000,000

-39.3%

8,234,013

17.6%

7,000,000

 

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

161,186

0%

0

  

 

Financial income (V)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Total financial income (Total V)

GP

0

0%

41,000,565

115.8%

19,000,000

 

Share financial income

GJ

0

0%

14,981,353

49.8%

10,000,000

 

Other investment income & capitalised receivables

GK

0

0%

77

0%

0

 

Other interest and similar income

GL

0

0%

24,505,156

172.3%

9,000,000

 

Released provisions and transferred charges

GM

0

0%

1,500,257

0%

0

 

Exchange gains

GN

0

0%

13,722

0%

0

 

Net income from disposal of investment securities

GO

0

0%

0

0%

0

 
Financial Charge (VI)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Total financial charge (Total VI)

GU

23,000,000

-52.1%

47,972,014

128.4%

21,000,000

 

Financial reserves and provisions

GQ

0

0%

1,269,416

26.9%

1,000,000

 

Interest and similar charges

GR

23,000,000

-50.7%

46,647,682

133.2%

20,000,000

 

Exchange losses

GS

0

0%

54,916

0%

0

 

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

  

Extraordinary income (VII)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Total extraordinary income (Total VII)

HD

25,000,000

-86.7%

187,397,085

0%

0

 

Extraordinary operating income

HA

25,000,000

-43.5%

44,249,773

0%

0

 

Extraordinary income from capital transactions

HB

0

0%

18,549,413

0%

0

 

Released provisions and transferred charges

HC

0

0%

124,597,899

0%

0

  

Extraordinary charges (VIII)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

0

0%

192,557,707

369.7%

41,000,000

 

Extraordinary operating charges

HE

0

0%

98,994,361

0%

0

 

Extraordinary charges from capital transactions

HF

0

0%

13,869,484

-66.2%

41,000,000

 

Extraordinary reserves and provisions

HG

0

0%

79,693,862

0%

0

  

 

Employee profit sharing (IX)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

77,000,000

-14.8%

90,325,611

-24.1%

119,000,000

  

Tax on profits (X)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Tax on profits (Total X)

HK

54,000,000

-58.7%

130,783,795

-23.1%

170,000,000

  

References

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Of which equipment leases

HP

0

0%

26,938

0%

0

 

Of which property leases

HQ

0

0%

594,762

0%

0

 

Of which transferred charges

A1

0

0%

26,840,005

0%

0

 

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

29,096,154

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

 Euro

 Kilo Euro


Other incomes tax return forms 
Reserve for depreciation | Provisions included in balance sheet | State deadlines claims and debts at the end of period
Table allocation results and other information 

Fixed Assets
Grand Total Fixed Assets (I to IV)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

9,995,369

0%

0

 

Decreasess by transfers

OK2

0

0%

248,392,129

0%

0

 

Gross value at the end of period

OL

0

0%

6,167,643,901

0%

0

 

 

Research and development Charge (Total I)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

827

0%

0

 

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

C01

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

C02

0

0%

0

0%

0

 

Gross value at the end of period

D0

0

0%

827

0%

0

 

Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Gross value at begin of period

KD

0

0%

1,729,358,160

0%

0

 

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

0

0%

11,515,507

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

476,101

0%

0

 

Decreasess by transfers

LV2

0

0%

7,991,071

0%

0

 

Gross value at the end of period

LW

0

0%

1,732,406,495

0%

0

 

Tangible fixed assets (Total III)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Gross value at begin of period

LN

0

0%

4,207,520,875

0%

0

 

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

0

0%

353,067,503

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

0%

9,519,268

0%

0

 

Decreasess by transfers

NG2

0

0%

230,311,099

0%

0

 

Gross value at the end of period

NH

0

0%

4,320,758,011

0%

0

 

Financial assets (Total IV)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Gross value at begin of period

LQ

0

0%

123,613,475

0%

0

 

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

0

0%

955,050

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NJ2

0

0%

10,089,958

0%

0

 

Gross value at the end of period

NK

0

0%

114,478,567

0%

0

  

 

Reserve for depreciation
Situation and movement of reserve for depreciation
Grand total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Reserve for depreciation value at begin of period

0N

0

0%

0

0%

0

Increases

0P

0

0%

0

0%

0

Decreasess

0Q

0

0%

0

0%

0

 

Reserve for depreciation value at the end of period

0R

0

0%

0

0%

0

 

Research and development charge (Total I)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0

 


 

Other intangible assets (Total II)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

0

0%

1,171,315,239

0%

0

Increases

PF

0

0%

90,733,699

0%

0

Decreasess

PG

0

0%

6,875,176

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PH

0

0%

1,255,173,762

0%

0

 

Total fixed assets amotisation (Total III)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

0

0%

2,156,185,122

0%

0

Increases

QV

0

0%

222,571,838

0%

0

Decreases

QW

0

0%

104,884,356

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

QX

0

0%

2,273,872,604

0%

0


Movements during period affecting charge allocated over several period 

Charges à rEpartir ou frais d'Emission d'emprunt

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0

 

Premium refund of obligations

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Net value at begining of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

827

0%

0

 

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

  

Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Value at begining of period

7C

0

0%

618,156,378

17.7%

525,000,000

Increases

UB

0

0%

251,606,875

-1.7%

256,000,000

Decreases

UC

0

0%

273,079,176

37.9%

198,000,000

 

Value at the end of period

UD

0

0%

596,684,077

2.3%

583,000,000

 


Includes Total allocations

 

Operating

UE

0

0%

171,669,725

0%

0

 

Financial

UG

0

0%

1,269,416

0%

0

 

Exceptional

UJ

0

0%

92,335,616

0%

0

Includes Total Withdrawal

 

Operating

UF

0

0%

210,433,795

0%

0

 

Financial

UH

0

0%

0

0%

0

 

Exceptional

UK

0

0%

76,313,263

0%

0

 

Total regulated provisions (Total I)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Value at begining of period

3Z

0

0%

359,150,078

33.5%

269,000,000

Increases

TS

0

0%

76,236,845

-29.4%

108,000,000

Decreases

TT

0

0%

64,388,235

13.0%

57,000,000

 

Value at the end of period

TU

0

0%

370,998,688

15.9%

320,000,000

 

Total risk and charge provisions (Total II)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Value at begining of period

5Z

0

0%

188,706,104

-4.2%

197,000,000

Increases

TV

0

0%

125,034,198

30.2%

96,000,000

Decreases

TW

0

0%

159,367,873

61.0%

99,000,000

 

Value at the end of period

TX

0

0%

154,372,429

-20.4%

194,000,000

 

Total Provision for depreciation (Total III)

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Value at begining of period

7B

0

0%

70,300,196

19.2%

59,000,000

Increases

TY

0

0%

50,335,832

-3.2%

52,000,000

Decreases

TZ

0

0%

49,323,069

17.4%

42,000,000

 

Value at the end of period

UA

0

0%

71,312,959

3.4%

69,000,000

  

State deadlines claims and debts at the end of period
State claims

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Gross value

VT

0

0%

886,365,680

8.8%

815,000,000

 

1 year at most

VU

0

0%

874,330,833

13.8%

768,000,000

 

More than one year

VV

0

0%

12,034,847

-74.4%

47,000,000

 

State of loans

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Claims related to holdings (gross)

UL

0

0%

0

0%

0

 

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

0%

0

0%

0

 

Loans (gross)

UP

0

0%

2,504,864

0%

0

 

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

447,030

0%

0

 

Other financial assets (gross)

UT

0

0%

9,364,231

0%

0

 

Other financial assets (1 year at most)

UV

0

0%

0

0%

0

 

Receivables statement of assets

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Customers doubtful or disputed

VA

0

0%

20,347,340

0%

0

 

Other claims customer

UX

0

0%

112,756,270

-64.5%

318,000,000

 

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

 

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

 

Personnel and associated accounts

UY

0

0%

786,585

-60.7%

2,000,000

 

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

1,245,021

0%

0

 

Income taxes

VM

0

0%

0

0%

0

 

Value added tax

VB

0

0%

83,922,682

-42.5%

146,000,000

 

Other taxes and payments assimilated

VN

0

0%

0

0%

0

 

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

41,588,346

0%

0

 

Group and Associates

VC

0

0%

79,434,013

164.8%

30,000,000

 

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

0

0%

519,372,924

71.4%

303,000,000

 

Prepaid

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Prepaid

VS

0

0%

15,043,406

-6.0%

16,000,000

 

State Debt

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Total debt (gross)

VY

0

0%

4,021,966,899

10.7%

3,634,000,000

1 year at most

VZ2

0

0%

3,492,041,597

-2.6%

3,587,000,000

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

0

0%

529,925,302

1027.5%

47,000,000

More than 5 years

VZ4

0

0%

0

0%

0

 

Details

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VG2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VH2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

0

0%

493,570,425

2803.4%

17,000,000

1 year at most

8A2

0

0%

19,570,425

15.1%

17,000,000

More than 1 year and 5 years at most

8A3

0

0%

474,000,000

0%

0

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

0

0%

2,060,940,724

-24.7%

2,737,000,000

1 year at most

8B2

0

0%

2,060,940,724

-24.7%

2,737,000,000

More than 1 year and 5 years at most

8B3

0

0%

2,060,940,724

-24.7%

2,737,000,000

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

0

0%

234,276,727

0%

0

1 year at most

8C2

0

0%

234,276,727

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

0

0%

179,811,553

0%

0

1 year at most

8D2

0

0%

179,811,553

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (gross)

VW1

0

0%

134,017,463

0%

0

1 year at most

VW2

0

0%

134,017,463

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

0

0%

110,472,747

0%

0

1 year at most

VQ2

0

0%

110,472,747

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

0

0%

53,158,177

0%

0

1 year at most

8J2

0

0%

53,158,177

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

636,024,616

0%

0

1 year at most

VI2

0

0%

636,024,616

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More 5 years

VI4

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

0

0%

32,670,206

-95.9%

803,000,000

1 year at most

8K2

0

0%

32,670,206

-95.9%

803,000,000

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

0

0%

87,024,262

13.0%

77,000,000

1 year at most

8L2

0

0%

31,098,960

3.7%

30,000,000

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

55,925,302

19.0%

47,000,000

 

References

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Loans made during the period

VJ

0

0%

34,559,353

0%

0

 

Debt repaid during the period

VK

0

0%

299,884

0%

0

  
Table allocation results and other information 
Dividends distributed

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Dividends

ZE

0

0%

504,660,119

0%

0

 

Commitments

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

 

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

 

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0

 

Other charges Externes

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Subcontracting

YT

0

0%

140,490,952

0%

0

 

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

167,623,319

0%

0

 

Staff outside the company

YU

0

0%

32,310,305

0%

0

 

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

129,551,412

0%

0

 

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

 

Other accounts

ST

0

0%

659,860,412

0%

0

 

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

1,129,836,400

0%

0

 

Taxes and Fees

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Business tax

YW

0

0%

72,858,320

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

177,388,168

0%

0

 

Total taxes and fees

YX

0

0%

250,246,488

0%

0

 

VAT

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Amount VAT collected

YY

0

0%

1,764,877,312

0%

0

 

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

1,450,009,717

0%

0

 

Average number of employees

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Average number of employees

YP

0

0%

51,411

4.1%

49,373

 

Groups and Shareholders

 

 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

 

Groups and Shareholders

ZR

0

-

0

-

-

 

 

Display parameter

Comparison mode

 Average

 Median

 

Ratios 
Structure and liquidity | Management or rotation | Profitability of the business | Return on capital 

Structure and Liquidity

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Sector Median2013

 

Fixed Asset Financing

0.87

10.1%

0.79

8.2%

0.73

1.11

-21.6%

Global Debt

99 days

-4.8%

104 days

9.5%

95 days

66 days

50.0%

Working Capital Fund overall net

-22 days

33.3%

-33 days

21.4%

-42 days

9 days

-344.4%

Financial independence

89.53%

-26.0%

120.96%

-97.9%

5688.24%

95.99%

-6.7%

Solvability

17.81%

42.7%

12.48%

-38.1%

20.17%

28.48%

-37.5%

Capacity debt futures

%

-

%

-

%

469.50%

-

Coverage of current assets by net working capital overall

-41.04%

30.1%

-58.69%

25.8%

-79.05%

18.91%

-317.0%

General Liquidity

 

-

0.25

19.0%

0.21

0.23

-

Restricted Liquidity

 

-

0.32

23.1%

0.26

0.50

-

 

Management or rotation

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Sector Median2013

 

Need background in operating working capital

-32 days

20.0%

-40 days

11.1%

-45 days

-3 days

-966.7%

Treasury

5 days

-16.7%

6 days

50.0%

4 days

9 days

-44.4%

Inventory turnover of goods

0 days

0%

43 days

-

days

30 days

0%

Average length of credit granted to customers

20 days

566.7%

3 days

-62.5%

8 days

2 days

900%

Average length of credit obtained suppliers

0 days

0%

59 days

-41.0%

100 days

29 days

0%

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

days

-

1 days

0%

0 days

21 days

-

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

days

-

324 days

-

days

740 days

-

Rotation tangible assets

%

-

323.76%

-

%

713.48%

-

 

Profitability of the business

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Sector Median2013

 

Margin trading

28.27%

43.9%

19.64%

0%

0

17.98%

57.2%

Profitability of the business

4.37

-17.9%

5.32

-62.9%

14.34

2.98%

46.6%

Net profit

1.08%

-7.7%

1.17%

-27.8%

1.62%

1.49%

-27.5%

Growth rate of turnover (excluding VAT)

0%

0%

0%

0%

-11.51%

1.69%

0%

Rates integration

4.37%

-78.4%

20.27%

-28.9%

28.51%

12.71%

-65.6%

Rate leasing furniture

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Work Factor

0%

0%

65.19%

48.5%

43.91%

66.09%

0%

Weight interests

0.17

-50.0%

0.34%

126.7%

0.15%

0.21%

-19.0%

 

 

Return on capital

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Sector Median2013

 

Cash flow from the overall profitability

3.47%

80.7%

1.92%

-53.4%

4.12%

2.60%

33.5%

Rates of economic profitability

38%

-44.1%

68%

-66.2%

201%

18%

111.1%

Financial profitability

819000000%

37.2%

597040840%

-38.3%

967000000%

2852162%

28615.1%

Return on investment

10.67%

-45.0%

19.39%

-22.1%

24.90%

10.66%

0.1%

 

Display parameter

Currency

 Euro

 Kilo Euro

Comparison mode

 Average

 Median

 


Soldes Intermediaires De Gestion 

 

31/12/2013

 

31/12/2011

 

31/12/2009

Sector Median2013

 

Turnover

13,752,000,000

-1.7%

13,988,738,535

1.2%

13,819,000,000

35,225,219 € 

38940.2% 

 

Sales of goods

13,752,000,000

13.3%

12,140,997,139

0%

0

 

 

- Purchase of goods

9,864,000,000

5.0%

9,395,690,359

0%

0

 

 

+/- Stock of goods variation

0

0%

-1,699,187

0%

0

 

 

Trading margin

3,888,000,000 €

41.5%

2,747,005,967 €

0%

0 €

6,328,405 € 

61337.3% 

 

28.27 % CA

43.9%

19.64 % CA

0%

0.00 % CA

17.98 % CA 

57.2% 

 

Sale of goods produced

0

0%

1,847,741,396

-86.6%

13,819,000,000

 

 

+/- Stocked production

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Self-constructed assets

0

0%

9,055,480

0%

0

 

 

Period production

0 €

0%

1,856,796,876 €

-86.6%

13,819,000,000 €

639,994 € 

0% 

 

0.00 % CA

0%

13.27 % CA

-86.7%

100.00 % CA

1.73 % CA 

0% 

 

Trading margin

3,888,000,000

41.5%

2,747,005,967

0%

0

6,328,405 

61337.3% 

+ Period Production

0

0%

1,856,796,876

-86.6%

13,819,000,000

639,994 

0% 

- Purchase of raw materials

0

0%

638,658,957

-93.5%

9,847,000,000

 

 

+/- Change in stocks of raw materiels

0

0%

-29,344

-100.1%

32,000,000

 

 

- Other external purchases and charges

3,287,000,000

190.9%

1,129,936,201

0%

0

 

 

Added value

601,000,000 €

-78.8%

2,835,237,029 €

-28.0%

3,940,000,000 €

4,589,365 € 

12995.5% 

 

4.37 % CA

-78.4%

20.27 % CA

-28.9%

28.51 % CA

12.71 % CA 

-65.6% 

 

Added value

601,000,000 €

-78.8%

2,835,237,029 €

-28.0%

3,940,000,000 €

4,589,365 € 

12995.5% 

+ Operating grants

0

0%

6,983,459

0%

0

 

 

- Tax, duty and similar payments

0

0%

250,246,488

9.3%

229,000,000

 

 

- Personal charges

0

0%

1,848,418,325

6.8%

1,730,000,000

 

 

Gross operating surplus

601,000,000 €

-19.2%

743,555,675 €

-62.5%

1,981,000,000 €

1,018,956 € 

58881.9% 

 

4.37 % CA

-17.9%

5.32 % CA

-62.9%

14.34 % CA

2.98 % CA 

46.6% 

 

Gross operating surplus

601,000,000 €

-19.2%

743,555,675 €

-62.5%

1,981,000,000 €

1,018,956 € 

58881.9% 

+ Release of reserves and provisions

0

0%

173,840,201

0%

0

 

 

+ Other operating income

0

0%

11,287,420

0%

0

 

 

- Depreciation/Amortisation

329,000,000

-30.1%

470,759,648

48.5%

317,000,000

 

 

- Other charges

0

0%

69,283,223

-93.8%

1,115,000,000

 

 

Operating result

272,000,000 €

-30.0%

388,640,425 €

-29.2%

549,000,000 €

777,989 € 

34861.9% 

 

1.98 % CA

-28.8%

2.78 % CA

-30.0%

3.97 % CA

2.20 % CA 

-10.0% 

 

Operating result

272,000,000 €

-30.0%

388,640,425 €

-29.2%

549,000,000 €

777,989 € 

34861.9% 

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

5,000,000

-38.1%

8,072,827

15.3%

7,000,000

 

 

+ Financial income

0

0%

41,000,565

115.8%

19,000,000

 

 

- Financial charges

23,000,000

-52.1%

47,972,014

128.4%

21,000,000

 

 

Pre-tax result

254,000,000 €

-34.8%

389,741,803 €

-29.6%

554,000,000 €

774,184 € 

32708.7% 

 

1.85 % CA

-33.7%

2.79 % CA

-30.4%

4.01 % CA

2.29 % CA 

-19.2% 

 

Extraordinary income

25,000,000

-86.7%

187,397,085

0%

0

44,923 

55550.8% 

- Extraordinary charges

0

0%

192,557,707

369.7%

41,000,000

 

 

Extraordinary result

25,000,000 €

584.4%

-5,160,622 €

87.4%

-41,000,000 €

01 € 

2499999900% 

 

0.18 % CA

550.0%

-0.04 % CA

86.7%

0 % CA

0 % CA 

0% 

 

Pre-tax result

254,000,000 €

-34.8%

389,741,803 €

-29.6%

554,000,000 €

774,184 € 

32708.7% 

Extraordinary result

25,000,000 €

584.4%

-5,160,622 €

87.4%

-41,000,000 €

01 € 

2499999900% 

- Employee profit sharing

77,000,000

-14.8%

90,325,611

-24.1%

119,000,000

 

 

- Tax on profits

54,000,000

-58.7%

130,783,795

-23.1%

170,000,000

 

 

Net result

148,000,000 €

-9.5%

163,471,775 €

-27.0%

224,000,000 €

517,476 € 

28500.4% 

1.08 % CA

-7.7%

1.17 % CA

-27.8%

1.62 % CA

1.49 % CA 

-27.5% 

 

 

judgements

 

Collective procedures

 

No judgment information for the company

Social security, pension funds preferential rights | Tax office preferential rights

 

Preferential rights details and history

 

Summary of preferential rights

 

Company monitored since

31/12/2009

 

 

Status of Monitoring

This company is under monitoring with at least one active preferential right

Number of active preferential rights

1

Total amount

53,597 EUR

Due remaining amount

53,597 EUR

 

Tax office preferential rights

Number of active preferential rights

1

Total amount

53,597 EUR

Due remaining amount

53,597 EUR

Date of last preferential right

08/10/2014

 

Active

Registration number

Registration date

Date of the planned end

Creditor

Amount of the debt

Due remaining amount

735275

08/10/2014

08/10/2018

COMPTABLE DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

53,597 EUR

53,597 EUR

Creditor

COMPTABLE DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES 
8 R COURTOIS 93505, PANTIN CEDEX

Debtor

AUCHAN FRANCE 
RTE NATIONALE 352 ENGLOS 59320 HAUBOURDIN

 

Pledges

Title of the act and date

bordereau inscription tresor Bordereau dinscription TrEsor en date du 20141006

 

Historical Data

Registration number

Registration date

Date of the planned end

Creditor

Amount of the debt

Due remaining amount

248409

26/08/2008

02/09/2010

COMPTABLE DE LA D.G.E.

96,540,913 EUR

-

Reason for closure

Crossed Off

Court

Lille

Creditor

COMPTABLE DE LA D.G.E. 

Debtor

AUCHAN FRANCE 
ENGLOS ROUTE NATIONALE 352 59320 HAUBOURDIN, HAUBOURDIN

 

Pledges

Title of the act and date

BORDEREAU INSCRIPTION TRESOR en date du 20080821

261601

18/03/2010

16/02/2012

COMPTABLE DE LA D.G.E.

97,211,813 EUR

-

Reason for closure

Crossed Off

Court

Lille

Creditor

COMPTABLE DE LA D.G.E. 

Debtor

AUCHAN FRANCE 
ENGLOS ROUTE NATIONALE 352 59320 HAUBOURDIN, HAUBOURDIN

 

Pledges

Title of the act and date

BORDEREAU INSCRIPTION TRESOR en date du 20100310

722376

08/10/2013

30/01/2014

COMPTABLE DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

59,244 EUR

-

Reason for closure

Crossed Off

Creditor

COMPTABLE DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES 

Debtor

AUCHAN FRANCE 
RTE NATIONALE 352 ENGLOS 59320 HAUBOURDIN

 

Pledges

Title of the act and date

bordereau inscription tresor Bordereau dinscription TrEsor en date du 20131002

 

 

Group data

 

Ultimate parent company

GROUPE AUCHAN

Direct parent

AUCHANHYPER - 100 %

Group – Number of companies

137

Linkages – Number of companies

24

Number of countries

4

 

 


Group Structure

 

Company Name

 

SIREN

Parts

Last account published

 GROUPE AUCHAN

 

476180625

-

31/12/2013

 RT MART INTERNATIONAL

 

-

61%

-

 IMMOCHAN

 

428803746

100%

31/12/2013

 IMMOCHAN FRANCE

 

969201532

100%

31/12/2012

 SERVICIMMOG

 

410777643

50%

-

 SCI IMMOCHAMP

 

431816289

93.75%

-

 DES FRAIS FONDS

 

442686952

Min blocking

-

 CITANIA

 

480076298

100%

31/12/2013

 LA CORBEILLERIE

 

534141460

60%

-

 MAS COSTE

 

439099748

100%

31/12/2013

 IMMOPROXI

 

384812061

100%

31/12/2013

 AUX NOUVELLES BOUTIQUES

 

410410468

100%

31/12/2013

 SNC LA GARENNE

 

479326316

50%

31/12/2013

 SCI BAGGERSEE OUEST

 

778843425

47.31%

-

 STRATANIM

 

480076215

100%

31/12/2013

 MARRELIMMO

 

422904409

99.99%

31/12/2013

 POITIERS EXTENSION INVEST

 

508059656

50%

31/12/2011

 ALLIAGES ET TERRITOIRES

 

529066433

100%

31/12/2013

 GRAND TARBES INVESTISSEMENT

 

518662432

100%

31/12/2013

 LES SAISONS DE MEAUX

 

519021380

100%

31/12/2013

 GALERIE DE BEZIERS

 

492225370

35%

-

 5 I IMMOFA

 

501507917

50%

-

 GALLERIE COMMERCIALI ITALIA S.P.A.

 

MI1668879

100%

31/12/2013

 IMMOCHAN ESPAÑA

 

360022

100%

31/12/2013

 IMMOCHAN MAGYARORSZAG

 

-

100%

-

 IMMOCHAN ALAPOK

 

-

95%

-

 GIE AUCHAN INTERNATIONAL TECHNOLOGY

 

422332312

99.88%

31/12/2011

 ALINEA

 

345197552

85.69%

31/12/2013

 SAFIPAR

 

444409551

100%

31/12/2013

 SOCIETE DE DISTRIBUTION REGIONALE

 

487702961

100%

31/12/2013

 SARCELDIS

 

407755230

100%

31/12/2013

 SOCIETA ITALIANA DISTRIBUZIONE MODER...

 

-

99%

-

 AUCHAN S.P.A.

 

MI1668908

99%

31/12/2012

 SMA S.P.A.

 

MI1260748

97%

31/12/2012

 AUCHANHYPER

 

410408959

100%

31/12/2013

 ORGANISATION INTRA-GROUPE DES ACHA...

 

421982745

99.89%

31/12/2013

 ALCAMPO

 

2266313

100%

31/12/2013

 ZENALCO

 

511582

100%

31/12/2013

 ZENOR ESPAGNE

 

-

95%

-

 REDARPA

 

-

95%

-

 AUCHAN HOLDING USA

 

-

100%

-

 AUCHAN

 

US47095123

100%

-

 SOFINANCE

 

417572955

100%

31/12/2013

 AUCHAN LUXEMBOURG

 

B45515

100%

31/12/2013

 GALERIE DE KIRCHBERG

 

-

96%

-

 AUCHAN INTERNATIONAL S.A.

 

B73616

100%

31/12/2011

 AUCHAN MAGYARDRSZÀG

 

-

100%

-

 AUCHAN FRANCE

 

410409460

100%

31/12/2013

 SERVICIMMOG

 

410777643

50%

-

 AUCHAN CARBURANT

 

379548001

100%

31/12/2013

 PETROVEX

 

317007342

100%

31/12/2013

 EURAUCHAN

 

410410260

78.30%

31/12/2013

 DISTICKET

 

422628289

66%

30/09/2013

 AUCHAN ASSURANCES

 

422231100

99.99%

31/12/2013

 SOC POUR COMMERCIALISATION FRUIT...

 

312668692

100%

31/12/2013

 CENTRALE DE SERVICES AUCHAN

 

340143668

75.27%

31/12/2013

 SOGEP

 

381491323

65.79%

-

 SOMARVRAC

 

481977460

Min blocking

31/12/2013

 AU COMMERCE RENNAIS

 

504697228

99.80%

31/12/2013

 AUCHAN SERVICES A DOMICILE

 

498062702

100%

31/12/2013

 BDL

 

-

100%

-

 AUCHAN PORTUGAL

 

-

100%

-

 ISENBOURG

 

-

100%

-

 ALVERCA HIPERMERCADOS

 

-

100%

-

 SINTRAPARQUE

 

-

100%

-

 MENDES E.COSTA

 

-

100%

-

 MULTICENCO

 

-

100%

-

 OMNIA CONSTRUTORA

 

-

100%

-

 PAO DE AÇUCAR

 

-

100%

-

 COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMER...

 

-

100%

-

 AUCHAN HIPERMERCADO PORTUGAL

 

-

100%

-

 FLOORAGEST IMOBILIARIA

 

-

100%

-

 PLANCO

 

-

100%

-

 RESIMOVEL

 

-

100%

-

 EMPREENDIMENTOS DO CARNAVIAL

 

-

100%

-

 AUCHAN POLSKA

 

-

100%

-

 AUCHAN ESPAÑA

 

891547

100%

31/12/2013

 SUN ART RETAIL

 

-

50%

-

 SCHIEVER POLSKA

 

-

50%

-

 SOGEPAR

 

433713963

100%

31/12/2013

 AUCHAN RUSSIE

 

-

100%

-

 AUCHAN NEDVIZHIMOST

 

-

100%

-

 RUSSKIE PRODUKTY TRADING COMPL...

 

-

100%

-

 STOYINVEST ALPHA

 

-

100%

-

 STROYINVEST BETA

 

-

100%

-

 DRAYCOTT

 

-

100%

-

 AUCHAN CHINE HONG KONG

 

-

67%

-

 SOPARALINEA

 

345127583

82.58%

31/12/2012

 BANQUE ACCORD

 

546380197

98%

-

 ONEY IFIC

 

-

100%

-

 ACCORD FINANCE

 

-

60%

-

 ACCORD ITALIA

 

-

100%

-

 ONEY FINANCE

 

-

100%

-

 ACCORD MAGYARORSZÀG

 

-

100%

-

 ACCORDFIN

 

-

51%

-

 ACCORD BUSINESS CONSULTING COMPANY

 

-

100%

-

 GEFIRUS

 

483303228

60%

31/12/2012

 BA FINANS

 

-

100%

-

 ONEY SERVICES

 

503428989

100%

31/12/2012

 ONEY INSURANCE LTD

 

-

100%

-

 ONEY LIFE LTD

 

-

100%

-

 ONEY UKRAINE

 

-

100%

-

 ONEY INVESTMENT

 

521009357

100%

31/12/2013

 ARONDE

 

-

100%

-

 INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES

 

674801329

97%

31/12/2013

 FREMARC

 

342281409

100%

31/12/2013

 SODIPAR

 

444410773

100%

31/12/2013

 ISMS POLSKA

 

-

60%

-

 ELEA

 

-

60%

-

 ATAC

 

410409015

99%

31/12/2013

 SA CHOLDIS

 

383272226

100%

31/12/2013

 COUSTE

 

439974551

100%

31/12/2013

 SOMADIS SOC MAGDUNOISE DISTRIBUT...

 

442726923

100%

31/12/2013

 SODIMA

 

433701554

100%

31/12/2013

 PASCAL

 

439974502

100%

31/12/2013

 CACHAN DISTRIBUTION

 

339544314

93%

31/12/2013

 PAREA

 

481020022

100%

31/12/2013

 SABECO

 

1764232

97%

-

 S.I. LACANAU

 

-

100%

-

 SABEKO BANAKETA

 

608999

100%

31/12/2013

 SERCOASTOR

 

276717

100%

-

 EL ASTORGANO

 

226421

100%

-

 CESARAUGUSTA

 

639556

100%

-

 SABEKO EUSKADI

 

-

100%

-

 SUPERLAUKO

 

373362

100%

-

 AUCHAN COORDINATION SERVICES SA

 

878922641

100%

31/12/2013

 LITTLE EXTRA

 

480089853

100%

31/12/2010

 ORGANISATION INTERNATIONALE DES ACHA...

 

-

100%

-

 ATAK

 

-

97%

-

 FCAU

 

-

100%

-

 AUCHAN-E-COMMERCE INTERNATIONAL

 

480075431

100%

31/12/2010

 GROSBILL

 

420437311

100%

31/12/2010

 AUCHAN E-COMMERCE FRANCE

 

413176033

100%

31/12/2010

 AUCHAN FINANCES INTERNATIONAL

 

480089911

100%

31/08/2013

 EDRIVE

 

519560353

93.64%

-

 CHRONODRIVE

 

433513892

100%

31/12/2004

 ADRIVE

 

523412781

100%

31/12/2010

 

 

Linkages

 

Ultimate parent company

GROUPE AUCHAN

Direct parent

AUCHANHYPER - 100 %

Group – Number of companies

137

Linkages – Number of companies

24

Number of countries

4

 

Company Name

 

SIREN

Last account

Turnover

ERREGEST S.P.A.

 

MI1260749

31/12/2012

896 785 €

GALLERIE GIUGLIANO S.R.L.

 

MI1763170

31/12/2012

10 826 757 €

COM-FACTOR COMMERCIO FACTORING SPA

 

MI1071893

-

-

S.C.S. SMA CAMBRIA SICILIA S.R.L.

 

ME208062

31/12/2012

182 024 341 €

SOCIETA' GENERALE DISTRIBUZIONE SPA

 

MI1570055

31/12/2012

118 853 113 €

INIZIATIVE COMMERCIALI NAPOLI SPA

 

MI1926042

31/12/2012

7 575 255 €

ICOM S.P.A.

 

MI1614915

31/12/2013

12 901 156 €

IMMOBILIARE COMMERCIALE XXXIII S.R.L. IN...

 

MI1726394

31/12/2012

1 €

B.V. INVESTMENT MESTRE

 

33244110

31/12/2013

-

AUCHAN CARBURANTI S.R.L.

 

MI1763309

31/12/2012

34 823 572 €

UNIGRET B.V.

 

34228434

31/12/2013

-

C'E' ITALIA S.R.L.

 

RN318784

31/12/2013

399 081 €

DUEMARI S.R.L.

 

MI1865029

31/12/2013

65 650 €

CONSULENZE COMMERCIALI IMMOBILIARI S.R.L...

 

MI1979697

31/12/2013

122 900 €

DORSHEUVEL B.V.

 

34269360

31/12/2013

-

MAASOORD B.V.

 

34269365

30/12/2013

-

MONITWEE B.V.

 

34312570

31/12/2013

-

SOCIETA' CONSORTILE EUROPA A R.L.

 

BS359380

31/12/2013

1 000 650 €

IMMOBILIARE COMMERCIALE 36 S.R.L.

 

MI1977125

31/12/2012

0 €

IMMOBILIARE COMMERCIALE 38 S.R.L.

 

MI1977127

31/12/2012

0 €

IMMOBILIARE COMMERCIALE 37 S.R.L.

 

MI1977167

31/12/2012

0 €

PUNTO RISPARMIO SICILIA S.R.L.

 

MI1997513

31/12/2012

428 010 €

AUCHAN SUPPLIERS ADVANCED PLATFORM SA

 

846545922

31/12/2013

66 862 €

CAISSE AUCHAN ITALIE SA

 

 

 

 

 

 

Status history

 

 

 

No Status History

 

Recent publications in Gazettes

 

 

Publication Date

Gazette Name

Description

 

31/10/2014

Bodacc C

Comptes Annuels Et Rapports

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Mã‰Tropole

5799 - 410409460 Rcs. Auchan FranceForme : Societe Anonyme. Adresse : 200 Rue De La Recherche 59650 Villeneuve-D Ascq. Commentaires : Comptes Annuels Et Rapports De L'exercice Clos Le : 31/12/2013.

23/10/2014

Bodacc A

Vente Et Cession : Vendeur

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Metropole

277 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Capital : 56882160 Eur. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Precedent Proprietaire : Auchan France. 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Precedent Proprietaire : Auchan Services A Domicile. 498 062 702 Rcs Lille Metropole. 
Date De Commencement De L’Activite : 01/01/0001. Oppositions : Article L.236-14 Du Code De Commerce. Descriptif : Avis Au Bodacc Relatif Au Projet De Fusion Simplifiee Entre La Sa Auchan France Et Sas Auchan Services E Domicilesociete Absorbante : Auchan France Forme : Societe Anonyme Adresse Du Siege :200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650) Montant Du Capital :56.882.160euros Ne Unique D'identification: 410 409 460 Lieu D'immatriculation : Lille Metropole Societe Absorbee : Auchan Services E Domicile Forme : Societe Par Actions Simplifiee Adresse Du Siege : 200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650) Montant Du Capital : Variable (Minimum 50.000 Euros) Ne Unique D'identification: 498 062 702 Lieu D'immatriculation : Lille Metropole. Evaluation De L'actif Et Du Passif Dont La Transmission E La Societe Absorbante Est Prevue : Actif : 42.167 Euros Passif : 1.051 Euros Mali De Fusion : 8.884 Euros. Rapport D'echange Des Droits Sociaux : Auchan France Possedant La Totalite Du Capital Social De La Sas Auchan Service E Domicile, Il N'a Pas Ete Etabli De Rapport D'echange Et Il N'en Resultera Aucune Augmentation De Capital Pour La Societe Absorbante. Date Du Projet Commun De Fusion : 15/10/2014 Date Et Lieu Du Depet Du Projet Commun De Fusion Au Rcs Au Titre De Chaque Societe Participante : Pour L'absorbante : 15/10/2014 Rcs Lille Metropole. Pour L'absorbee : 15/10/2014 Rcs Lille Metropole. Commentaires : Autre Achat, Apport, Attribution.

23/10/2014

Bodacc A

Vente Et Cession : Vendeur

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Metropole

280 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Capital : 56882160 Eur. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Precedent Proprietaire : Societe De Distribution Regionale. 487 702 961 Rcs Lille Metropole. Precedent Proprietaire : Auchan France. 410 409 460 Rcs Lille Metropole. 
Date De Commencement De L’Activite : 15/10/2014. Oppositions : Article L.236-14 Du Code De Commerce. Descriptif : Avis Au Bodacc Relatif Au Projet De Fusion Simplifiee Entre La Sa Auchan France Et Sas Societe De Distribution Regionale.Societe Absorbante : Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Adresse Du Siege : 200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650) Montant Du Capital : 56.882.160 Euros Ne Unique D'identification: 410 409 460 Lieu D'immatriculation : Lille Metropole. Societe Absorbee : Societe De Distribution Regionale. Forme : Societe Par Actions Simplifiee. Adresse Du Siege : Rue Du Marechal De Lattre De Tassigny (59170) Croix. Montant Du Capital : Variable (Minimum 50.000 Euros) Ne Unique D'identification: 487 702 961. Lieu D'immatriculation : Lille Metropole. Evaluation De L'actif Et Du Passif Dont La Transmission E La Societe Absorbante Est Prevue : Actif : 37.290 Euros. Passif : 1.330 Euros. Mali De Fusion : 14.040 Euros. Rapport D'echange Des Droits Sociaux : Auchan France Possedant La Totalite Du Capital Social De La Sas Societe De Distribution Regionale, Il N'a Pas Ete Etabli De Rapport D'echange Et Il N'en Resultera Aucune Augmentation De Capital Pour La Societe Absorbante. Date Du Projet Commun De Fusion : 15/10/2014. Date Et Lieu Du Depet Du Projet Commun De Fusion Au Rcs Au Titre De Chaque Societe Participante : Pour L'absorbante : 15/10/2014 Rcs Lille Metropole. Pour L'absorbee : 15/10/2014 Rcs Lille Metropole. Commentaires : Autre Achat, Apport, Attribution.

23/10/2014

Bodacc A

Vente Et Cession : Vendeur

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Metropole

279 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Capital : 56882160 Eur. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Precedent Proprietaire : Auchan Services A Domicile. 498 062 702 Rcs Lille Metropole. Precedent Proprietaire : Auchan France. 410 409 460 Rcs Lille Metropole. 
Date De Commencement De L’Activite : 01/01/0001. Oppositions : Article L.236-14 Du Code De Commerce. Descriptif : Avis Au Bodacc Relatif Au Projet De Fusion Simplifiee Entre La Sa Auchan France Et Sas Auchan Services E Domicilesociete Absorbante : Auchan France Forme : Societe Anonyme Adresse Du Siege :200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650) Montant Du Capital :56.882.160euros Ne Unique D'identification: 410 409 460 Lieu D'immatriculation : Lille Metropole Societe Absorbee : Auchan Services E Domicile Forme : Societe Par Actions Simplifiee Adresse Du Siege : 200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650) Montant Du Capital : Variable (Minimum 50.000 Euros) Ne Unique D'identification: 498 062 702 Lieu D'immatriculation : Lille Metropole. Evaluation De L'actif Et Du Passif Dont La Transmission E La Societe Absorbante Est Prevue : Actif : 42.167 Euros Passif : 1.051 Euros Mali De Fusion : 8.884 Euros. Rapport D'echange Des Droits Sociaux : Auchan France Possedant La Totalite Du Capital Social De La Sas Auchan Service E Domicile, Il N'a Pas Ete Etabli De Rapport D'echange Et Il N'en Resultera Aucune Augmentation De Capital Pour La Societe Absorbante. Date Du Projet Commun De Fusion : 15/10/2014 Date Et Lieu Du Depet Du Projet Commun De Fusion Au Rcs Au Titre De Chaque Societe Participante : Pour L'absorbante : 15/10/2014 Rcs Lille Metropole. Pour L'absorbee : 15/10/2014 Rcs Lille Metropole. Commentaires : Autre Achat, Apport, Attribution.

23/10/2014

Bodacc A

Vente Et Cession : Vendeur

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Metropole

278 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Capital : 56882160 Eur. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Precedent Proprietaire : Auchan France. 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Precedent Proprietaire : Societe De Distribution Regionale. 487 702 961 Rcs Lille Metropole. 
Date De Commencement De L’Activite : 15/10/2014. Oppositions : Article L.236-14 Du Code De Commerce. Descriptif : Avis Au Bodacc Relatif Au Projet De Fusion Simplifiee Entre La Sa Auchan France Et Sas Societe De Distribution Regionale.Societe Absorbante : Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Adresse Du Siege : 200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650) Montant Du Capital : 56.882.160 Euros Ne Unique D'identification: 410 409 460 Lieu D'immatriculation : Lille Metropole. Societe Absorbee : Societe De Distribution Regionale. Forme : Societe Par Actions Simplifiee. Adresse Du Siege : Rue Du Marechal De Lattre De Tassigny (59170) Croix. Montant Du Capital : Variable (Minimum 50.000 Euros) Ne Unique D'identification: 487 702 961. Lieu D'immatriculation : Lille Metropole. Evaluation De L'actif Et Du Passif Dont La Transmission E La Societe Absorbante Est Prevue : Actif : 37.290 Euros. Passif : 1.330 Euros. Mali De Fusion : 14.040 Euros. Rapport D'echange Des Droits Sociaux : Auchan France Possedant La Totalite Du Capital Social De La Sas Societe De Distribution Regionale, Il N'a Pas Ete Etabli De Rapport D'echange Et Il N'en Resultera Aucune Augmentation De Capital Pour La Societe Absorbante. Date Du Projet Commun De Fusion : 15/10/2014. Date Et Lieu Du Depet Du Projet Commun De Fusion Au Rcs Au Titre De Chaque Societe Participante : Pour L'absorbante : 15/10/2014 Rcs Lille Metropole. Pour L'absorbee : 15/10/2014 Rcs Lille Metropole. Commentaires : Autre Achat, Apport, Attribution.

10/09/2014

Bodacc C

Comptes Annuels Et Rapports

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Mã‰Tropole

1503 - 410409460 Rcs. Auchan FranceForme : Societe Anonyme. Adresse : 200 Rue De La Recherche 59650 Villeneuve-D Ascq. Commentaires : Comptes Annuels Et Rapports De L'exercice Clos Le : 31/12/2013.

19/08/2014

Bodacc B

Modification Et Mutation Diverse

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Metropole

352 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Administration : Modification De L'administrateur Jolivet, Yvon. Capital : 56882160 Eur.Activite : 
Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Commentaires : Modification Survenue Sur L'administration.

10/08/2014

Bodacc B

Modification Et Mutation Diverse

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Metropole

1018 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Enseigne : Auchan France. Capital : 56882160 Eur. Activite : Hypermarche - Courtage En Assurance Vente De Scooter Et Produits Motorises (Quad, Buggy, Etc.) Commissionnaire De Transport. La Vente Et Le Depã´T-Vente De Toute Activite De Billeterie. Formation. L'achat, La Vente, L'installation Et La Reparation Des Equipements De Genie Climatique, Chauffage, Energies Renouvelables Et Appareils à Economie D'energie, La Location De Tous Biens D'equipements. La Fourniture à Titre Onereux Et Conformes Aux Prescriptions Legales Et Reglementaires Applicables Aux Agents De Voyages De Prestations De Services Afferentes à L'organisation De Voyages (Billetterie, Excursions, Hã´Tellerie, Locations, Assurances Voyages) Et Toutes Autres Prestations Annexes Normalement Assures Par Une Agence De Voyages. Adresse De L’Etablissement Principal : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Commentaires : Modification Survenue Sur L'activite De L'etablissement Principal.

10/08/2014

Bodacc B

Modification Et Mutation Diverse

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Metropole

1019 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Administration : Nomination Du Directeur : Sainte-Marie, Frederic. Capital : 56882160 Eur. Activite : 
Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Commentaires : Modification Survenue Sur L'administration.

25/07/2014

JAL

Appointment Of The Social Representative

 

 

Syndicat Agricole (Le)


Date De Decision : 20/06/2014
Societe Faisant L'objet D'une Nomination : 410409460 - AUCHAN FRANCE, AUCHAN DRIVE, 200 RUE DE LA RECHERCHE, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
Nomine : Monsieur Frederic SAINTE-MARIE, 92400 COURBEVOIE
En La Fonction De : Directeur

25/07/2014

JAL

Resignation / Revocation Of The Social Representative

 

 

Syndicat Agricole (Le)


Date De Decision : 10/04/2014
La Societe 410409460 - AUCHAN FRANCE, AUCHAN DRIVE, 200 RUE DE LA RECHERCHE, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
Fait L'objet Du Depart De Monsieur Yvon JOLIVET

08/05/2014

Bodacc A

Vente Et Cession : Vendeur

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Metropole

411 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Capital : 56882160 Eur. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Precedent Proprietaire : Auchan France. 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Precedent Proprietaire : Mondial Travel. 400 669 768 Rcs Lille Metropole. 
Date De Commencement De L’Activite : 28/04/2014. Oppositions : Article L.236-14 Du Code De Commerce. Descriptif : Avis Au Bodacc Relatif Au Projet De Fusion Simplifiee Entre La Sa Anchan France Et Sarl Mondial Travel :Societe Absorbante :Auchan France,Societe Anonyme,200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650),56.882.160 Euros,410 409 460 Rcs Lille Metropole.Societe Absorbee : Mondial Travel,Societe E Responsabilite Limitee,200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650),Variable (Montant Actuel 100.572,89 Euros),400 669 768 Rcs Lille Metropole.Evaluation De L'actif Et Du Passif Dont La Transmission E La Societe Absorbante Est Prevue :Actif :7.290.842 Euros,Passif : 8.793.000 Euros,Mali De Fusion : 4.502.158 Euros,Rapport D'echange Des Droits Sociaux : Auchan France Possedant La Totalite Du Capital Social De La Sarl Mondial Travel, Il N'a Pas Ete Etabli De Rapport D'echange Et Il N'en Resultera Aucune Augmentation De Capital Pour La Ste Absorbante.Date Du Projet Commun De Fusion : 28/04/2014.Date Et Lieu Du Depet Du Projet Commun De Fusion Au Rcs Au Titre De Chaque Societe Participante :Pour L'absorbante : 28/04/2014 Rcs Lille Metropole,Pour L'absorbee : 28/04/2014 Rcs Lille Metropole. Commentaires : Autre Achat, Apport, Attribution.

08/05/2014

Bodacc A

Vente Et Cession : Vendeur

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Metropole

412 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Capital : 56882160 Eur. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Precedent Proprietaire : Mondial Travel. 400 669 768 Rcs Lille Metropole. Precedent Proprietaire : Auchan France. 410 409 460 Rcs Lille Metropole. 
Date De Commencement De L’Activite : 28/04/2014. Oppositions : Article L.236-14 Du Code De Commerce. Descriptif : Avis Au Bodacc Relatif Au Projet De Fusion Simplifiee Entre La Sa Anchan France Et Sarl Mondial Travel :Societe Absorbante :Auchan France,Societe Anonyme,200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650),56.882.160 Euros,410 409 460 Rcs Lille Metropole.Societe Absorbee : Mondial Travel,Societe E Responsabilite Limitee,200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650),Variable (Montant Actuel 100.572,89 Euros),400 669 768 Rcs Lille Metropole.Evaluation De L'actif Et Du Passif Dont La Transmission E La Societe Absorbante Est Prevue :Actif :7.290.842 Euros,Passif : 8.793.000 Euros,Mali De Fusion : 4.502.158 Euros,Rapport D'echange Des Droits Sociaux : Auchan France Possedant La Totalite Du Capital Social De La Sarl Mondial Travel, Il N'a Pas Ete Etabli De Rapport D'echange Et Il N'en Resultera Aucune Augmentation De Capital Pour La Ste Absorbante.Date Du Projet Commun De Fusion : 28/04/2014.Date Et Lieu Du Depet Du Projet Commun De Fusion Au Rcs Au Titre De Chaque Societe Participante :Pour L'absorbante : 28/04/2014 Rcs Lille Metropole,Pour L'absorbee : 28/04/2014 Rcs Lille Metropole. Commentaires : Autre Achat, Apport, Attribution.

27/04/2014

Bodacc B

Modification Et Mutation Diverse

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Metropole

1760 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Administration : Modification De L'administrateur Cavrois, Thierry. Capital : 56882160 Eur. Activite : 
Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Commentaires : Modification Survenue Sur L'administration.

27/04/2014

Bodacc B

Modification Et Mutation Diverse

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Metropole

1761 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Enseigne : Auchan France. Administration : Nomination De L'administrateur : Cavrois, Thierry, Commissaire Aux Comptes Titulaire Partant : Societe Roubaisienne D'expertise Comptable, Modification Du Commissaire Aux Comptes Titulaire Kpmg S.A., Modification Du Commissaire Aux Comptes Suppleant Toulemonde, Cedric. Capital : 56882160 Eur. Activite : Hypermarche - Courtage En Assurance Vente De Scooter Et Produits Motorises (Quad, Buggy, Etc.) Commissionnaire De Transport. La Vente Et Le Depã´T-Vente De Toute Activite De Billeterie. Formation. L'achat, La Vente, L'installation Et La Reparation Des Equipements De Genie Climatique, Chauffage, Energies Renouvelables Et Appareils à Economie D'energie, La Location De Tous Biens D'equipements. Adresse De L’Etablissement Principal : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Commentaires : Modification Survenue Sur L'activite De L'etablissement Principal Et L'administration.

24/04/2014

Bodacc A

Vente Et Cession : Vendeur

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Metropole

497 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Capital : 56882160 Eur. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Precedent Proprietaire : Auchan France. 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Precedent Proprietaire : Bdl. 428 307 870 Rcs Lille Metropole. 
Date De Commencement De L’Activite : 15/04/2014. Oppositions : Article L.236-14 Du Code De Commerce. Descriptif : Avis Au Bodacc Relatif Au Projet De Fusion Simplifiee Entre La Sa Auchan France Et La Sci Bdl. Societe Absorbante : Auchan France Forme : Societe Anonyme Adresse Du Siege : 200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650) Montant Du Capital : 56.882.160 Euros Ne Unique D'identification : 410 409 460 Lieu D'immatriculation : Lille Metropole. Societe Absorbee : Bdl Forme : Societe Civile Immobiliere Adresse Du Siege : Rue Du Marechal De Lattre De Tassigny 59170 Croix Montant Du Capital : 30.489,80 Euros Ne Unique D'identification: 428 307 870 Lieu D'immatriculation : Lille Metropole. Evaluation De L'actif Et Du Passif Dont La Transmission E La Societe Absorbante Est Prevue : Actif : 19.505 Euros Passif : 0 Euros Boni De Fusion : 21 Euros Rapport D'echange Des Droits Sociaux : Auchan France Possedant La Totalite Du Capital Social De La Sci Bdl, Il N'a Pas Ete Etabli De Rapport D'echange Et Il N'en Resultera Aucune Augmentation De Capital Pour La Ste Absorbante. Date Du Projet Commun De Fusion : 15/04/2014. Date Et Lieu Du Depet Du Projet Commun De Fusion Au Rcs Au Titre De Chaque Societe Participante : Pour L'absorbante : 15/04/2014 Rcs Lille Metropole Pour L'absorbee : 15/04/2014 Rcs Lille Metropole. Commentaires : Autre Achat, Apport, Attribution.

24/04/2014

Bodacc A

Vente Et Cession : Vendeur

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Metropole

502 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Capital : 56882160 Eur. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Precedent Proprietaire : Auchan Telecom. 480 067 719 Rcs Lille Metropole. Precedent Proprietaire : Auchan France. 410 409 460 Rcs Lille Metropole. 
Date De Commencement De L’Activite : 01/01/0001. Oppositions : Article L.236-14 Du Code De Commerce. Descriptif : Avis Au Bodacc Relatif Au Projet De Fusion Simplifiee Entre Sa Auchan France Et Sas Auchan Telecomsociete Absorbante : Auchan France Forme : Societe Anonyme Adresse Du Siege : 200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650) Montant Du Capital : 56.882.160 Euros Ne Unique D'identification: 410 409 460 Lieu D'immatriculation : Lille Metropole. Societe Absorbee : Auchan Telecom Forme : Societe Par Actions Simplifiee Adresse Du Siege : 200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650) Montant Du Capital : Variable (Minimum : 5.000.000 Euros) Ne Unique D'identification: 480 067 719 Lieu D'immatriculation : Lille Metropole. Evaluation De L'actif Et Du Passif Dont La Transmission E La Societe Absorbante Est Prevue : Actif : 13.945.716 Euros Passif : 10.877.385 Euros Mali De Fusion : 381.669 Euros Rapport D'echange Des Droits Sociaux : Auchan France Possedant La Totalite Du Capital Social De La Sas Auchan Telecom, Il N'a Pas Ete Etabli De Rapport D'echange Et Il N'en Resultera Aucune Augmentation De Capital Pour La Ste Absorbante. Date Du Projet Commun De Fusion : 15/04/2014 Date Et Lieu Du Depet Du Projet Commun De Fusion Au Rcs Au Titre De Chaque Societe Participante : Pour L'absorbante : 15/04/2014 Rcs Lille Metropole Pour L'absorbee : 15/04/2014 Rcs Lille Metropole. Commentaires : Autre Achat, Apport, Attribution.

24/04/2014

Bodacc A

Vente Et Cession : Vendeur

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Metropole

501 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Capital : 56882160 Eur. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Precedent Proprietaire : Auchan France. 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Precedent Proprietaire : Auchan Telecom. 480 067 719 Rcs Lille Metropole. 
Date De Commencement De L’Activite : 01/01/0001. Oppositions : Article L.236-14 Du Code De Commerce. Descriptif : Avis Au Bodacc Relatif Au Projet De Fusion Simplifiee Entre Sa Auchan France Et Sas Auchan Telecomsociete Absorbante : Auchan France Forme : Societe Anonyme Adresse Du Siege : 200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650) Montant Du Capital : 56.882.160 Euros Ne Unique D'identification: 410 409 460 Lieu D'immatriculation : Lille Metropole. Societe Absorbee : Auchan Telecom Forme : Societe Par Actions Simplifiee Adresse Du Siege : 200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650) Montant Du Capital : Variable (Minimum : 5.000.000 Euros) Ne Unique D'identification: 480 067 719 Lieu D'immatriculation : Lille Metropole. Evaluation De L'actif Et Du Passif Dont La Transmission E La Societe Absorbante Est Prevue : Actif : 13.945.716 Euros Passif : 10.877.385 Euros Mali De Fusion : 381.669 Euros Rapport D'echange Des Droits Sociaux : Auchan France Possedant La Totalite Du Capital Social De La Sas Auchan Telecom, Il N'a Pas Ete Etabli De Rapport D'echange Et Il N'en Resultera Aucune Augmentation De Capital Pour La Ste Absorbante. Date Du Projet Commun De Fusion : 15/04/2014 Date Et Lieu Du Depet Du Projet Commun De Fusion Au Rcs Au Titre De Chaque Societe Participante : Pour L'absorbante : 15/04/2014 Rcs Lille Metropole Pour L'absorbee : 15/04/2014 Rcs Lille Metropole. Commentaires : Autre Achat, Apport, Attribution.

24/04/2014

Bodacc A

Vente Et Cession : Vendeur

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Metropole

498 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Capital : 56882160 Eur. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Precedent Proprietaire : Bdl. 428 307 870 Rcs Lille Metropole. Precedent Proprietaire : Auchan France. 410 409 460 Rcs Lille Metropole. 
Date De Commencement De L’Activite : 15/04/2014. Oppositions : Article L.236-14 Du Code De Commerce. Descriptif : Avis Au Bodacc Relatif Au Projet De Fusion Simplifiee Entre La Sa Auchan France Et La Sci Bdl. Societe Absorbante : Auchan France Forme : Societe Anonymeadresse Du Siege : 200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650) Montant Du Capital : 56.882.160 Euros Ne Unique D'identification: 410 409 460 Lieu D'immatriculation : Lille Metropole. Societe Absorbee : Bdl Forme : Societe Civile Immobiliere Adresse Du Siege : Rue Du Marechal De Lattre De Tassigny 59170 Croix Montant Du Capital : 30.489,80 Euros Ne Unique D'identification: 428 307 870 Lieu D'immatriculation : Lille Metropole. Evaluation De L'actif Et Du Passif Dont La Transmission E La Societe Absorbante Est Prevue : Actif : 19.505 Euros Passif : 0 Euros Boni De Fusion : 21 Euros Rapport D'echange Des Droits Sociaux : Auchan France Possedant La Totalite Du Capital Social De La Sci Bdl, Il N'a Pas Ete Etabli De Rapport D'echange Et Il N'en Resultera Aucune Augmentation De Capital Pour La Ste Absorbante. Date Du Projet Commun De Fusion : 15/04/2014. Date Et Lieu Du Depet Du Projet Commun De Fusion Au Rcs Au Titre De Chaque Societe Participante : Pour L'absorbante : 15/04/2014 Rcs Lille Metropole Pour L'absorbee : 15/04/2014 Rcs Lille Metropole. Commentaires : Autre Achat, Apport, Attribution.

13/04/2014

Bodacc A

Vente Et Cession : Vendeur

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Metropole

403 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Capital : 56882160 Eur. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Precedent Proprietaire : Auchan France. 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Precedent Proprietaire : Ste Jardi Bearn. 327 113 387 Rcs Lille Metropole. 
Date De Commencement De L’Activite : 20/03/2014. Oppositions : Article L.236-14 Du Code De Commerce. Descriptif : Avis Au Bodacc Relatif Au Projet De Fusion Simplifiee Entre La Sa Auchan France Et La Sarl Jardi Bearn :Societe Absorbante :Auchan France,Societe Anonyme,200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650),56.882.160 Euros,Rcs 410 409 460 Lille Metropole,Societe Absorbee :Ste Jardi-Bearn,Sarl,200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650),7.622,45euros,Rcs 327 113 387 Lille Metropole,Evaluation De L'actif Et Du Passif Dont La Transmission E La Societe Absorbante Est Prevue :Actif :20.619 Euros,Passif : 38.180 Euros,Mali De Fusion : 907.561 Euros,Rapport D'echange Des Droits Sociaux : Auchan France Possedant La Totalite Du Capital Social De La Ste Jardi-Bearn, Il N'a Pas Ete Etabli De Rapport D'echange Et Il N'en Resultera Aucune Augmentation De Capital Pour La Ste Absorbante.Date Du Projet Commun De Fusion : 20/03/2014.Date Et Lieu Du Depet Du Projet Commun De Fusion Au Rcs Au Titre De Chaque Societe Participante :Pour L'absorbante : 04/04/2014 Rcs Lille Metropole,Pour L'absorbee : 04/04/2014 Rcs Lille Metropole. Commentaires : Autre Achat, Apport, Attribution.

13/04/2014

Bodacc A

Vente Et Cession : Vendeur

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Metropole

404 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Capital : 56882160 Eur. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Precedent Proprietaire : Ste Jardi Bearn. 327 113 387 Rcs Lille Metropole. Precedent Proprietaire : Auchan France. 410 409 460 Rcs Lille Metropole. 
Date De Commencement De L’Activite : 20/03/2014. Oppositions : Article L.236-14 Du Code De Commerce. Descriptif : Avis Au Bodacc Relatif Au Projet De Fusion Simplifiee Entre La Sa Auchan France Et La Sarl Jardi Bearn :Societe Absorbante :Auchan France,Societe Anonyme,200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650),56.882.160 Euros,Rcs 410 409 460 Lille Metropole,Societe Absorbee :Ste Jardi-Bearn,Sarl,200 Rue De La Recherche E Villeneuve D'ascq (59650),7.622,45euros,Rcs 327 113 387 Lille Metropole,Evaluation De L'actif Et Du Passif Dont La Transmission E La Societe Absorbante Est Prevue :Actif :20.619 Euros,Passif : 38.180 Euros,Mali De Fusion : 907.561 Euros,Rapport D'echange Des Droits Sociaux : Auchan France Possedant La Totalite Du Capital Social De La Ste Jardi-Bearn, Il N'a Pas Ete Etabli De Rapport D'echange Et Il N'en Resultera Aucune Augmentation De Capital Pour La Ste Absorbante.Date Du Projet Commun De Fusion : 20/03/2014.Date Et Lieu Du Depet Du Projet Commun De Fusion Au Rcs Au Titre De Chaque Societe Participante :Pour L'absorbante : 04/04/2014 Rcs Lille Metropole,Pour L'absorbee : 04/04/2014 Rcs Lille Metropole. Commentaires : Autre Achat, Apport, Attribution.

11/04/2014

JAL

Resignation / Revocation Of The Social Representative

 

 

Syndicat Agricole (Le)


Date De Decision : 29/04/2013
La Societe 410409460 - AUCHAN FRANCE, AUCHAN DRIVE, 200 RUE DE LA RECHERCHE, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
Fait L'objet Du Depart De Monsieur Thierry CAVROIS, 
De ACEA/MAZARS, 
De Monsieur Cedric TOULEMONDE

11/04/2014

JAL

Appointment Of The Social Representative

 

 

Syndicat Agricole (Le)


Date De Decision : 12/11/2013
Societe Faisant L'objet D'une Nomination : 410409460 - AUCHAN FRANCE, AUCHAN DRIVE, 200 RUE DE LA RECHERCHE, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
Nomine : Monsieur Thierry CAVROIS, 59420 MOUVAUX
En La Fonction De : Administrateur

09/03/2014

Bodacc A

Vente Et Cession : Acheteur

 

 

62 - Pas-De-Calais

Greffe Du Tribunal De Commerce De Boulogne-Sur-Mer

520 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D'ascq. 
Origine Du Fonds : Acquis Par Achat Au Prix Stipule De 191964,12 Euros. Etablissement : Etablissement Complementaire. Activite : Vente à Distance Sur Catalogue En General.Adresse : Rue Marcel Doret, 62100 Calais. 
Precedent Proprietaire : Chronodrive. 433 513 892 Rcs Lille Metropole. 
Date De Commencement De L’Activite : 01/01/2014. Publication Legale : Le Syndicat Agricole Du 31/01/2014. Oppositions : Au Siã¨Ge Du Fonds Cede. Descriptif : .Commentaires : Autre Achat, Apport, Attribution.

28/02/2014

Bodacc A

Vente Et Cession : Acheteur

 

 

77 - Seine-Et-Marne

Greffe Du Tribunal De Commerce De Meaux

464 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Origine Du Fonds : Achat Au Prix Stipule De 217612,00 Euros. Etablissement : Etablissement Complementaire. Enseigne : Auchan Drive. Adresse : Rond Point Du 6 Juin 1944, 77270 Villeparisis. 
Precedent Proprietaire : Adrive. 523 412 781 Rcs Meaux. 
A Dater Du : 22/04/1998. Date De Commencement De L’Activite : 01/01/0001. Publication Legale : Horizon Centre Ile De France Du 21/02/2014. Oppositions : Au Fonds Cede Rond Point Du 6 Juin 1944 77270 Villeparisis Pour La Validite, Au Cessionnaire 200 Rue De La Recherche 59650 Villeneuve-D'ascq Pour La Correspondance . Descriptif : .Commentaires : Achat D'un Etablissement Secondaire Ou Complementaire Par Une Personne Morale.

28/02/2014

Bodacc A

Vente Et Cession : Acheteur

 

 

44 - Loire-Atlantique

Greffe Du Tribunal De Commerce De Nantes

265 - 410 409 460 Rcs Lille Metropole. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Origine Du Fonds : Achat Au Prix Stipule De 286359,47 Euros. Etablissement : Etablissement Complementaire. Activite : Vente A Distance Sur Catalogue General. Enseigne :Auchan Drive. Adresse : 8 Rue De L'atlantique, 44115 Basse Goulaine. 
Precedent Proprietaire : Chronodrive. 433 513 892 Rcs Nantes. 
A Dater Du : 07/04/1998. Date De Commencement De L’Activite : 01/01/2014. Publication Legale : La Loire Atlantique Agricole Du 07/02/2014. Oppositions : Au Fonds Cede 8 Rue De L'atlantique 44115 Basse Goulaine Pour La Validite. Descriptif : Commentaires : Achat D'un Etablissement Secondaire Ou Complementaire Par Une Personne Morale.

21/02/2014

JAL

Activity Or Goodwill Cession: Buyer

 

 

Horizons/Edition De Seine Et Marne


Date De Decision : 19/12/2013 
Cedant : 523412781 - ADRIVE, AUCHAN DRIVE, RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 59170 CROIX
Cessionnaire : 410409460 - AUCHAN FRANCE, 200 RUE DE LA RECHERCHE, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Prix De Vente : 217612 ‚¬
Date D’Effet : 01/01/2014 

31/01/2014

JAL

Activity Or Goodwill Cession: Buyer

 

 

Syndicat Agricole (Le)


Date De Decision : 24/12/2013 
Cedant : 433513892 - CHRONODRIVE, CHRONODRIVE, RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 59170 CROIX
Cessionnaire : 410409460 - AUCHAN FRANCE, 200 RUE DE LA RECHERCHE, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Prix De Vente : 191964 ‚¬
Date D’Effet : 01/01/2014 

03/09/2013

Bodacc C

Comptes Annuels Et Rapports

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille Mã‰Tropole

4796 - 410409460 Rcs. Auchan FranceForme : Societe Anonyme. Adresse : 200 Rue De La Recherche 59650 Villeneuve-D Ascq. Commentaires : Comptes Annuels Et Rapports De L'exercice Clos Le : 31/12/2012.

31/10/2012

Bodacc B

Modification Et Mutation Diverse

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille

1926 - 410 409 460 Rcs Lille. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Enseigne : Auchan France. Capital : 56882160 Eur. Activite : Hypermarche - Courtage En Assurance Vente De Scooter Et Produits Motorises (Quad, Buggy, Etc.) Commissionnaire De Transport. La Vente Et Le Depã´T-Vente De Toute Activite De Billeterie. Formation.Adresse De L’Etablissement Principal : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Commentaires : Modification Survenue Sur L'activite De L'etablissement Principal.

24/10/2012

Bodacc C

Comptes Annuels Et Rapports

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille

5411 - 410409460 Rcs. Auchan FranceForme : Societe Anonyme. Adresse : 200 Rue De La Recherche 59650 Villeneuve-D Ascq. Commentaires : Comptes Annuels Et Rapports De L'exercice Clos Le : 31/12/2011.

29/08/2012

Bodacc A

Vente Et Cession : Acheteur

 

 

60 - Oise

Greffe Du Tribunal De Commerce De Compiãˆgne

391 - 410 409 460 Rcs Compiegne. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve D'ascq. 
Origine Du Fonds : Achat D'un Fonds De Commerce Au Prix Stipule De 500000 Euros. Etablissement : Etablissement Principal. Activite : Un Fonds De Commerce D'exploitation De Magasins De Detail De Type Supermarches. Adresse : Rue Claire Lacombe, Zac Du Bois Des Fenãªtres, 60740 Saint-Maximin. 
Precedent Proprietaire : Supermarches Lcc. 393 370 820 Rcs Soissons. 
Date De Commencement De L’Activite : 01/09/2012. Publication Legale : Le Courrier Picard Du 23/08/2012. Oppositions : Au Fonds Vendu Pour La Correspondance : Au Cabinet Altana (Maã®Tre Soret) Sis 45 Rue De Tocqueville 75017 Paris Et à L'ordre Des Avocats à Paris Pour La Validite Et Pour La Correspondance Ordre Des Avocats 11 Place Dauphine 75053 Paris Rp Sp. Descriptif : Commentaires : Achat D'un Fonds Par Une Personne Morale (Insertion Provisoire).

14/08/2012

JAL

Activity Or Goodwill Cession

 

 

Picardie La Gazette


Date De Decision : 01/08/2012 
Cedant : 393370820 - Supermarches Lcc, Leader Price, 3 Av Ernest Couvrecelle, 02400 Etampes Sur Marne
Cessionnaire : 410409460 - Auchan France, 200 Rue De La Recherche, 59491 Villeneuve D'ascq
Prix De Vente : 500000 ‚¬
Date D’Effet : 01/09/2012 

27/05/2012

Bodacc A

Vente Et Cession : Acheteur

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille

466 - 410 409 460 Rcs Lille. Auchan France. Forme : Societe Anonyme à Conseil D'administration. Capital : 56882160 Eur. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Precedent Proprietaire : Auchan Carburant. 379 548 001 Rcs Lille. 
Date De Commencement De L’Activite : 01/01/0001. Oppositions : Article L.236-14 Du Code De Commerce. Descriptif : Avis Relatif Au Projet Commun D'apport Partiel D'actif Sous Le Regime Des Scissions Par Auchan France Societe Anonyme Au Capital De 56882160.00 Euros Adresse De Son Siege Oe Peut Etre Consulte Le Projet D'apport : 200 Rue De La Recherche 59650 Villeneuve D'ascq - Rcs Lille 410 409 460 Societe Apporteuse Au Profit De Auchan Carburant Sas Au Capital Variable (Minimum 10000000.00 Euros) Libere Pour Un Montant De 46247620.00 Euros) Adresse Du Siege Social Ou Peut Etre Consulte Le Projet D'apport : Rue Du Marechal De Lattre De Tassigny 59170 Croix - Rcs Roubaix Tourcoing 379 548 001 - Apport De La Branche Complete Et Autonome D'activite Constituee D'une Station-Service Et De Ses Accessoires (Ensemble Des Elements Incorporels Constitutifs De Ce Fonds, Clientele, Achalandage, Archives Techniques Et Commerciales, Savoir-Faire Et Informations Relatives E Sa Mise En Oeuvre, Benefice Et Charge De Tous Traites, Conventions Et Engagements Conclu, Contrats Avec Tiers, Clients Fournisseurs, Membres Du Personnel, Droit Au Bail...) L'evaluation De L'actif Et Du Passif De Chaque Societe Participante Dont La Transmission E La Societe Nouvelle Ou Absorbante Est Prevue : Valeur De L'actif Apporte E La Beneficiaire : 569741.45 Euros Valeur Du Passif Pris En Charge En Contrepartie Par Le Beneficiaire : 139741.46 Euros, Soit Montant De L'apport Net De La Branche D'activite : 430000.00 Euros. En Renumeration De Cet Apport, La Societe Auchan France Recevra 10 762 Actions Nouvelles De 20 Euros Chacune (Valeur Nominale), Entierement Liberees, Creees E Titre D'augmentation De Son Capital Par La Societe Auchan Carburant. Lesdites Actions Seront Entierement Assimilees Aux Actions Anciennes Et Porteront Jouissance Retroactivement E Compter Du 01/01/2012, Date D'ouverture De L'exercice En Cours. Prime D'apport : Egale E La Difference Entre La Valeur Nette Des Biens Et Droits Apportes (430.000.00 Euros) Et La Valeur Nominale Des Parts Qui Seront Creees Par Auchan Carburant Au Titre De L'augmentation De Son Capital (215240.00 Euros), Soit 214760.00 Euros, Qui Sera Inscrite Au Passif De La Societe Auchan France. Date Du Projet Commun De Fusion Ou De Scission : 15/05/2012. Date Et Lieu Du Depet Au Rcs Au Titre De Chaque Societe Participante 16/05/2012 Rcs Roubaix Tourcoing Pour Auchan Carburant 16/05/2012 Rcs Lille Pour Auchan France. Commentaires : Autre Achat, Apport, Attribution.

25/05/2012

Bodacc A

Vente Et Cession : Vendeur

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Roubaix-Tourcoing

1018 - 379 548 001 Rcs Roubaix / Tourcoing. Auchan Carburant. Forme : S.A.S. Unipersonnelle. Capital : 0 Eur. Adresse : Rue Du Marechal De Lattre De Tassigny, 59170 Croix. 
Precedent Proprietaire : Auchan France. 410 409 460 Rcs Roubaix / Tourcoing. 
Date De Commencement De L’Activite : 15/05/2012. Oppositions : Article L.236-14 Du Code De Commerce. Descriptif : Avis Du Projet Commun D'apport Partiel D'actif Par La Sa Auchan France, 200 Rue De La Recherche 59650 Villeneuve D'ascq Au Capital De 56.882.160 Euros (Rcs Lille 410.409.460) Au Profit De La Sas Auchan Carburant, Rue Du Marechal De Lattre De Tassigny 59170 Croix Au Capital Variable Au Minimun De 10.000.000 Euros (Rcs Roubaix-Tourcoing 379.548.001). Apport De La Branche Complã¨Te Et Autonome D'activite Constituee D'une Station-Service Et De Ses Accessoires (Ensemble Des Elements Incorporels Constitutifs De Ce Fonds, Clientã¨Le, Achalandage, Archives Techniques Et Commerciales, Savoir Faire Et Informations Relatives à Sa Mise En Oeuvre, Benefice Et Charge De Tous Traites, Conventions Et Engagements Conclu, Contrats Avec Tiers, Clients Fournisseurs, Membres Du Personnel, Droit Au Bail...). L'evaluation De L'actif Et Du Passif De Chaque Societe Participante Dont La Transmission à La Societe Nouvelle Ou Absorbante Est Prevue : Valeur De L'actif Apporte à La Beneficiaire : 569.741,45 Euros ; Valeur Du Passif Pris En Charge En Contrepartie Par La Beneficiaire : 139.741,46 Euros ; Soit Montant De L'apport Net De La Branche D'activite : 430.000 Euros. En Remuneration De Cet Apport, La Societe Auchan France Recevra 10.762 Actions Nouvelles De 20 Euros Chacune (Valeur Nominale), Entiã¨Rement Liberees, Creees à Titre D'augmentation De Son Capital Par La Societe Auchan Carburant. Lesdites Actions Seront Entiã¨Rement Assimilees Aux Actions Anciennes Et Porteront Jouissance Retroactivement à Compter Du 01/01/2012, Date D'ouverture De L'exercice En Cours. Prime D'aport : Egale à La Difference Entre La Valeur Nette Des Biens Et Droits Apportes (430.000 Euros) Et La Valeur Nominale Des Parts Qui Seront Creees Par Auchan Carburant Au Titre De L'augmentation De Son Capital (215.240 Euros), Soit 214.760 Euros, Qui Sera Inscrite Au Passif De La Societe Auchan France. Date Du Projet Commun De Fusion Ou De Scission : 15/05/2012. Date Et Lieu De Depã´T Au Rcs Au Titre De Chaque Societe Participante : 16/05/2012 Rcs Roubaix Tourcoing Pour Auchan Carburant ; 16/05/2012 Rcs Lille Pour Auchan France. Commentaires : Autre Achat, Apport, Attribution.

10/05/2012

Bodacc A

Vente Et Cession : Acheteur

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille

1032 - 410 409 460 Rcs Lille. Auchan France. Forme : Societe Anonyme à Conseil D'administration. Capital : 56882160 Eur. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Precedent Proprietaire : Tomblaine Distribution. 332 640 770 Rcs Lille. 
Date De Commencement De L’Activite : 01/01/0001. Oppositions : Article L.236-14 Du Code De Commerce. Descriptif : Avis Relatif Au Projet Commun De Fusion Par Voie D'absorption De La Sa Tomblaine Distribution Au Capital De 1 000 000 Euros Siege Social 200 Rue De La Recherche 59650 Villeneuve D'ascq - 332 640 770 Rcs Lille (Societe Absorbee). L'evaluation De L'actif Et Du Passif De Chaque Societe Participante Dont La Transmission E La Societe Nouvelle Ou Absorbante Est Prevue : Actif De La Societe Absorbee : 14 161 559 Euros Passif De La Societe Absorbee : 5 255 119 Euros. Le Raport D'echange Des Droits Sociaux Dans Chaque Societe Participante : Il N'y A Pas De Rapport D'echange Car La Societe Absorbee Est Une Filiale E 100% De La Societe Absorbante.Le Montant Prevu De La Prime De Fusion Ou De Scission Pour Chaque Societe Participante : Neant. La Date Du Projet Commun De Fusion Ou De Scission : 25.04.2012. Les Date Et Lieu Du Depet Au Rcs Au Titre De Chaque Societe Participante : 27 Avril 2012 0 Lille Pour La Societe Auchan France Ainsi Que Pour La Societe Tomblaine Distribution. Commentaires : Autre Achat, Apport, Attribution.

10/05/2012

Bodacc A

Vente Et Cession : Vendeur

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille

1033 - 332 640 770 Rcs Lille. Tomblaine Distribution. Forme : Societe Anonyme à Conseil D'administration. Capital : 1000000 Eur. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D Ascq. 
Precedent Proprietaire : Auchan France. 410 409 460 Rcs Lille. 
Date De Commencement De L’Activite : 01/01/0001. Oppositions : Article L.236-14 Du Code De Commerce. Descriptif : Avis Relatif Au Projet Commun De Fusion Par Voie D'absorption Par La Sa Auchan France Au Capital De 56 882 160 Euros Siã¨Ge Social 200 Rue De La Recherche 59650 Villeneuve D'ascq 410 409 4060 Rcs Lille (Societe Absorbante). L'evaluation De L'actif Et Du Passif De Chaque Societe Participante Dont La Transmission à La Societe Nouvelle Ou Absorbante Est Prevue : Actif De La Societe Absorbee : 14 161 559 Euros Passif De La Societe Absorbee : 5 255 119 Euros. Le Rapport D'echange Des Droits Sociaux Dans Chaque Societe Participante : Neant. La Date Du Projet Commun De Fusion Ou De Scision : 25.04.2012. Les Date Et Lieu Du Depã´T Au Titre De Chaque Societe Participante : 27 Avril 2012 à Lille Pour La Societe Auchan France Ainsi Que La Societe Tomblaine Distribution. Commentaires : Autre Achat, Apport, Attribution.

15/10/2011

Bodacc C

Comptes Annuels Et Rapports

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille

1075 - 410409460 Rcs. Auchan FranceForme : Societe Anonyme à Conseil D'administration. Adresse : 200 Rue De La Recherche 59650 Villeneuve-D'ascq. Commentaires :Comptes Annuels Et Rapports De L'exercice Clos Le : 31/12/2010.

16/09/2011

JAL

Appointment Of The Social Representative

 

 

Syndicat Agricole (Le)


Societe Faisant L'objet D'une Nomination : 481977460 - SOMARVRAC, PRIXBAS PAR AUCHAN, RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 59170 CROIX 
Nomine : 
En La Fonction De : President
Nomine : Monsieur Frederic MIOCHE, 75019 PARIS 19
En La Fonction De : Directeur General
Date D'effet : 01/04/2011

13/09/2011

Bodacc B

Modification Et Mutation Diverse

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille

345 - 410 409 460 Rcs Lille. Auchan France. Forme : Societe Anonyme à Conseil D'administration. Enseigne : Auchan France. Administration : President Du Conseil D'administration : Mulliez Arnaud Directeur General : Mignot Vincent Administrateur : Jolivet Yvon Administrateur : Mulliez Arnaud Administrateur : Baroukh Philippe Administrateur : Mathias Henri Administrateur : Leclercq Bertrand Administrateur : Cavrois Thierry Commissaire Aux Comptes Titulaire : Societe Roubaisienne D'expertise Comptab Commissaire Aux Comptes Titulaire : Fiduciaire De France Dpt Kpmg Audit Commissaire Aux Comptes Suppleant : Toulemonde Cedric Commissaire Aux Comptes Suppleant : Delaroque Alphonse. Capital : 56882160 Eur. Activite : Hypermarche - Courtage En Assurance Vente De Scooter Et Produits Motorises (Quad, Buggy, Etc.) Commissionnaire De Transport. La Vente Et Le Depã´T-Vente De Toute Activite De Billeterie. Adresse De L’Etablissement Principal : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D'ascq. 
Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D'ascq. 
Commentaires : Nomination D'un Administrateur. Date De Commencement De L’Activite : 01/12/1997. Date D’Effet : 01/07/2011.

01/07/2011

JAL

Appointment Of The Social Representative

 

 

Syndicat Agricole (Le)


Societe Faisant L'objet D'une Nomination : 481977767 - SODIVRAC, RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 59170 CROIX 
Nomine : 
En La Fonction De : President
Nomine : Monsieur Guy VERDIER, 41 Rue Saint Exupery, 94320 THIAIS
En La Fonction De : Directeur General
Date D'effet : 16/05/2011

28/06/2011

Bodacc A

Vente Et Cession : Acheteur

 

 

60 - Oise

Greffe Du Tribunal De Commerce De Compiãˆgne

642 - 410 409 460 Rcs Compiegne. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve D'ascq. 
Origine Du Fonds : Achat D'un Fonds De Commerce Au Prix Stipule De 250000 Euros. Etablissement : Etablissement Complementaire. Activite : Vente Au Detail De Chaussures.Adresse : 101 Avenue De L'europe, 60180 Nogent-Sur-Oise. 
Precedent Proprietaire : Dagbert (Jocelyne). 342 103 074 Rcs Beauvais. Precedent Proprietaire : Lucas (Patrick). Rcs Non Inscrit. 
Date De Commencement De L’Activite : 12/05/2011. Publication Legale : L'oise Hebdo Du 15/06/2011. Oppositions : En L'etude De Maã®Tre Jacques Hutin 4 Avenue De L'europe 60100 Creil Pour La Validite Et Pour La Correspondance. Descriptif : Commentaires : Achat D'un Fonds Par Une Personne Morale (Insertion Provisoire).

28/06/2011

Bodacc A

Vente Et Cession : Acheteur

 

 

60 - Oise

Greffe Du Tribunal De Commerce De Compiãˆgne

643 - 410 409 460 Rcs Compiegne. Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve D'ascq. 
Origine Du Fonds : Achat D'un Fonds De Commerce Au Prix Stipule De 220000 Euros. Etablissement : Etablissement Complementaire. Activite : Laverie, Blanchisserie, Teinturerie De Detail. Adresse : 101 Avenue De L'europe, 60180 Nogent-Sur-Oise. 
Precedent Proprietaire : Chatelain (Denis). 333 793 602 Rcs Compiegne. Precedent Proprietaire : Varlet (Nelly). Rcs Non Inscrit. 
Date De Commencement De L’Activite : 12/05/2011. Publication Legale : L'oise Hebdo Du 15/06/2011. Oppositions : En L'etude De Maã®Tre Jacques Hutin 4 Avenue De L'europe 60100 Creil Pour La Validite Et Pour La Correspondance. Descriptif : Commentaires : Achat D'un Fonds Par Une Personne Morale (Insertion Provisoire).

15/06/2011

JAL

Activity Or Goodwill Cession

 

 

Oise Hebdo (L')


Date De Decision : 12/05/2011 
Cedant : 333793602 - MONSIEUR DENIS CHATELAIN, 11 RUE DE LA REPUBLIQUE, 60600 CLERMONT
Cessionnaire : 410409460 - AUCHAN FRANCE, 200 RUE DE LA RECHERCHE, 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
Prix De Vente : 220000 ‚¬
Date D’Effet : 12/05/2011 

15/06/2011

JAL

Activity Or Goodwill Cession

 

 

Oise Hebdo (L')


Date De Decision : 12/05/2011 
Cedant : 342103074 - MADAME JOCELYNE LUCAS, J. LUCAS CHAUSSEUR MAROQUINIER, 1 PL DE VERDUN, 60120 BRETEUIL
Cessionnaire : 410409460 - AUCHAN FRANCE, 200 RUE DE LA RECHERCHE, 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
Prix De Vente : 250000 ‚¬
Date D’Effet : 12/05/2011 

02/02/2011

Bodacc A

Vente Et Cession : Vendeur

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille

907 - 413 176 033 Rcs Lille. Auchandirect. Forme : Societe Par Actions Simplifiee. Adresse : Rue Du Marechal De Lattre De, Tassigny, 59170 Croix. 
Origine Du Fonds : Fonds Acquis Par Achat Au Prix Stipule De 2.300.000,00 Eur. Etablissement : Etablissement Second. (I.P.). Activite : Fonds De Commerce De "Auchan.Fr".Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D'ascq. 
Precedent Proprietaire : Auchan France. 410 409 460 Rcs Lille. 
A Dater Du : 27/06/2008. Date De Commencement De L’Activite : 18/06/2008. Publication Legale : Le Syndicat Agricole Du 07/01/2011. Oppositions : Au Siã¨Ge Du Cedant 200 Rue De La Recherche 59650 Villeneuve D'ascq. Commentaires : Achat D'un Fonds Par Une Personne Morale (Insertion Provisoire). Date D’Effet : 01/01/2011.

07/01/2011

JAL

Activity Or Goodwill Cession

 

 

Syndicat Agricole (Le)


Date De Decision : 24/12/2010 
Cedant : 410409460 - AUCHAN FRANCE, 200 RUE DE LA RECHERCHE, 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
Cessionnaire : 413176033 - AUCHANDIRECT, RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 59170 CROIX
Prix De Vente : 2300000 ‚¬
Date D’Effet : 01/01/2011 

24/12/2010

JAL

Appointment Of The Social Representative

 

 

Syndicat Agricole (Le)


Societe Faisant L'objet D'une Nomination : 410410260 - EURAUCHAN, 200 RUE DE LA RECHERCHE, 59491 VILLENEUVE D'ASCQ 
Nomine : 
En La Fonction De : President
Nomine : Monsieur Jean-Denis DEWEINE, 99 Rue Royale, 59000 LILLE
En La Fonction De : Directeur General
Date D'effet : 19/04/2010

03/12/2010

JAL

Appointment Of The Social Representative

 

 

Syndicat Agricole (Le)


Societe Faisant L'objet D'une Nomination : 487702896 - SOCIETE DE DISTRIBUTION COMMUNALE, RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, DE TASSIGNY, 59170 CROIX 
Nomine : 
En La Fonction De : President
Nomine : Monsieur Jean-Luc HERVO, 6 Rue Claude Monet, 33185 LE HAILLAN
En La Fonction De : Directeur General
Date D'effet : 13/09/2010

03/12/2010

JAL

Appointment Of The Social Representative

 

 

Echo Regional (L')


Societe Faisant L'objet D'une Nomination : 407755230 - SARCELDIS, LECLERC, 8 PL DE NAVARRE, CTRE CIAL LES FLANADES 1, 95200 SARCELLES 
Nomine : 
En La Fonction De : President
Nomine : Monsieur Jean-Luc HERVO, 6 Rue Claude Monet, 33185 LE HAILLAN
En La Fonction De : Directeur General
Date D'effet : 13/09/2010

28/09/2010

Bodacc C

Comptes Annuels Et Rapports

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille

7859 - 410409460 Rcs. Auchan FranceForme : Societe Anonyme à Conseil D'administration. Adresse : 200 Rue De La Recherche 59650 Villeneuve-D'ascq. Commentaires :Comptes Annuels Et Rapports De L'exercice Clos Le : 31/12/2009.

04/08/2010

Bodacc B

Modification Et Mutation Diverse

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille

735 - 410 409 460 Rcs Lille. Auchan France. Forme : Societe Anonyme à Conseil D'administration. Enseigne : Auchan France. Administration : President Du Conseil D'administration : Mulliez Arnaud Directeur General : Mignot Vincent Administrateur : Mulliez Arnaud Administrateur : Baroukh Philippe Administrateur : Mathias Henri Administrateur : Leclercq Bertrand Administrateur : Cavrois Thierry Commissaire Aux Comptes Titulaire : Societe Roubaisienne D'expertise Comptab Commissaire Aux Comptes Titulaire : Fiduciaire De France Dpt Kpmg Audit Commissaire Aux Comptes Suppleant : Toulemonde Cedric Commissaire Aux Comptes Suppleant : Delaroque Alphonse.Capital : 56882160 Eur. Activite : Hypermarche - Courtage En Assurance Vente De Scooter Et Produits Motorises (Quad, Buggy, Etc.) Commissionnaire De Transport. La Vente Et Le Depã´T-Vente De Toute Activite De Billeterie. Adresse De L’Etablissement Principal : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D'ascq. 
Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D'ascq. 
Commentaires : Adjonction D'activite Changement De Directeur General. Date De Commencement De L’Activite : 01/12/1997. Date D’Effet : 16/07/2010.

30/07/2010

JAL

Resignation / Revocation Of The Social Representative

 

 

Le Syndicat Agricole


Date De Decision : 01/07/2010
La Societe 410409460 - Auchan France, 250 Av Du Huit Mai 1945, 86000 Poitiers 
Fait L'objet Du Depart De Monsieur Christophe Dubrulle 

30/07/2010

JAL

Resignation / Revocation Of The Social Representative

 

 

Le Syndicat Agricole


Date De Decision : 01/07/2010
La Societe 410409460 - Auchan France, 250 Av Du Huit Mai 1945, 86000 Poitiers 
Fait L'objet Du Depart De Monsieur Philippe Baroukh 

30/07/2010

JAL

Appointment Of The Social Representative

 

 

Le Syndicat Agricole


Societe Faisant L'objet D'une Nomination : 410409460 - Auchan France, 250 Av Du Huit Mai 1945, 86000 Poitiers 
Nomine : Monsieur Vincent Mignot, 17 Rue 17 Rue Des Freres Bonduel, 59223 Roncq
En La Fonction De : Dg - Directeur General

16/02/2010

Bodacc A

Vente Et Cession : Vendeur

 

 

68 - Haut-Rhin

Greffe Du Tribunal D'instance De Mulhouse

839 - 481 977 460 Rcs Roubaix. Somarvrac. Forme : Societe Par Actions Simplifiee. Adresse : Rue De Lattre De Tassigny, 59170 Croix. 
Origine Du Fonds : Etablissement Secondaire Acquis Par Achat Au Prix Stipule De 1 500 000 Euros. Etablissement : Etablissement Secondaire. Activite : Hypermarches. Adresse :170 Rue Des Romains, 68050 Mulhouse. 
Precedent Proprietaire : Auchan France. 410 409 460 Rcs Lille. 
Date De Commencement De L’Activite : 01/10/2009. Publication Legale : Petites Affiches Du Haut Rhin Du 18/10/2009. Oppositions : 170, Rue Des Romains - 68050 Mulhouse.Commentaires : Achat D'un Etablissement Secondaire Ou Complementaire Par Une Personne Morale.

23/12/2009

Bodacc B

Modification Et Mutation Diverse

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille

318 - 410 409 460 Rcs Lille. Auchan France. Forme : Societe Anonyme à Conseil D'administration. Enseigne : Auchan France. Administration : President Du Conseil D'administration : Mulliez Arnaud Directeur General Administrateur : Baroukh Philippe Administrateur : Dubrulle Christophe Administrateur : Mulliez Arnaud Administrateur : Mathias Henri Administrateur : Leclercq Bertrand Administrateur : Cavrois Thierry Commissaire Aux Comptes Titulaire : Societe Roubaisienne D'expertise Comptab Commissaire Aux Comptes Titulaire : Fiduciaire De France Dpt Kpmg Audit Commissaire Aux Comptes Suppleant : Toulemonde Cedric Commissaire Aux Comptes Suppleant : Delaroque Alphonse. Capital : 56882160 Eur. Activite : Hypermarche - Courtage En Assurance Vente De Scooter Et Produits Motorises (Quad, Buggy, Etc.) Commissionnaire De Transport.Adresse De L’Etablissement Principal : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D'ascq. 
Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D'ascq. 
Commentaires : Changement D'administrateur. Date De Commencement De L’Activite : 01/12/1997. Date D’Effet : 10/11/2009.

18/10/2009

JAL

Activity Or Goodwill Cession

 

 

Les Petites Affiches Du Haut Rhin


Date De Decision : 05-10-2009
Fond Cede : 410409460 - Auchan France, Auchan, 170 R Des Romains, 68200, Mulhouse
Cedant : 410409460 - Auchan France, 200 R De La Recherche, 59491, Villeneuve D'ascq
Cessionnaire : 481977460 - Somarvrac, R Mal De Lattre De Tassigny, 59170, Croix
Prix De Vente : 1 500 000,00 €

01/07/2009

Bodacc C

Comptes Annuels Et Rapports

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille

6960 - 410409460 Rcs. Auchan FranceForme : Societe Anonyme à Conseil D'administration. Adresse : 200 Rue De La Recherche 59650 Villeneuve-D'ascq. Commentaires :Comptes Annuels Et Rapports De L'exercice Clos Le : 31/12/2008.

30/01/2009

Bodacc C

Comptes Annuels Et Rapports

 

 

57 - Moselle

Greffe Du Tribunal D'instance De Metz

897 - 410409460 Rcs. Auchan FranceForme : S.A. à Conseil D'administration. Adresse : 200â Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D'ascq. Commentaires : Comptes Annuels Et Rapports De L'exercice Clos Le : 31/03/2007.

25/10/2008

Bodacc C

Comptes Annuels Et Rapports

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille

7129 - 410409460 Rcs. Auchan FranceForme : Societe Anonyme à Conseil D'administration. Adresse : 200 Rue De La Recherche 59650 Villeneuve-D'ascq. Commentaires :Comptes Annuels Et Rapports De L'exercice Clos Le : 31/12/2007.

10/08/2008

Bodacc B

Modification Et Mutation Diverse

 

 

59 - Nord

Greffe Du Tribunal De Commerce De Lille

1195 - 410 409 460 Rcs Lille. Auchan France. Forme : Societe Anonyme à Conseil D'administration. Enseigne : Auchan France. Administration : President Du Conseil D'administration : Mulliez Arnauddirecteur General Administrateur : Baroukh Philippe. Administrateur : Dubrulle Christophe. Administrateur : Mulliez Arnaud. Administrateur : Delom De Mezerac Xavier. Administrateur : Mathias Henri. Administrateur : Saudo Philippe. Commissaire Aux Comptes Titulaire : Societe Roubaisienne D'expertise Comptab. Commissaire Aux Comptes Titulaire : Fiduciaire De France Dpt Kpmg Audit. Commissaire Aux Comptes Suppleant : Toulemonde Cedric. Commissaire Aux Comptes Suppleant : Delaroque Alphonse. Capital : 56882160 Eur. Activite : Hypermarche - Courtage En Assurance Vente De Scooter Et Produits Motorises (Quad, Buggy, Etc.) Commissionnaire De Transport. Adresse De L’Etablissement Principal : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D'ascq. 
Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-D'ascq. 
Commentaires : Adjonction D'activite. Date De Commencement De L’Activite : 01/12/1997. Date D’Effet : 09/06/2008.

30/04/2008

Bodacc A

Vente Et Cession : Acheteur

 

 

92 - Hauts-De-Seine

Greffe Du Tribunal De Commerce De Nanterre

1249 - 410 409 460 Rcs Nanterre. Sa Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Capital : 56882160 Eur. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve D'ascq. 
Origine Du Fonds : Achat De Droit Au Bail. Etablissement : Etablissement Principal. Activite : Droit Au Bail D'un Local Commercial Nâ°30/31 Dependant Du Centre Commercial Denommee Les Trois Moulins, Zac Sainte Lucie 92130 Issy Les Moulineaux. Adresse : Local Commercial Nâ°30/31, Centre, Commercial Les Trois Moulins, Zac Sainte-Lucie 92130 Issy-Les-Moulineaux. 
Precedent Proprietaire : Amusan Jean (Christophe). . 
Publication Legale : Gazette Du Palais Du 08/04/2008. Oppositions : Au Fonds Vendu (Dans Les Locaux Objet Du Droit Au Bail Cede) Pour La Validite Et Pour La Correspondance Sequestre De L'ordre Des Avocats 11 Place Dauphine 75053 Paris Rp Sp. Descriptif : Fonds Acquis Par Achat Au Prix Stipule De 250000 Euros. Commentaires : Achat D'un Fonds Par Une Personne Morale (Insertion Provisoire).

03/04/2008

Bodacc A

Vente Et Cession : Acheteur

 

 

92 - Hauts-De-Seine

Greffe Du Tribunal De Commerce De Nanterre

5302 - 410 409 460 Rcs Nanterre. Sa Auchan France. Forme : Societe Anonyme. Capital : 56882160 Eur. Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve D'ascq. 
Origine Du Fonds : Achat De Droit Au Bail. Etablissement : Etablissement Principal. Activite : Le Droit Au Bail De Locaux Dependant D'un Immeuble. Adresse : Centre Commercial Les 3 Moulins, - Zac Sainte-Lucie - Local Nâ°29 - Niveau 1 -, 92130 Issy-Les-Moulineaux. 
Precedent Proprietaire : Orassi. 443 840 830 Rcs Nanterre. 
Publication Legale : Journal Special Des Societes Franã§Aises Du 08/03/2008. Oppositions : Au Mandataire Etude De Me Olivier Herrnberger - 6 Rue Andre Chenier - 92130 Issy Les Moulineaux Pour La Validite Et Pour La Correspondance. Descriptif : Fonds Acquis Par Achat Au Prix Stipule De 520000 Euros. Commentaires : Achat D'un Fonds Par Une Personne Morale (Insertion Provisoire).

07/12/2007

Bodacc C

Avis De Depã´T Des Comptes

 

 

6757 - 410 409 460. RCS Lille AUCHAN FRANCE. Forme: Societe Anonyme à Conseil D'administration. Adresse Du Siã¨Ge Social: 200 Rue De La Recherche 59650 Villeneuve-d'Ascq. Comptes Annuels Et Rapports De L'exercice Clos Le: 31 Decembre 2006.

19/12/2006

Bodacc B

Modifications Et Mutations Diverses

 

 

1053 - RCS Roubaix-Tourcoing B 410 409 460. RC 97-B 10. AUCHAN FRANCE. Forme : S.A. à Conseil D'administration. Capital : 56 882 160 Euros. Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche,, 59650 Etablissement Principal - Activite : Exploitation D'un Hypermarche Courtage D'assurances . Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Etablissement Principal - Nouvelle Situation - Adjonction D'activite : Vente De Scooters, De Produits Motorises, De Quads Et De Buggys. Date D'effet : 1er Septembre 2006.

22/08/2006

Bodacc C

Avis De Depã´T Des Comptes

 

 

2434 - RCS Roubaix-Tourcoing B 410 409 460. RC 97-B 10. AUCHAN FRANCE. Forme: S.A. à Conseil D'administration . Adresse Du Siã¨Ge Social: 200, Rue De La Recherche,59650 Villeneuve-D'ascq. Comptes Annuels Et Rapports De L'exercice Clos Le: 31 Decembre 2005.

19/05/2006

Bodacc B

Modifications Et Mutations Diverses

 

 

1145 - RCS Roubaix-Tourcoing B 410 409 460. RC 97-B 10. AUCHAN FRANCE. Forme : S.A. à Conseil D'administration. Capital : 56 882 160 Euros. Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche,, 59650 Administration : President Du Conseil D'administration : MULLIEZ (Arnaud). Directeur General Et Administrateur : BAROUKH (Philippe). Administrateurs : DUBRULLE (Christophe) MULLIEZ (Arnaud) DELOM DE MEZERAC (Xavier) MATHIAS (Henri) SAUDO (Philippe). Commissaires Aux Comptes Titulaires : STE ROUBAISIENNE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE DPT K.P.M.G. AUDIT. Commissaires Aux Comptes Suppleants : CARLIER (Didier) TOULEMONDE (Cedric). Ancienne Administration : Ancien Administrateur : MULLIEZ (Thierry). Etablissement Principal - Activite : Exploitation D'un Hypermarche Courtage D'assurances . Adresse : 200 Rue De La Recherche, 59650 Date D'effet : 27 Fevrier 2006.

17/03/2006

Bodacc C

Avis De Depã´T Des Comptes

 

 

2716 - RCS Roubaix-Tourcoing B 410 409 460. RC 97-B 10. AUCHAN FRANCE. Forme: S.A. à Conseil D'administration . Adresse Du Siã¨Ge Social: 200, Rue De La Recherche,59650 Villeneuve-D'ascq. Comptes Annuels Et Rapports De L'exercice Clos Le: 31 Decembre 2004.

26/10/2005

Bodacc A

Vente Et Cession

 

 

1616 - RCS Roubaix-Tourcoing B 410 409 460. AUCHAN FRANCE. Forme : S.A. Capital : 56 882 160 Euros. Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Etablissement Secondaire - Enseigne : Ind-O-Chine. Activite : Traiteur. Adresse : Z.A.C. De La Forãªt, Centre Commercial, 86100 Chã¢Tellerault. Etablissement Secondaire Acquis Par Achat Au Prix Stipule De 68 602 Euros. Date D'effet : 27 Juin 2005. Precedents Proprietaires : VONGSOUTHI (Sipaseut). Nom D'usage : VEOPRASEUTH. VEOPRASEUTH (Sompong). RCS Poitiers A 393 037 775. Publication Legale : Le Courrier Franã§Ais Du 15 Juillet 2005. Oppositions : Me Philippon (Jean-Pierre), Notaire, 8 Boulevard Victor-Hugo, 86105 Chã¢Tellerault Cedex.

25/09/2005

Bodacc A

Vente Et Cession

 

 

731 - RCS Roubaix-Tourcoing B 410 409 460. AUCHAN FRANCE S.A. Forme : S.A. Capital : 56 882 160 Euros. Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Etablissement Secondaire - Enseigne : L'Egypte. Activite : Restauration Rapide Et Fabrication De Specialites Orientales à Emporter. Adresse : Z.A.C. De La Forãªt, Le Marchais-d'Ozon-Nord, 86100 Chã¢Tellerault. Etablissement Secondaire Acquis Par Achat Au Prix Stipule De 110 000 Euros. Date D'effet : 30 Juin 2005. Precedents Proprietaires : AHMED MOUSTAFA (Hussam, Kamal, Eldin, Shokari). AHMED MOUSTAFA, Nee ELTAHLAWY (Islam). RCS Poitiers A 451 135 305. Publication Legale : Le Courrier Franã§Ais Du 22 Juillet 2005. Oppositions : Me Proust (Bernard), Notaire, 57 Boulevard Blossac, 86100 Chã¢Tellerault.

25/09/2005

Bodacc A

Vente Et Cession

 

 

734 - RCS Roubaix-Tourcoing B 410 409 460. AUCHAN FRANCE S.A. Forme : S.A. Capital : 56 882 160 Euros. Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Etablissement Secondaire - Activite : Organisation Et Distribution D'animaux. Adresse : Z.A.C. De La Forãªt, Le Marche-d'Ozon-Nord, 86100 Chã¢Tellerault. Elements, Dependant De l'Etablissement Secondaire, Acquis Par Achat Au Prix Stipule De 125 200 Euros. Date D'effet : 30 Juin 2005. Precedent Proprietaire : STEINMETZ (Jacques). STEINMETZ, Nee QUENEAU (Dominique). RCS Poitiers A 300 298 668. Publication Legale : Le Courrier Franã§Ais Du 15 Juillet 2005. Oppositions : Me Proust (Bernard), Notaire, 57 Boulevard Blossac, 86100 Chã¢Tellerault.

25/09/2005

Bodacc A

Vente Et Cession

 

 

733 - RCS Roubaix-Tourcoing B 410 409 460. AUCHAN FRANCE S.A. Forme : S.A. Capital : 56 882 160 Euros. Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Etablissement Secondaire - Enseigne : La Boã®Te à Cadeaux. Activite : Cadeaux Et Soldes. Adresse : Z.A.C. De La Forãªt, Le Marchais-d'Ozon-Nord, 86100 Chã¢Tellerault. Etablissement Secondaire Acquis Par Achat Au Prix Stipule De 91 469,41 Euros. Date D'effet : 30 Juin 2005. Precedent Proprietaire : PAINEAU (Patrice). RCS Poitiers A 324 224 070. Publication Legale : Le Courrier Franã§Ais Du 22 Juillet 2005. Oppositions : Me Proust (Bernard), Notaire, 57 Boulevard Blossac, 86100 Chã¢Tellerault.

25/09/2005

Bodacc A

Vente Et Cession

 

 

732 - RCS Roubaix-Tourcoing B 410 409 460. AUCHAN FRANCE S.A. Forme : S.A. Capital : 56 882 160 Euros. Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Etablissement Secondaire - Activite : Cafe, Bar, Crãªperie Et P.M.U. Adresse : Z.A.C. De La Forãªt, Le Marchais-d'Ozon-Nord, 86100 Chã¢Tellerault. Etablissement Secondaire Acquis Par Achat Au Prix Stipule De 130 000 Euros. Date D'effet : 30 Juin 2005. Precedents Proprietaires : GRIGNON (Andre). GRIGNON, Nee GERMON (Marie, Laure). RCS Poitiers A 325 006 427. Publication Legale : Le Courrier Franã§Ais Du 15 Juillet 2005. Oppositions : Me Montier, Mandataire Judiciaire à La Liquidation Des Entreprises, 67 Boulevard Chasseigne, 86000 Poitiers.

24/08/2005

Bodacc A

Vente Et Cession

 

 

1025 - RCS Roubaix-Tourcoing B 410 409 460. AUCHAN FRANCE. Forme : S.A. Capital : 56 882 160 Euros. Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Administration : Directeur General : BAROUKH (Philippe). Etablissement Secondaire - Activite : Cafe, Bar Et Brasserie. Adresse : Z.A.C. De La Forãªt, 6 Avenue Camille-Page, 86100 Chã¢Tellerault. Etablissement Secondaire Acquis Par Achat Au Prix Stipule De 106 714,31 Euros. Date D'effet : 18 Juillet 2005. Precedent Proprietaire : LE SWEENY S.A.R.L. RCS Poitiers B 388 193 542. Publication Legale : La Nouvelle Republique Du Centre-Ouest Du 30 Juillet 2005. Oppositions : Me Duval, 19 Boulevard Victor-Hugo, 86100 Chã¢Tellerault.

11/08/2005

Bodacc A

Vente Et Cession

 

 

618 - RCS Roubaix-Tourcoing 410 409 460. AUCHAN FRANCE. Forme : S.A. Capital : 56 882 160 Euros. Adresse Du Siã¨Ge Social : 200 Rue De La Recherche, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Administration : P.D.G. : BAROUKH (Philippe). Etablissement Principal - Activite : Mercerie. Adresse : Z.A.C. De La Forãªt, 6 Avenue Camille-Page, 86100 Chã¢Tellerault. Etablissement Principal Acquis Par Cession Au Prix Stipule De 53 357,16 Euros. Date D'effet : 28 Juin 2005. Precedent Proprietaire Exploitant : BICHIER (Jacques, Jean, Michel). Conjoint MADEJ-BICHIER (Stasnislawa, Janin). RCS Lille 398 740 431. Publication Legale : La Nouvelle Republique Du 11 Juillet 2005. Oppositions : Me Duval, 19 Boulevard Victor-Hugo, 86100 Chã¢Tellerault.

 

 


Company events history

 

 

 

 

Date

Description

31/10/2014

Bodacc C : Deposit accounts notice

23/10/2014

Bodacc A : Sale and transfer

10/10/2014

Update Limit

10/10/2014

Update Rating

09/10/2014

Update Limit

09/10/2014

Update Rating

08/10/2014

New Filling of Tax Office preferential right

06/10/2014

Payment incident closed

16/09/2014

Declaration of conformity

16/09/2014

Merger

10/09/2014

Bodacc C : Deposit accounts notice

29/08/2014

Update Rating

29/08/2014

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

19/08/2014

Bodacc B: Various editing or changing

10/08/2014

Bodacc B: Various editing or changing

05/08/2014

Update Rating

01/08/2014

Disengagement in other companies

25/07/2014

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

22/07/2014

Minutes of general meeting of shareholders

22/07/2014

Changes to the Board of Directors

21/07/2014

Declaration of conformity

18/07/2014

Updated articles of association

18/07/2014

Minutes of general meeting of shareholders

18/07/2014

Change to corporate purpose

18/07/2014

Amendment

20/06/2014

Legal Gazette: Appointment of the social representative

08/05/2014

Bodacc A : Sale and transfer

28/04/2014

Merger

27/04/2014

Bodacc B: Various editing or changing

24/04/2014

Bodacc A : Sale and transfer

15/04/2014

Update Rating

15/04/2014

Planned merger

13/04/2014

Bodacc A : Sale and transfer

11/04/2014

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

10/04/2014

New auditor

10/04/2014

Change to corporate purpose

10/04/2014

Changes to the Board of Directors

10/04/2014

Updated articles of association

10/04/2014

Amendment

04/04/2014

Merger

20/03/2014

Payment incident closed

09/03/2014

Bodacc A : Sale and transfer

28/02/2014

Bodacc A : Sale and transfer

31/01/2014

Update Rating

31/12/2013

New accounts available

24/12/2013

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer

19/12/2013

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer

12/11/2013

Legal Gazette: Appointment of the social representative

01/11/2013

Update of participations in other companies

01/11/2013

New ultimate parent

24/10/2013

Update Rating

20/10/2013

Update Rating

16/10/2013

Update Rating

08/10/2013

New Filling of Tax Office preferential right

08/10/2013

Unfiling of a Tax Office preferential right

04/10/2013

Disengagement in other companies

03/09/2013

Bodacc C : Deposit accounts notice

31/08/2013

Invalid balance sheet

07/06/2013

Disengagement in other companies

01/06/2013

Formation of Establishment

10/12/2012

Modification of Establishment Activity

20/11/2012

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

02/11/2012

Disengagement in other companies

31/10/2012

Bodacc B: Various editing or changing

24/10/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

15/10/2012

Updated articles of association

15/10/2012

Amendment

15/10/2012

Change to corporate purpose

29/08/2012

Bodacc A : Sale and transfer

03/08/2012

Disengagement in other companies

01/08/2012

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

17/07/2012

Declaration of conformity

17/07/2012

Amendment

17/07/2012

Audit or Management Report

17/07/2012

Private document

21/06/2012

Merger

21/06/2012

Declaration of conformity

27/05/2012

Bodacc A : Sale and transfer

25/05/2012

Bodacc A : Sale and transfer

25/05/2012

Payment incident detected

16/05/2012

Partial contribution

10/05/2012

Bodacc A : Sale and transfer

04/05/2012

Payment incident closed

27/04/2012

Planned merger

24/04/2012

Amendment

24/04/2012

Application and court order

20/04/2012

Payment incident detected

01/03/2012

Payment incident detected

24/02/2012

Payment incident detected

31/12/2011

New accounts available

21/12/2011

Payment incident detected

25/11/2011

Payment incident detected

15/10/2011

Bodacc C : Deposit accounts notice

14/10/2011

Invalid balance sheet

13/09/2011

Bodacc B: Various editing or changing

02/09/2011

Update of participations in other companies

01/09/2011

PV d'AssemblEe

01/09/2011

Minutes of general meeting of shareholders

01/09/2011

Changes to the Board of Directors

01/09/2011

Modification du Conseil d'Administration

28/06/2011

Bodacc A : Sale and transfer

03/06/2011

Update of participations in other companies

03/06/2011

New subsidiarie(s) detected

16/05/2011

Legal Gazette: Appointment of the social representative

12/05/2011

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

01/04/2011

Legal Gazette: Appointment of the social representative

04/03/2011

New ultimate parent

02/02/2011

Bodacc A : Sale and transfer

24/12/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

15/10/2010

Disengagement in other companies

28/09/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

13/09/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

02/09/2010

Preferential right lapsed

19/08/2010

Payment incident closed

18/08/2010

Payment incident closed

13/08/2010

Update of participations in other companies

13/08/2010

Disengagement in other companies

13/08/2010

New participations in other companies

13/08/2010

New subsidiarie(s) detected

04/08/2010

Bodacc B: Various editing or changing

30/07/2010

Application and court order

30/07/2010

Requête et Ordonnance

30/07/2010

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

22/07/2010

Amendment

22/07/2010

Acte modificatif

22/07/2010

Updated articles of association

22/07/2010

Statuts mis à jour

22/07/2010

Minutes of Board meeting

22/07/2010

PV d'AssemblEe

22/07/2010

Minutes of general meeting of shareholders

22/07/2010

Modification du Conseil d'Administration

22/07/2010

Changes to the Board of Directors

22/07/2010

Change to corporate purpose

22/07/2010

Modification de l'objet social

16/07/2010

Modification of Establishment Activity

09/07/2010

Disengagement in other companies

02/07/2010

Payment incident closed

01/07/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

03/05/2010

New subsidiarie(s) detected

19/04/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

13/04/2010

Payment incident detected

08/04/2010

Payment incident closed

06/04/2010

New subsidiarie(s) detected

18/03/2010

Unfiling of a Tax Office preferential right

18/03/2010

New Filling of Tax Office preferential right

04/03/2010

Payment incident detected

02/03/2010

New participations in other companies

02/03/2010

New subsidiarie(s) detected

16/02/2010

Bodacc A : Sale and transfer

04/02/2010

Payment incident closed

31/12/2009

Collection of preferential rights activated for this company

31/12/2009

New accounts available

30/12/2009

Payment incident closed

29/12/2009

Payment incident detected

23/12/2009

Bodacc B: Various editing or changing

01/12/2009

Acte modificatif

01/12/2009

Changes to the Board of Directors

01/12/2009

Modification du Conseil d'Administration

25/11/2009

Payment incident closed

24/11/2009

Payment incident detected

19/11/2009

Payment incident closed

04/11/2009

Payment incident closed

18/10/2009

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

13/10/2009

Payment incident closed

29/09/2009

Payment incident closed

09/09/2009

Payment incident closed

07/09/2009

Payment incident closed

04/09/2009

Payment incident detected

06/08/2009

Payment incident detected

29/07/2009

Payment incident closed

16/07/2009

Payment incident closed

01/07/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

22/06/2009

Payment incident detected

17/06/2009

Payment incident closed

25/05/2009

Payment incident detected

22/04/2009

Payment incident closed

11/03/2009

Payment incident closed

05/03/2009

Payment incident closed

30/01/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

29/01/2009

Payment incident detected

31/12/2008

New accounts available

23/12/2008

Payment incident detected

22/12/2008

Payment incident closed

04/12/2008

Payment incident detected

24/11/2008

Payment incident protested

24/11/2008

Payment incident detected

13/11/2008

Payment incident closed

25/10/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

08/10/2008

Payment incident closed

02/10/2008

Payment incident detected

29/09/2008

Payment incident closed

15/09/2008

Payment incident closed

12/09/2008

Payment incident detected

03/09/2008

Payment incident closed

26/08/2008

Unfiling of a Tax Office preferential right

26/08/2008

Filling of Tax Office Preferential Right

26/08/2008

New Filling of Tax Office preferential right

10/08/2008

New Bodacc B ads detected

10/08/2008

Bodacc B: Various editing or changing

07/08/2008

Payment incident detected

04/06/2008

Payment incident closed

29/05/2008

Payment incident closed

27/05/2008

Payment incident closed

30/04/2008

Bodacc A : Sale and transfer

30/04/2008

New Bodacc A ads detected

03/04/2008

Bodacc A : Sale and transfer

03/04/2008

New Bodacc A ads detected

03/04/2008

Payment incident detected

26/03/2008

Payment incident detected

31/12/2007

New accounts available

07/12/2007

New auditor

07/12/2007

PV d'AssemblEe

07/12/2007

Minutes of general meeting of shareholders

07/12/2007

Private document

07/12/2007

Appointment/resignation of company officers

07/12/2007

Changement de Commissaire aux Comptes

05/12/2007

Updated articles of association

05/12/2007

Statuts mis à jour

05/12/2007

Minutes of general meeting of shareholders

05/12/2007

PV d'AssemblEe

05/12/2007

Private document

05/12/2007

Change to corporate purpose

05/12/2007

Modification de l'objet social

31/12/2006

New accounts available

05/10/2006

Private document

05/10/2006

Private document

05/10/2006

Planned merger

05/10/2006

Planned merger

05/10/2006

Projet de Fusion

28/04/2006

Private document

28/04/2006

Private document

28/04/2006

Acte sous seing privE

28/04/2006

Modification du Conseil d'Administration

28/04/2006

Changes to the Board of Directors

28/04/2006

Changes to the Board of Directors

28/04/2006

Nomination/dEmission des organes de gestion

28/04/2006

Appointment/resignation of company officers

28/04/2006

Appointment/resignation of company officers

31/12/2005

New accounts available

07/10/2005

Acte sous seing privE

31/12/2004

New accounts available

23/09/2004

Planned merger

23/09/2004

Private document

23/09/2004

Acte sous seing privE

23/09/2004

Projet de Fusion

23/09/2004

Private document

23/09/2004

Planned merger

02/06/2004

Acte sous seing privE

02/06/2004

Private document

02/06/2004

Changes to the Board of Directors

02/06/2004

Modification du Conseil d'Administration

02/06/2004

Nomination/dEmission des organes de gestion

02/06/2004

Acte modificatif

02/06/2004

PV d'AssemblEe

02/06/2004

Minutes of general meeting of shareholders

02/06/2004

Appointment/resignation of company officers

31/12/2003

New accounts available

27/11/2003

Acte sous seing privE

27/11/2003

PV d'AssemblEe

27/11/2003

DEclaration de conformitE

27/11/2003

Augmentation de Capital

27/11/2003

Statuts mis à jour

06/10/2003

Projet de Fusion

06/10/2003

Acte sous seing privE

03/07/2003

Acte modificatif

03/07/2003

PV du Conseil d'Administration

03/07/2003

PV d'AssemblEe

03/07/2003

Nomination/dEmission des organes de gestion

03/07/2003

Acte sous seing privE

03/07/2003

Modification du Conseil d'Administration

03/07/2003

Changement de PrEsident (PDG, PCA)

13/01/2003

Acte sous seing privE

13/01/2003

DEclaration de conformitE

13/01/2003

Nomination/dEmission des organes de gestion

13/01/2003

PV d'AssemblEe

13/01/2003

Statuts mis à jour

13/01/2003

Augmentation de Capital

29/10/2002

Projet de Fusion

29/10/2002

Acte sous seing privE

01/10/2002

Nomination/dEmission des organes de gestion

02/07/2002

PV d'AssemblEe

02/07/2002

Nomination/dEmission des organes de gestion

02/07/2002

Acte sous seing privE

02/07/2002

Modification du Conseil d'Administration

16/04/2002

Changement de PrEsident (PDG, PCA)

16/04/2002

PV d'AssemblEe

16/04/2002

PV du Conseil d'Administration

16/04/2002

Nomination/dEmission des organes de gestion

16/04/2002

Acte modificatif

16/04/2002

Modification du Conseil d'Administration

16/04/2002

Statuts mis à jour

16/04/2002

Acte sous seing privE

11/03/2002

Modification du Conseil d'Administration

11/03/2002

Nomination/dEmission des organes de gestion

11/03/2002

Acte sous seing privE

30/01/2002

Statuts mis à jour

30/01/2002

PV d'AssemblEe

30/01/2002

DEclaration de conformitE

30/01/2002

Nomination/dEmission des organes de gestion

30/01/2002

Acte sous seing privE

30/01/2002

Modification du Conseil d'Administration

30/01/2002

Augmentation de Capital

29/10/2001

PV d'AssemblEe

29/10/2001

Acte modificatif

29/10/2001

Nomination/dEmission des organes de gestion

29/10/2001

Acte sous seing privE

29/10/2001

Modification du Conseil d'Administration

29/10/2001

Statuts mis à jour

29/10/2001

Conversion du Capital Social en Euros

29/10/2001

Augmentation de Capital

01/10/2001

Projet de Fusion

01/10/2001

Acte sous seing privE

19/02/2001

Statuts mis à jour

19/02/2001

PV d'AssemblEe

19/02/2001

Acte sous seing privE

19/02/2001

Modification de l'objet social

24/07/2000

Rapport des Commissaires ou du GErant

24/07/2000

Acte sous seing privE

23/06/2000

Rapport des Commissaires ou du GErant

23/06/2000

Acte sous seing privE

31/05/2000

Projet de Fusion

31/05/2000

Acte sous seing privE

21/01/2000

Acte sous seing privE

21/01/2000

Statuts mis à jour

21/01/2000

PV d'AssemblEe

21/01/2000

Augmentation de Capital

22/12/1999

Rapport des Commissaires ou du GErant

22/12/1999

Acte sous seing privE

30/11/1999

Projet de Fusion

30/11/1999

Acte sous seing privE

29/07/1999

Nomination/dEmission des organes de gestion

29/07/1999

PV d'AssemblEe

29/07/1999

Modification du Conseil d'Administration

29/07/1999

Acte sous seing privE

15/04/1999

Acte sous seing privE

15/04/1999

PV d'AssemblEe

15/04/1999

Nomination/dEmission des organes de gestion

16/03/1999

Dissolution

16/03/1999

DEclaration de conformitE

16/03/1999

Acte modificatif

16/03/1999

Fusion

16/03/1999

Acte sous seing privE

17/02/1999

Acte sous seing privE

17/02/1999

Procuration

27/01/1999

Augmentation de Capital

27/01/1999

Acte sous seing privE

27/01/1999

Statuts mis à jour

27/01/1999

PV d'AssemblEe

28/12/1998

Acte sous seing privE

28/12/1998

Rapport des Commissaires ou du GErant

07/12/1998

Augmentation de Capital

07/12/1998

Acte modificatif

07/12/1998

Statuts mis à jour

07/12/1998

Modification du Conseil d'Administration

07/12/1998

PV d'AssemblEe

07/12/1998

Nomination/dEmission des organes de gestion

07/12/1998

Acte sous seing privE

30/11/1998

Projet de Fusion

30/11/1998

Acte sous seing privE

25/11/1998

Acte sous seing privE

25/11/1998

Procuration

24/09/1998

Acte sous seing privE

24/09/1998

Rapport des Commissaires ou du GErant

31/08/1998

Projet de Fusion

31/08/1998

Acte sous seing privE

31/08/1998

Fusion

31/08/1998

Cession de parts

26/05/1998

Acte sous seing privE

26/05/1998

Procuration

25/05/1998

Acte sous seing privE

25/05/1998

Procuration

22/05/1998

Acte sous seing privE

22/05/1998

Procuration

30/01/1998

PV du Conseil d'Administration

30/01/1998

Acte sous seing privE

30/01/1998

Nomination/dEmission des organes de gestion

30/01/1998

Statuts mis à jour

30/01/1998

Modification du Conseil d'Administration

30/01/1998

Acte modificatif

30/01/1998

PV d'AssemblEe

30/01/1998

Modification de l'objet social

30/01/1998

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

30/01/1998

Augmentation de Capital

30/01/1998

Changement de Commissaire aux Comptes

27/11/1997

PV du Conseil d'Administration

27/11/1997

Statuts mis à jour

27/11/1997

Rapport des Commissaires ou du GErant

27/11/1997

Procuration

27/11/1997

Acte modificatif

27/11/1997

Augmentation de Capital

27/11/1997

REduction de Capital

27/11/1997

Changement de dEnomination sociale

27/11/1997

Changement de PrEsident (PDG, PCA)

27/11/1997

Modification du Conseil d'Administration

27/11/1997

Acte sous seing privE

27/11/1997

Certificat de dEpôt des fonds

27/11/1997

Nomination/dEmission des organes de gestion

27/11/1997

PV d'AssemblEe

24/11/1997

Acte sous seing privE

24/11/1997

Rapport des Commissaires ou du GErant

31/10/1997

Acte sous seing privE

31/10/1997

Projet de Fusion

10/09/1997

Statuts mis à jour

10/09/1997

PV d'AssemblEe

10/09/1997

Acte sous seing privE

10/09/1997

Changement de dEnomination sociale

10/09/1997

Modification de l'objet social

03/01/1997

Changement de PrEsident (PDG, PCA)

03/01/1997

Acte sous seing privE

03/01/1997

Nomination/dEmission des organes de gestion

03/01/1997

PV du Conseil d'Administration

03/01/1997

Modification to Establishment Address or Identifier

03/01/1997

Statuts

03/01/1997

Acte modificatif

03/01/1997

Formation de SociEtE

03/01/1997

Certificat de dEpôt des fonds

 

 

 

 

 

Establishment events history

 

 

 

 

Date

Description

29/10/2014

Update of phone numbers

29/08/2014

Update Rating

29/08/2014

Update Limit

16/05/2014

Update of Establishment Trade name

16/05/2014

Modification of Head office

31/01/2014

Update Rating

09/10/2013

Update Rating

05/10/2013

Update Limit

07/09/2013

Update Rating

01/06/2013

Modification of Head office

12/01/2013

Update of phone numbers

10/12/2012

Modification of Head office Activity

10/12/2012

Update of Establishment Activity

10/12/2012

Update of Establishment Workforce

20/11/2012

Update Rating

20/11/2012

Update Limit

24/10/2012

Update of phone numbers

18/05/2012

Update of phone numbers

17/02/2012

Update Rating

03/12/2011

Update Rating

04/11/2011

Update Rating

08/10/2011

Update Limit

03/09/2011

Update Rating

25/04/2011

Update Rating

04/02/2011

Update Limit

04/02/2011

Update Rating

19/10/2010

Update of phone numbers

03/09/2010

Update Rating

03/09/2010

Update Limit

19/08/2010

Update Rating

16/07/2010

Update of Establishment Activity

16/07/2010

Modification of Head office Activity

27/04/2010

Update Rating

27/02/2010

Update of phone numbers

08/06/2009

Update Rating

02/02/2009

Update Rating

18/09/2008

Update Rating

04/09/2008

Update Rating

01/09/2008

Update Rating

13/01/2008

Update Limit

03/01/2008

Update Limit

16/12/2007

Update Limit

11/12/2007

Update Limit

10/12/2007

Update Limit

09/12/2007

Update Limit

07/12/2007

Update Rating

06/12/2007

Update Rating

19/11/2007

Update Limit

15/11/2007

Update Rating

13/11/2007

Update Rating

17/10/2007

Update Limit

17/10/2007

Update Rating

 

 

directors

 

 

Name

M. MULLIEZ ARNAUD

 

Manager position

Chairman of the Board, Administrator

Date of birth

12/03/1959

 

Place of birth

MALESTROIT (56140)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. MIGNOT VINCENT

 

Manager position

Managing director

Date of birth

26/04/1972

 

Place of birth

CHAUMONT (52000)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. BAROUKH PHILIPPE

 

Manager position

Administrator

Date of birth

16/08/1957

 

Place of birth

(TUNISIE) TUNIS(TUNISIE)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. MATHIAS HENRI

 

Manager position

Administrator

Date of birth

17/03/1952

 

Place of birth

LILLE (59000)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. LECLERCQ BERTRAND

 

Manager position

Administrator

Date of birth

16/12/1966

 

Place of birth

ROUBAIX (59051)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. CAVROIS THIERRY

 

Manager position

Administrator

Date of birth

27/04/1948

 

Place of birth

ROUBAIX (59100)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

                                       

Previous Directors

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

 

Administrator

M THIERRY CAVROIS

4/27/1948 - ROUBAIX (59051)

 

Administrator

M CHRISTOPHE DUBRULLE

- - -

 

Administrator

M YVON JOLIVET

2/17/1951 - PETOSSE (85570)

 

Chairman of the Board

M ARNAUD MULLIEZ

3/12/1959 - MALESTROIT (56140)

 

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.61.95

UK Pound

1

Rs.97.16

Euro

1

Rs.76.75

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

DIV

 

 

Report Prepared by :

MNL

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.