MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

01.02.2014

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

 

 

Registered Office :

Zi Parisnord Ii Imm Edison, 33 Rue Des Vanesses, 93420 Villepinte

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2012

 

 

Date of Incorporation :

November 1988

 

 

Com. Reg. No.:

RCS Bobigny 9 348 982 307

 

 

Legal Form :

Simplified Joint Stock Company with Single Associate

 

 

Line of Business :

Subject is engaged in diversified business such as autopilot flight controller, commercial weather radar system, business jet turbofan engine, revolutionary technology for aerospace, gas detection, fire systems, personal protective equipment, building controls & automotive turbocharging

 

 

No. of Employees :

100 to 199 employees 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

 

Status :

Satisfactory 

 

 

Payment Behaviour :

No Complaints 

 

 

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – december 01, 2013

 

Country Name

Previous Rating

(30.09.2013)

Current Rating

(01.12.2013)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 

france ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With at least 79 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that reduce income disparity and the impact of free markets on public health and welfare. France's real GDP contracted 2.6% in 2009, but recovered somewhat in 2010 and 2011, before stagnating in 2012. The unemployment rate increased from 7.4% in 2008 to 10.3% in 2012. Youth unemployment shot up to 24.2% during the third quarter of 2012 in metropolitan France. Lower-than-expected growth and high unemployment costs have strained France's public finances. The budget deficit rose sharply from 3.4% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 4.5% of GDP in 2012, while France's public debt rose from 68% of GDP to 89% over the same period. Under President SARKOZY, Paris implemented some austerity measures to bring the budget deficit under the 3% euro-zone ceiling by 2013 and to highlight France's commitment to fiscal discipline at a time of intense financial market scrutiny of euro-zone debt. Socialist Party candidate Francois HOLLANDE won the May 2012 presidential election, after advocating pro-growth economic policies, the separation of banks' traditional deposit taking and lending activities from more speculative businesses, increasing the top corporate and personal tax rates, and hiring an additional 60,000 teachers during his five-year term. The government's attempt to introduce a 75% wealth tax on income over one million euros for two years was struck down by the French Constitutional Council in December 2012 because it applied to individuals rather than households. France ratified the EU fiscal stability treaty in October 2012 and HOLLANDE's government has maintained France's commitment to meeting the budget deficit target of 3% of GDP during 2013 even amid signs that economic growth will be lower than the government's forecast of 0.8%. Despite stagnant growth and fiscal challenges, France's borrowing costs declined during the second half of 2012 to euro-era lows.

 

Source : CIA

 

 

 

REGISTERED NAME & COMPANY SUMMARY

 

Name

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

SIRET

348 982 307 00137

 

 

Company summary

 

 

EUR VAT Number

FR34348982307

 

Activity (APE)

Subject is engaged in diversified business such as autopilot flight controller, commercial weather radar system, business jet turbofan engine, revolutionary technology for aerospace, gas detection, fire systems, personal protective equipment, building controls & automotive turbocharging

Legal form

Simplified Joint Stock Company with Single Associate

 

Phone

 

RCS Registration

RCS Bobigny 9 348 982 307

 

Fax

 

Share capital

17,750,000 Euros

 

Address

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
ZI PARISNORD II IMM EDISON
33 RUE DES VANESSES
93420 VILLEPINTE

Incorporated Date

12/1988

 

Nationality

France

Status

Economically active

 

 

Company details

 

 

 

Activity (APE)

Subject is engaged in diversified business such as autopilot flight controller, commercial weather radar system, business jet turbofan engine, revolutionary technology for aerospace, gas detection, fire systems, personal protective equipment, building controls & automotive turbocharging

 

RCS Registration

RCS Bobigny 9 348 982 307

Share capital

17,750,000 Euros

 

Registration Court

Bobigny (93)

Legal form

Simplified Joint Stock Company with Single Associate

 

Court Registry Number

19 9 4B01054

EUR VAT Number

FR34348982307

 

Incorporation Date

12/1988

Formation Date

11/1988

 

Deregistration Date

 

Last account Date

31/12/2012

 

Nationality

France

 

 

Establishment details

 

 

 

Activity (APE)

Subject is engaged in diversified business such as autopilot flight controller, commercial weather radar system, business jet turbofan engine, revolutionary technology for aerospace, gas detection, fire systems, personal protective equipment, building controls & automotive turbocharging

 

Postal Address

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
ZI PARISNORD II IMM EDISON
33 RUE DES VANESSES
93420 VILLEPINTE

Trading Address

33 RUE DES VANESSES
93420 VILLEPINTE

 

Business Pages FT®

 

 

 

 

 

 

 

Type

Head office

Status

Economically active

 

Formation Date

07/2002

Reason for formation

Other

 

Closure Date

 

Reason for closure

Deleted

 

Reactivation Date

 

Production Role

 

 

Activity Nature

-

Activity Location

Other

 

Location surface

 

Seasonality

 

 

 

 

Department

Seine-Saint-Denis (93)

Region

Ile-de-France

 

District

2

Area

40

 

City

VILLEPINTE

Size of urban area

Paris conglomeration

 


DIRECTORS/MANAGEMENT

 

Directors

 

Name

M. DUBOIS STÉPHANE, MARC

 

Manager position

President

Date of birth

30/10/1977

 

Place of birth

LONDRES(ROYAUME-UNI)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. TOUCHAIS OLIVIER

 

Manager position

Managing director

Date of birth

11/11/1970

 

Place of birth

PARIS

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. BURCKART CHRISTOPHE

 

Manager position

Managing director

Date of birth

29/03/1969

 

Place of birth

ALGER(ALGERIE)

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Directors

 

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

 

President

M BRICE BRICHETEAU DE LA MORANDIERE

15/03/1965 - PARIS 16

 

President

M CHRISTOPHE LAMOINE

19/07/1960 - LA CIOTAT

 

President

M CHRISTOPHE LAMOINE

19/07/1960 - LA CIOTAT

 

President

M JEROME RONZE

- - -

 

President

M JÉRÔME RONZE

24/08/1962 - PARIS

 

Managing director

M MARC BEAUFILS

18/10/1961 - DIJON

 

Managing director

M OLIVIER, YVES, MARIE DUVAL DU CHESNAY

06/11/1974 - PARIS

 

Managing director

M OLIVIER, YVES, MARIE DUVAL DU CHESNAY

04/11/1974 - PARIS

 

Managing director

M CHRISTOPHE LAMOINE

19/07/1960 - LA CIOTAT

 

Managing director

M PHILIPPE SUHAS

- - -

 

Managing director

M PHILIPPE SUHAS

19/08/1966 - TOULON

 

Managing director

M OLIVIER, YVES, MARIE DUVAL DU CHESNAY

06/11/1974 - PARIS

 

 

SHARE & SHARE CAPITAL INFORMATION

 

Shareholders

Type of shareholder

Shareholders

 

GROUP STRUCTURE & AFFILIATED COMPANIES

 

Ultimate Holding Company

 

Company Name

 

Company number

 

 

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

 

US44905874

 

 

 

Group data

Ultimate parent company

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

Direct parent

SPERIAN PROTECTION - 100 %

Group – Number of companies

127

Linkages – Number of companies

309

Number of countries

22

 

Group Structure

Go directly to the current company

Display only where participation % > 33 %

Display all participations

 

Company Name

SIREN

Parts

Last account published

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

US44905874

-

-

HONEYWELL HOLDING FRANCE

425137833

99%

31/12/2012

SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERON...

542065271

100%

31/12/2012

HONEYWELL

562004796

99.99%

31/12/2012

HONEYWELL AEROSPACE

340797919

99%

31/12/2012

SPERIAN PROTECTION

327359345

90%

31/12/2012

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

348982307

100%

31/12/2012

HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING

309047454

100%

31/12/2012

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRAN...

440331247

100%

31/12/2012

SPERIAN PROTECTION FOOTWEAR GI...

351044607

100%

31/12/2012

SP DEFENSE

379999477

100%

31/12/2012

SPERIAN PROTECTION HUNGARIA KFT

-

60%

-

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS AUTU...

439886730

100%

31/12/2012

EL BEYDA

-

66.70%

-

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS PLAN...

542091699

100%

31/12/2012

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

675450167

100%

31/12/2012

HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY P...

552057440

100%

31/12/2012

SPERIAN PROTECTION RESPIRATORY POLSKA

-

98%

-

SOCIETE ANNIC

778115436

99%

31/12/2012

ANIMAC

-

70%

-

SPERIAN PROTECTION LOGISTIQUE ...

431434208

100%

31/12/2012

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS VALE...

414781013

100%

31/12/2012

SPERIAN PROTECTION FOOTWEAR SLOVAKIA SRO

-

100%

-

BACOU UK

-

100%

-

HONEYWELL FALL PROTECTION FRAN...

338833577

54.56%

31/12/2012

SPERIAN PROTECTION

US49950932

68.52%

-

NACRE US INC

US29623972

100%

-

HONEYWELL HEARING TECHNOLO...

971199636

100%

31/12/2012

BACOU-DALLOZ SAFETY INC.

-

100%

-

SPERIAN PROTECTION INVESTMENT, INC

-

100%

-

100%

2

0 $

-

 

100%

NC

-

-

 

100%

NC

-

-

 

40%

NC

-

-

 

100%

NC

-

-

 

100%

NC

-

-

 

99%

NC

-

-

 

 

SPERIAN PROTECTION DISTRIBUTION DE MEXIC...

-

100%

NC

-

-

PROTECTION SALES DE MEXICO SA DE CV

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTIVE GLOVES USA, LLC

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION OPTICAL, ...

US27305840

100%

23

14 600 $

-

SPERIAN PROTECTION INSTRUMENTATION, LLC

-

100%

NC

-

-

SPERIAN METAL MESH PROTECTIO...

US26358190

100%

69

7 000 $

-

SP USA FINANCE, INC.

-

100%

NC

-

-

SPERIAN EYE & FACE PROTECTIO...

US45031127

100%

46

400 000 $

-

SPERIAN HEARING PROTECTION L...

US26248984

100%

11

38 200 $

-

SPERIAN HEARING PROTECTION DE MEXICO, S....

-

100%

NC

-

-

SPERIAN FALL PROTECTION, INC

US40437296

100%

NC

-

-

SPERIAN FALL PROTECTION CANADA LTD

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTIVE APPAREL USA, LLC

-

100%

NC

-

-

SPERIAN FALL ARREST SYSTEM...

US49701923

100%

34

900 $

-

SPERIAN PROTECTION GLOVES TORI...

MI1907653

100%

NC

-

31/12/2011

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS IBER...

31070

100%

80

0 €

31/12/2012

SPERIAN PROTECTION INDIA PRIVATE LTD

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION NETHERLANDS...

23019696

100%

53

10 000 €

31/12/2011

SPERIAN PROTECTIVE APPAREL LTD

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION ITALIA

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTIVE WORKWEAR DORNO SRL

-

100%

NC

-

-

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS DEUT...

HRA 4021 HL

100%

74

325 000 €

31/12/2011

SPERIAN WELDING PROTECTION AG

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION HOLDING NET...

27065440

99%

43

500 €

31/12/2011

SPERIAN SAFETY LLC

-

100%

NC

-

-

SAFETY TECHNOLOGIES LTD

-

60%

NC

-

-

GAS DETECTION FRANCE

487650814

100%

35

1 000 €

31/12/2012

BD PROJECT 4

487674640

100%

47

1 000 €

31/12/2012

CEP

-

100%

NC

-

-

MUSITANI S.A

-

100%

NC

-

-

COMBISAFE FRANCE SAS

499319218

100%

55

20 000 €

31/12/2012

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS SWEDEN...

5560680893

100%

99

550 KSEK

31/12/2012

DALLOZ HOLDING PTY LTD

-

100%

NC

-

-

SPERIAN FALL PROTECTION AUSTRALIA PTY LT...

-

100%

NC

-

-

AURALGUARD PTY LTD

-

100%

NC

-

-

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS NORD...

5566702162

100%

77

500 KSEK

31/12/2012

SPERIAN PROTECTION AUSTRALIA PTY LTD

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION HONG KONG LTD

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (N...

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION SLOVAKIA S.R.O

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION NEW ZEALAND LTD

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION CHINA CO LTD

-

100%

NC

-

-

COMBISAFE INTERNATIONAL AKTIEB...

5562630664

100%

84

1 350 KSEK

31/12/2012

COMBISAFE DENMARK APS

-

100%

NC

-

-

COMBISAFE DEUTSCHLAND GMBH

HRB 5159

100%

26

0 €

31/12/2011

COMBISAFE NORGE AS

886838972

100%

93

400 KNOK

31/12/2012

COMBISAFE NEDERLAND B.V.

20139451

100%

NC

-

31/12/2011

COMBISAFE GULF LLC

-

100%

NC

-

-

COMBISAFE SUOMI OY

22060629

100%

30

1 500 €

31/12/2010

COMBISAFE INTERNATIONAL (UK) LTD

-

100%

NC

-

-

ADVANCED SCAFFOLD PRODUCTS...

03871922

100%

NC

-

31/12/2012

BACOUDEV2

440337814

100%

20

0 €

31/12/2012

FAGUNIT MOROCCO

-

90%

NC

-

-

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR

497180695

100%

100

1 500 000 €

31/12/2012

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE

338833577

45.44%

95

1 200 000 €

31/12/2012

SPERIAN PROTECTION TUNISIA

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION HOLDING (UK) ...

03730866

100%

69

500 £

31/12/2012

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS (UK)...

01093827

89%

98

135 000 £

31/12/2012

OLDHAM - DALLOZ FALL PROTECTION LTD

-

100%

NC

-

-

I.T.K. (SAFETY) LIMITED

02905213

100%

NC

-

31/12/2008

LOGANDENE LIMITED

01761921

100%

NC

-

31/12/2008

 

SPERIAN PROTECTION DISTRIBUTION DE MEXIC...

-

100%

NC

-

-

PROTECTION SALES DE MEXICO SA DE CV

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTIVE GLOVES USA, LLC

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION OPTICAL, ...

US27305840

100%

23

14 600 $

-

SPERIAN PROTECTION INSTRUMENTATION, LLC

-

100%

NC

-

-

SPERIAN METAL MESH PROTECTIO...

US26358190

100%

69

7 000 $

-

SP USA FINANCE, INC.

-

100%

NC

-

-

SPERIAN EYE & FACE PROTECTIO...

US45031127

100%

46

400 000 $

-

SPERIAN HEARING PROTECTION L...

US26248984

100%

11

38 200 $

-

SPERIAN HEARING PROTECTION DE MEXICO, S....

-

100%

NC

-

-

SPERIAN FALL PROTECTION, INC

US40437296

100%

NC

-

-

SPERIAN FALL PROTECTION CANADA LTD

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTIVE APPAREL USA, LLC

-

100%

NC

-

-

SPERIAN FALL ARREST SYSTEM...

US49701923

100%

34

900 $

-

SPERIAN PROTECTION GLOVES TORI...

MI1907653

100%

NC

-

31/12/2011

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS IBER...

31070

100%

80

0 €

31/12/2012

SPERIAN PROTECTION INDIA PRIVATE LTD

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION NETHERLANDS...

23019696

100%

53

10 000 €

31/12/2011

SPERIAN PROTECTIVE APPAREL LTD

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION ITALIA

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTIVE WORKWEAR DORNO SRL

-

100%

NC

-

-

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS DEUT...

HRA 4021 HL

100%

74

325 000 €

31/12/2011

SPERIAN WELDING PROTECTION AG

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION HOLDING NET...

27065440

99%

43

500 €

31/12/2011

SPERIAN SAFETY LLC

-

100%

NC

-

-

SAFETY TECHNOLOGIES LTD

-

60%

NC

-

-

GAS DETECTION FRANCE

487650814

100%

35

1 000 €

31/12/2012

BD PROJECT 4

487674640

100%

47

1 000 €

31/12/2012

CEP

-

100%

NC

-

-

MUSITANI S.A

-

100%

NC

-

-

COMBISAFE FRANCE SAS

499319218

100%

55

20 000 €

31/12/2012

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS SWEDEN...

5560680893

100%

99

550 KSEK

31/12/2012

 

PROTECTIVE WORKWEAR DORNO SRL

-

100%

NC

-

-

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS DEUT...

HRA 4021 HL

100%

74

325 000 €

31/12/2011

SPERIAN WELDING PROTECTION AG

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION HOLDING NET...

27065440

99%

43

500 €

31/12/2011

SPERIAN SAFETY LLC

-

100%

NC

-

-

SAFETY TECHNOLOGIES LTD

-

60%

NC

-

-

GAS DETECTION FRANCE

487650814

100%

35

1 000 €

31/12/2012

BD PROJECT 4

487674640

100%

47

1 000 €

31/12/2012

CEP

-

100%

NC

-

-

MUSITANI S.A

-

100%

NC

-

-

COMBISAFE FRANCE SAS

499319218

100%

55

20 000 €

31/12/2012

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS SWEDEN...

5560680893

100%

99

550 KSEK

31/12/2012

DALLOZ HOLDING PTY LTD

-

100%

NC

-

-

SPERIAN FALL PROTECTION AUSTRALIA PTY LT...

-

100%

NC

-

-

AURALGUARD PTY LTD

-

100%

NC

-

-

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS NORD...

5566702162

100%

77

500 KSEK

31/12/2012

SPERIAN PROTECTION AUSTRALIA PTY LTD

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION HONG KONG LTD

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (N...

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION SLOVAKIA S.R.O

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION NEW ZEALAND LTD

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION CHINA CO LTD

-

100%

NC

-

-

COMBISAFE INTERNATIONAL AKTIEB...

5562630664

100%

84

1 350 KSEK

31/12/2012

COMBISAFE DENMARK APS

-

100%

NC

-

-

COMBISAFE DEUTSCHLAND GMBH

HRB 5159

100%

26

0 €

31/12/2011

COMBISAFE NORGE AS

886838972

100%

93

400 KNOK

31/12/2012

COMBISAFE NEDERLAND B.V.

20139451

100%

NC

-

31/12/2011

COMBISAFE GULF LLC

-

100%

NC

-

-

COMBISAFE SUOMI OY

22060629

100%

30

1 500 €

31/12/2010

COMBISAFE INTERNATIONAL (UK) LTD

-

100%

NC

-

-

ADVANCED SCAFFOLD PRODUCTS...

03871922

100%

NC

-

31/12/2012

BACOUDEV2

440337814

100%

20

0 €

31/12/2012

FAGUNIT MOROCCO

-

90%

NC

-

-

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR

497180695

100%

100

1 500 000 €

31/12/2012

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE

338833577

45.44%

95

1 200 000 €

31/12/2012

 

SPERIAN PROTECTION TUNISIA

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION HOLDING (UK) ...

03730866

100%

69

500 £

31/12/2012

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS (UK)...

01093827

89%

98

135 000 £

31/12/2012

OLDHAM - DALLOZ FALL PROTECTION LTD

-

100%

NC

-

-

I.T.K. (SAFETY) LIMITED

02905213

100%

NC

-

31/12/2008

LOGANDENE LIMITED

01761921

100%

NC

-

31/12/2008

PULSAFE SAFETY PRODUCTS

-

100%

NC

-

-

SAFETY EYEWARE LIMITED

01250725

100%

NC

-

31/12/2008

PULSAFE EUROPE HOLDING BV

-

100%

NC

-

-

OPMA ARBEITSSCHUTZ GMBH

HRB 4163

100%

73

100 000 €

31/12/2011

HONEYWELL FALL PROTECTION DEUTSC...

HRA 3596

100%

65

135 000 €

31/12/2011

SPERIAN PROTECTION SHANGHAI TRADING CO L...

-

100%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION GLOVES MOROCCO

-

54.50%

NC

-

-

SPERIAN PROTECTION VERWALTUNG GM...

HRB 5562 HL

100%

50

2 500 €

31/12/2011

SPERIAN PROTECTION MANAGEMENT GM...

HRB 3084

100%

57

2 500 €

31/12/2011

SPERIAN PROTECTION ARGENTINA SA

-

100%

NC

-

-

MOXHAM SAFETY PTY LTD

-

100%

NC

-

-

FINANCIERE HONEYWELL

572198984

50%

93

4 200 000 €

31/12/2012

HONEYWELL PITTWAY FRANCE

420206765

86%

100

150 000 €

31/12/2012

NOVAR FRANCE

428737605

100%

92

2 000 000 €

31/12/2012

SECURITE COMMUNICATIONS

310245931

100%

99

2 150 000 €

31/12/2012

L.M.B SA

388595845

100%

75

150 000 €

30/06/2012

HONEYWELL SL

-

Majority

NC

-

-

ADI-GARDINER EMEA

421419755

100%

55

680 000 €

31/12/2012

ADI-GARDINER

732060272

100%

40

72 000 €

31/12/2012

STENTORIUS

712005685

100%

80

420 000 €

31/12/2012

THE GARDINER GROUP

-

100%

NC

-

-

UOP LLC

-

100%

NC

-

-

THOMAS RUSSELL CO.

-

70%

NC

-

-

MAXON INTERNATIONAL BVBA

402966803

Majority

98

905 000 €

31/12/2012

MAXON S A R L

719802910

100%

75

75 000 €

31/12/2011

MAXON CORPORATION

-

100%

NC

-

-

MAXON COMBUSTION EQUIPMENT (SHANGHAI) CO...

-

Majority

NC

-

-

MAXON CORPORATION

-

Majority

NC

-

-

MAXON

-

Majority

NC

-

-

 

Ultimate parent company

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

Direct parent

SPERIAN PROTECTION - 100 %

Group – Number of companies

127

Linkages – Number of companies

309

Number of countries

22

 

Company Name

SIREN

Last account

Turnover

HONEYWELL AUTOMATION INDIA

1729745

31/12/2012

255 928 444 €

HONEYWELL GROUP LTD

03408580

31/12/2012

0 £

HONEYWELL GROUP HOLDING UK II

03896222

31/12/2012

0 £

HONEYWELL ACQUISITIONS II LIMITED

05667809

31/12/2012

0 £

NOVAR LIMITED

02262172

31/12/2012

0 £

HONEYWELL ACQUISITIONS LIMITED

05319521

31/12/2012

0 £

HONEYWELL GROUP HOLDING UK

03893519

31/12/2012

0 £

NOVAR EUROPE LIMITED

00557280

31/12/2012

0 £

HONEYWELL EUROPE FINANCE LIMITED

05764884

31/12/2012

0 £

HONEYWELL NORTH ATLANTIC HOLDINGS LIMITE...

05993855

31/12/2012

0 £

FIRST TECHNOLOGY (2002) LIMITED

04624611

31/12/2012

1 766 404 £

GARRETT THERMAL SYSTEMS UK LIMITED

03327983

31/12/2012

0 £

HONEYWELL CONTROL SYSTEMS LIMITED

00217803

31/12/2012

372 967 000 £

FIRST TECHNOLOGY OVERSEAS LIMITED

04302488

31/12/2012

0 £

NOVAR (STELRAD) LIMITED

02226002

31/12/2012

3 145 000 £

UOP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

05057202

31/12/2012

0 £

FT FINANCE LIMITED

02504094

31/12/2012

0 £

MB GROUP LIMITED

02226007

31/12/2012

0 £

NOVAR EUROPEAN HOLDINGS B.V.

14042256

31/12/2012

-

HONEYWELL GMBH

HRB 40462

31/12/2011

273 126 403 €

HONEYWELL LIMITED

00320495

31/12/2012

0 £

MATRIKON

1943891

31/08/2009

51 521 153 €

NOVAR INTERNATIONAL LIMITED

02957947

31/12/2012

936 000 £

FT NORTH AMERICA LIMITED

05054501

31/12/2012

0 £

PITTWAY SYSTEMS TECHNOLOGY GROUP EUROPE ...

02247430

31/12/2012

16 697 000 £

HONEYWELL UK LIMITED

00301598

31/12/2012

29 633 000 £

HONEYWELL SECURITY UK LIMITED

01248725

31/12/2012

55 345 000 £

HONEYWELL INTERNATIONAL UK LIMITED

00078289

31/12/2012

0 £

NOVAR ELECTRICAL HOLDINGS LIMITED

00866782

31/12/2012

0 £

ABI ACQUISITION 2 LIMITED

03011776

31/12/2012

0 £

ABI ACQUISITION 1 LIMITED

03011781

31/12/2012

0 £

FIRST TECHNOLOGY LIMITED

01882393

31/12/2012

0 £

HONEYWELL GLOBAL TRACKING LIMITED

04154553

31/12/2012

15 957 502 £

 

NOVAR PROPERTIES LIMITED

02340596

31/12/2012

64

235 000 £

0 £

METROLOGIC INSTRUMENTS GMBH

HRB 84857

31/12/2011

73

100 000 €

40 497 €

ADI-GARDINER EMEA LIMITED

02005506

31/12/2012

74

100 000 £

1 785 000 £

HONEYWELL ANALYTICS LIMITED

00412070

31/12/2012

95

1 500 000 £

19 476 000 £

TREND CONTROL SYSTEMS LIMITED

01664519

31/12/2012

97

60 000 £

58 428 000 £

HONEYWELL INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIM...

IE063614

31/12/2012

94

9 000 000 €

0 €

CITY TECHNOLOGY LIMITED

01326515

31/12/2012

93

150 000 £

15 502 000 £

ENVITEC-WISMAR GMBH UMWELTSCHUTZ UND MED...

HRB 1838

31/12/2011

88

100 000 €

11 000 629 €

TRIDIUM EUROPE LIMITED

04088286

31/12/2012

98

305 000 £

7 016 000 £

HONEYWELL NORMALAIR-GARRETT (HOLDINGS) L...

00406281

31/12/2012

97

100 000 £

681 000 £

BRYAN DONKIN RMG GAS CONTROLS LIMITED

03123056

31/12/2012

90

145 000 £

10 714 000 £

EMS SATCOM UK, LTD.

03164520

31/12/2012

89

100 000 £

3 600 000 £

HONEYWELL MEASUREX (IRELAND) LIMITED

IE041581

31/12/2012

97

1 350 000 €

163 334 400 €

NOVAR ED&S LIMITED

00189291

31/12/2012

90

60 000 £

129 921 000 £

UOP LIMITED

00521570

31/12/2012

95

4 100 000 £

94 406 000 £

HYMATIC ENGINEERING COMPANY,LIMITED(THE)

00331969

31/12/2012

54

500 £

6 490 000 £

HONEYWELL HOLDINGS LIMITED

03560836

31/12/2012

84

100 000 £

0 £

HONEYWELL RMG NETHERLANDS B.V.

34105492

31/12/2010

NC

-

3 048 190 €

 

COMBISAFE INTERNATIONAL LIMITED

02814205

31/12/2012

90

60 000 £

5 994 000 £

UOP SERVICES LIMITED

03511545

31/12/2012

97

410 000 £

3 017 980 £

NOVAR OVERSEAS HOLDINGS B.V.

33268514

31/12/2012

91

3 100 000 €

-

CALVARI LIMITED

IE302837

31/12/2012

64

500 €

0 €

ADI-GARDINER LIMITED

01322200

31/12/2012

94

215 000 £

89 614 000 £

HONEYWELL AVIONICS SYSTEMS LIMITED

02160822

31/12/2012

98

100 000 £

171 000 £

ENRAF HOLDING B.V.

27293061

31/12/2012

99

4 250 000 €

-

HONEYWELL HOLDING B.V.

33295972

31/12/2012

66

4 650 000 €

-

HONEYWELL SPECIALTY WAX & ADDITIVES LIMI...

00146739

31/12/2012

90

1 700 000 £

0 £

HONEYWELL AEROSPACE IRELAND LIMITED

IE118718

31/12/2012

91

1 500 €

13 008 000 €

KAC ALARM COMPANY LIMITED

01205354

31/12/2012

94

1 050 000 £

19 367 000 £

NOVAR SYSTEMS LIMITED

00264047

31/12/2012

97

490 000 £

59 837 000 £

MAXON COMBUSTION SYSTEMS LIMITED

01654316

31/12/2012

90

120 000 £

2 087 000 £

PULSAFE EUROPE HOLDINGS B.V.

33220860

31/12/2012

65

2 500 €

-

PILLAR ELECTRICAL OVERSEAS LIMITED

00277288

31/12/2012

64

50 000 £

0 £

HONEYWELL TRANSPORTATION IRELAND LIMITED

IE087753

31/12/2012

92

40 000 €

60 379 000 €

COMBISAFE NEDERLAND B.V.

20139451

31/12/2011

51

110 000 €

-

UOP PRODUCTS UK LIMITED

00502623

31/12/2012

NC

-

1 676 000 £

MATRIKON EUROPE LIMITED

SC209760

31/12/2012

92

185 000 £

4 499 000 £

FT NORTH AMERICA (HOLDINGS) LIMITED

05054486

31/12/2012

69

500 £

0 £

HAND HELD PRODUCTS (UK) LIMITED

03138032

31/12/2012

84

100 000 £

3 443 000 £

UOP MIDDLE EAST COMPANY LIMITED

01376403

31/12/2012

90

50 000 £

2 021 144 £

 

MORNING PRIDE MANUFACTURING, LLC

US47012933

-

17

10 100 $

0 $

HONEYWELL VIDEO SYSTEMS

US47016444

-

69

2 400 $

0 $

SPERIAN RESPIRATORY PROTECTION USA LLC

US48510676

-

11

27 300 $

0 $

HONEYWELL POWER SYSTEMS INC

US48530216

-

53

1 100 $

0 $

HONEYWELL H & BC

US48530217

-

54

37 200 $

0 $

INTELLIGENT AUTOMATION CORP

US48530219

-

8

4 900 $

0 $

HONEYWELL IAC

US48601043

-

20

2 100 $

0 $

HONEYWELL BUILDING SOLUTIONS SES CORP

US48610076

-

19

500 $

0 $

HONEYWELL SENSOTECH INC

US48610591

-

8

0 $

0 $

HONEYWELL ANALYTICS INC

US48610593

-

12

9 800 $

0 $

HONEYWELL BURDICK & JACKSON

US48669023

-

4

0 $

0 $

EMS DEFENSE TECHNOLOGIES, INC

US48763087

-

23

600 $

0 $

INTEGRATED GUIDANCE SYSTEMS LLC

US48881717

-

16

1 700 $

0 $

HONEYWELL INTERNATIONAL FINANCE CORP

US48993263

-

NC

-

15 000 000 $

SPERIAN PROTECTION USA, INC

US49042216

-

16

2 100 $

0 $

HONEYWELL DMC SERVICES INC

US49603322

-

10

9 600 $

0 $

HONEYWELL MEASUREX SYSTEMS INC

US49629768

-

64

18 400 $

0 $

INTERMEC SYSTEMS CORP

US61459094

-

14

1 000 $

0 $

INTERMEC MEDIA PRODUCTS

US61904837

-

11

9 800 $

0 $

INTERMEC INTERNATIONAL INC

US61938386

-

41

600 $

0 $

HONEYWELL GLOBAL FINANCE, LLC

US71942949

-

6

24 300 $

0 $

HONEYWELL FIRE SYSTEMS GROUP SERVICES

US71983825

-

6

1 400 $

0 $

HONEYWELL UTILITY SOLUTIONS

US72030651

-

7

600 $

0 $

HONEYWELL IMAGING & MOBILITY

US72034943

-

47

2 400 $

0 $

HONEYWELL SHARED SERVICES

US72090720

-

8

6 200 $

0 $

NACRE US, INC

US72102405

-

92

1 400 $

0 $

SPERIAN FALL PROTECTION, INC

US72123062

-

8

7 400 $

0 $

SPERIAN PROTECTION APPAREL LIMITED

US72155460

-

50

900 $

0 $

HONEYWELL INDUSTRIAL CONTROLS

US72156731

-

9

500 $

0 $

HONEYWELL TURBO TECHNOLOGIES

US72162279

-

5

1 400 $

0 $

SPERIAN METAL MESH PROTECTION USA INC

US72291189

-

67

1 200 $

0 $

VOCOLLECT HEALTHCARE SYSTEMS, INC

US72307215

-

31

600 $

0 $

INTERMEC SOUTH, INC

US72315431

-

53

800 $

0 $

GENESIS CABLE SYSTEMS, LLC

US72322015

-

76

5 600 $

0 $

HONEYWELL COMMERCIAL ELECTRONIC SYSTEMS

US72358632

-

9

250 $

0 $

COMBISAFE DANMARK APS

-

-

 

-

-

COMBISAFE GULF LLC

-

-

 

-

-

EMS TECHNOLOGIES CANADA LTD

-

-

 

-

-

GARDINER GROUPE EUROPE SAS

-

-

 

-

-

HAND HELD PRODUCTS INTERNATIONAL LTD

-

-

 

-

-

HONEYWELL ACS VENTURES LLC

-

-

 

-

-

HONEYWELL ANALYTICS (SWITZERLAND) GMBH

-

-

 

-

-

HONEYWELL BERMUDA HOLDINGS LP

-

-

 

-

-

HONEYWELL CONTROLS INTERNATIONAL LIMITED

-

-

 

-

-

HONEYWELL FINANCE (CYPRUS) LTD

-

-

 

-

-

HONEYWELL SL

-

-

 

-

-

HONEYWELL SPECIALITY WAX & ADDITIVES INC

-

-

 

-

-

HONEYWELL SPECIALTY WAX & ADDITIVES INC

-

-

 

-

-

MAXON HOLDING BV

-

-

 

-

-

PROTECTIVE PRODUCTS HOLDINGS INC

-

-

 

-

-

RMG REGEL & MESSTECHNIK GMBH

-

-

 

-

-

SATRONIC HOLDINGS AG

-

-

 

-

-

SPERIAN PROTECTION AUSTRALIA PTY LTD

-

-

 

-

-

SPERIAN PROTECTION HONG-KONG LTD

-

-

 

-

-

SPERIAN PROTECTION NEW ZEALAND LTD

-

-

 

-

-

SPERIAN PROTECTION S.A

-

-

 

-

-

SPERIAN PROTECTION SA

-

-

 

-

-

SPERIAN PROTECTION SLOVAKIA S.R.O

-

-

 

-

-

 

FINANCIAL INFORMATION

 

Trends

 

Profitability

Liquidity

Net worth

 

Accounts

Active Account | Passive Account |  Account Results

 

Synthesized Accounts

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

Comparison mode

Average

Median

 

 

Annual Accounts

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Account period (month)

12

12

12

Account Type

Normal

Normal

Normal

Date of capture

17/07/2013

31/08/2012

22/08/2011

Activity Code

4649Z

4649Z

4649Z

Employees

0

0

0

 

Active account

Annual Accounts

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Sector Median 2012

 

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

109 505 299

-3,4%

113 303 785

-4,8%

119 021 914

21 278

514540,9%

- Intangible assets

6 787 609

-15,0%

7 985 727

-12,0%

9 077 839

0

0%

- Tangible assets

1 643 573

-21,8%

2 102 723

-28,1%

2 923 314

5 189

31574,2%

- Financial assets

101 074 117

-2,1%

103 215 335

-3,6%

107 020 761

1 226,50

8240757,5%

Net current assets

297 442 707

2,6%

289 927 032

0,1%

289 518 167

204 874,50

145082,9%

- Stocks

29 172 841

16,8%

24 987 235

10,7%

22 581 966

43 163,50

67486,8%

- Advanced payments

30 587

2,6%

175 162

-60,3%

441 012

0

0%

- Receivables

268 198 311

1,3%

264 683 237

-0,6%

266 305 663

63 073

425118,9%

- Securities and cash

40 968

-49,7%

81 398

-57,1%

189 526

28 407

44,2%

- Prepaid expenses

-

-

-

-

-

87,50

-

Accounts of regularization

3 394 137

-13,4%

3 920 376

-30,2%

5 614 244

0

0%

Total Assets

410 342 145

0,8%

407 151 193

-1,7%

414 154 327

259 109,50

158266,3%

 

Passive Account

Annual Accounts

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Sector Median 2012

 

Shareholders' equity

301 686 794

-1,3%

305 759 121

-1,4%

310 053 221

79 500,50

379377,9%

Share capital

17 750 000

0%

17 750 000

0%

17 750 000

12 000

147816,7%

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

16 715 647

-5,4%

17 664 733

26,0%

14 020 940

0

0%

Liabilities

87 736 951

8,0%

81 230 343

-5,0%

85 539 631

150 126

58342,2%

- Financial liabilities

24 390

-62,1%

64 310

-90,3%

662 881

18 114,50

34,6%

- Advanced payments received

0

0%

0

0%

0

0

0%

- Trade account payables

31 401 950

66,9%

18 810 891

-30,5%

27 053 038

42 914

73074,1%

- Tax and social liabilities

6 872 432

-24,2%

9 062 948

17,3%

7 724 658

34 333

19917,0%

- Other debts and fixed assets liabilities

53 150 658

-3,8%

55 228 875

1,1%

54 639 588

5 395,50

984992,4%

Account regularization

490 274

-12,5%

560 313

0%

0

0

0%

Total liabilities

410 342 145

0,8%

407 151 193

-1,7%

414 154 324

258 877

158408,5%

 

Results

Annual Accounts

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Sector Median 2012

 

Sales of Goods

172 260 864

1,7%

169 317 458

-3,5%

175 409 772

394 641,50

43550,0%

Net turnover

170 406 083

1,6%

167 704 537

0,2%

167 370 520

388 204,50

43796,0%

- of which net export turnover

97 502 397

3,8%

93 954 955

4,3%

90 051 245

0

0%

Operating charges

171 954 288

4,0%

165 359 785

-0,4%

166 082 793

379 979

45153,6%

Operating profit/loss

306 576

-92,3%

3 957 673

-57,6%

9 326 979

7 954

3754,4%

Financial income

11 595 732

-41,8%

19 923 155

-54,9%

44 128 649

33

35138481,8%

Financial charges

14 984 185

-42,6%

26 093 739

-42,1%

45 051 879

853,50

1755516,3%

Financial profit/loss

-3 388 453

45,1%

-6 170 584

-568,4%

-923 230

-176,50

-1919703,4%

Pre-tax net operating income

-3 081 877

-39,3%

-2 212 911

-126,3%

8 403 749

6 777

-45575,5%

Extraordinary income

483 278

1,6%

475 473

-82,6%

2 733 497

0

0%

Extraordinary charges

35 929

-73,2%

134 073

-98,4%

8 542 218

153

23383,0%

Extraordinary profit/loss

447 349

31,0%

341 400

105,9%

-5 808 721

0

0%

Net result

-3 616 180

6,9%

-3 883 426

-2436,3%

-153 115

6 535,50

-55431,3%

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

Normal Account

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Months

12

12

12


Accounts - Active
Current Assets |  Equalization accounts |  Reference

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Grand Total (I to VI)

Net

410 342 145

0,8%

407 151 193

-1,7%

414 154 327

 

Gross

CO

466 495 379

1,3%

460 312 038

-0,5%

462 851 733

 

Amortisation

1A

56 153 234

5,6%

53 160 845

9,2%

48 697 406

 

Non declared distributed capital (I)

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AA

0

0%

0

0%

0

 

Active fixed asset (II)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Total Active fixed asset (II)

Net

109 505 299

-3,4%

113 303 785

-4,8%

119 021 914

 

Gross

BJ

157 083 183

-0,8%

158 277 549

-1,9%

161 360 113

 

Amortisation

BK

47 577 884

5,8%

44 973 764

6,2%

42 338 199

 

Intangilble fixed assets

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R & D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AE

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

60 535

0%

60 535

0%

60 535

 

Gross

AF

60 535

0%

60 535

0%

60 535

 

Amortisation

AG

0

0%

0

0%

0

Goodwill

Net

2 544 495

0%

2 544 495

0%

2 544 495

 

Gross

AH

2 544 495

0%

2 544 495

0%

2 544 495

 

Amortisation

AI

0

0%

0

0%

0

Other intangible fixed assets

Net

4 182 579

-22,3%

5 380 697

-16,9%

6 472 809

 

Gross

AJ

12 656 184

1,6%

12 459 662

1,0%

12 334 705

 

Amortisation

AK

8 473 605

19,7%

7 078 965

20,8%

5 861 896

Pre-payments and down payments

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible Assets

Net

6 787 609

-15,0%

7 985 727

-12,0%

9 077 839

 

Tangilble fixed assets

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Lands

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AN

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AO

0

0%

0

0%

0

Buildings

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AP

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AQ

0

0%

0

0%

0

Plant

Net

145 794

-9,1%

160 447

-18,1%

196 015

Gross

AR

576 041

-1,1%

582 660

0%

582 660

Amortisation

AS

430 247

1,9%

422 213

9,2%

386 645

Other tangible fixed assets

Net

1 407 326

-27,5%

1 942 276

-28,1%

2 700 367

Gross

AT

5 758 390

-24,9%

7 668 894

-8,7%

8 401 089

Amortisation

AU

4 351 064

-24,0%

5 726 618

0,5%

5 700 722

Fixed assets in construction

Net

90 453

0%

0

0%

26 932

Gross

AV

90 453

0%

0

0%

26 932

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AX

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

Sub Total Tangible asset

Net

1 643 573

 

2 102 723

 

2 923 314

 

Financial assets

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

55 482 445

-1,6%

56 401 332

-2,3%

57 724 664

Gross

CU

89 805 188

1,9%

88 147 075

0,0%

88 106 407

Amortisation

CV

34 322 743

8,1%

31 745 743

4,5%

30 381 743

Inter-company receivables

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BC

0

0%

0

0%

0

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

Loans

Net

44 929 654

-2,8%

46 219 586

-5,0%

48 667 649

Gross

BF

44 929 654

0%

46 219 586

0%

48 667 649

Amortisation

BG

0

 

0

 

0

Other financial assets

Net

662 018

11,4%

594 417

-5,4%

628 448

Gross

BH

662 243

11,4%

594 642

-6,5%

635 641

Amortisation

BI

225

0%

225

-96,9%

7 193

Sub Total Financial Assets

 

101 074 117

 

103 215 335

 

107 020 761

 

Current Assets (III)

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Total Assets

Net

297 442 707

2,6%

289 927 032

0,1%

289 518 167

Gross

CJ

306 018 058

2,7%

298 114 112

0,8%

295 877 374

Amortisation

CK

8 575 351

4,7%

8 187 080

28,7%

6 359 207

 

Stocks

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Raw materials

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BL

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BM

0

0%

0

0%

0

Work in progress (goods)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BN

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BR

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BS

0

0%

0

0%

0

Goods for resale

Net

29 172 841

16,8%

24 987 235

10,7%

22 581 966

Gross

BT

32 495 849

16,7%

27 854 474

5,7%

26 361 492

Amortisation

BU

3 323 008

15,9%

2 867 239

-24,1%

3 779 526

Sub Total Stocks

Net

29 172 841

16,8%

24 987 235

10,7%

22 581 966

 

Advance payments to suppliers

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Advance payments to suppliers

Net

30 587

-82,5%

175 162

-60,3%

441 012

Gross

BV

30 587

-82,5%

175 162

-60,3%

441 012

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0

 

Debtors

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Trade accounts receivable

Net

45 577 946

7,5%

42 403 496

59,5%

26 581 585

Gross

BX

45 577 946

7,2%

42 502 800

59,5%

26 650 585

Amortisation

BY

0

0%

99 304

43,9%

69 000

Other debtors

Net

222 028 919

0,4%

221 225 168

-7,5%

239 052 595

Gross

BZ

227 281 262

0,4%

226 445 705

-6,3%

241 563 276

Amortisation

CA

5 252 343

0,6%

5 220 537

107,9%

2 510 681

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

Sub Total Debtors

Net

267 606 865

1,5%

263 628 664

-0,8%

265 634 180

 

Divers

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CD

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

40 968

-49,7%

81 398

-57,1%

189 526

Gross

CF

40 968

-49,7%

81 398

-57,1%

189 526

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

Sub Total Divers

Net

40 968

-49,7%

81 398

-57,1%

189 526

 

Prepaid expenses

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Prepaid expenses

Net

591 446

-43,9%

1 054 573

57,1%

671 483

Gross

CH

591 446

-43,9%

1 054 573

57,1%

671 483

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts (IV to VI)

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Multi-period charges

CW3

0

0%

0

0%

0

Gross

 

0

0%

0

0%

0

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

Gross

 

0

0%

0

0%

0

Currency differential gain

CN3

3 394 137

-13,4%

3 920 376

-30,2%

5 614 244

Gross

 

3 394 137

-13,4%

3 920 376

-30,2%

5 614 244

 

References

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Accounts - Passive
Other capital resources | Provisions for risks and charges | Liabilities | Translation loss | Equalization accounts | References

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Grand Total (I to V)

EE

410 342 145

0,8%

407 151 193

-1,7%

414 154 324

 

Shareholder Equity (I)

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Total shareholders' equity (Total I)

DL

301 686 794

-1,3%

305 759 121

-1,4%

310 053 221

Equity and shareholders' equity

DA

17 750 000

0%

17 750 000

0%

17 750 000

Issue and merger premiums

DB

12 953 320

0%

12 953 320

0%

12 953 320

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

Legal reserve

DD

2 073 899

0%

2 073 899

0%

2 073 899

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

Other reserves

DG

275 567 801

0%

275 567 801

0,0%

275 567 768

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

 

0

0%

0

Profits or losses brought forward

DH

-4 036 540

-2536,3%

-153 115

0%

0

Profit or loss for the period

DI

-3 616 180

6,9%

-3 883 426

-2436,3%

-153 115

Investment grants

DJ

12 196

0%

12 196

0%

12 196

Special tax-allowable reserves

DK

982 298

-31,7%

1 438 446

-22,2%

1 849 153

 

Other capital resources (II)

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

 

Provisions for risks and charges (III)

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

16 715 647

-5,4%

17 664 733

26,0%

14 020 940

Risk provisions

DP

16 666 953

-5,5%

17 632 651

25,8%

14 020 940

Reserves for charges

DQ

48 694

51,8%

32 082

0%

0

  Liabilities (IV)

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Total Liabilities (Total IV)

EC

87 736 951

8,0%

81 230 343

-5,0%

85 539 631

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

Bank loans and liabilities

DU

24 390

-62,1%

64 310

-90,3%

662 881

Sundry loans and financial liabilities

DV

0

0%

0

0%

0

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

Advance payments received for current orders

DW

0

0%

0

0%

0

Trade accounts payables

DX

31 401 950

66,9%

18 810 891

-30,5%

27 053 038

Tax and social security liabilities

DY

6 872 432

-24,2%

9 062 948

17,3%

7 724 658

Fixed asset liabilities

DZ

399 925

0%

399 925

0%

399 925

Other debts

EA

48 547 980

-7,2%

52 331 956

5,3%

49 699 129

 

Translation loss (V)

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Translation loss (Total V)

ED

4 202 753

68,3%

2 496 994

-45,0%

4 540 534

 

Equalization accounts

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Deferred income

EB

490 274

-12,5%

560 313

0%

0

 

References

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Result account
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges | Financial income | Financial charges | Financial charges | Extraordinary charges | Employee profit sharing | Tax on profits | References

1- Operating result (I-II)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Operating result (Total I-II)

GG

306 576

-92,3%

3 957 673

-57,6%

9 326 979

 

2 - Financial result (V - VI)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Financial result (Total V-VI)

GV

-3 388 453

45,1%

-6 170 584

-568,4%

-923 230

 

3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

-3 081 877

-39,3%

-2 212 911

-126,3%

8 403 749

 


4 - Extraordinary result (VII-VIII)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

447 349

31,0%

341 400

105,9%

-5 808 721

 

Profit or loss

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Profit or loss

HN

-3 616 180

6,9%

-3 883 426

-2436,3%

-153 115

 

Total Income (I+III+V+VII)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Total Income (I+III+V+VII)

HL

184 339 874

-2,8%

189 716 086

-14,6%

222 271 918

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

187 956 056

-2,9%

193 599 513

-13,0%

222 425 037

 

Operating income (I)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Total operating income (Total I)

FR

172 260 864

1,7%

169 317 458

-3,5%

175 409 772

 

Operating income (details)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Sale of goods for resale

FC

147 161 167

2,8%

143 125 974

1,2%

141 397 649

 

France

FA

50 363 011

-0,3%

50 489 617

-2,9%

52 022 908

 

Export

FB

96 798 156

4,5%

92 636 357

3,6%

89 374 741

Sale of goods produced

FF

0

0%

0

0%

0

 

France

FD

0

0%

0

0%

0

 

Export

FE

0

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

23 244 916

-5,4%

24 578 563

-5,4%

25 972 871

 

France

FG

22 540 675

-3,1%

23 259 965

-8,1%

25 296 367

 

Export

FH

704 241

-46,6%

1 318 598

94,9%

676 504

Net turnover

FL

170 406 083

1,6%

167 704 537

0,2%

167 370 520

 

France

FJ

72 903 686

-1,1%

73 749 582

-4,6%

77 319 275

 

Export

FK

97 502 397

3,8%

93 954 955

4,3%

90 051 245

 

Stocked production

FM

0

0%

0

0%

0

 

Self-constructed assets

FN

196 521

55,3%

126 510

-84,6%

818 907

 

Operating grants

FO

820

-94,3%

14 341

-63,4%

39 204

 

Release of reserves and provisions

FP

1 657 440

12,6%

1 472 070

-40,5%

2 472 859

 

Other income

FQ

0

0%

0

0%

4 708 282

 

Operating charges (II)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Total operating charges (Total II)

GF

171 954 288

4,0%

165 359 785

-0,4%

166 082 793

 

Exploitation charges

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Purchase of goods for resale

FS

116 771 633

10,2%

106 000 000

3,1%

102 827 061

 

Change in stocks of goods for resale

FT

-4 641 375

-210,9%

-1 492 981

-149,4%

3 019 210

 

Purchase of raw materials

FU

0

0%

0

0%

0

 

Change in stocks of raw materials

FV

0

0%

0

0%

0

 

Other external purchases and charges

FW

36 887 714

-2,2%

37 722 091

3,7%

36 372 490

 

Tax, duty and similar payments

FX

1 344 063

-1,0%

1 358 024

-0,9%

1 370 408

 

Payroll

FY

11 907 293

-10,7%

13 329 317

6,9%

12 473 169

 

Social security costs

FZ

5 897 985

-1,3%

5 973 427

3,7%

5 761 753

 

Depreciation

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Depreciation of fixed assets

GA

1 985 292

2,0%

1 947 030

-3,1%

2 009 046

 

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

0

 

Depreciation/amortisation of current assets

GC

1 155 442

323,3%

272 984

235,4%

81 400

 

Provisions for risks and charges

GD

114 806

-52,4%

241 422

64,9%

146 402

 

Other charges

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Other charges

GE

531 435

6173,6%

8 471

-99,6%

2 021 854

 

Operating charges (III-IV)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

 

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

 

Financial income (V)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Total financial income (Total V)

GP

11 595 732

-41,8%

19 923 155

-54,9%

44 128 649

 

Share financial income

GJ

25 371

-83,2%

150 861

-95,1%

3 067 633

 

Other investment income & capitalised receivables

GK

0

0%

0

0%

0

 

Other interest and similar income

GL

3 123 878

-33,8%

4 717 670

54,2%

3 059 604

 

Released provisions and transferred charges

GM

6 871 957

-29,9%

9 803 032

-32,6%

14 553 377

 

Exchange gains

GN

1 574 526

-70,0%

5 251 592

-77,6%

23 448 035

 

Net income from disposal of investment securities

GO

0

0%

0

0%

0

 

Financial Charge (VI)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Total financial charge (Total VI)

GU

14 984 185

-42,6%

26 093 739

-42,1%

45 051 879

 

Financial reserves and provisions

GQ

9 293 333

-47,2%

17 593 957

-5,5%

18 622 708

 

Interest and similar charges

GR

280 591

-44,0%

501 368

16,3%

431 066

 

Exchange losses

GS

5 410 261

-32,4%

7 998 414

-69,2%

25 998 105

 

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary income (VII)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Total extraordinary income (Total VII)

HD

483 278

1,6%

475 473

-82,6%

2 733 497

 

Extraordinary operating income

HA

0

0%

38 170

5683,3%

660

 

Extraordinary income from capital transactions

HB

7 840

800,1%

871

-100,0%

2 323 690

 

Released provisions and transferred charges

HC

475 438

8,9%

436 432

6,7%

409 147

 

Extraordinary charges (VIII)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

35 929

-73,2%

134 073

-98,4%

8 542 218

 

Extraordinary operating charges

HE

150

-98,4%

9 155

159,4%

3 529

 

Extraordinary charges from capital transactions

HF

34 489

-65,2%

99 193

-98,8%

8 294 228

 

Extraordinary reserves and provisions

HG

1 290

-95,0%

25 725

-89,5%

244 461

 

Employee profit sharing (IX)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

277 599

1,5%

273 591

-34,1%

414 987

 

Tax on profits (X)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Tax on profits (Total X)

HK

704 055

-59,5%

1 738 325

-25,5%

2 333 160

 

References

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

 

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

 

Of which transferred charges

A1

0

0%

0

0%

0

 

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Other incomes tax return forms
Reserve for depreciation | Provisions included in balance sheet | State deadlines claims and debts at the end of period
Table allocation results and other information


Fixed Assets
Grand Total Fixed Assets (I to IV)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

66 726

0%

0

 

Decreasess by transfers

OK2

3 299 590

-3,9%

3 432 447

-85,4%

23 537 235

 

Gross value at the end of period

OL

157 083 184

-0,8%

158 277 551

-1,9%

161 360 115

 

Research and development Charge (Total I)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

C01

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

C02

0

0%

0

0%

0

 

Gross value at the end of period

D0

0

0%

0

0%

0

 

Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Gross value at begin of period

KD

15 064 693

0,8%

14 939 735

11,5%

13 397 269

 

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

196 521

55,3%

126 510

-92,5%

1 684 891

 

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

LV2

0

0%

1 552

-98,9%

142 425

 

Gross value at the end of period

LW

15 261 214

1,3%

15 064 693

0,8%

14 939 735

 

Tangible fixed assets (Total III)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Gross value at begin of period

LN

8 251 554

-8,4%

9 010 681

14,8%

7 847 185

 

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

153 487

103,9%

75 287

-93,6%

1 169 116

 

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

0%

66 726

0%

0

 

Decreasess by transfers

NG2

1 980 157

157,9%

767 688

13559,9%

5 620

 

Gross value at the end of period

NH

6 424 884

-22,1%

8 251 554

-8,4%

9 010 681

 

Financial assets (Total IV)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Gross value at begin of period

LQ

134 961 304

-1,8%

137 409 698

-13,6%

159 071 112

 

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

1 755 214

717,1%

214 812

-87,6%

1 727 776

 

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NJ2

1 319 432

-50,5%

2 663 206

-88,6%

23 389 190

 

Gross value at the end of period

NK

135 397 086

0,3%

134 961 304

-1,8%

137 409 698

 

Reserve for depreciation
Situation and movement of reserve for depreciation
Grand total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Reserve for depreciation value at begin of period

0N

0

0%

0

0%

0

Increases

0P

0

0%

0

0%

0

Decreasess

0Q

0

0%

0

0%

0

 

Reserve for depreciation value at the end of period

0R

0

0%

0

0%

0

 

Research and development charge (Total I)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0

 

Other intangible assets (Total II)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

7 078 965

20,8%

5 861 896

23,4%

4 749 158

Increases

PF

1 394 640

14,6%

1 217 068

3,8%

1 172 381

Decreasess

PG

0

0%

0

0%

59 643

 

Decreasess by budget item transfer

PH

8 473 605

19,7%

7 078 964

20,8%

5 861 896

 

Total fixed assets amotisation (Total III)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

6 148 832

1,0%

6 087 367

15,9%

5 251 037

Increases

QV

590 651

-19,1%

729 961

-12,8%

836 664

Decreases

QW

1 958 172

192,9%

668 498

200049,1%

334

 

Decreasess by budget item transfer

QX

4 781 311

-22,2%

6 148 830

1,0%

6 087 367


Movements during period affecting charge allocated over several period

Charges à répartir ou frais d'émission d'emprunt

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0

 

Premium refund of obligations

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Net value at begining of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

 

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

 

Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Value at begining of period

7C

59 036 228

12,2%

52 618 236

3,3%

50 944 234

Increases

UB

10 564 870

-45,6%

19 403 902

1,6%

19 094 970

Decreases

UC

9 004 834

-30,7%

12 985 911

-25,5%

17 420 969

 

Value at the end of period

UD

60 596 264

2,6%

59 036 227

12,2%

52 618 235

Includes Total allocations

 

Operating

UE

1 270 248

146,9%

514 406

125,8%

227 802

 

Financial

UG

9 293 333

-47,2%

17 593 957

-5,5%

18 622 708

 

Exceptional

UJ

1 290

-95,0%

25 725

-89,5%

244 461

Includes Total Withdrawal

 

Operating

UF

1 657 440

12,2%

1 476 632

-39,9%

2 458 444

 

Financial

UH

6 871 957

-29,9%

9 803 032

-32,6%

14 553 377

 

Exceptional

UK

475 438

8,9%

436 432

6,7%

409 147

 

Total regulated provisions (Total I)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Value at begining of period

3Z

1 438 446

-22,2%

1 849 153

-8,2%

2 013 840

Increases

TS

1 290

-95,0%

25 725

-89,5%

244 461

Decreases

TT

457 438

4,8%

436 432

6,7%

409 147

 

Value at the end of period

TU

982 298

-31,7%

1 438 446

-22,2%

1 849 154

 

Total risk and charge provisions (Total II)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Value at begining of period

5Z

17 664 733

26,0%

14 020 940

-1,6%

14 245 648

Increases

TV

5 799 139

-50,2%

11 644 102

37,0%

8 496 346

Decreases

TW

6 748 225

-15,7%

8 000 309

-8,3%

8 721 054

 

Value at the end of period

TX

16 715 647

-5,4%

17 664 733

26,0%

14 020 940

 

Total Provision for depreciation (Total III)

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Value at begining of period

7B

39 933 048

8,7%

36 748 143

5,9%

34 684 746

Increases

TY

4 764 442

-38,4%

7 734 075

-25,3%

10 354 164

Decreases

TZ

1 799 171

-60,5%

4 549 169

-45,1%

8 290 768

 

Value at the end of period

UA

42 898 319

7,4%

39 933 049

8,7%

36 748 142

 

State deadlines claims and debts at the end of period
State claims

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Gross value

VT

319 042 552

0,7%

316 817 306

-0,4%

318 188 634

 

1 year at most

VU

319 042 552

17,9%

270 597 720

0,4%

269 520 985

 

More than one year

VV

0

0%

46 219 586

-5,0%

48 667 649

 

State of loans

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Claims related to holdings (gross)

UL

0

0%

0

0%

0

 

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

0%

0

0%

0

 

Loans (gross)

UP

44 929 654

-2,8%

46 219 586

-5,0%

48 667 649

 

Loans (1 year at most)

UR

44 929 654

0%

0

0%

0

 

Other financial assets (gross)

UT

662 243

11,4%

594 642

-6,5%

635 641

 

Other financial assets (1 year at most)

UV

662 243

11,4%

594 642

-6,5%

635 641

 

Receivables statement of assets

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Customers doubtful or disputed

VA

0

0%

0

0%

0

 

Other claims customer

UX

45 577 946

7,2%

42 502 800

59,5%

26 650 585

 

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

 

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

 

Personnel and associated accounts

UY

216 980

348,5%

48 378

82,3%

26 538

 

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

3 903

0%

0

 

Income taxes

VM

0

0%

2 162 426

1143,7%

173 872

 

Value added tax

VB

1 575 519

27,9%

1 231 917

-19,9%

1 537 835

 

Other taxes and payments assimilated

VN

0

0%

0

0%

0

 

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

21 748

0%

0

 

Group and Associates

VC

225 313 204

1,2%

222 597 972

-7,1%

239 518 058

 

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

175 559

-53,7%

379 361

23,6%

306 973

 

Prepaid

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Prepaid

VS

591 446

-43,9%

1 054 573

57,1%

671 483

 

State Debt

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Total debt (gross)

VY

87 736 950

8,0%

81 230 344

-5,0%

85 539 631

1 year at most

VZ2

87 736 950

8,0%

81 230 344

-5,0%

85 539 631

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

VZ4

0

0%

0

0%

0

 

Details

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

24 390

-62,1%

64 310

-90,3%

662 881

1 year at most

VG2

24 390

-62,1%

64 310

-90,3%

662 881

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VH2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8A2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8A3

0

0%

0

0%

0

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

31 401 950

66,9%

18 810 891

-30,5%

27 053 038

1 year at most

8B2

31 401 950

66,9%

18 810 891

-30,5%

27 053 038

More than 1 year and 5 years at most

8B3

31 401 950

66,9%

18 810 891

-30,5%

27 053 038

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

2 956 419

17,0%

2 527 512

-3,1%

2 608 129

1 year at most

8C2

2 956 419

17,0%

2 527 512

-3,1%

2 608 129

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

2 271 221

-20,1%

2 841 950

31,0%

2 169 897

1 year at most

8D2

2 271 221

-20,1%

2 841 950

31,0%

2 169 897

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

110 162

-94,0%

1 838 963

-19,5%

2 285 823

1 year at most

8E2

110 162

-94,0%

1 838 963

-19,5%

2 285 823

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (gross)

VW1

881 742

-28,3%

1 230 158

2167,5%

54 252

1 year at most

VW2

881 742

-28,3%

1 230 158

2167,5%

54 252

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

652 887

4,6%

624 365

2,9%

606 556

1 year at most

VQ2

652 887

4,6%

624 365

2,9%

606 556

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

399 925

0%

399 925

0%

399 925

1 year at most

8J2

399 925

0%

399 925

0%

399 925

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

47 167 224

5,8%

44 574 664

1 year at most

VI2

0

0%

47 167 224

5,8%

44 574 664

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More 5 years

VI4

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

48 547 980

840,0%

5 164 732

0,8%

5 124 465

1 year at most

8K2

48 547 980

840,0%

5 164 732

0,8%

5 124 465

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

490 274

-12,5%

560 313

0%

0

1 year at most

8L2

490 274

-12,5%

560 313

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0

 

References

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Loans made during the period

VJ

0

0%

0

0%

0

 

Debt repaid during the period

VK

0

0%

0

0%

0

 

Table allocation results and other information
Dividends distributed

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0

 

Commitments

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

 

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

 

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0

 

Other charges Externes

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

 

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

 

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

 

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

 

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

 

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

 

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0

 

Taxes and Fees

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

 

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0

 

VAT

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

 

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0

 

Average number of employees

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Average number of employees

YP

0

0%

0

0%

0

 

Groups and Shareholders

 

 

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

Groups and Shareholders

ZR

0

-

0

-

-

 

Display parameter

Comparison mode

Average

Median


Ratios
Structure and liquidity | Management or rotation | Profitability of the business | Return on capital


Structure and Liquidity

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Sector Median 2012

 

Fixed Asset Financing

2,33

0%

2,33

2,6%

2,27

2,63

-11,4%

Global Debt

185 days

6,3%

174 days

-5,4%

184 days

123 days

50,4%

Working Capital Fund overall net

441 days

-2,2%

451 days

2,0%

442 days

74 days

495,9%

Financial independence

1236928,22%

160,2%

475445,69%

916,5%

46773,59%

434,46%

284604,7%

More ratios

Solvability

73,52%

-2,1%

75,10%

0,3%

74,86%

34,90%

110,7%

Capacity debt futures

1236928,22%

160,2%

475445,69%

916,5%

46773,59%

1141,41%

108268,4%

Coverage of current assets by net working capital overall

68,40%

-3,3%

70,75%

1,5%

69,69%

45,09%

51,7%

General Liquidity

3,64

9,3%

3,33

5,7%

3,15

0,55

561,8%

Restricted Liquidity

3,64

9,3%

3,33

5,7%

3,15

0,97

275,3%

 

Management or rotation

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Sector Median 2012

 

Need background in operating working capital

443 days

-0,9%

447 days

2,1%

438 days

31 days

1329,0%

Treasury

0 days

0%

0 days

0%

0 days

11 days

0%

Inventory turnover of goods

104 days

8,3%

96 days

6,7%

90 days

99 days

5,1%

Average length of credit granted to customers

96 days

5,5%

91 days

59,6%

57 days

42 days

128,6%

Average length of credit obtained suppliers

76 days

58,3%

48 days

-29,4%

68 days

53 days

43,4%

More ratios

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

0 days

0%

0 days

0%

0 days

0 days

0%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

days

-

days

-

days

1344 days

-

Rotation tangible assets

2652,28%

30,5%

2032,40%

9,4%

1857,47%

1366,11%

94,1%

 

Profitability of the business

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Sector Median 2012

 

Margin trading

20,56%

-10,7%

23,03%

8,4%

21,24

32,57%

-36,9%

Profitability of the business

1,43

-51,5%

2,95

-23,0%

3,83

3,08%

-53,6%

Net profit

 

-2,12%

8,6%

-2,32%

-2477,8%

-0,09%

1,65%

-228,5%

More ratios

Growth rate of turnover (excluding VAT)

 

1,61%

705,0%

0,20%

-90,4%

2,09%

0%

0%

Rates integration

 

12,67%

-17,0%

15,27%

-1,6%

15,52%

21,15%

-40,1%

Rate leasing furniture

 

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Work Factor

82,49%

9,4%

75,40%

7,4%

70,21%

69,94%

17,9%

Weight interests

8,79

-43,5%

15,56%

-42,2%

26,92%

0,23%

3721,7%

 

Return on capital

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Sector Median 2012

 

Cash flow from the overall profitability

-0,77%

-131,8%

2,42%

-56,3%

5,54%

2,57%

-130,0%

Rates of economic profitability

1%

-50,0%

2%

0%

2%

11%

-90,9%

Financial profitability

301686794%

-1,3%

305759121%

-1,4%

310053221%

51745%

582926,0%

Return on investment

3,77%

-48,1%

7,26%

-49,8%

14,45%

7,92%

-52,4%

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

Comparison mode

Average

Median

 

Soldes Intermédiaires de Gestion

 

31/12/2012

 

31/12/2011

 

31/12/2010

Sector Median 2012

 

Turnover

170 406 083

1,6%

167 704 537

0,2%

167 370 520

388 204 € 

43796,0% 

 

Sales of goods

147 161 167

2,8%

143 125 974

1,2%

141 397 649

 

 

- Purchase of goods

116 771 633

10,2%

106 000 000

3,1%

102 827 061

 

 

+/- Stock of goods variation

-4 641 375

-210,9%

-1 492 981

-149,4%

3 019 210

 

 

Trading margin

35 030 909 €

-9,3%

38 618 955 €

8,6%

35 551 378 €

110 544,50 € 

31589,4% 

 

20,56 % CA

-10,7%

23,03 % CA

8,4%

21,24 % CA

33,42 % CA 

-38,5% 

 

Sale of goods produced

23 244 916

-5,4%

24 578 563

-5,4%

25 972 871

 

 

+/- Stocked production

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Self-constructed assets

196 521

55,3%

126 510

-84,6%

818 907

 

 

Period production

23 441 437 €

-5,1%

24 705 073 €

-7,8%

26 791 778 €

9 295,50 € 

252080,5% 

 

13,76 % CA

-6,6%

14,73 % CA

-8,0%

16,01 % CA

2,50 % CA 

450,4% 

 

Trading margin

35 030 909

-9,3%

38 618 955

8,6%

35 551 378

110 544,50 

31589,4% 

+ Period Production

23 441 437

-5,1%

24 705 073

-7,8%

26 791 778

9 295,50 

252080,5% 

- Purchase of raw materials

0

0%

0

0%

0

 

 

+/- Change in stocks of raw materiels

0

0%

0

0%

0

 

 

- Other external purchases and charges

36 887 714

-2,2%

37 722 091

3,7%

36 372 490

 

 

Added value

21 584 632 €

-15,7%

25 601 937 €

-1,4%

25 970 666 €

89 177 € 

24104,3% 

 

12,67 % CA

-17,0%

15,27 % CA

-1,6%

15,52 % CA

21,15 % CA 

-40,1% 

 

Added value

21 584 632 €

-15,7%

25 601 937 €

-1,4%

25 970 666 €

89 177 € 

24104,3% 

+ Operating grants

820

-94,3%

14 341

-63,4%

39 204

 

 

- Tax, duty and similar payments

1 344 063

-1,0%

1 358 024

-0,9%

1 370 408

 

 

- Personal charges

17 805 278

-7,8%

19 302 744

5,9%

18 234 922

 

 

Gross operating surplus

2 436 111 €

-50,8%

4 955 510 €

-22,6%

6 404 540 €

10 821,50 € 

22411,8% 

 

1,43 % CA

-51,5%

2,95 % CA

-23,0%

3,83 % CA

3,09 % CA 

-53,7% 

 

Gross operating surplus

2 436 111 €

-50,8%

4 955 510 €

-22,6%

6 404 540 €

10 821,50 € 

22411,8% 

+ Release of reserves and provisions

1 657 440

12,6%

1 472 070

-40,5%

2 472 859

 

 

+ Other operating income

0

0%

0

0%

4 708 282

 

 

- Depreciation/Amortisation

3 255 540

32,3%

2 461 436

10,0%

2 236 848

 

 

- Other charges

531 435

6173,6%

8 471

-99,6%

2 021 854

 

 

Operating result

306 576 €

-92,3%

3 957 673 €

-57,6%

9 326 979 €

7 994 € 

3735,1% 

 

0,18 % CA

-92,4%

2,36 % CA

-57,6%

5,57 % CA

2,21 % CA 

-91,9% 

 

Operating result

306 576 €

-92,3%

3 957 673 €

-57,6%

9 326 979 €

7 994 € 

3735,1% 

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Financial income

11 595 732

-41,8%

19 923 155

-54,9%

44 128 649

 

 

- Financial charges

14 984 185

-42,6%

26 093 739

-42,1%

45 051 879

 

 

Pre-tax result

-3 081 877 €

-39,3%

-2 212 911 €

-126,3%

8 403 749 €

6 783,50 € 

-45532,0% 

 

-1,81 % CA

-37,1%

-1,32 % CA

-126,3%

5,02 % CA

1,95 % CA 

-192,8% 

 

Extraordinary income

483 278

1,6%

475 473

-82,6%

2 733 497

0% 

- Extraordinary charges

35 929

-73,2%

134 073

-98,4%

8 542 218

 

 

Extraordinary result

447 349 €

31,0%

341 400 €

105,9%

-5 808 721 €

0 € 

0% 

 

0,26 % CA

30,0%

0,20 % CA

105,8%

-3 % CA

0 % CA 

0% 

 

Pre-tax result

-3 081 877 €

-39,3%

-2 212 911 €

-126,3%

8 403 749 €

6 783,50 € 

-45532,0% 

Extraordinary result

447 349 €

31,0%

341 400 €

105,9%

-5 808 721 €

0 € 

0% 

- Employee profit sharing

277 599

1,5%

273 591

-34,1%

414 987

 

 

- Tax on profits

704 055

-59,5%

1 738 325

-25,5%

2 333 160

 

 

Net result

-3 616 182 €

6,9%

-3 883 427 €

-2436,2%

-153 119 €

6 520,50 € 

-55558,7% 

-2,12 % CA

8,6%

-2,32 % CA

-2477,8%

-0,09 % CA

1,64 % CA 

-229,3%


ADDITIONAL INFORMATION

 

Other establishments

 

Branches

4 branch entities in this company

Head office

 
> HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE <<<  - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (4649Z)  in VILLEPINTE  (93420)
 

Secondary establishments

>  SPERIAN PROTECTION EUROPE  - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (4649Z)  in MORBIER  (39400)
>  SPERIAN PROTECTION EUROPE  - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (4649Z)  in MOREZ  (39400)
>  SPERIAN PROTECTION EUROPE  - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (4649Z)  in THANN  (68800)
>  SPERIAN PROTECTION EUROPE  - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (4649Z)  in ROMILLY SUR SEINE  (10100)
> ...

 

 

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas having at least 80% of workforce in same area

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which one activity grouping from 80 to 99% of workforce

 

Workforces

 

Workforce at address

100 to 199 employees

Company workforce

100 to 199 employees

 

Preferential rights details and history

 

Summary of preferential rights

Company monitored since

03/02/2009

 

 

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

 

event history

 

Status history

 

 

No Status History

 

 

Recent publications in Gazettes

 

Publication date

Gazette Name

Description

 

02/08/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

14175 - 348982307 RCS. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE. Forme : Société par actions simplifiée à associé unique. Adresse : 33 rue des Vanesses Immeuble Edison Zone Industrielle Paris Nord 2 93420 Villepinte. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2012.

31/05/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

1535 - 348 982 307 RCS Bobigny. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE. Forme : Société par actions simplifiée à associé unique. Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BURRIER Jerome modification le 24 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT modification le 24 Juillet 2012 Président : DUBOIS Stéphane, Marc en fonction le 13 Mai 2013 Directeur général : TOUCHAIS Olivier en fonction le 23 Mai 2013 Directeur général : BURCKART Christophe en fonction le 23 Mai 2013. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant.

21/05/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

1707 - 348 982 307 RCS Bobigny. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE. Forme : Société par actions simplifiée à associé unique. Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BURRIER Jerome modification le 24 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT modification le 24 Juillet 2012 Directeur général : DUVAL du CHESNAY Olivier, Yves, Marie modification le 06 Mai 2011 Président : DUBOIS Stéphane, Marc en fonction le 13 Mai 2013. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant.

19/05/2013

JAL

Appointment of the social representative

 

 

Journal spécial des sociétés (Le)


Date de décision : 06/05/2013
Société faisant l'objet d'une nomination : 348982307 - HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE, 33 RUE DES VANESSES, ZI PARISNORD II IMM EDISON, 93420 VILLEPINTE
Nominé : Monsieur Olivier TOUCHAIS, 75015 PARIS 15
En la fonction de : Directeur général
Nominé : Monsieur Christophe BURCKART, 78600 MAISONS LAFFITTE
En la fonction de : Directeur général

19/05/2013

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

Journal spécial des sociétés (Le)


Date de décision : 06/05/2013
La société 348982307 - HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE, 33 RUE DES VANESSES, ZI PARISNORD II IMM EDISON, 93420 VILLEPINTE
Fait l'objet du départ de Monsieur Olivier DUVAL du CHESNAY

08/05/2013

JAL

Appointment of the social representative

 

 

Journal spécial des sociétés (Le)


Date de décision : 06/05/2013
Société faisant l'objet d'une nomination : 348982307 - HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE, 33 RUE DES VANESSES, ZI PARISNORD II IMM EDISON, 93420 VILLEPINTE
Nominé : Monsieur Stéphane DUBOIS, 01630 SERGY
En la fonction de : Président

08/05/2013

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

Journal spécial des sociétés (Le)


Date de décision : 06/05/2013
La société 348982307 - HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE, 33 RUE DES VANESSES, ZI PARISNORD II IMM EDISON, 93420 VILLEPINTE
Fait l'objet du départ de Monsieur Christophe LEMOINE

29/08/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

11769 - 348982307 RCS. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE. Forme : Société par actions simplifiée à associé unique. Adresse : 33 rue des Vanesses Immeuble Edison Zone Industrielle Paris Nord 2 93420 Villepinte. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011.

04/05/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

1511 - 348 982 307 RCS Bobigny. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE. Forme : Société par actions simplifiée à associé unique. Activité : .
Commentaires : Modification de la dénomination.

01/06/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

2811 - 348 982 307 RCS Bobigny. SPERIAN PROTECTION EUROPE. Forme : Société par actions simplifiée à associé unique. Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BURRIER Jerome en fonction le 31 Juillet 2007 Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT en fonction le 31 Juillet 2007 Président : LAMOINE Christophe modification le 22 Mars 2011 Directeur général : DUVAL du CHESNAY Olivier, Yves, Marie en fonction le 03 Mai 2011. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant.

24/04/2011

JAL

Appointment of the social representative

 

 

Journal spécial des sociétés (Le)


Société faisant l'objet d'une nomination : 348982307 - SPERIAN PROTECTION EUROPE, 33 RUE DES VANESSES, ZI PARISNORD II IMM EDISON, 93420 VILLEPINTE
Nominé : Monsieur Olivier DUVAL DU CHESNAY, 52 Rue Jean Pierre Timbaud, 92400 COURBEVOIE
En la fonction de : Directeur général
Date d'effet : 30/03/2011

31/03/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

4367 - 348 982 307 RCS Bobigny. SPERIAN PROTECTION EUROPE. Forme : Société par actions simplifiée à associé unique. Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BURRIER Jerome en fonction le 31 Juillet 2007 Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT en fonction le 31 Juillet 2007 Président : LAMOINE Christophe modification le 22 Mars 2011. Activité : .
Commentaires : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.

16/03/2011

JAL

Appointment of the social representative

 

 

Journal spécial des sociétés (Le)


Société faisant l'objet d'une nomination : 348982307 - SPERIAN PROTECTION EUROPE, 33 RUE DES VANESSES, ZI PARISNORD II IMM EDISON, 93420 VILLEPINTE
Nominé : Monsieur Christophe LAMOINE
En la fonction de : Président
Date d'effet : 16/02/2011

16/03/2011

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

Journal spécial des sociétés (Le)


Date de décision : 16/02/2011
La société 348982307 - SPERIAN PROTECTION EUROPE, 33 RUE DES VANESSES, ZI PARISNORD II IMM EDISON, 93420 VILLEPINTE
Fait l'objet du départ de Date d'effet : 16/02/2011

30/08/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

12395 - 348982307 RCS. SPERIAN PROTECTION EUROPE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 33 rue des Vanesses Immeuble Edison Zone Industrielle Paris Nord 2 93420 Villepinte. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

10/08/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

1786 - 348 982 307 RCS Bobigny. SPERIAN PROTECTION EUROPE. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BURRIER Jerome en fonction le 31 Juillet 2007 Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT en fonction le 31 Juillet 2007 Président : RONZE Jérôme en fonction le 06 Septembre 2007 Directeur général : LAMOINE Christophe en fonction le 16 Juillet 2010.
Commentaires : Modification de représentant.

27/07/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

1990 - 348 982 307 RCS Bobigny. SPERIAN PROTECTION EUROPE. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Directeur général : BEAUFILS Marc en fonction le 10 Mai 2007 Commissaire aux comptes suppléant : BURRIER Jerome en fonction le 31 Juillet 2007 Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT en fonction le 31 Juillet 2007 Président : RONZE Jérôme en fonction le 06 Septembre 2007 Directeur général : LAMOINE Christophe en fonction le 16 Juillet 2010.
Commentaires : Modification de représentant.

23/07/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

L'INFORMATEUR JUDICIAIRE


Date de décision : 21/06/2010
La société 348982307 - SPERIAN PROTECTION EUROPE, 30 AV MAURICE RENE SIMONET, 26000 VALENCE
Fait l'objet du départ de Monsieur Marc BEAUFILS

09/07/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

SAINT BRIEUC


Société faisant l'objet d'une nomination : 497180695 - SPERIAN PROTECTION ARMOR, ZI DE LA GARE, BP 9, 22940 PLAINTEL
Nominé :
En la fonction de : Présidente

15/06/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

LES PETITES AFFICHES


Société faisant objet d'une nomination : 440331247 - SPERIAN PROTECTION FRANCE, 33 RUE DES VANESSES, ZI PARIS NORD II, 93420 VILLEPINTE
Nominé :
En la fonction de : Présidente

15/06/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

LES PETITES AFFICHES


Société faisant objet d'une nomination : 379999477 - SPERIAN PROTECTION DEFENSE, 33 RUE DES VANESSES, IMM EDISSON PARIS NORD II, 93420 VILLEPINTE
Nominé :
En la fonction de : Présidente

10/06/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

LES PETITES AFFICHES


Société faisant objet d'une nomination : 552057440 - SPERIAN RESPIRATORY PROTECTION FRANCE, 33 RUE DES VANESSES, IMM EDISON ZI PARIS.ND II, 93420 VILLEPINTE
Nominé :
En la fonction de : Présidente

06/01/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

LES PETITES AFFICHES


Société faisant objet d'une nomination : 499319218 - COMBISAFE FRANCE SAS, 63 BD DE MENILMONTANT, 75011 PARIS 11
Nominé :
En la fonction de : Présidente

07/10/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

9930 - 348982307 RCS. SPERIAN PROTECTION EUROPE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 33 rue des Vanesses Immeuble Edison Zone Industrielle Paris Nord 2 93420 Villepinte. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

09/09/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

8594 - 348982307 RCS. SPERIAN PROTECTION EUROPE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 33 rue des Vanesses Immeuble Edison Zone Industrielle Paris Nord 2, 93420 Villepinte. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

29/11/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

9920 - 348 982 307. RCS Bobigny SPERIAN PROTECTION EUROPE. Forme: Société par actions simplifiée. Adresse du siège social: 33 rue des Vanesses Immeuble Edison Zone Industrielle Paris Nord 2, 93420 Villepinte. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

07/10/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

3391 - RCS Bobigny B 348 982 307. RC 94-B 1054. SPERIAN PROTECTION EUROPE. Forme : S.A.S. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président partant : BRICHETEAU DE LA MORANDIERE (Brice). Nomination du président : RONZE (Jérôme).

12/09/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2207 - RCS Bobigny B 348 982 307. RC 94-B 1054. SPERIAN PROTECTION EUROPE. Forme : S.A.S. Commentaires : modification survenue sur la dénomination.

05/09/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1979 - RCS Bobigny B 348 982 307. RC 94-B 1054. BACOU-DALLOZ EUROPE. Forme : S.A.S. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : commissaire aux comptes suppléant partant : GUENARD (Jean-Pierre). Commissaires aux comptes titulaires partants : ERNST & YOUNG AUDIT CABINET DAUGE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant partant : MOREL (François). Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : BURRIER (Jérôme). Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT.

12/06/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2805 - RCS Bobigny B 348 982 307. RC 94-B 1054. BACOU-DALLOZ EUROPE. Forme : S.A.S. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : directeur général partant : SUHAS (Philippe). Nomination d'un directeur général : BEAUFILS (Marc).

04/02/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2762 - RCS Bobigny B 348 982 307. RC 94-B 1054. BACOU-DALLOZ EUROPE. Forme : S.A.S. Capital : 17 750 000 euros. Commentaires : modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation) et l'administration. Administration : nomination d'un directeur général : SUHAS (Philippe).

25/08/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

4583 - RCS Bobigny B 348 982 307. RC 94-B 1054. BACOU DALLOZ INTERNATIONAL SERVICES. Forme: SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - SAS. Adresse du siège social: immeuble Edison Z.I. Paris Nord 2, 33, rue des Vanesses,93420 Villepinte. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

17/08/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

3472 - RCS Bobigny B 348 982 307. RC 94-B 1054. BACOU-DALLOZ INTERNATIONAL SERVICES. Forme : S.A.S. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président partant : VOEGELI (Christian). Modification du président : BRICHETEAU DE LA MORANDIERE (Brice).

01/09/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2391 - RCS Bobigny B 348 982 307. RC 94-B 1054. BACOU-DALLOZ INTERNATIONAL SERVICES. Forme : S.A.S. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un directeur général : BRICHETEAU DE LA MORANDIERE (Brice).

18/08/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

4034 - RCS Bobigny B 348 982 307. RC 94-B 1054. BACOU DALLOZ INTERNATIONAL SERVICES. Forme: SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. Adresse du siège social: immeuble Edison Z.I. Paris Nord 2, 33, rue des Vanesses,93420 Villepinte. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

06/07/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2154 - RCS Bobigny B 348 982 307. RC 94-B 1054. BACOU-DALLOZ INTERNATIONAL SERVICES. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : Z.I. Paris-Nord 2, immeuble Edison, 33 rue des Vanesses,, 93420 Commentaires : modification survenue sur la dénomination, l'adresse du siège social et l'adresse de l'établissement principal. Etablissement principal - Adresse : Z.I. Paris-Nord 2, immeuble Edison, 33 rue des Vanesses, 93420

21/01/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2822 - RCS Bobigny B 348 982 307. RC 94-B 1054. BACOU DALLOZ FRANCE. Forme : S.A.S. Commentaires : modification survenue sur la forme juridique et l'administration. Administration : administrateurs partants : LEBHAR (Salomon) BACOU-DALLOZ, représentée par CAMUS (Emmanuelle). Modification du président : VOEGELI (Christian). Administrateur partant : BACOU DALLOZ EUROPE, représentée par SUHAS (Philippe).

06/01/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2153 - RCS Bobigny B 348 982 307. RC 94-B 1054. BACOU DALLOZ FRANCE. Forme : S.A. à conseil d'administration. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : MONBEIG (Andrieu, Gérald). Nomination d'un administrateur : BACOU DALLOZ EUROPE, représentée par SUHAS (Philippe).

22/09/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Bobigny B 348982307 RC 94-B 1054 BACOU DALLOZ FRANCE. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 17 271 440 euros. Activité : commercialisation, tant en neuf qu'en occasion, de tous produits industriels, tant pour la société meme que pour les tiers, à la commission ou au forfait négoce d'équipement de sécurité, de protection et de travail. Tant en France qu'à l'étranger, négoce d' articles de protection et de produits de marque. Gestion de la fabrication en sous-traitance de produits de marque. Exploitation d'une plate-forme de stockage. Ordonnancement de fabrication en sous-traitance, en France ou à l' importation des articles d'équipements de protection individuelle du GOUPE BACOU. Tant en France qu'à l'étranger, négoce d'articles d'équipements de protection individuelle sous contrats d' exclusivité du GROUPE BACOU. Exploitation de la marque > Bacou < ou des marques de fabrication et de commerce dont la STE BACOU pourrait devenir propriétaire, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de ses filiales et/ou de sous filiales, par tout moyen et notamment, par tous réseaux de systèmes de distribution, de réseaux de franchise, y compris le développement de tous systèmes d' informations destinées aux sociétés faisant partie du GROUPE BACOU DALLOZ. Développement de systèmes informatiques. Conception de logiciels. Gestion de la ressource informatique du GROUPE BACOU DALLOZ. Acquisition, exploitation, cession, concession de tous brevets, de procédés ou de marques de fabrique. Prestations de manutention, d' entreposage et de services. Acquisition, gestion de valeurs mobilières, de parts d'intérets, de droits mobiliers ou immobiliers. Promotion, distribution de produits d'équipements et de protections, ainsi que les lunettes, les bouchons d'oreilles, les produits commercialisés sous les marques > Bilsom <, > Pulsafe <, > Willson < et > Miller <. Adresse du siège soci

08/09/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Romans B 348982307 RC 88-B 584 BACOU DALLOZ FRANCE. Forme : S.A. Capital : 18 639 376 euros. Adresse du siège social : 168 avenue des Auréats, 26000 Valence. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d' administration et directeur général : VOEGELI (Christian) ( Nom d'usage : VOEGELI). Administrateurs : BACOU- DALLOZ, représentée par CAMUS ( Emmanuelle) ( Nom d'usage : NIKITINE) LEBHAR (Salomon) ( Nom d'usage : LEBHAR) MONBEIG ANDRIEU (Gérald) ( Nom d'usage : MONBEIG ANDRIEU). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET ERNST & YOUNG AUDIT CABINET DAUGE ET ASSOCIES. Commissaires aux comptes suppléants : SOREL (François) ( Nom d'usage : SOREL) GUENARD (Jean- Pierre) ( Nom d'usage : GUENARD). Date d'effet : 30 juin 2004.

14/08/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Romans B 348982307 RC 88-B 584 BACOU DALLOZ FRANCE. Forme : S.A. Capital : 18 639 376 euros. Adresse du siège social : 168 avenue des Auréats, 26000 Valence. Commentaires : modification survenue sur la dénomination. Date d'effet : 30 juin 2003.

17/12/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Romans B 348982307 RC 88-B 584 BACOU S.A. Forme : S.A. Capital : 18 639 376 euros. Activité : commercialisation de tous produits industriels, neufs ou d'occasion pour son propre compte ou pour celui de tiers, à la commission ou au forfait négoce d'équipement de sécurité, de protection et de travail. Négoce d'articles de protection, tant en France qu'à l'étranger et de produits de marque. Gestion de la fabrication en sous-traitance de produits de marque. Exploitation d'une plate-forme de stockage. Ordonnancement de fabrication en sous-traitance en France ou à l'importation d'articles d' équipement de protection individuelle du Groupe BACOU. Négoce, tant en France qu'à l'étranger, d'articles d' équipement de protection individuelle sous contrats d'exclusivité > Bacou <. Exploitation de la marque > Bacou <, de marques de fabrication ou de commerce dont la STE BACOU pourrait etre propriétaire, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de ses filiales ou de sous-filiales par tous moyens et notamment, par tous réseaux de systèmes de distribution, de réseaux de franchise compris. Développement de tous systèmes d' information destinés aux sociétés faisant partie du Groupe BACOU DALLOZ. Développement de systèmes informatiques. Conception de logiciels. Gestion de la ressource informatique du Groupe BACOU DALLOZ. Acquisition, exploitation, cession ou concession de tous brevets, de procédés ou de marques de fabrique. Prestations de manutention, d' entreposage et de services. Acquisition, gestion de valeurs mobilières, de parts d'intérets, de droits mobiliers ou immobiliers. Adresse du siège social : 168 avenue des Auréats, 26000 Valence. Commentaires : modification survenue sur l'activité. Date d'effet : 23 octobre 2002.

19/11/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Romans B 348982307 RC 88-B 584 BACOU S.A. Forme : S.A. Capital : 18 639 376 euros. Adresse du siège social : 168 avenue des Auréats, 26000 Valence. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d'administration et directeur général : VOEGELI ( Christian) ( Nom d'usage : VOEGELI). Administrateurs : BACOU-DALLOZ, représentée par CAMUS (Emmanuelle) ( Nom d'usage : NIKITINE) LEBHAR ( Salomon) ( Nom d'usage : LEBHAR) BACOU (Christophe) ( Nom d'usage : BACOU) BALLEYGUIER (Claude) ( Nom d' usage : BALLEYGUIER). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET ERNST ET YOUNG AUDIT CABINET DAUGE ET ASSOCIES. Commissaires aux comptes suppléants : SOREL (François) ( Nom d'usage : SOREL) GUENARD (Jean-Pierre) ( Nom d'usage : GUENARD). Date d'effet : 27 septembre 2002.

31/07/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Romans B 348982307 RC 88-B 584 BACOU S.A. Forme : S.A. Capital : 18 639 376 euros. Adresse du siège social : 168 avenue des Auréats, 26000 Valence. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d'administration et directeur général : BACOU (Philippe) ( Nom d'usage : BACOU). Administrateurs : LEBHAR (Salomon) ( Nom d'usage : LEBHAR) BACOU ( Christophe) ( Nom d'usage : BACOU). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET ERNST & YOUNG AUDIT CABINET DAUGE ET ASSOCIES. Commissaires aux comptes suppléants : SOREL (François) ( Nom d'usage : SOREL) GUENARD (Jean- Pierre) ( Nom d'usage : GUENARD). Date d'effet : 7 juin 2002.

24/07/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Romans B 348982307 RC 88-B 584 BACOU S.A. Forme : S.A. Capital : 18 639 376 euros. Adresse du siège social : 168 avenue des Auréats, 26000 Valence. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d'administration et directeur général : BACOU (Philippe) ( Nom d'usage : BACOU). Administrateurs : HEDOUIN (Guy) ( Nom d' usage : HEDOUIN) BACOU (Christophe) ( Nom d'usage : BACOU). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET ERNST & YOUNG AUDIT CABINET DAUGE ET ASSOCIES. Commissaires aux comptes suppléants : SOREL (François) ( Nom d'usage : SOREL) GUENARD (Jean-Pierre) ( Nom d'usage : GUENARD). Date d'effet : 17 décembre 2001.

14/02/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Romans B 348982307 RC 88-B 584 BACOU S.A. Forme : S.A. Capital : 18 639 376 euros. Adresse du siège social : 168 avenue des Auréats, 26000 Valence. Commentaires : modification survenue sur le capital (diminution) et l' administration. Ancien capital : 128 145 710 F, soit 19 535 687,55 euros. Fusion-absorption à compter du 1 e r janvier 2001 des sociétés COMMEINHES- REMCO,. RCS Bobigny 586 180 135 et SOFRAF,. RCS Bobigny 552 094 708. Cette fusion n'a pas donné lieu à une augmentation du capital. Administration : président du conseil d'administration : BACOU (Philippe) ( Nom d'usage : BACOU) . Administrateurs : HEDOUIN (Guy) ( Nom d'usage : HEDOUIN) BACOU (Christophe) ( Nom d'usage : BACOU). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET ERNST & YOUNG AUDIT CABINET DAUGE ET ASSOCIES. Commissaires aux comptes suppléants : SOREL (François) ( Nom d'usage : SOREL) GUENARD (Jean-Pierre) ( Nom d'usage : GUENARD). Administrateurs partants à compter du 15 novembre 2001 : STEPHAN ( Walter) et LEIGHT (Hoxard). Fin des fonctions de directeur général : BACOU ( Christophe) et de HEDOUIN (Guy). Administrateur partant : DUVERT (René). Date d'effet : 17 décembre 2001.

22/11/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Romans B 348982307 RC 88-B 584 BACOU S.A. Forme : S.A. Capital : 128 145 710 F. Adresse du siège social : 168 avenue des Auréats, 26000 Valence. Commentaires : modification survenue sur le capital (diminution). Date d'effet : 6 septembre 2001.

26/08/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Romans B 348982307 RC 88-B 584 BACOU S.A. Forme : S.A. Capital : 136 038 870 F. Adresse du siège social : 168 avenue des Auréats, 26000 Valence. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d'administration : BACOU (Philippe) ( Nom d'usage : BACOU) . Directeurs généraux et administrateurs : HEDOUIN (Guy) ( Nom d' usage : HEDOUIN) BACOU (Christophe) ( Nom d'usage : BACOU). Administrateurs : DUVERT (René) ( Nom d'usage : DUVERT) STEPAN (Walter) ( Nom d'usage : STEPAN) LEIGHT (Howard) ( Nom d'usage : LEIGHT) . Commissaires aux comptes titulaires : CABINET ERNST ET YOUNG AUDIT CABINET DAUGE ET ASSOCIES. Commissaires aux comptes suppléants : SOREL (François) ( Nom d'usage : SOREL) GUENARD (Jean- Pierre) ( Nom d'usage : GUENARD). Date d'effet : 29 juin 2001.

29/11/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Romans-sur-Isère B 348982307 RC 88- B 584 BACOU S.A. Forme : S.A. Capital : 136 038 870 F. Adresse du siège social : 168 avenue des Auréats, 26000 Valence. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d'administration : BACOU (Philippe) ( Nom d'usage : BACOU) . Directeurs généraux et administrateurs : HEDOUIN (Guy) ( Nom d' usage : HEDOUIN) BACOU (Christophe) ( Nom d'usage : BACOU). Administrateurs : DUVERT (René) ( Nom d'usage : DUVERT) STEPAN (Walter) ( Nom d'usage : STEPAN) LEIGHT (Howard) ( Nom d'usage : LEIGHT) . Commissaires aux comptes titulaires : K.P.M.G. S.A. MASSOUTRE (Patrick) ( Nom d'usage : MASSOUTRE). Commissaires aux comptes suppléants : S.C.P. DE COMMISAIRES AUX COMPTES J.-C. ANDRE ET AUTRES PURVIS (Robert) ( Nom d'usage : PURVIS). Date d'effet : 9 octobre 2000.

20/08/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Romans-sur-Isère B 348982307 RC 88- B 584 BACOU S.A. Forme : S.A. Capital : 136 038 870 F. Adresse du siège social : 168 avenue des Auréats, 26000 Valence. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d'administration : BACOU (Philippe) ( Nom d'usage : BACOU) . Directeurs généraux et administrateurs : HEDOUIN (Guy) ( Nom d' usage : HEDOUIN) BACOU (Christophe) ( Nom d'usage : BACOU). Administrateurs : DUVERT (René) ( Nom d'usage : DUVERT) STEPAN (Walter) ( Nom d'usage : STEPAN) VANDEPUTTE (Gilbert) ( Nom d'usage : VANDEPUTTE) LEIGHT (Howard) ( Nom d' usage : LEIGHT) DE GRAAF (Pieter) ( Nom d'usage : DE GRAAF). Commissaires aux comptes titulaires : K.P.M.G. S.A. MASSOUTRE (Patrick) ( Nom d'usage : MASSOUTRE). Commissaires aux comptes suppléants : S.C.P. DE COMMISAIRES AUX COMPTES J.C. ANDRE ET AUTRES PURVIS ( Robert) ( Nom d'usage : PURVIS). Date d'effet : 30 juin 2000.

20/08/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Romans-sur-Isère B 348982307 RC 88- B 584 BACOU S.A. Forme : S.A. Capital : 136 038 870 F. Adresse du siège social : 168 avenue des Auréats, 26000 Valence. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d'administration : BACOU (Philippe) ( Nom d'usage : BACOU) . Directeurs généraux et administrateurs : HEDOUIN (Guy) ( Nom d' usage : HEDOUIN) BACOU (Christophe) ( Nom d'usage : BACOU). Administrateurs : DUVERT (René) ( Nom d'usage : DUVERT) STEPAN (Walter) ( Nom d'usage : STEPAN) LEIGHT (Howard) ( Nom d'usage : LEIGHT) DE GRAAF (Pieter) ( Nom d'usage : DE GRAAF). Commissaires aux comptes titulaires : K.P.M.G. S.A. MASSOUTRE ( Patrick) ( Nom d'usage : MASSOUTRE). Commissaires aux comptes suppléants : S. C.P. DE COMMISAIRES AUX COMPTES J.C. ANDRE ET AUTRES PURVIS (Robert) ( Nom d'usage : PURVIS). Date d'effet : 7 juillet 2000.

23/04/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Romans-sur-Isère B 348982307 RC 88- B 584 BACOU S.A. Forme : S.A. Capital : 136 038 870 F. Activité : commercialisation de tous produits industriels, neufs ou d'occasion, tant pour elle meme que pour le compte de tiers, à la commission ou au forfait négoce d' équipements de sécurité, de protection et de travail. Négoce d'articles de protection et de produits de marque, tant en France qu'à l'étranger. Gestion de la fabrication en sous-traitance de produits de marque, exploitation d'une plate-forme de stockage, ordonnancement de fabrication en sous-traitance, en France ou à l'importation, d'articles d' équipements de protection individuelle du GROUPE BACOU. Négoce, tant en France qu'à l'étranger, d'articles et d' équipements de protection individuelle sous contrats d'exclusivité < Bacou >. Exploitation de la marque < Bacou > ou de marques de fabrication ou de commerce dont la STE BACOU pourra etre propriétaire, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de ses filiales et/ou de sous filiales, par tout moyen, notamment par tous réseaux de systèmes de distribution et de franchise. Adresse du siège social : 168 avenue des Auréats, 26000 Valence. Commentaires : modification survenue sur l'adresse du siège social. Date d'effet : 13 mars 2000.

28/03/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

348 982 307. RCS Romans. RC 88-B 584 BACOU S.A. Forme : S.A. Capital : 136 038 870 F (fixe). Adresse du siège social : immeuble Ellipsis, 125 rue de l' Hostellerie, 30900 Nimes. Commentaires : suppression de l'activité de distribution finale de produits d' équipements de protection individuelle auprès de CLIENTS FINAUX FRANCE par suite d'apport de la branche d'activité à BACOU DEVELOPPEMENT, 324 397 363. RCS Nimes, 125 rue de l'Hostellerie, 30900 Nimes. Date d'effet : 31 décembre 1999.

12/03/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nimes B 348982307 RC 99-B 397 BACOU S.A. Forme : S.A. Activité : commercialisation, tant en neuf que d' occasion, de tous produits industriels tant pour elle, meme que pour le compte de tous tiers, à la commission ou au forfait. Négoce d'équipements de sécurité, de protection et de travail, d'articles de protection tant en France qu'à l'étranger, produits de marque, exploitation d'une plate-forme de stockage, ordonnancement de la fabrication en sous-traitance en France ou à l'importation des articles d' équipements de protection individuelle du groupe BACOU. Négoce, tant en France qu'à l'étranger, des articles d' équipements de protection individuelle sous contrats d'exclusivité BACOU, exploitation de la marque BACOU ou des marques de fabrication ou de commerce dont la STE BACOU S.A. est ou pourra etre propriétaire, directement ou indirectement par BACOU ou des marques de fabrication ou de commerce de la STE BACOU S.A., notamment par tous réseaux de systèmes de distribution, réseaux de franchise compris. Adresse du siège social : immeuble Ellipsis, 125 rue de l' Hostellerie, 30900 Nimes. Commentaires : modification survenue sur l'activité. Date d'effet : 31 décembre 1999.

08/06/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Nimes B 348982307 A dater du: 29 avril 1999 RC 99-B 397 BACOU S.A. Forme : S.A. Capital : 136 038 870 F. Adresse du siège social : immeuble Ellipsis, 12 rue de l'Hostellerie, 30900 Nimes. Administration : président du conseil d' administration : BACOU (Philippe). Administrateurs et directeurs généraux : HEDOUIN (Guy) et BACOU (Christophe). Administrateurs : DUVERT (René) STEPHAN (Walter) VANDEPUTTE (Gilbert) LEIGHT (Howard) et DE GRAAF (Pieter). Commissaires aux comptes titulaires : BOYER (Louis) et HANS (Bernard). Commissaires aux comptes suppléants : MAHOUDEAUX BOYER ASSOCIES-M.B.A. et ESTANY (Georges). Commentaires : cette société transfère son siège du 168 avenue des Auréats, 26000 Valence Etablissement principal: Activité : commercialisation, tant en neuf que d' occasion, de tous produits industriels, tant pour elle-meme que pour le compte de tous tiers, à la commission ou au forfait négoce d'équipements de sécurité, de matériel de protection et de travail, en France et à l'étranger. Distribution finale de produits, d' équipements de protection individuelle auprès de clients finaux France. Gestion de la fabrication en sous- traitance de produits de marque. Exploitation d'une plate-forme de stockage. Ordonnancement des fabrications en sous-traitance en France ou à l'importation des articles d'équipements de protection individuelles du GROUPE BACOU. Négoce, en France et à l'étranger des articles d'équipements de protection individuelles sous contrat d' exclusivité < Bacou >. Exploitation de la marque < Bacou > ou des marques de fabrication ou de commerce dont la STE BACOU S.A. est ou pourra etre propriétaire, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de ses filiales et /ou de ses sous- filiales, par tous moyens et notamment par tous réseaux de systèmes de distribution, réseaux de franchises compris. Adresse : 168 avenue des Auréats, 26000 Valence. Date d'effet :

22/05/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS *. RCS Bobigny B 348 982 307 RC RC 94-B 1054 BACOU S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : 168, avenue des Auréats 26000 Valence. Commentaires : achat de la branche d'activité achat, vente, importation, exportation de tous articles de protection individuelle, précédemment donnée en location par la société S.D.F.R.A.F. à la société BACOU.

02/03/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Romans B 348 982 307 RC 88-B 584 BACOU S.A. Forme : S.A. Capital : 136 038 870 F. Adresse du siège social : 168 avenue des Auréats 26000 Romans. Administration : nouvel administrateur : LIEGHT (Howard). Date d'effet : 30 novembre 1998.

09/12/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Romans B 348 982 307 RC 88-B 584 BACOU S.A. Forme : S.A. Capital : 136 038 870 F. Adresse du siège social : 168 avenue des Auréats 26000 Valence. Administration : nouvel administrateur : DE GRAAF (Pieter). Date d'effet : 29 juillet 1997.

29/03/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Romans B 348 982 307 RC 88-B 584 BACOU S.A. Forme : S.A. Capital : 136 038 870 F (fixe). Adresse du siège social : 168 avenue des Auréats, 26000 Valence. Administration : nomination en qualité de directeur général : BACOU ( Christophe), déjà administrateur. Date d'effet : 19 décembre 1996.

25/10/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Romans B 348 982 307 RC 88-B 584 BACOU S.A. Forme : S.A. Capital : 136 038 870 F (fixe). Adresse du siège social : 168 avenue des Auréats, 26000 Valence. Administration : ancien président du conseil d'administration : BACOU (Henri) décédé nouveau président du conseil d' administration : BACOU (Philippe), déjà directeur général et administrateur nouveaux administrateurs : BACOU ( Christophe), VANDEPUTTE (Gilbert). Date d'effet : 4 juillet 1996.

28/10/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Romans B 348982307 RC 88-B 584 BACOU S.A. Forme : S.A. Capital : 136 038 870 F (fixe). Adresse du siège social : 168, avenue des Aureats, 26000 Valence. Administration : administrateur partant : HECKEL (Joseph) administrateur nouveau : STEPAN (Walker). Date d'effet : 30 mai 1995.

04/02/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

RCS Bobigny B 348 982 307 RC 94-B 1054 BACOU S.A. Forme : S.A. Activité : commercialisation, tant en neuf que d' occasion, de tous produits, pour elle- meme et pour le compte de tiers, à la commission et au forfait achat, vente, import-export de tous articles de protection individuelle. Adresse du siège social : 168 avenue des Auréats 26000 Valence Branche d'activité reçue en location-gérance. Date d'effet : 1er décembre 1994 Propriétaire SOCIETE SOFRAF. RCS B 552

 

Company events history

 

 

Date

Description

02/08/2013

Bodacc C : Deposit accounts notice

28/07/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

15/07/2013

Amendment

31/05/2013

Bodacc B: Various editing or changing

23/05/2013

Amendment

23/05/2013

Changes to the Board of Directors

21/05/2013

Bodacc B: Various editing or changing

19/05/2013

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

13/05/2013

Amendment

13/05/2013

New chairman (CEO, CoB)

08/05/2013

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

06/05/2013

Legal Gazette: Appointment of the social representative

31/12/2012

New accounts available

01/09/2012

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

29/08/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

24/07/2012

Amendment

24/07/2012

Updated articles of association

04/05/2012

Bodacc B: Various editing or changing

25/04/2012

Updated articles of association

25/04/2012

Amendment

25/04/2012

Modification to Company Identifier

25/04/2012

Update of Company Name

25/04/2012

New company name

31/12/2011

New accounts available

24/08/2011

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

03/06/2011

New ultimate parent

01/06/2011

Bodacc B: Various editing or changing

03/05/2011

Changes to the Board of Directors

03/05/2011

Amendment

31/03/2011

Bodacc B: Various editing or changing

30/03/2011

Legal Gazette: Appointment of the social representative

22/03/2011

Amendment

22/03/2011

New chairman (CEO, CoB)

22/03/2011

Changes to the Board of Directors

16/03/2011

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

16/02/2011

Legal Gazette: Appointment of the social representative

16/02/2011

Other modification of Establishment (error correction)

16/02/2011

Update of Company Legal Form

31/12/2010

New accounts available

12/11/2010

New ultimate parent

15/10/2010

Update of participations in other companies

15/10/2010

Disengagement in other companies

15/10/2010

New subsidiarie(s) detected

15/10/2010

New ultimate parent

30/08/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

10/08/2010

Bodacc B: Various editing or changing

29/07/2010

Changes to the Board of Directors

29/07/2010

Minutes of general meeting of shareholders

29/07/2010

Amendment

27/07/2010

Bodacc B: Various editing or changing

23/07/2010

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

16/07/2010

Amendment

16/07/2010

Acte modificatif

16/07/2010

Changes to the Board of Directors

16/07/2010

Modification du Conseil d'Administration

07/06/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

19/05/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

03/05/2010

Disengagement in other companies

31/12/2009

New accounts available

24/12/2009

Legal Gazette: Appointment of the social representative

07/10/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

09/09/2009

Acte modificatif

09/09/2009

Updated articles of association

09/09/2009

Statuts mis à jour

09/09/2009

Amendment

03/02/2009

Collection of preferential rights activated for this company

31/12/2008

New accounts available

09/09/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

31/12/2007

New accounts available

06/09/2007

Private document

06/09/2007

Changement de Président (PDG, PCA)

06/09/2007

Amendment

06/09/2007

Acte modificatif

06/09/2007

Statuts mis à jour

06/09/2007

New chairman (CEO, CoB)

06/09/2007

Minutes of general meeting of shareholders

06/09/2007

Appointment/resignation of company officers

06/09/2007

Updated articles of association

03/08/2007

Modification to Company Identifier

03/08/2007

Statuts mis à jour

03/08/2007

Updated articles of association

03/08/2007

Private document

03/08/2007

Update of Company Name

03/08/2007

Acte modificatif

03/08/2007

New company name

03/08/2007

Changement de dénomination sociale

03/08/2007

Minutes of general meeting of shareholders

03/08/2007

PV d'Assemblée

31/07/2007

Appointment/resignation of company officers

31/07/2007

Private document

31/07/2007

PV d'Assemblée

31/07/2007

Acte modificatif

31/07/2007

New auditor

31/07/2007

Changement de Commissaire aux Comptes

31/07/2007

Minutes of general meeting of shareholders

10/05/2007

Nomination/démission des organes de gestion

10/05/2007

Private document

10/05/2007

Minutes of general meeting of shareholders

10/05/2007

Appointment/resignation of company officers

10/05/2007

Modification du Conseil d'Administration

10/05/2007

Acte modificatif

23/01/2007

New company name

23/01/2007

Acte modificatif

23/01/2007

Changement de dénomination sociale

23/01/2007

Private document

23/01/2007

Private document

23/01/2007

Minutes of general meeting of shareholders

23/01/2007

Minutes of general meeting of shareholders

23/01/2007

Modification du Conseil d'Administration

23/01/2007

New company name

23/01/2007

Déclaration de conformité

23/01/2007

Declaration of conformity

23/01/2007

Declaration of conformity

23/01/2007

Updated articles of association

23/01/2007

Statuts mis à jour

23/01/2007

Updated articles of association

31/12/2006

New accounts available

12/12/2006

Audit or Management Report

12/12/2006

Private document

12/12/2006

Private document

12/12/2006

Audit or Management Report

12/12/2006

Rapport des Commissaires ou du Gérant

12/12/2006

Fusion

16/11/2006

Private document

16/11/2006

Projet de Fusion

16/11/2006

Private document

16/11/2006

Fusion

16/11/2006

Planned merger

16/11/2006

Planned merger

03/11/2006

Acte modificatif

03/11/2006

Application and court order

03/11/2006

Application and court order

03/11/2006

Requête et Ordonnance

21/07/2006

Appointment/resignation of company officers

21/07/2006

Private document

21/07/2006

Private document

21/07/2006

Changement de Président (PDG, PCA)

21/07/2006

Minutes of general meeting of shareholders

21/07/2006

Minutes of general meeting of shareholders

21/07/2006

PV d'Assemblée

21/07/2006

Appointment/resignation of company officers

31/12/2005

New accounts available

05/08/2005

Private document

05/08/2005

Acte modificatif

05/08/2005

PV d'Assemblée

05/08/2005

Minutes of general meeting of shareholders

05/08/2005

Minutes of general meeting of shareholders

05/08/2005

Nomination/démission des organes de gestion

05/08/2005

Appointment/resignation of company officers

05/08/2005

Appointment/resignation of company officers

05/08/2005

Private document

05/08/2005

Acte sous seing privé

05/08/2005

Modification du Conseil d'Administration

06/06/2005

Private document

06/06/2005

Private document

06/06/2005

Changement de dénomination sociale

06/06/2005

New company name

06/06/2005

New company name

06/06/2005

Minutes of general meeting of shareholders

06/06/2005

Acte sous seing privé

06/06/2005

Updated articles of association

06/06/2005

Minutes of general meeting of shareholders

06/06/2005

PV d'Assemblée

06/06/2005

Declaration of conformity

06/06/2005

Declaration of conformity

06/06/2005

Déclaration de conformité

06/06/2005

Statuts mis à jour

06/06/2005

Updated articles of association

14/04/2005

Private document

14/04/2005

Planned merger

14/04/2005

Projet de Fusion

14/04/2005

Apport Partiel

14/04/2005

Acte sous seing privé

14/04/2005

Private document

14/04/2005

Planned merger

31/12/2004

New accounts available

23/12/2004

Changement de Forme Juridique sans changement de catégorie

23/12/2004

New legal form – no new category

23/12/2004

New legal form – no new category

23/12/2004

Acte sous seing privé

23/12/2004

Private document

23/12/2004

Private document

23/12/2004

Appointment/resignation of company officers

23/12/2004

Appointment/resignation of company officers

23/12/2004

Nomination/démission des organes de gestion

23/12/2004

Minutes of general meeting of shareholders

23/12/2004

Minutes of general meeting of shareholders

23/12/2004

PV d'Assemblée

23/12/2004

Statuts mis à jour

23/12/2004

Updated articles of association

23/12/2004

Updated articles of association

23/12/2004

Audit or Management Report

23/12/2004

Audit or Management Report

23/12/2004

Rapport des Commissaires ou du Gérant

23/12/2004

Changement de Forme Juridique avec changement de catégorie

07/12/2004

Changes to the Board of Directors

07/12/2004

Changes to the Board of Directors

07/12/2004

Modification du Conseil d'Administration

07/12/2004

Acte sous seing privé

07/12/2004

Private document

07/12/2004

Private document

07/12/2004

Appointment/resignation of company officers

07/12/2004

Appointment/resignation of company officers

07/12/2004

Nomination/démission des organes de gestion

07/12/2004

Minutes of Board meeting

07/12/2004

Minutes of Board meeting

07/12/2004

PV du Conseil d'Administration

07/12/2004

Acte modificatif

27/08/2004

Augmentation de Capital

27/08/2004

Rapport des Commissaires ou du Gérant

27/08/2004

Capital reduction

27/08/2004

Réduction de Capital

27/08/2004

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

27/08/2004

Immatriculation secondaire devient principale

27/08/2004

Secondary registration becomes main registration

27/08/2004

Secondary registration becomes main registration

27/08/2004

Capital reduction

27/08/2004

Audit or Management Report

27/08/2004

Audit or Management Report

27/08/2004

Updated articles of association

27/08/2004

Updated articles of association

27/08/2004

Statuts mis à jour

27/08/2004

PV d'Assemblée

27/08/2004

Minutes of general meeting of shareholders

27/08/2004

Minutes of general meeting of shareholders

27/08/2004

Private document

27/08/2004

Private document

27/08/2004

Acte sous seing privé

02/08/2004

Nomination/démission des organes de gestion

02/08/2004

Appointment/resignation of company officers

02/08/2004

Appointment/resignation of company officers

02/08/2004

PV d'Assemblée

02/08/2004

Minutes of general meeting of shareholders

02/08/2004

Changes to the Board of Directors

02/08/2004

Private document

02/08/2004

Private document

02/08/2004

Acte sous seing privé

02/08/2004

Modification du Conseil d'Administration

02/08/2004

Changes to the Board of Directors

02/08/2004

Minutes of general meeting of shareholders

31/12/2003

New accounts available

28/07/2003

Statuts mis à jour

28/07/2003

PV d'Assemblée

28/07/2003

Changement de dénomination sociale

28/07/2003

Acte sous seing privé

30/01/2003

PV d'Assemblée

30/01/2003

Acte sous seing privé

30/01/2003

Fusion

30/01/2003

Déclaration de conformité

01/01/2003

Requête et Ordonnance

18/12/2002

Acte sous seing privé

18/12/2002

Rapport des Commissaires ou du Gérant

18/12/2002

PV d'Assemblée

18/12/2002

Acte modificatif

29/11/2002

Acte modificatif

29/11/2002

Acte sous seing privé

29/11/2002

Projet de Fusion

29/11/2002

PV d'Assemblée

18/11/2002

Modification de l'objet social

18/11/2002

Modification du Conseil d'Administration

18/11/2002

Acte sous seing privé

18/11/2002

Nomination/démission des organes de gestion

18/11/2002

PV d'Assemblée

18/11/2002

Statuts mis à jour

18/11/2002

Acte modificatif

21/10/2002

Modification du Conseil d'Administration

21/10/2002

Changement de Président (PDG, PCA)

21/10/2002

PV d'Assemblée

21/10/2002

Acte sous seing privé

21/10/2002

Acte modificatif

21/10/2002

Nomination/démission des organes de gestion

21/10/2002

PV du Conseil d'Administration

30/09/2002

Acte modificatif

30/09/2002

Requête et Ordonnance

30/09/2002

PV d'Assemblée

02/07/2002

Acte sous seing privé

02/07/2002

Acte modificatif

02/07/2002

Nomination/démission des organes de gestion

02/07/2002

Modification du Conseil d'Administration

02/07/2002

PV du Conseil d'Administration

01/07/2002

Requête et Ordonnance

10/01/2002

Modification du Conseil d'Administration

10/01/2002

Statuts mis à jour

10/01/2002

PV du Conseil d'Administration

10/01/2002

Réduction de Capital

10/01/2002

Acte modificatif

10/01/2002

Conversion du Capital Social en Euros

10/01/2002

PV d'Assemblée

10/01/2002

Déclaration de conformité

10/01/2002

Nomination/démission des organes de gestion

10/01/2002

Acte sous seing privé

07/12/2001

Acte sous seing privé

07/12/2001

Acte modificatif

07/12/2001

Rapport des Commissaires ou du Gérant

07/12/2001

PV d'Assemblée

06/12/2001

Acte modificatif

06/12/2001

Acte sous seing privé

06/12/2001

PV d'Assemblée

26/11/2001

Projet de Fusion

26/11/2001

Acte modificatif

26/11/2001

Acte sous seing privé

26/11/2001

PV d'Assemblée

19/11/2001

Acte modificatif

19/11/2001

Projet de Fusion

19/11/2001

Acte sous seing privé

19/11/2001

PV d'Assemblée

25/10/2001

Acte sous seing privé

25/10/2001

Réduction de Capital

25/10/2001

PV d'Assemblée

25/10/2001

Acte modificatif

25/10/2001

Statuts mis à jour

25/10/2001

PV du Conseil d'Administration

22/10/2001

Acte modificatif

22/10/2001

PV d'Assemblée

22/10/2001

Requête et Ordonnance

14/08/2001

PV d'Assemblée

14/08/2001

Réduction de Capital

14/08/2001

Acte sous seing privé

31/07/2001

Nomination/démission des organes de gestion

31/07/2001

Changement de Commissaire aux Comptes

31/07/2001

Acte sous seing privé

31/07/2001

PV d'Assemblée

01/01/2001

Requête et Ordonnance

06/11/2000

Nomination/démission des organes de gestion

06/11/2000

Acte sous seing privé

06/11/2000

PV du Conseil d'Administration

06/11/2000

Acte modificatif

06/11/2000

Modification du Conseil d'Administration

28/07/2000

Acte sous seing privé

28/07/2000

Changement de Commissaire aux Comptes

28/07/2000

PV du Conseil d'Administration

28/07/2000

Acte modificatif

28/07/2000

PV d'Assemblée

28/07/2000

Modification du Conseil d'Administration

28/07/2000

Nomination/démission des organes de gestion

22/03/2000

PV d'Assemblée

22/03/2000

Statuts mis à jour

22/03/2000

Immatriculation secondaire devient principale

22/03/2000

Modification de l'objet social

22/03/2000

Acte sous seing privé

18/02/2000

Déclaration de conformité

18/02/2000

PV d'Assemblée

18/02/2000

Acte modificatif

18/02/2000

Acte sous seing privé

18/01/2000

Procuration

18/01/2000

PV d'Assemblée

18/01/2000

Déclaration de conformité

18/01/2000

Acte sous seing privé

07/12/1999

Rapport des Commissaires ou du Gérant

07/12/1999

Statuts

23/11/1999

Acte sous seing privé

23/11/1999

Projet de Fusion

21/06/1999

Acte sous seing privé

21/06/1999

Acte modificatif

21/06/1999

Statuts

29/04/1999

PV d'Assemblée

29/04/1999

Acte sous seing privé

29/04/1999

Immatriculation suite à transfert

29/04/1999

Modification de l'objet social

29/04/1999

Statuts mis à jour

04/02/1999

Acte modificatif

04/02/1999

PV d'Assemblée

04/02/1999

Déclaration de conformité

04/02/1999

Acte sous seing privé

27/01/1999

Modification de l'objet social

27/01/1999

Statuts mis à jour

27/01/1999

PV d'Assemblée

27/01/1999

Acte sous seing privé

01/01/1999

Rapport des Commissaires ou du Gérant

01/01/1999

Acte sous seing privé

18/11/1998

Acte modificatif

18/11/1998

Acte sous seing privé

18/11/1998

PV d'Assemblée

18/11/1998

Projet de Fusion

21/10/1997

Modification du Conseil d'Administration

21/10/1997

PV d'Assemblée

21/10/1997

Acte sous seing privé

21/10/1997

Nomination/démission des organes de gestion

22/05/1997

Requête et Ordonnance

07/04/1997

Acte sous seing privé

07/04/1997

Requête et Ordonnance

14/02/1997

PV d'Assemblée

14/02/1997

Acte modificatif

14/02/1997

PV du Conseil d'Administration

01/01/1997

Modification du Conseil d'Administration

01/01/1997

Nomination/démission des organes de gestion

01/01/1997

Acte sous seing privé

01/01/1997

PV du Conseil d'Administration

23/09/1996

Modification du Conseil d'Administration

23/09/1996

PV du Conseil d'Administration

23/09/1996

Changement de Président (PDG, PCA)

23/09/1996

PV d'Assemblée

23/09/1996

Acte modificatif

23/09/1996

Nomination/démission des organes de gestion

07/09/1995

PV d'Assemblée

07/09/1995

Modification du Conseil d'Administration

07/09/1995

Nomination/démission des organes de gestion

02/12/1993

Acte modificatif

02/12/1993

PV du Conseil d'Administration

26/03/1993

Nomination/démission des organes de gestion

26/03/1993

PV d'Assemblée

12/11/1992

PV d'Assemblée

12/11/1992

Acte modificatif

 

 

Establishment events history

 

 

Date

Description

14/11/2012

Update of phone numbers

25/04/2012

Modification of Head office

16/02/2011

Modification of Head office

29/07/2010

Update Rating

29/12/2009

Update Rating

20/10/2009

Update Limit

20/10/2009

Update Rating

02/10/2009

Update Limit

05/09/2009

Update Rating

02/09/2008

Update Rating

03/07/2008

Update Rating

09/12/2007

Update Limit

13/11/2007

Update of phone numbers

10/10/2007

Update Rating

 

NOTES & COMMENTS

 

Commentary

The comments are ordered according to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative for another or can change depending on its value. This is a purely statistical decision.

 

The shareholder's equity is 301,686,794 €

The ratio total assets to total liabilities is 3,93

The liabilities are 87,736,951 €

The net current assets are 297,442,707 €

The net turnover is 170,406,083 €

The risk provisions are 16,715,647 €

The total assets are 410,342,145 €

The company has 3 directors

Industry code with low risk rating

Department code with low risk rating

The creditor days are 67.26

High risk workforce size

The pre-tax profit is -2,912,125 €

The sales to current assets ratio is 0,57

The stock to turnover ratio is 17.12

The return on total assets employed is -0,71

The decrease of tangible fixed assets over the last two accounting periods is 22 %

 


FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.62.48

UK Pound

1

Rs.102.95

Euro

1

Rs.84.60

 

INFORMATION DETAILS

 

Report Prepared by :

MNL

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

New Business

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.