MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

17.02.2014

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

SAGEM DEFENSE 

 

 

Registered Office :

18 Au 20, 18 Quai Du Point Du Jour, 92100 Boulogne Billancourt

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2011

 

 

Date of Incorporation :

December 2004

 

 

Com. Reg. No.:

RCS Nanterre 1 480 107 911

 

 

Legal Form :

Public limited company with board of directors

 

 

Line of Business :

Manufacturer of navigational aids

 

 

No. of Employees :

6059 (31.12.2011)

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory

 

 

Payment Behaviour :

No Complaints 

 

 

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – december 01, 2013

 

Country Name

Previous Rating

(30.09.2013)

Current Rating

(01.12.2013)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 

france ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With at least 79 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that reduce income disparity and the impact of free markets on public health and welfare. France's real GDP contracted 2.6% in 2009, but recovered somewhat in 2010 and 2011, before stagnating in 2012. The unemployment rate increased from 7.4% in 2008 to 10.3% in 2012. Youth unemployment shot up to 24.2% during the third quarter of 2012 in metropolitan France. Lower-than-expected growth and high unemployment costs have strained France's public finances. The budget deficit rose sharply from 3.4% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 4.5% of GDP in 2012, while France's public debt rose from 68% of GDP to 89% over the same period. Under President SARKOZY, Paris implemented some austerity measures to bring the budget deficit under the 3% euro-zone ceiling by 2013 and to highlight France's commitment to fiscal discipline at a time of intense financial market scrutiny of euro-zone debt. Socialist Party candidate Francois HOLLANDE won the May 2012 presidential election, after advocating pro-growth economic policies, the separation of banks' traditional deposit taking and lending activities from more speculative businesses, increasing the top corporate and personal tax rates, and hiring an additional 60,000 teachers during his five-year term. The government's attempt to introduce a 75% wealth tax on income over one million euros for two years was struck down by the French Constitutional Council in December 2012 because it applied to individuals rather than households. France ratified the EU fiscal stability treaty in October 2012 and HOLLANDE's government has maintained France's commitment to meeting the budget deficit target of 3% of GDP during 2013 even amid signs that economic growth will be lower than the government's forecast of 0.8%. Despite stagnant growth and fiscal challenges, France's borrowing costs declined during the second half of 2012 to euro-era lows.

 

Source : CIA

 

 

 

 
REGISTERED NAME & COMPANY SUMMARY

 

Name

SAGEM DEFENSE

 

Company summary

 

 

 

 

EUR VAT Number

FR39480107911

 

 

Activity (APE)

Manufacture of navigational aids (2651A)

Legal form

Public limited company with board of directors

 

 

Phone

 

RCS Registration

RCS Nanterre 1 480 107 911

 

 

Fax

 

Share capital

372,884,426 Euros

 

 

Address

SAGEM DEFENSE SECURITE
18 AU 20
18 QUAI DU POINT DU JOUR
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Incorporated Date

12/2004

 

 

Nationality

France

Status

Economically active

 

 

Establishment details

 

 

 

Activity (APE)

Manufacture of navigational aids (2651A)

Business Pages FT®

 

 

Postal Address

“Le       Ponant de Paris“ 27,        rue Leblanc F-75512 PARIS CEDEX     15 FRANCE

Trading Address

18 QUAI DU POINT DU JOUR
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

 

Telephone:

+33(0)1 581178  00

 

 

 

Fax

33 (0)1  58 1178 50

 

 

 

DIRECTORS/MANAGEMENT

 

Current Directors

4

Previous Directors

 

 

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

 

Chairman of the Board

M JEAN-LIN FOURNEREAUX

- - -

 

Chairman of the Board

M JEAN HERTEMAN

- - -

 

Chairman of the Board

M PHILIPPE PETITCOLIN

28/09/1952 - SAINT-MIHIEL (55300)

 

Managing director

M BRUNO EVEN

15/03/1968 - LONGJUMEAU (91160)

 

Managing director

M JEAN-LIN FOURNEREAUX

- - -

 

Managing director

M JEAN HERTEMAN

- - -

 

Managing director

M PHILIPPE PETITCOLIN

28/09/1952 - SAINT-MIHIEL (55300)

 

Delegated managing director

M CHRISTIAN JAEGER

- - -

 

Administrator

M BRUNO EVEN

15/03/1968 - LONGJUMEAU (91160)

 

Administrator

M YVES IMBERT

- - -

 

Administrator

M YVES LECLERE

- - -

 

Administrator

M YVES LECLERE

04/08/1950 - LYON

 

Administrator

M YVES LECLERE

04/08/1950 - LYON (69006)

 

Administrator

M ROSS MC INNES

08/03/1954 - CALCULTTA(INDE)

 

Administrator

M PHILIPPE PETITCOLIN

28/09/1952 - SAINT-MIHIEL (55300)

 

Administrator

SAFRAN

30/01/1968 - PARIS 75004

 

Managing director

M JEAN-LIN FOURNEREAUX

11/05/1952 - KASBA TADLA(MAROC)

 

 

NEGATIVE INFORMATION

 

Last published preferential right

This company is not under monitoring

 

 

Collection of preferential rights for this company has been stopped by the Court

 

Judgements

Collective procedures

 

No judgment information for the company

Social security, pension funds preferential rights | Tax office preferential rights

 

Preferential rights details and history

 

Summary of preferential rights

Company monitored since

04/03/2008

 

 

Status of Monitoring

Collection of preferential rights for this company has been stopped by the Court

 

Tax office preferential rights

Number of active preferential rights

0

Total amount

-

Due remaining amount

-

Date of last preferential right

-

 

Historical Data

Registration number

Registration date

Date of the planned end

Creditor

Amount of the debt

Due remaining amount

41106065

23/11/2011

12/09/2012

RECETTE REGIONAL DES DOUANES DE POITIERS

50 743 EUR

-

Reason for closure

Crossed Off

Court

Paris

Creditor

RECETTE REGIONAL DES DOUANES DE POITIERS

Debtor

SA SAGEM DEFENSE SECURITE
LE PONANT DE PARIS 27 R LEBLANC 75015 PARIS

41204838

23/10/2012

30/10/2013

DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

28 987 EUR

-

Reason for closure

Crossed Off

Court

Paris

Creditor

DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

Debtor

SA SAGEM DEFENSE SECURITE
LE PONANT DE PARIS 27 R LEBLANC 75015 PARIS

 

Recent publications in Gazettes

 

 

Publication date

Gazette Name

Description

 

26/11/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1208 - 480 107 911 RCS Nanterre. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Administration : Président du conseil d'administration Administrateur : PETITCOLIN Philippe en fonction le 24 Septembre 2013 Directeur général Administrateur : EVEN Bruno modification le 18 Novembre 2013 Administrateur : SAFRAN en fonction le 24 Septembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS en fonction le 24 Septembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 30 Septembre 2013 Administrateur : ABRIAL Stephane en fonction le 18 Novembre 2013. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant.

18/11/2013

JAL

Appointment of the social representative

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 21/10/2013
Société faisant l'objet d'une nomination : 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, 18 QUAI DU POINT DU JOUR, 18 AU 20, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Nominé : Monsieur Stéphane ABRIAL, 75016 PARIS 16
En la fonction de : Administrateur

18/11/2013

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 21/10/2013
La société 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, 18 QUAI DU POINT DU JOUR, 18 AU 20, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Fait l'objet du départ de Monsieur Yves LECLERE

02/10/2013

Bodacc A

Immatriculation

 

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

487 - 480 107 911 RCS Nanterre. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Administration : Président du conseil d'administration Administrateur : PETITCOLIN Philippe Directeur général Administrateur : EVEN Bruno Administrateur : SAFRAN Administrateur : LECLERE Yves Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS. Capital : 372884426.40 EUR. Adresse : 18-20 quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt.
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du si¿ge hors ressort. Commentaires : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social.

24/09/2013

JAL

Head Office Transfer

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 01/09/2013
Transfert du siège social de la société 480107911 -  SAGEM DEFENSE SECURITE
Adresse du nouveau siège : 18 QUAI DU POINT DU JOUR, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Ancienne localisation : 27 RUE LEBLANC, LE PONANT DE PARIS, 75015 PARIS 15
Date d'effet : 01/09/2013

23/07/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1002 - 480 107 911 RCS Paris. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Administration : nomination du Directeur général et Administrateur : Even, Bruno, Administrateur partant : Mc Innes, Ross, modification de l'Administrateur Petitcolin, Philippe. Capital : 372884426.40 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 27 rue Leblanc, Le Ponant de Paris, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

05/07/2013

JAL

Appointment of the social representative

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 27/06/2013
Société faisant l'objet d'une nomination : 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 RUE LEBLANC, LE PONANT DE PARIS, 75015 PARIS 15
Nominé : Monsieur Bruno EVEN, 64000 PAU
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Monsieur Bruno EVEN, 64000 PAU
En la fonction de : Directeur général

05/07/2013

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 27/06/2013
La société 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 RUE LEBLANC, LE PONANT DE PARIS, 75015 PARIS 15
Fait l'objet du départ de Monsieur Ross MC INNES

17/06/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

9802 - 480107911 RCS. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Adresse : 27 rue Leblanc 75015 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2012.

03/03/2013

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

871 - 334 835 709 RCS Pontoise. SOCIETE FRANCAISE DE DETECTEURS INFRAROUGES - SOFRADIR. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 6000000 EUR. Adresse : 43/47 rue Camille Pelletan, 92290 Châtenay-Malabry.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 5000000 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : dans le domaine de la Techonologie indium Antimonide (Insb) à l'exclusion de l'activité détecteurs pour Autodirecteurs mistral de première génération. Adresse : 72 rue Tour Billy, Bp 72, 95101 Argenteuil Cedex.
Précédent propriétaire : SAGEM DEFENSE SECURITE. 480 107 911 RCS Paris.
Date de commencement de l’activité : 01/01/2013. Publication légale : Le Parisien du 01/02/2013. Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance SOFRADIR (Responsable Juridique) 364 Route de Valence ACTIPOLE - BP 21 38113 VEUREY VOROIZE. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

25/11/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1287 - 480 107 911 RCS Paris. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur partant : Gillyboeuf, Jean Paul. Capital : 372884426.40 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 27 rue Leblanc, Le Ponant de Paris, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

14/11/2012

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 22/05/2012
La société 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 RUE LEBLANC, LE PONANT DE PARIS, 75015 PARIS 15
Fait l'objet du départ de Monsieur Jean-Paul GILLYBOEUF

25/06/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

9712 - 480107911 RCS. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Adresse : 27 rue Leblanc 75015 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011.

08/12/2011

JAL

Proposed merger

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 23/11/2011
Absorbant : 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 RUE LEBLANC, LE PONANT DE PARIS, 75015 PARIS 15
Absorbé : 440293637 - SAGEM INDUSTRIES, 12 RUE COLBERT, BP 30411, 35300 FOUGERES

07/12/2011

JAL

Proposed merger

 

 

Ouest France/Edition d'Ille et Vilaine


Date de décision : 23/11/2011
Absorbant : 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 RUE LEBLANC, LE PONANT DE PARIS, 75015 PARIS 15
Absorbé : 440293637 - SAGEM INDUSTRIES, 12 RUE COLBERT, BP 30411, 35300 FOUGERES

13/07/2011

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

 

65 - HAUTES-PYRENEES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

1398 - 528 855 471 RCS Bordeaux. ALSYOM. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 50000 EUR. Adresse : place Saint-Exupéry, Parc Saint-Exupéry, 33700 Mérignac.
Origine du fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 9306911 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire.
Activité : Réalisation de systèmes mécaniques. Adresse : 12 boulevard Pierre Renaudet, 65000 Tarbes.
Précédent propriétaire : SAGEM DEFENSE SECURITE. 480 107 911 RCS Paris.
Date de commencement de l’activité : 01/03/2011. Publication légale : La dépêche du Midi édition : Hautes-Pyrénées du 03/06/2011. Oppositions : au siège du fonds cédé : 12, boulevard Pierre Renaudet 65000 Tarbes Pour la correspondance : ALCEN 6 rue Paul Baudry 75008 -PARIS-. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

04/07/2011

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

8258 - 480107911 RCS. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Adresse : 27 rue Leblanc 75015 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2010.

29/06/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2019 - 480 107 911 RCS Paris. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Fournereaux, Jean-Lin, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Petitcolin, Philippe. Capital : 372884426.40 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 27 rue Leblanc, Le Ponant de Paris, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

14/06/2011

JAL

Appointment of the social representative

 

 

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Société faisant l'objet d'une nomination : 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 RUE LEBLANC, LE PONANT DE PARIS, 75015 PARIS 15
Nominé : Monsieur Philippe PETITCOLIN, 10 Allée de la Fontaine-au-Blanc, 78860 ST NOM LA BRETECHE
En la fonction de : Président du Conseil d'Administration
Nominé : Monsieur Philippe PETITCOLIN, 10 Allée de la Fontaine-au-Blanc, 78860 ST NOM LA BRETECHE
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Monsieur Philippe PETITCOLIN, 10 Allée de la Fontaine-au-Blanc, 78860 ST NOM LA BRETECHE
En la fonction de : Directeur général
Date d'effet : 07/06/2011

01/04/2011

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

 

33 - GIRONDE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

186 - 528 855 471 RCS Bordeaux. ALSYOM. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : place Saint-Exupery, Parc Saint-Exupery, 33700 Mérignac.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 6400000 Euros. Etablissement : Etablissemennt complémentaire. Activité : montage de pièces mécaniques et industrielles. Adresse : parc d'activités Laseris 1, 33114 le Barp.
Précédent propriétaire : SAGEM DEFENSE SECURIT. 480 107 911 RCS Paris.
Date de commencement de l’activité : 01/01/2011. Publication légale : Les Echos Judiciaires Girondins du 18/03/2011. Oppositions : Au fonds vendu parc d'activités laseris 1 33114 LE BARP pour la validité et pour la correspondance ALCEN 6 rue PAUL BAUDRY 75008 PARIS. Descriptif : Etablissement secondaire/complémentaire acquis par achat. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

18/03/2011

JAL

Activity or goodwill cession

 

 

Echos Judiciaires Girondins (Les)


Date de décision : 15/11/2010
Cédant : 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 RUE LEBLANC, LE PONANT DE PARIS, 75015 PARIS 15
Cessionnaire : 345252084 - SOC ALCEN, 6 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS 8
Prix de vente : 400000 €
Date d’effet : 31/12/2010

02/03/2011

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

 

86 - VIENNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

1628 - 440 293 637 RCS Poitiers. SAGEM INDUSTRIES. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Adresse : 12 rue Colbert, 35300 Fougères.
Origine du fonds : montant de l'évaluation : 1.092.000,00 EUR. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Fabrication d'équipements de communication. Adresse : 26 avenue des Hauts de la Chaume, 86280 Saint-Benoît.
Précédent propriétaire : SAGEM DEFENSE SECURITE. 480 107 911 RCS Poitiers.
A dater du : 06/12/2010. Date de commencement de l’activité : 01/01/2011. Publication légale : LE COURRIER FRANCAIS du 21/01/2011.
Oppositions : A l'adresse du fonds cédé. Descriptif : Achat d'une partie de fonds de commerce afférente à la production et à l'industrialisation des cartes électroniques précédemment exploitée par le précédent propriétaire au 26 avenue des Hauts de la Chaume 86280 SAINT BENOIT. Commentaires : Autre achat, apport, attribution. Date d’effet : 01/01/2011.

21/01/2011

JAL

Activity or goodwill cession

 

 

Courrier Français (Le)/Edition de la Vienne et des deux -Sèvres


Date de décision : 31/12/2010
Cédant : 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 RUE LEBLANC, LE PONANT DE PARIS, 75015 PARIS 15
Cessionnaire : 440293637 - SAGEM INDUSTRIES, 12 RUE COLBERT, BP 30411, 35300 FOUGERES
Prix de vente : 1092000 €
Date d’effet : 01/01/2011

10/12/2010

JAL

Activity or goodwill cession

 

 

Dépêche du Midi (La)/Edition des Hautes Pyrénées


Date de décision : 15/11/2010
Cédant : 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 RUE LEBLANC, LE PONANT DE PARIS, 75015 PARIS 15
Cessionnaire : 345252084 - SOC ALCEN, 6 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS 8
Prix de vente : 6400000 €
Date d’effet : 31/12/2010

08/07/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

7870 - 480107911 RCS. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Adresse : 27 R LEBLANC 75015 PARIS. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

16/06/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2424 - 480 107 911 RCS Paris. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur partant : Le Portz, Louis. Capital : 372884426.40 EUR.
Adresse du siège social : 27 rue Leblanc, Le Ponant de Paris, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

16/06/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2427 - 480 107 911 RCS Paris. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur partant : Imbert, Yves, Commissaire aux comptes titulaire partant : CONSTANTIN ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS, Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS SARL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS. Capital : 372884426.40 EUR.
Adresse du siège social : 27 rue Leblanc, Le Ponant de Paris, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

16/06/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2426 - 480 107 911 RCS Paris. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur partant : Andries, Olivier, nomination de l'Administrateur : Mc Innes, Ross. Capital : 372884426.40 EUR.
Adresse du siège social : 27 rue Leblanc, Le Ponant de Paris, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

16/06/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2425 - 480 107 911 RCS Paris. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Serval, Jean Francois, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL. Capital : 372884426.40 EUR.
Adresse du siège social : 27 rue Leblanc, Le Ponant de Paris, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

06/06/2010

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

 

03 - ALLIER

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET

16 - 520 893 249 RCS Cusset. ASPIC. Forme : Société à responsabilité limitée. Administration : Gérant(e) : BAPTISTA RIBEIRO Georges. Capital : 100000 EUR. Adresse : rue des Champs Elysées, Usine des Jalfrettes Zone Intercommunale, 3500 Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Origine du fonds : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 550000 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : Fabrication de pièces mécaniques, montage de sous ensembles mécaniques, étude et réalisation de tous outils et outillages pour la fabrication de matériaux composites. Adresse : rue des Champs Elysées, Usine des Jalfrettes Zone Intercommunale, 3500 Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Précédent propriétaire : SAGEM DEFENSE SECURITE. 480 107 911 RCS Paris.
Précédent exploitant : SAGEM DEFENSE SECURITE. 480 107 911 RCS Paris.
Date de commencement de l’activité : 01/04/2010. Publication légale : Les Affiches de l'Allier du 06/05/2010. Oppositions : Siège de la sté ASPIC rue des Champs Elysées Usine des Jalfrettes Zone Intercommunale 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule. Descriptif : Mise en activité de la société. Commentaires : Mise en activité d'une société suite à achat.

21/05/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

LES PETITES AFFICHES


Société faisant objet d'une nomination : 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 RUE LEBLANC, LE PONANT DE PARIS, 75015 PARIS 15
Nominé : Monsieur Olivier ANDRIES
En la fonction de : Administrateur

21/05/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

 

LES PETITES AFFICHES


Société faisant objet d'une nomination : 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 RUE LEBLANC, LE PONANT DE PARIS, 75015 PARIS 15
Nominé : Monsieur Ross MC INNES, 2 RUE 2 RUE DU COLONEL COMBES, 75007 PARIS
En la fonction de : Administrateur

21/05/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

LES PETITES AFFICHES


Date de décision : 23/04/2010
La société 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 RUE LEBLANC, LE PONANT DE PARIS, 75015 PARIS 15
Fait l'objet du départ de Monsieur Yves IMBERT

21/05/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

LES PETITES AFFICHES


Date de décision : 11/02/2010
La société 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 RUE LEBLANC, LE PONANT DE PARIS, 75015 PARIS 15
Fait l'objet du départ de Monsieur Olivier ANDRIES

21/05/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

LES PETITES AFFICHES


Date de décision : 03/02/2009
La société 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 RUE LEBLANC, LE PONANT DE PARIS, 75015 PARIS 15
Fait l'objet du départ de Monsieur Louis LE PORTZ

21/05/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

 

LES PETITES AFFICHES


Date de décision : 25/01/2010
La société 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 RUE LEBLANC, LE PONANT DE PARIS, 75015 PARIS 15
Fait l'objet du départ de Monsieur Jean-Paul HERTEMAN

06/05/2010

JAL

Activity or goodwill cession

 

 

les affiches de l'allier


Date de décision : 03/05/2010
Fond cédé : 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, LES JALFRETTES, 03500 SAINT POURCAIN SUR SIOULE
Cédant : 480107911 - SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 RUE LEBLANC, LE PONANT DE PARIS, 75015 PARIS 15
Cessionnaire : 520893249 - ASPIC, USINE DES JALFRETTES, 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE
Prix de vente : 550000 €

08/08/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

11479 - 480107911 RCS. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Adresse : 27 rue Leblanc 75015 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

24/03/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1992 - 480 107 911 RCS Paris. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Capital : 372884426.40 EUR.
Adresse du siège social : 27 rue Leblanc, Le Ponant de Paris, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le capital (diminution).

05/11/2008

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

 

95 - VAL-D'OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

1601 - 440 294 510 RCS Pontoise. SAGEM COMMUNICATIONS SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 158291895 EUR. Adresse : 27 rue Leblanc, le Ponant de Paris, 75015 Paris.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : études industrielles et techniques (Eit) et du centre qualité composants (Cqc). Adresse : 4 rue du Petit Albi, 95807 Cergy Pontoise Cedex.
Précédent propriétaire : SAGEM DEFENSE SECURITE. 480 107 911 RCS Paris.
Publication légale : L'écho - le régional du 31/10/2008. Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance à l'adresse des sièges sociaux respectifs de chaque partie. Descriptif : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 140000 Euros. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

27/08/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1944 - 480 107 911 RCS Paris. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Administration : Directeur général délègué partant : Jaeger, Christian. Capital : 593303000 EUR.
Adresse du siège social : 27 rue Leblanc, Le Ponant de Paris, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

05/08/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1275 - 480 107 911 RCS Paris. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur partant : Sevian, Patrick, nomination de l'Administrateur : Andries, Olivier. Capital : 593303000 EUR.
Adresse du siège social : 27 rue Leblanc, Le Ponant de Paris, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

05/08/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

5336 - 480107911 RCS. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Adresse : 27 rue Leblanc 75015 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

03/04/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2213 - 480 107 911 RCS Paris. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Administration : DIRECTEUR GENERAL DELEGUE partant : FONT, GILBERT. Capital : 593303000 EUR.
Adresse du siège social : 27 R LEBLANC, LE PONANT DE PARIS, 75015 PARIS.
Commentaires : Texte de la publication: RCS Paris B480107911. RC 04-B23402. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : Société anonyme. Capital : 593 303 000 euros. Adresse du siège social : LE PONANT DE PARIS 27 R LEBLANC 75015 PARIS. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : DIRECTEUR GENERAL DELEGUE partant : FONT (GILBERT).

16/12/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

9371 - 480 107 911. RCS Paris SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme: Société anonyme. Adresse du siège social: 27 rue Leblanc 75015 Paris. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

16/12/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

9372 - 480 107 911. RCS Paris SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme: Société anonyme. Adresse du siège social: 27 rue Leblanc 75015 Paris. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

07/11/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

651 - RCS Paris B 480 107 911. RC 04-B 23402. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : S.A. Capital : 593 303 000 euros. Adresse du siège social : Le Ponant de Paris, 27 rue Leblanc,, 75015 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un administrateur : IMBERT (Yves).

07/11/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

652 - RCS Paris B 480 107 911. RC 04-B 23402. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : S.A. Capital : 593 303 000 euros. Adresse du siège social : Le Ponant de Paris, 27 rue Leblanc,, 75015 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d'administration et directeur général partant : HERTEMAN (Jean, Paul). Nomination du président du conseil d'administration et directeur général : FOURNEREAUX (Jean-Lin).

16/09/2007

Bodacc A

Vente et cession

 

 

51 - RCS B 498 660 448. RC 07-B 80. DUONS PRN. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 49 avenue Kléber, 75116 Paris. Etablissement secondaire - Activité : fabrication, commercialisation de lignes de produits acoustiques, d'interrupteurs magnétiques et de détecteurs ferroviaires. Adresse : 32 route de Caen, 14400 Bayeux. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 2 950 000 euros. Date de début d'activité : 29 juin 2007. Précédent propriétaire : SAGEM DEFENSE SECURITE. RCS B 480 107 911. Publication légale : L'Agriculteur normand du 26 juillet 2007. Oppositions : au fonds.

21/01/2007

Bodacc A

Vente et cession

 

 

1350 - RCS B 480 107 911. RC 05-B 2328. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : S.A. Adresse du siège social : Le Ponant de Paris, 27 rue Leblanc, 75015 Paris. Etablissement secondaire - Activité : études, développement, industrialisation, production et fourniture d'équipements terrestres pour véhicules blindés (systèmes de feu, conduites et stabilisations de tourelles et canons, brouilleurs infra-rouges, calculateurs de bord) et supports asservis (lance-missiles Tetral) d'équipements d'artillerie (calculateurs balistiques, stations de travail embarquées, conduites de tirs artillerie et mortier) et de surveillance d'équipements de marine pour navires de combats et frégates (lance-leurres, conduites de tir électro-optiques, systèmes de contrôle optroniques), ainsi que des services associés (support client) . Adresse : parc Technopolis, bâtiment Olympe, zone d'activités de Courtab uf, 91940 Les Ulis. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 9 703 000 euros. Date de début d'activité : 1er décembre 2006. Précédent propriétaire : EADS DEFENSE AND SECURITY SYSTEMS S.A.S. RCS non inscrit. Publication légale : La Semaine de l'Ile-de-France du 19 décembre 2006. Oppositions : au fonds pour la validité et à l'adresse des sièges sociaux respectifs des deux parties, pour la correspondance.

26/12/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1865 - RCS Paris B 480 107 911. RC 04-B 23402. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : S.A. Capital : 593 303 000 euros. Adresse du siège social : Le Ponant de Paris, 27 rue Leblanc,, 75015 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : OLIVIER (Grégoire). Nomination d'un administrateur : GILLYBOEUF (Jean, Paul).

26/12/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1866 - RCS Paris B 480 107 911. RC 04-B 23402. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : S.A. Capital : 593 303 000 euros. Adresse du siège social : Le Ponant de Paris, 27 rue Leblanc,, 75015 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d'administration et directeur général partant : PACCARD (Jacques). Administrateur partant : DUPUY (Daniel). Nomination du président du conseil d'administration et directeur général : HERTEMAN (Jean, Paul). Nomination d'un administrateur : LECLERE (Yves).

27/08/2006

Bodacc A

Vente et cession

 

 

0392 - RCS Versailles B 301 501 391. LABINAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : 9 avenue Franklin, 78180 Montigny-le-Bretonneux. Etablissement secondaire - Activité : conception, fabrication et commercialisation de meubles électriques. Adresse : Z.I. du Vazzio, B.P. 948, 20700 Ajaccio Cedex 9. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 571 158 euros. Date de début d'activité : 1er juillet 2006. Précédent propriétaire : SAGEM DEFENSE SECURITE. RCS Paris 480 107 911. Publication légale : L'Informateur corse du 28 juillet 2006. Oppositions : au fonds.

18/08/2006

Bodacc A

Vente et cession

 

 

0363 - RCS B 301 501 391. RC 06-B 324. LABINAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : 9 avenue Franklin, 78180 Montigny-le-Bretonneux. Etablissement secondaire - Activité : conception, vente de tous objets se rapportant aux installations électriques et notamment, aux meubles électriques pour l'industrie aéronautique. Adresse : Z.I. du Vazzio, B.P. 948, 20700 Ajaccio. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 571 158 euros. Date de début d'activité : 1er juillet 2006. Précédent propriétaire : SAGEM DEFENSE SECURITE. RCS B 480 107 911. Publication légale : L'Informateur corse du 28 juillet 2006. Oppositions : au fonds.

29/06/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

1951 - RCS Paris B 480 107 911. RC 04-B 23402. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : S.A. Capital : 593 303 000 euros. Adresse du siège social : Le Ponant de Paris, 27 rue Leblanc,, 75015 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un directeur général délégué : FONT (Gilbert).

15/06/2006

Bodacc A

Vente et cession

 

 

0321 - Ancienne situation du siège social : RCS Angoulême B 487 737 256. A dater du : 29 décembre 2005. RC 05-B 442. SELP SECURE. Forme : S.A.S. Capital : 40 000 euros. Adresse : La Grand-Marais, 16400 La Couronne. Administration : directeur général : SCHIFANO (Salvatore). Commissaire aux comptes titulaire : GARDILLOU DAMPERAT ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : DAMPERAT (Michel). Nouvelle situation du siège social - Capital : 2 204 000 euros. Adresse : rue Louis-Pergaud, 16000 Angoulême. Etablissement principal - Activité : conception, prototypage, industrialisation, commercialisation de tous types de cartes imprimées et de composants y attachés. Adresse : rue Louis-Pergaud, 16000 Angoulême. Mise en activité de la société suite à l'apport de l'établissement principal au montant évalué à 1 064 000 euros. Date de début d'activité : 1er avril 2006. Date d'effet : 18 mai 2006. Précédent propriétaire : S.A. SAGEM DEFENSE SECURITE. RCS B 480 107 911. Publication légale : Le Courrier français de Charente du 2 juin 2006. Déclarations de créances : au tribunal de commerce d'Angoulême.

04/05/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2270 - RCS Paris B 480 107 911. RC 04-B 23402. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : S.A. Capital : 593 303 000 euros. Adresse du siège social : Le Ponant de Paris, 27 rue Leblanc,, 75015 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : IMBERT (Yves). Nomination d'un administrateur : SAFRAN.

04/05/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2271 - RCS Paris B 480 107 911. RC 04-B 23402. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : S.A. Capital : 593 303 000 euros. Adresse du siège social : Le Ponant de Paris, 27 rue Leblanc,, 75015 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un directeur général délégué : JAEGER (Christian).

11/02/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

 

5622 - RCS Paris B 480 107 911. RC 04-B 23402. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme: S.A. Adresse du siège social: le Ponant de Paris 27, R Leblanc,Paris, 75015 Paris. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

11/09/2005

Bodacc A

Vente et cession

 

 

1553 - RCS B 480 107 911. RC 05-B 2129. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : S.A. Adresse du siège social : Le Ponant-de-Paris, 27 rue Leblanc, 75015 Paris. Etablissement secondaire - Activité : fabrication d'équipements dans le domaine de la défense et de la sécurité comprenant les divisions navigation et systèmes aéronautiques, optroniques et systèmes aéro-terrestres et de sécurité . Adresse : parc d'activité des Bellevues, 21 avenue du Gros-Chêne, 95610 Eragny-sur-Oise. Etablissement secondaire acquis par apport au montant évalué à 594 960 720,76 euros. Date de début d'activité : 10 mai 2005. Précédent propriétaire : SAFRAN. Publication légale : Les Petites affiches du 24 mai 2005. Déclarations de créances : au tribunal de commerce de Pontoise.

11/09/2005

Bodacc A

Vente et cession

 

 

1554 - RCS B 480 107 911. RC 05-B 2129. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : S.A. Adresse du siège social : Le Ponant-de-Paris, 27 rue Leblanc, 75015 Paris. Etablissement secondaire - Activité : fabrication d'équipements dans le domaine de la défense et de la sécurité comprenant les divisions de navigation et de systèmes aéronautiques, optroniques et de systèmes aéro-terrestres et de sécurité . Adresse : 70 rue de la Tour-Billy, 95100 Argenteuil. Etablissement secondaire acquis par apport au montant évalué à 594 960 720,76 euros. Date de début d'activité : 10 mai 2005. Précédent propriétaire : SAFRAN. Publication légale : Les Petites affiches du 24 mai 2005. Déclarations de créances : au tribunal de commerce de Pontoise.

05/07/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2262 - RCS Paris B 480 107 911. RC 04-B 23402. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : S.A. Capital : 593 303 000 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration. Administration : administrateurs partants : PHILIPPE (Hervé) NOGUERA (Dominique). Nomination d'administrateurs : DUPUY (Daniel) IMBERT (Yves) LE PORTZ (Louis) SEVIAN (Patrick).

27/05/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2167 - RCS Paris B 480 107 911. RC 04-B 23402. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination du président du conseil d'administration et directeur général : PACCARD (Jacques). Modification d'un administrateur : OLIVIER (Grégoire).

26/05/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

 

2262 - RCS Paris B 480 107 911. RC 04-B 23402. SAGEM DEFENSE SECURITE. Forme : S.A. Activité : exploitation, tant en France qu'à l'étranger, pour elle-même ou pour le compte de tiers de toutes entreprises ayant trait aux applications générales de l'électricité de la radioélectricité, de l'électronique, de l'optique, de la cryptologie et de la mécanique dans les domaines de l'aéronautique, de la défense et de la sécurité, de toutes activités, produits ou services relevant de ces domaines. Gestion d'un portefeuille de participations et de valeurs mobilières, françaises ou étrangères, ayant trait à son domaine d'exploitation . Commentaires : modification survenue sur la dénomination et l'activité.

13/01/2005

Bodacc A

Création d'établissement

 

 

772 - RCS Paris B 480 107 911. RC 04-B 23402. LEBLANC. Forme : S.A. Capital : 37 000 euros. Activité : participation, directe ou indirecte, par tous moyens à toutes opérations ou entreprises ayant un caractère commercial, industriel, immobilier ou financier gestion d'un portefeuille de participations et de valeurs mobilières, françaises ou étrangères et opérations y afférentes. Acquisition par tous moyens, notamment par voie d'achat, d'échange, de souscription, de tous biens ou droits immobiliers. Réalisation de tous immeubles sur tous terrains acquis ou pris à bail à cet effet. Gestion de son patrimoine immobilier, notamment par voie de location . Adresse du siège social : Le Ponant de Paris, 27 rue Leblanc, 75015 Paris. Administration : président du conseil d'administration et directeur général : OLIVIER (Grégoire). Administrateurs : PHILIPPE (Hervé) NOGUERA (Dominique). Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : SERVAL (Jean, François). Cette société se constitue . Date de début d'activité : 2 décembre 2004.

 

SHARE & SHARE CAPITAL INFORMATION

 

Shareholders

Type of shareholder

Shareholders

 

Shareholder(s)

 

Name

SAFRAN

 

Name of representative

 

 

Manager position

Administrator

Date of birth

 

 

Place of birth

 

 

 

 

Type

Moral person

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. PETITCOLIN PHILIPPE

 

Manager position

Chairman of the Board, Administrator

Date of birth

28/09/1952

 

Place of birth

ST MIHIEL

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. EVEN BRUNO

 

Manager position

Managing director, Administrator

Date of birth

15/03/1968

 

Place of birth

LONGJUMEAU

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

M. ABRIAL STEPHANE

 

Manager position

Administrator

Date of birth

07/09/1954

 

Place of birth

CONDOM

 

 

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

PAYMENT INFORMATION

 

Payment Information Summary - Trade Payment Data

 

Total number of Invoices available

91

 

Total number of Invoices paid within or up to 30 days after the due date

64

 

Total number of Invoices paid more than 30 days after the due date

1

 

Total number of Invoices currently outstanding where the due date has not yet been reached

0

 

Total number of Invoices currently outstanding beyond the due date

26

 

 

GROUP STRUCTURE & AFFILIATED COMPANIES

 

Ultimate Holding Company

 

Company Name

 

 

Company number

 

 

SAFRAN

 

 

562082909

 

 

Ultimate Parent

1 ultimate parent company for this company
>  SAFRAN  - Activités des sièges sociaux (7010Z)  in PARIS 15  (75015)

 

Group data

Ultimate parent company

SAFRAN

Direct parent

SAFRAN - 100 %

Group – Number of companies

146

Linkages – Number of companies

609

Number of countries

33

 

Company Name

 

SIREN

Parts

Last account published

SAFRAN

 

562082909

-

31/12/2010

SNECMA

 

414815217

100%

31/12/2010

FAN BLADE ASSOCIATES INC

 

-

100%

-

CFAN

 

-

50%

-

CFM INTERNATIONAL

 

302527700

50%

31/12/2012

CFM INTERNATIONAL INC

 

US21496522

50%

-

FABRICATIONS MECANIQUES DE L'ATLAN...

 

321853798

50%

31/12/2012

POWERJET

 

434020822

50%

31/12/2009

SNECMA XINYI AIRFOIL CASTINGS CO LTD

 

-

100%

-

HISPANO-SUIZA

 

692015217

100%

31/12/2012

FADEC INTERNATIONAL LLC

 

-

50%

-

HISPANO-SUIZA POLSKA SP. ZOO

 

-

100%

-

ASTRAC

 

484459912

50%

31/12/2011

HERAKLES

 

440513059

100%

31/12/2012

PYROALLIANCE

 

579504119

85%

31/12/2012

ROXEL

 

384122222

50%

31/12/2012

STRUCTIL

 

331620385

80.05%

31/12/2011

REGULUS

 

350490678

40%

31/12/2010

SNECMA SERVICES PARTICIPATIONS INC.

 

-

100%

-

SOCIETE DE MOTORISATIONS AERONAUTI...

 

410773386

100%

31/12/2012

SNECMA MOROCCO ENGINE SERVICES

 

-

51%

-

SNECMA SERVICES BRUSSELS SA

 

464802323

100%

31/12/2012

PROPULSION TECHNOLOGIES INTERNATIO...

 

US33267063

100%

-

SNECMA SUZHOU CO LTD

 

-

100%

-

SNECMA AMERICA ENGINE SERVICES

 

-

100%

-

CFM MATERIALS, LP

 

US37441670

50%

-

SAGEM DEFENSE SECURITE

 

480107911

100%

31/12/2011

SAGEM NAVIGATION GMBH

 

HRB 310819

100%

31/12/2012

SAFRAN ELECTRONICS CANADA INC

 

-

100%

-

MORPHO

 

440305282

100%

31/12/2012

WUHAN SAGEM TIANYU ELECTRONICS CO, LTD

 

-

100%

-

WUHAN TIANYU INFORMATION INDUSTRY CO, LT...

 

-

33.35%

-

MORPHO AUSTRALASIA PTY LTD

 

-

100%

-

SAGEM ORGA GMBH

 

HRB 1350

100%

31/12/2009

SAGEM ORGA PTE LTD

 

-

100%

-

ORGA ZELENOGRAD SMART CARDS AND SYSTEMS ...

 

-

100%

-

SAGEM ORGA DO BRASIL

 

-

100%

-

SMART CHIP LTD

 

-

100%

-

SYSCOM CORPORATION LTD

 

-

100%

-

SAGEM ORGA USA INC

 

-

100%

-

MORPHO CARDS UK LIMITED

 

02586027

100%

31/12/2012

ORGACARD PORTUGAL-CARTOES E SISTEMAS INT...

 

-

100%

-

SAGEM ORGA SA PTY LTD

 

-

100%

-

SAGEM ORGA FZ LLC

 

-

100%

-

SAGEM ORGA SRL

 

-

100%

-

SAGEM ORGA MEXICO

 

-

100%

-

MORPHO B.V.

 

34088563

100%

31/12/2012

SAGEM SÉCURITÉ MAROC

 

-

100%

-

ALEAT

 

-

75%

-

EASYDENTIC INC

 

US38977410

34%

-

VECTRONIX AG

 

4537337

100%

-

VECTRONIX INC

 

US27330525

100%

-

SAFRAN ELECTRONICS ASIA PTE LTD

 

-

100%

-

SOCIETE FRANCAISE DETECTEURS INFRA...

 

334835709

50%

31/12/2012

MORPHO UK LIMITED

 

06195781

100%

31/12/2012

MORPHO SOUTH AFRICA PTY LTD

 

-

100%

-

REOSC

 

492019419

100%

31/12/2012

EUROPROPULSION SA

 

388250797

50%

31/12/2011

SPW INTERNATIONAL

 

417890134

Min blocking

-

MESSIER-BUGATTI-DOWTY

 

712019538

100%

31/12/2012

HYDRAULIC REPAIR AND SUPPORT

 

381211184

50%

31/12/2012

MESSIER-GOODRICH

 

394225528

49.99%

-

MESSIER SERVICES PTE LTD

 

-

100%

-

MESSIER SERVICES ASIA PTE LTD

 

-

100%

-

MESSIER SERVICES INC

 

-

100%

-

AERO PRECISION, INC

 

US13246507

50%

-

MESSIER-DOWTY INCORPORATED

 

-

100%

-

MESSIER SERVICES LIMITED

 

03528628

100%

31/12/2012

MESSIER-DOWTY INTERNATIONAL LIMITE...

 

03548785

100%

31/12/2009

MESSIER-BUGATTI USA LLC WALTON

 

-

100%

-

MESSIER SERVICES AMERICAS

 

-

100%

-

MESSIER SERVICES MEXICO

 

-

100%

-

SUZHOU II

 

-

100%

-

SNECMASAT

 

418540233

100%

31/12/2006

SAGEM MOBILES

 

440349181

100%

31/12/2012

ETABLISSEMENTS VALLAROCHE

 

542028154

100%

31/12/2011

S S I

 

384299277

74%

31/12/2012

VALLAROCHE CONSEIL

 

410163182

99.76%

31/12/2011

SAFRAN CONSULTING

 

440297919

99.76%

31/12/2011

SAFRAN SIXTY

 

440305266

99.98%

31/12/2012

SAFRAN INTERNATIONAL RESOURCES

 

490484631

100%

31/12/2007

INVESTMONDE

 

432807394

33.25%

31/12/2011

SOCIÉTÉ DE RÉASSURANCE VALLAROCHE

 

B27433

100%

-

SOC EXPLOITATION MATERIELS MARTIN BA...

 

592027312

50%

31/12/2012

TURBOMECA

 

338481955

100%

31/12/2012

TURBOMECA CANADA INC.

 

-

100%

-

TURBOMECA DO BRASIL

 

-

100%

-

SA MICROTURBO

 

630800084

100%

31/12/2012

MICROTURBO AUSTRALASIA

 

-

100%

-

TURBOMECA GERMANY GMBH

 

HRB 47905

100%

31/12/2012

TURBOMECA ASIA PACIFIC PTE LTD

 

-

100%

-

TURBOMECA AUSTRALASIA PTY LTD

 

-

100%

-

TURBOMECA AFRICA PTY LTD

 

-

100%

-

TURBOMECA SUD AMERICANA

 

-

100%

-

TURBOMECA AMERICA LATINA

 

-

100%

-

TURBOMECA BEIJING HELICOPTER ENGINES TRA...

 

-

100%

-

SAFRAN UK

 

-

100%

-

TURBOMECA UK LIMITED

 

01148466

100%

31/12/2012

LABINAL AERO & DEFENSE SYSTEMS GMBH

 

-

Majority

-

SAFRAN USA INC

 

-

100%

-

SAGEM AVIONICS, INC

 

US17642124

100%

-

LABINAL DE MEXICO SA DE CV

 

-

100%

-

LABINAL INVESTMENTS INC.

 

-

100%

-

LABINAL DE CHIHUAHUA SA DE CV

 

-

100%

-

TURBO MECA

 

US36296634

100%

-

LABINAL INC

 

US16028637

100%

-

LABINAL SALISBURY, INC

 

US43355123

100%

-

SAFRAN ELECTRONICS INC

 

-

100%

-

SAFRAN ELECTRONICS USA INC

 

-

100%

-

TURBOMECA MANUFACTURING, INC

 

US33727403

100%

-

SAFRAN EMPLOYMENT SERVICES INC

 

-

100%

-

LABINAL POWER SYSTEMS

 

301501391

100%

31/12/2012

MATIS AEROSPACE

 

-

33.33%

-

LABINAL MAROC

 

-

100%

-

ELECTRICAL HARNESS MANUFACTURING S...

 

492213384

50%

31/07/2012

SAFRAN ENGINEERING SERVICES

 

352876197

100%

31/12/2012

SAFRAN ENGINEERING SERVICES INDIA

 

-

100%

-

SAFRAN ENGINEERING SERVICES MAROC

 

-

100%

-

LABINAL GMBH

 

HRB 68097

100%

31/12/2011

SHANGHAI SAIFEI AVIATION EWIS MANUFACTUR...

 

-

49%

-

TECHSPACE AÉRO SA

 

432618812

55.80%

31/12/2012

TECHSPACE AERO

 

US08004032

100%

-

CENCO, INC

 

US14918312

100%

-

SOFRANCE

 

757502240

100%

31/12/2012

TECHNOFAN

 

710802547

95.15%

31/12/2011

LEXSA

 

572046670

100%

31/12/2011

IBERICA DEL ESPACIO

 

12572

50%

31/12/2012

AIRCELLE

 

352050512

88.50%

31/12/2012

AIRCELLE LIMITED

 

02344610

100%

31/12/2012

AIRCELLE MAROC

 

-

100%

-

SOC LORRAINE DE CONSTRUCTION AERON...

 

317401065

100%

31/12/2011

AIRCELLE EUROPE SERVICES

 

434020970

100%

31/12/2011

MACCHI HUREL DUBOIS SAS

 

423667260

50%

31/12/2012

SNECMA HAL AEROSPACE PVT LTD

 

-

Majority

-

MORPHO DETECTION INTERNATIONAL INC

 

414615633

81%

31/12/2012

PRINTRACKINTERNATIONAL

 

US22265638

100%

-

L-1 IDENTITY SOLUTIONS INC

 

-

Majority

-

MORPHO USA INC

 

-

100%

-

MORPHO DETECTION INC

 

-

100%

-

MORPHODETECTION INTERNATIONAL INC

 

-

100%

-

QUANTUM MAGNETICS, INC

 

US20851348

100%

-

MORPHODETECTION GMBH

 

-

100%

-

MORPHO DETECTION (UK) LIMITED

 

03880571

100%

31/12/2012

MORPHODETECTION HONG KONG LTD

 

-

100%

-

MORPHOTRAK, INC

 

US37667548

100%

-

OPTROLEAD

 

-

50%

-

 

Linkages

Ultimate parent company

SAFRAN

Direct parent

SAFRAN - 100 %

Group – Number of companies

146

Linkages – Number of companies

609

Number of countries

33

 

Company Name

 

SIREN

Last account

Turnover

GE MONEY SERVICING LIMITED

 

03859120

30/11/2012

101 986 000 £

GE HEALTHCARE HOLDING NORGE AS

 

988963755

31/12/2012

0 KNOK

GE HEALTHCARE AS

 

914829674

31/12/2012

24 044 977 KNOK

GE FRANCE

 

480046895

31/12/2011

0 €

GE ENERGY EUROPE B.V.

 

20093546

31/12/2011

237 947 000 €

GE ENERGY NETHERLANDS B.V.

 

24236237

31/12/2012

15 164 000 €

GE UK GROUP

 

06486634

31/12/2012

0 £

GE CORPORATE FINANCE

 

479119224

31/12/2012

0 €

SOCIETE DE PARTICIPATIONS DE L'EST

 

323192344

31/12/2012

0 €

SOPHIA GE

 

315228163

31/12/2011

40 865 833 €

GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT

 

400628079

31/12/2011

33 847 871 €

GE UK HOLDINGS

 

04108905

31/12/2012

0 £

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX)...

 

20029235

31/12/2011

16 606 000 €

GROUPE FIGARO

 

401328919

31/12/2011

0 €

SONDEX LIMITED

 

04530983

31/12/2012

0 £

SAGEM DEFENSE SECURITE

 

480107911

31/12/2011

1 204 654 000 €

ROND POINT IMMOBILIER

 

408129963

31/12/2011

0 €

ROLLS-ROYCE PLC

 

01003142

31/12/2012

12 161 000 000 £

GE INDUSTRIAL FRANCE

 

390213478

31/12/2010

4 680 830 €

GE MEDICAL SYSTEMS LIMITED

 

00252567

31/12/2012

229 768 000 £

ENGINE SUPPORT HOLDINGS

 

IE132070

31/12/2012

0 €

GE AIRCRAFT ENGINE SERVICES LIMITED

 

02605713

31/12/2012

1 443 807 000 £

IPBM

 

333434728

31/12/2012

33 855 275 €

MORPHO

 

440305282

31/12/2012

393 568 000 €

ALCOR SAS

 

552146482

31/12/2012

0 €

GE SERVICES FRANCE

 

493460042

31/12/2012

0 €

DASSAULT SYSTEMES

 

322306440

31/12/2010

742 259 000 €

GENECOMMERCE

 

328296892

31/12/2012

3 €

NUOVO PIGNONE S.R.L.

 

FI606899

-

3 107 339 488 €

GE CAPITAL LEASING

 

444662431

31/12/2012

52 040 007 €

GE INSPECTION AND REPAIR SERVICES LIMITE...

 

01182449

31/12/2012

24 702 000 £

GE MEDICAL SYSTEMS

 

315013359

31/12/2012

1 371 518 523 €

SOC INVESTISSEMENTS FONCIERS PARTICIPA

 

722070018

31/12/2012

942 €

DASSAULT AVIATION

 

712042456

31/12/2011

2 914 346 000 €

WHATMAN INTERNATIONAL LIMITED

 

00106789

31/12/2012

33 390 000 £

FORSEE POWER INDUSTRY

 

442208534

31/12/2011

12 103 775 €

CAPITAL FRANCE HOTEL SCA

 

494620602

31/12/2012

0 €

FINANCIERE DASSAULT

 

318122561

31/12/2012

326 165 €

WHATMAN HOLDINGS UK LIMITED

 

03860036

31/12/2008

0 £

GE ENERGY POWER CONVERSION GROUP

 

477832638

31/12/2011

31 427 025 €

INVISION TECHNOLOGIES BETEILIGUNGS GMBH ...

 

HRA 98374

23/09/2009

-

MESSIER SERVICES INTERNATIONAL

 

434020996

31/12/2009

3 854 252 €

IMMOBILIERE DASSAULT SA

 

783989551

31/12/2012

14 695 377 €

GE HEALTHCARE LIMITED

 

01002610

31/12/2012

181 614 000 £

GE FINANCIAL IRELAND

 

IE383421

31/12/2006

1 880 000 000 €

GE LIGHTING

 

351782750

31/12/2012

27 963 705 €

THERMODYN

 

428764682

31/12/2012

304 277 604 €

GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SCES

 

300773413

31/12/2012

252 763 669 €

PATRIGES VILLIERS

 

393337506

31/12/2012

880 €

MESSIER-DOWTY LIMITED

 

03548809

31/12/2012

411 459 000 £

TIP TRAILER SERVICES FRANCE SAS

 

310880604

31/12/2012

40 273 273 €

CB16 DEVELOPPEMENT

 

423610922

31/12/2012

1 294 023 €

DASSAULT DEVELOPPEMENT

 

401709456

31/12/2012

0 €

CFH MONTMARTRE

 

503333148

31/12/2012

2 993 193 €

HIBERNIA (FRANCE)

 

350958104

31/12/2012

11 158 300 €

CFH CAP D'AIL

 

503333163

31/12/2012

11 574 450 €

GE CALEDONIAN LIMITED

 

SC064580

31/12/2012

410 501 128 £

SOPHIA GE FUNDING

 

485160030

31/12/2012

0 €

GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE

 

481213692

31/12/2012

351 241 854 €

SAFRAN UK LIMITED

 

02178689

31/12/2012

196 730 £

GE CAPITAL FUNDING SERVICES LIMITED

 

03731225

31/12/2012

23 461 000 £

SOCIETE DU FIGARO

 

542077755

31/12/2012

315 322 417 €

DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS

 

702052838

31/12/2012

146 734 138 €

GE CAPITAL IT SOLUTIONS

 

309072619

31/12/2012

0 €

LOGEROUTE

 

353735574

31/12/2012

1 910 950 €

PATRIGES CAP D'AIL

 

394310387

31/12/2012

0 €

CFH MONTPARNASSE

 

503333171

31/12/2012

2 371 452 €

SAS DES TOURS DU PONT DE SEVRES

 

528932130

31/12/2011

0 €

G.I.G

 

421011826

31/12/2012

2 226 267 €

OSMONICS SA

 

302178165

31/12/2012

179 000 €

CFH BOULOGNE

 

503337529

31/12/2012

1 846 885 €

AMERSHAM HEALTH NORGE AS

 

979306946

31/12/2012

0 KNOK

DI FRANCE

 

435190459

31/12/2012

0 €

DASSAULT INVESTISSEMENTS

 

378795546

31/12/2012

0 €

GE CAPITAL FACTORING GMBH

 

HRB 55178

31/12/2009

20 734 311 €

GE ENERGY POWER CONVERSION INT

 

481213718

31/12/2011

0 €

GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC

 

349942458

31/12/2012

1 546 214 830 €

FIGAROMEDIAS

 

552037244

31/12/2012

152 453 973 €

GE CAPITAL FUNDING SERVICE

 

435165899

31/12/2012

20 441 469 €

MARELLI MOTORI SPA

 

VI237401

31/12/2012

141 105 048 €

FIGARO CLASSIFIEDS

 

431373471

31/12/2010

67 588 293 €

SHANNON ENGINE SUPPORT LIMITED

 

IE130807

31/12/2012

91 800 979 €

SAS HVP

 

500040365

31/12/2012

10 437 296 €

SOBATER

 

377593306

31/12/2012

352 211 €

NORDAM EUROPE LIMITED

 

03223042

31/12/2012

40 937 211 £

BUC

 

425102837

31/12/2012

1 027 674 €

PARALLEL DESIGN

 

424704914

31/12/2012

15 124 723 €

SOGITEC INDUSTRIES

 

652011867

31/12/2012

103 695 187 €

SOCIETE D'EDITION DU TV MAGAZINE

 

440308625

31/12/2006

29 184 106 €

CHATEAU DASSAULT

 

781986070

31/12/2012

2 961 712 €

BRINTONS LIMITED

 

00034239

04/07/2009

87 343 000 £

DASSAULT FALCON SERVICE

 

679801886

31/12/2012

150 109 152 €

GE MEDICAL HOLDING

 

440356459

31/12/2012

0 €

G.I.X.

 

425044138

31/12/2012

639 961 €

GE POWER CONTROLS FRANCE

 

328611900

31/12/2012

32 857 706 €

SOPHIA GE INVESTMENT MANAGEMENT

 

501197420

31/12/2012

17 186 663 €

SOC INVEST SANTE

 

533479440

31/12/2011

20 800 €

GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES AB

 

5561081919

31/12/2012

7 990 587 KSEK

GE CAPITAL INVOICE FINANCE LIMITED

 

00417709

31/12/2012

10 831 000 £

LA BANQUE AUDIOVISUELLE

 

452698558

31/12/2012

653 107 €

GE REAL ESTATE EUROPE MANAGEMENT

 

341860401

31/12/2012

11 501 €

GE INSPECTION TECHNOLOGIES LIMITED

 

03645466

31/12/2012

15 440 000 £

DASSAULT MEDIAS

 

662053180

31/12/2011

388 944 €

ARTCU-BRIEST-POUL-F. TAJAN S.A.S

 

440088235

31/12/2012

29 945 215 €

GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOG...

 

MI1272528

31/12/2012

10 944 €

EURL LE MILLENNIUM

 

432522183

31/12/2012

740 671 €

EURL DONAT

 

432788552

31/12/2012

746 627 €

DASSAULT INTERNATIONAL 99 SOC

 

689802700

31/12/2012

4 197 485 €

WHATMAN LIMITED

 

00630958

31/12/2012

0 £

YXLON INTERNATIONAL X-RAY GMBH

 

HRB 51821

31/12/2007

61 194 985 €

EVENE

 

424414019

31/12/2011

2 318 635 €

GE HOLDINGS LUXEMBOURG & CO S.À R.L.

 

B56198

31/12/2011

656 559 €

WELLSTREAM HOLDINGS LIMITED

 

04601199

31/12/2012

0 £

GEFH AS

 

990400156

31/12/2012

0 KNOK

BIOS INTERBANCA S.R.L.

 

MI1792992

31/12/2012

0 €

G.I.W.

 

425078813

31/12/2012

327 767 €

GE TRANSPORTATION FRANCE

 

522536580

31/12/2012

27 740 264 €

G.I.I

 

421011339

31/12/2012

258 561 €

GE FACTO HOLDING

 

383935632

31/12/2012

0 €

HOCKING HOLDINGS

 

02151446

31/12/2011

0 £

METEOCONSULT

 

347613879

31/12/2012

9 322 301 €

B.U.D

 

428178156

31/12/2012

261 874 €

ARTCURIAL

 

301483814

31/12/2012

7 071 579 €

DASSAULT ASSURANCES COURTAGE

 

712029651

31/12/2011

554 020 €

BENTLY NEVADA

 

303447338

31/12/2012

74 568 176 €

HOCKING NDT LIMITED

 

01015778

31/12/2011

0 £

TOUR LYON BERCY

 

417902582

31/12/2003

2 388 676 €

SOC DOMAINE DU GRAND DUC

 

303878490

31/12/2012

0 €

FIGARO NAUTISME

 

438399685

31/12/2012

1 788 558 €

IMMOBILIERE ALCOR ET COMPAGNIE

 

302019799

31/12/2012

344 000 €

CLUB CH

 

433373651

31/12/2012

0 €

CLACF LIMITED

 

01508646

31/12/2010

0 £

G.I.J

 

421011198

31/12/2012

14 899 €

SOCIETE DASSAULT AERO SERVICE

 

303995658

31/12/2012

0 €

GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES FRANCE

 

388131013

31/12/2012

53 023 545 €

ITRS GROUP LIMITED

 

02873731

31/03/2013

8 532 384 £

GE CAPITAL FRANCE SERVICES

 

438742470

31/12/2012

0 €

SOPHIA CONSEIL

 

340038413

31/12/2012

730 034 €

ADEN GRAND SUD OUEST

 

514247006

31/12/2012

2 179 945 €

DASSAULT FALCON SERVICE FRANCE

 

342088085

31/12/2012

0 €

STE EURO CONSTRUC AVION BREGUET ATLANT

 

649804234

31/12/2012

9 967 601 €

INVISION TECHNOLOGIES VERWALTUNGS GMBH

 

HRB 87155

31/12/2009

-

SCI BOULOGNE-PONT DE SEVRES

 

441314705

31/12/2005

7 583 916 €

TURBINE BLADING LIMITED

 

01265008

31/12/2012

7 113 000 £

W4TCH

 

452091473

31/12/2012

1 410 219 €

SOC ASSURANCE COURTAGES ETUDES DE RISQ

 

389729849

31/12/2012

317 207 €

VOD PRODUCTION

 

504135872

31/12/2012

28 428 €

G.I.Q

 

421012485

31/12/2012

224 656 €

SAFRAN ENGINEERING SERVICES UK LIMITED

 

04842222

31/12/2012

3 168 225 £

GE FUNDING FINLAND OY

 

19673598

-

-

MARNE BROSSOLETTE

 

400117438

31/12/2003

1 181 998 €

FALCON TRAINING CENTER

 

306926353

31/12/2012

21 836 891 €

WELLSTREAM INTERNATIONAL LIMITED

 

04582101

31/12/2012

196 061 000 £

WELLSTREAM FINANCE LIMITED

 

04601173

31/12/2012

1 183 000 £

GEH HOLDINGS

 

05414492

31/12/2012

0 £

ARTCURIAL INVESTISSEMENT

 

500953880

31/12/2012

2 050 €

TURBOMECA322 LIMITED

 

00860268

31/12/2012

138 176 088 £

DIRECT RECRUIT LIMITED

 

03687074

31/12/2012

-

SAGEM SECURITY IRELAND LIMITED

 

IE465684

31/12/2012

1 873 167 €

WHATMAN SCIENTIFIC LIMITED

 

00089950

30/06/2010

0 £

TURBOMECA LIMITED

 

02349435

31/12/2012

-

GE LEASE ENGINE MANAGEMENT LIMITED

 

03242963

31/12/2011

-

MESSIER-DOWTY PENSION TRUSTEES LIMITED

 

03562124

31/03/2013

-

GE MEDICAL HOLDINGS (CANADA)

 

04343405

31/12/2009

-

LOCALJOBS LIMITED

 

04596025

30/11/2012

-

GE FINANCIAL FUNDING

 

IE383419

31/12/2012

0 €

WELLSTREAM (TRUSTEE) LIMITED

 

SC258934

31/12/2012

-

GE FACTOFRANCE

 

063802466

-

-

EXPRESS LOAN

 

1249194

-

-

WHATMAN HISPANICA

 

1473698

-

-

SOCIETE GUADELOUPEENNE DE FINANCEMENT

 

303120554

-

-

SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT

 

303160501

-

-

SCI AUSTERLITZ 2000

 

308270420

-

-

SOCIETE REUNIONNAISE FINANCEMENT-SOREF

 

313886590

-

-

CAMGE FINANCIERA E F C

 

328383

31/12/2011

-

GENERAL ELECTRIC FINANCING C.V.

 

33251668

-

-

RAFALE INTERNATIONAL

 

341219715

-

-

SOPHIA-BAIL

 

343183901

-

-

GENERAL ELECTRIC CAPITAL SAS

 

347836520

-

-

REUNIBAIL

 

351716907

-

-

GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE

 

352862346

-

-

BANSABADELL FINCOM EFC

 

382298

31/12/2012

-

SCI CRISTAL PARC

 

382316883

-

-

GE HEALTHCARE BVBA

 

404632629

31/12/2012

73 407 297 €

DASSAULT BELGIQUE AVIATION SA

 

406132367

31/12/2012

-

INTERGRANDSTADE

 

408956423

-

-

INTER IVRY

 

412558918

-

-

INTER LA PLAINE

 

414804468

-

-

PERCIER UIS 111 VILLEBON BALTIQUE 26

 

422382986

-

-

SCI TOUR 21 24

 

423554427

-

-

GE EUROPE NV

 

438407534

31/12/2012

-

SCI CANDI 149

 

441254620

-

-

COMITE D'ENTREPRISE JOURNAL DES FINANC

 

442315172

-

-

SCIENCE DEVELOPMENT SA

 

444528036

31/12/2012

-

TICKETAC

 

453134777

-

-

GE CORPORATE FINANCE BANK

 

479432312

-

-

INVEST 6

 

505212415

-

-

GE REAL ESTATE FRANCE OPCI DIVERSIFIE

 

507977403

-

-

GE SCF SOC EN COMMANDITE PAR ACTIONS

 

513406991

-

-

DASSAULT REASSURANCE

 

640801742

-

-

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC

 

662047216

-

-

SOC COFACREDIT

 

682022389

-

-

GE MONEY BANK

 

784393340

-

-

SIDA GRUNDSTÜCKS-VERMIETUNGSGESELLSCHAFT...

 

HRA 2542 CB

31/12/2012

-

GENERAL ELECTRIC FINANCE HOLDING GMBH

 

HRB 40689

-

-

MORPHO CARDS GMBH

 

HRB 12975 KI

31/12/2010

316 362 000 €

YXLON INTERNATIONAL HOLDING GMBH

 

HRB 69331

-

-

GE HEALTHCARE EUROPEAN HOLDINGS S.À R.L.

 

B58866

-

-

OBSERVINT TECHNOLOGIES, INC

 

US00864359

-

0 $

GE CAPITAL RETAIL BANK

 

US01090587

-

0 $

MORPHO DETECTION INC

 

US01270847

-

0 $

GE CARD SERVICES

 

US01444478

-

0 $

GE CAPITAL FLEET SERVICES

 

US01451128

-

0 $

HELLER FINANCIAL INC

 

US01504608

-

0 $

GE POLYMERLAND INC

 

US01504693

-

0 $

GE CAPITAL FRANCHISE FINANCE CORP

 

US01520226

-

0 $

GE INFRASTRUCTURE SENSING INC

 

US01564205

-

2 172 000 $

GE ACT COMMUNICATIONS INC

 

US01597658

-

1 033 000 $

GE GLOBAL PATENT OPERATION

 

US01597853

-

0 $

GE INTERLOGIX INC

 

US01597854

-

0 $

DRESSER, INC

 

US03600383

-

0 $

EMERGING SOVEREIGN PARTNERS LLC

 

US04106879

-

202 000 $

IMATRON FEDERAL SYSTEMS, INC

 

US04176977

-

0 $

TCW FUNDS MANAGEMENT, INC

 

US05788827

-

2 151 000 $

GE LIGHTING SYSTEMS, INC

 

US07313414

-

30 000 000 $

ELECTRIC MACHINERY

 

US07560551

-

150 000 $

GECAS ASSET MANAGEMENT SERVICES

 

US08162102

-

4 412 000 $

VITARICH LABORATORIES, INC

 

US08189918

-

2 000 000 $

GE CAPITAL AVIATION SERVICE

 

US08225412

-

5 490 000 $

REXALL SUNDOWN, INC

 

US08246258

-

595 664 000 $

CHROMALLOY CASTINGS TAMPA CORP

 

US08252604

-

0 $

GE MEDICAL SYSTEMS

 

US08418389

-

0 $

INVISION INTERNATIONAL

 

US08672680

-

496 000 $

COMMTEST INSTRUMENTS, INC

 

US08711025

-

1 479 000 $

GE LIGHTING

 

US09704694

-

51 146 000 $

GE AVIATION SYSTEMS LLC

 

US09729811

-

0 $

GE CONSUMER AND INDUSTRIAL

 

US09771014

-

57 874 000 $

ALLISON TRANSMISSION, INC

 

US09784824

-

2 162 800 000 $

GE TRI-REMANUFACTURING

 

US09795464

-

30 000 000 $

HCR MANORCARE, INC

 

US09799356

-

3 613 185 000 $

GE ENGINE SERVICES INC

 

US09809505

-

178 000 000 $

MORRIS TECHNOLOGIES, INC

 

US09862752

-

0 $

PRODUCT DISTRIBUTION CO

 

US09909862

-

2 432 000 $

HEARTLAND REHABILITATION SERVICES, INC

 

US09929478

-

0 $

GE ENGINE SERVICES DISTRIBUTION

 

US09960286

-

40 800 000 $

MESSIER-BUGATTI USA

 

US10254987

-

320 000 $

TECH DEVELOPMENT

 

US10332705

-

14 592 000 $

GE APPLIANCES

 

US10512746

-

0 $

GEA PARTS, LLC

 

US10588073

-

1 200 000 $

GEAE TECHNOLOGY, INC

 

US10658884

-

0 $

PECO II, INC

 

US10809315

-

42 287 000 $

MILESTONE HEALTHCARE, INC

 

US10949173

-

23 000 000 $

PECO II GLOBAL SERVICES, INC

 

US11037489

-

1 855 000 $

GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES

 

US11698595

-

0 $

COLONIAL PACIFIC LEASING CORP

 

US11710054

-

80 000 000 $

MIDWEST ELECTRIC PRODUCTS INC

 

US11710889

-

7 614 000 $

B&B ASSETS LLC

 

US11722885

-

6 698 000 $

GE MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS, INC

 

US11750892

-

0 $

JOHNSON TECHNOLOGY

 

US11760716

-

17 500 000 $

GE ZENITH CONTROLS

 

US11800966

-

2 267 000 $

GENERAL ELECTRIC RAILCAR SERVICES CORP

 

US11871488

-

1 000 000 $

GE OIL & GAS, INC

 

US11902274

-

0 $

GE CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTI...

 

US11981025

-

1 983 000 $

WAUKESHA ENGINE DRESSER, INC

 

US12000204

-

0 $

ULTIMA LABS INC

 

US12309282

-

1 750 000 $

GE PACKAGED POWER INC

 

US12328088

-

0 $

GE OIL & GAS PRESSURE CONTROL LP

 

US12399925

-

1 992 600 000 $

AXALTA POWDER COATING SYSTEMS USA, INC

 

US12431212

-

0 $

SEQWRIGHT INCORPORATED

 

US12496120

-

2 500 000 $

IDX SYSTEMS CORP

 

US12723727

-

392 000 $

LUXOLOGY LLC

 

US12993397

-

0 $

OPTIMIZATION ALTERNATIVES

 

US12995739

-

0 $

SONDEX LP

 

US13039810

-

0 $

ANDREW SYSTEMS INC

 

US13099608

-

4 016 561 000 $

DRESSER ROOTS

 

US13301486

-

0 $

SOLARC, INC

 

US13426857

-

0 $

CLARIENT, INC

 

US13532352

-

91 599 000 $

GE MEDICAL SYSTEMS ULTRASOUND

 

US13583658

-

25 000 $

GE HEALTHCARE TECHNICAL SERVICES

 

US13915108

-

301 000 $

DATEX OHMEDA INC

 

US14404714

-

15 000 000 $

GE

 

US15234469

-

8 300 000 $

WOODVISION, INC

 

US15586732

-

0 $

JUPITERIMAGES CORP

 

US15706329

-

0 $

GE AVIATION MATERIALS LP

 

US16205728

-

11 100 000 $

DRESSER, INC

 

US16293427

-

2 000 000 000 $

GE ENERGY SERVICES

 

US16345024

-

295 000 $

WESCO AIRCRAFT HARDWARE CORP

 

US16365009

-

80 000 000 $

GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS CORP

 

US16440581

-

4 745 000 $

BENTLY NEVADA, INC

 

US16481429

-

0 $

OEC MEDICAL SYSTEMS, INC

 

US16534748

-

877 000 $

TCW CAPITAL INVESTMENT CORP

 

US17040133

-

0 $

GE TRANSPORTATION SYSTEMS GLOBAL SIGNALI...

 

US17041174

-

280 800 000 $

OPTICS 1, INC

 

US17061396

-

6 412 000 $

COMMSCOPE NEVADA, LLC

 

US17077196

-

0 $

GE FANUC

 

US17361717

-

0 $

THE TCW GROUP, INC

 

US17397707

-

0 $

WALBRO ENGINE MANAGEMENT L.L.C

 

US17590008

-

0 $

MORPHOTRUST USA, INC

 

US17764810

-

562 872 000 $

PRECOAT METALS

 

US17915061

-

4 189 000 $

AUSTIN DIGITAL, INC

 

US17998223

-

0 $

METROPOLITAN WEST ASSET MANAGEMENT, LLC

 

US18713419

-

8 600 000 $

CHROMALLOY SAN DIEGO CORP

 

US19019478

-

20 000 000 $

TCW ASSET MANAGEMENT CO INC

 

US19229763

-

0 $

THE ESTER C CO

 

US19412584

-

412 000 $

CONCORD CAPITAL ENTERPRISE

 

US19538840

-

0 $

GE MONEY

 

US19599119

-

400 000 $

GE-FAIRCHILD LLC

 

US20149382

-

0 $

XCELLEREX, INC

 

US20437615

-

17 500 000 $

ITRACS CORP

 

US20529615

-

0 $

SMA ENGINES, INC

 

US20797075

-

1 088 000 $

COMMSCOPE, INC

 

US21040034

-

3 024 859 000 $

COMMSCOPE WIRELESS NETWORK SOLUTIONS

 

US21117297

-

209 000 $

GE CLINICAL SERVICES, INC

 

US21141189

-

0 $

WELLSTREAM INTERNATIONAL LIMITED

 

US21158360

-

0 $

SUPERCIRCUITS, INC

 

US21342421

-

0 $

SYNIVERSE TECHNOLOGIES, INC

 

US21421627

-

1 207 000 $

HYDRIL PRESSURE CONTROL

 

US21490579

-

300 000 000 $

AVALON ADVISORS, LLC

 

US21492879

-

1 800 000 $

CHROMALLOY POWER SERVICES CORP

 

US21729056

-

0 $

LABINAL DE MEXICO

 

US21969307

-

4 859 000 $

APPLIED ELECTRONIC SYSTEMS, INC

 

US22132385

-

9 010 000 $

SYAGEN TECHNOLOGY INC

 

US22172314

-

2 300 000 $

TURBOMECA USA, INC

 

US22182833

-

25 000 $

LUFKIN INDUSTRIES, INC

 

US22304530

-

0 $

CFAN INC

 

US22387909

-

32 500 000 $

CELLSITE INDUSTRIES, INC

 

US22395841

-

2 100 000 $

CHROMALLOY GAS TURBINE CORP

 

US22454503

-

0 $

MORPHO DETECTION, INC

 

US22455077

-

260 000 000 $

GETTY IMAGES, INC

 

US22556030

-

857 591 000 $

COAST CRANE CO

 

US22610416

-

7 616 000 $

CARDINAL OPERATING PERSONNEL, INC

 

US22616039

-

20 000 000 $

SAGEM MORPHO, INC

 

US22649989

-

1 374 000 $

APPLIED PRECISION, INC

 

US22687571

-

37 500 000 $

GE HEALTHCARE

 

US22820928

-

0 $

MESSIER-DOWTY USA, INC

 

US23039831

-

5 836 000 $

ANDREW WIRELESS SOLUTIONS

 

US23156217

-

2 208 000 $

U-SYSTEMS, INC

 

US23371787

-

0 $

QUINN PUMPS CALIFORNIA INC

 

US23574646

-

1 180 000 $

UNISON ENGINE COMPONENTS

 

US23644490

-

150 000 000 $

COMNETIX INC

 

US23956911

-

0 $

BENTLY NV

 

US23981361

-

10 062 000 $

ADVANCED SERVICES, INC

 

US24143736

-

0 $

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP

 

US24190303

-

4 700 000 $

INOVEC INC

 

US24284309

-

43 000 $

BALANCE BAR CO

 

US24688589

-

0 $

PRIMESTAR SOLAR, INC

 

US24702842

-

379 000 $

OPEN LINK FINANCIAL INC

 

US25104114

-

138 694 000 $

GE AVIATION

 

US25196182

-

0 $

GE IONICS

 

US25352309

-

37 500 000 $

PARADIGM PRECISION HOLDINGS, LLC

 

US25636667

-

0 $

GE AVIATION SYSTEMS LLC

 

US26091465

-

91 584 000 $

ITRS AMERICA

 

US26481667

-

3 000 000 $

CALNETIX POWER SOLUTIONS INC

 

US26654037

-

2 000 000 $

SAFRAN USA INC

 

US27208452

-

10 000 000 $

VETCOGRAY INC

 

US27301753

-

2 600 000 $

L-1 ENROLLMENT SERVICES DIV

 

US27301992

-

0 $

SYNATECH HOLDINGS, INC

 

US27303298

-

0 $

LEINER HEALTH PRODUCTS INC

 

US27849309

-

626 916 000 $

ALBEO TECHNOLOGIES INC

 

US28000279

-

0 $

PARADIGM PRECISION - MALDEN

 

US28273281

-

214 000 $

EZ-ID, LLC

 

US28328234

-

0 $

ECHOSERVE INC

 

US28513777

-

269 000 $

TMG AIREPAIRS

 

US28621157

-

0 $

GE APPLIANCES CARIBBEAN & CO

 

US29286334

-

0 $

SONORA MEDICAL SYSTEMS

 

US29513027

-

0 $

COMMSCOPE INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC

 

US29612357

-

0 $

GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS

 

US29612789

-

0 $

PARADIGM PRECISION - TEMPE

 

US29614770

-

0 $

UNISYN MEDICAL TECHNOLOGIES, INC

 

US30988847

-

0 $

ROLL COATER, INC

 

US31357020

-

23 290 000 $

GE CAPITAL REAL ESTATE

 

US31557741

-

650 000 $

LINEAGE POWER CORP

 

US32265447

-

3 185 000 $

REDWOOD SYSTEMS, INC

 

US32440408

-

0 $

DASSAULT AIRCRAFT SERVICES CORP

 

US32629252

-

0 $

GE CORPORATE FINANCIAL SERVICES

 

US32738283

-

0 $

GE CAPITAL FINANCIAL INC

 

US32949165

-

0 $

PHOTOLIBRARY NEW YORK

 

US33219740

-

0 $

TM INDUSTRIES, INC

 

US33384625

-

3 894 000 $

MARELLI USA, INC

 

US33466135

-

4 706 000 $

LIGHTFOOT CAPITAL PARTNERS

 

US33474950

-

220 000 $

L-1 SECURE CREDENTIALING, INC

 

US34086869

-

0 $

INFINIAS, LLC

 

US34230699

-

0 $

HELLER FINANCIAL LEASING INC

 

US35004979

-

0 $

PICSCOUT, INC

 

US35181559

-

601 000 $

GE CREDIT CORP OF TN

 

US35960447

-

236 000 $

NBTY MANUFACTURING LLC

 

US36018751

-

0 $

GE PACKAGED POWER, INC

 

US36080574

-

0 $

DIGIOP TECHNOLOGIES, LIMITED

 

US37595796

-

0 $

MICROTURBO, INC

 

US37797397

-

500 000 000 $

AXALTA COATING SYSTEMS

 

US37815027

-

0 $

GE INTELLIGENT PLATFORMS, INC

 

US37907742

-

0 $

LINEAGE POWER OEM DIVISION

 

US38553129

-

0 $

GEA PRODUCTS, L.P

 

US38722280

-

0 $

REALFLEX TECHNOLOGIES LT

 

US40831572

-

0 $

EMERGING SOVEREIGN GROUP

 

US41430991

-

15 000 000 $

GE TRANSPORTATION PARTS, LLC

 

US41945014

-

0 $

SALOF CO

 

US42262730

-

0 $

BIOMETRICA SYSTEMS, LLC

 

US42450208

-

0 $

WHATMAN INC

 

US42460205

-

339 000 $

GE ENERGY FINANCIAL SERVICES

 

US42562113

-

0 $

POTTERS INDUSTRIES, INC

 

US42699900

-

110 000 000 $

GE TRANSPORTATION

 

US42881759

-

0 $

GE INDUSTRIAL

 

US43099741

-

1 600 000 $

INDEPENDENT FINANCIAL MARKETING GROUP, I...

 

US43145344

-

0 $

SEQUA CORP

 

US43152955

-

2 183 816 000 $

DASSAULT PROCUREMENT SERVICES INC

 

US43184721

-

3 089 000 $

VERMILLION ASSET MGMT. LLC

 

US43277777

-

0 $

CLAREN ROAD ASSET MANAGEMENT LLC

 

US43313560

-

512 000 $

GE SECURITY MANUFACTURING, INC

 

US43366746

-

446 000 $

TRU-FORM INC

 

US43369660

-

4 825 000 $

GE ENERGY PARTS

 

US43393188

-

0 $

SLEEP SERVICES OF AMERICA, INC

 

US43470356

-

1 340 000 $

GE INVESTMENTS INC

 

US43661976

-

0 $

EVEREST VIT INC

 

US43699058

-

7 000 000 $

METROPOLITAN REAL ESTATE EQUITY MANAGEME...

 

US43854567

-

0 $

DOWTY AEROSPACE PROPELLERS, REPAIR & OVE...

 

US43987116

-

0 $

TC GROUP, L.L.C

 

US44027216

-

0 $

FORTIGENT, LLC

 

US44087412

-

135 000 $

CARLYLE HOLDING CORP

 

US44096322

-

0 $

GE CAPITAL RESIDENTIAL CONNECTIONS CORP

 

US44174573

-

400 000 $

PARADIGM PRECISION BERLIN OPERATIONS

 

US44271951

-

105 000 $

GENERAL ELECTRIC CAPITAL ASIA INVESTMENT...

 

US44417572

-

0 $

GE FANUC AUTOMATION, INC

 

US44453825

-

500 000 000 $

ZEOLYST INTERNATIONAL

 

US44582835

-

60 000 000 $

CONVERTEAM INC

 

US44591873

-

1 431 000 $

GE COMMERCIAL FINANCE

 

US44613849

-

322 000 $

VITAL SIGNS, INC

 

US44638671

-

205 257 000 $

TURBINE AIRFOIL COATING & REPAIR LLC

 

US44663454

-

0 $

GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES

 

US44857012

-

6 954 000 $

ALPINVEST PARTNERS INC

 

US44877384

-

0 $

GE SENSING & INSPECTION TECHNOLOGIES

 

US44879695

-

0 $

GE INFRASTRUCTURE

 

US44882958

-

0 $

CHROMALLOY AMERICAN CORP

 

US44930639

-

3 000 000 000 $

RETICA SYSTEMS INC

 

US44938971

-

50 000 $

ARINC INCORPORATED

 

US45089906

-

919 000 000 $

BOOZ ALLEN HAMILTON INC

 

US45099353

-

4 100 000 000 $

THE CARLYLE GROUP, LLC

 

US45101527

-

0 $

GE THERMOMETRICS SAINT MARYS

 

US45113400

-

54 400 000 $

DASSAULT FALCON JET-WILMINGTON CORP

 

US45174457

-

50 018 000 $

GE BETZ

 

US45412930

-

0 $

GENERAL ELECTRIC CAPITAL SERVICES, INC

 

US45538852

-

82 515 000 000 $

GE CONSUMER FINANCE, INC

 

US45565248

-

0 $

NATURAL PRODUCTS GROUP

 

US45570673

-

0 $

GE HEALTHCARE FINANCIAL SERVICES

 

US45586209

-

900 000 $

PETER ARNOLD INC

 

US45627647

-

413 000 $

GENERAL ELECTRIC CO

 

US45668369

-

47 400 000 000 $

VITAMIN WORLD, INC

 

US45775787

-

604 000 $

SMITHS AEROSPACE

 

US45789159

-

800 000 000 $

CHESAPEAKE PACKAGING PRODUCTS OF MARYLAN...

 

US45798446

-

0 $

NBTY, INC

 

US45808363

-

2 179 469 000 $

GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOG...

 

US45820483

-

0 $

GE OSMONICS

 

US45896246

-

0 $

REUTER-STOKES, INC

 

US45928721

-

4 335 000 $

GE RAIL

 

US45965567

-

0 $

GE ENERGY

 

US46017628

-

1 900 000 $

G.E. CAPITAL AUTOLEASE

 

US46049250

-

580 000 $

GE TRANSPORTATION OPTIMIZATION

 

US46050045

-

21 500 000 $

GE ASSET MANAGEMENT

 

US46196118

-

0 $

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL, INC

 

US46206660

-

0 $

GE INDUSTRIAL PR LLC

 

US46216833

-

0 $

ENGINIVITY LLC

 

US46346305

-

6 578 000 $

GENERAL ELECTRIC CREDIT EQUITIES, INC

 

US46388067

-

0 $

MACH CIBERNET

 

US46439222

-

0 $

PQ CORP

 

US46471400

-

60 000 000 $

GE INSPECTION TECHNOLOGIES

 

US46480856

-

114 450 000 $

PURITAN'S PRIDE, INC

 

US46485667

-

5 300 000 $

MRA SYSTEMS INC

 

US46502422

-

0 $

GRANITE SERVICES INTERNATIONAL, INC

 

US46523430

-

1 040 000 $

ARINC MANAGED SERVICES, LLC

 

US46638032

-

700 000 000 $

GE DRIVES & CONTROLS, INC

 

US46650754

-

30 075 000 $

UNISON INDUSTRIES, LLC

 

US46741076

-

970 000 $

BRINTONS USA INC

 

US46767891

-

4 068 000 $

COMMSCOPE OPTICAL TECHNOLOGIES, INC

 

US46772899

-

0 $

GE GENERATORS PENSACOLA

 

US47715952

-

0 $

BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP

 

US49515927

-

5 758 059 000 $

SAFRAN ENGINEERING SERVICES

 

US55315688

-

0 $

TMAC MORTGAGE CO

 

US57536516

-

1 325 000 $

ARINC TECHNICAL SERVICES, LLC

 

US57738581

-

0 $

BHA GROUP, INC

 

US57763799

-

0 $

BHA GROUP HOLDINGS, INC

 

US57788837

-

0 $

ANDREW CORP

 

US57850938

-

0 $

GE WIND ENERGY LLC

 

US57859942

-

0 $

BOOZ ALLEN HAMILTON ENGINEERING SERVICES...

 

US57965802

-

0 $

GE OSMONICS INC

 

US58290209

-

0 $

GE MEASUREMENT & CONTROL

 

US59414923

-

0 $

AEROFRAME SERVICES

 

US61029702

-

75 000 000 $

CHESAPEAKE PACKAGING PRODUCTS OF VIRGINI...

 

US61313104

-

0 $

GE GENERATORS PENSACOLA, LLC

 

US62472949

-

0 $

GE ENERGY PARTS, INC

 

US62919023

-

0 $

GE OIL & GAS ESP, INC

 

US63006351

-

0 $

QUINN PUMPS INC

 

US63314740

-

0 $

TECHNOFAN, INC

 

US64037786

-

160 000 $

AXALTA COATING SYSTEMS, LLC

 

US68647511

-

0 $

SAGEM ORGA USA, INC

 

US69991153

-

0 $

CRATON EQUITY PARTNERS LLC

 

US72383019

-

0 $

SECURITY CAMERAS DIRECT, LP

 

US72579038

-

0 $

GE BETZ INTERNATIONAL INC

 

US72624167

-

0 $

AMERSHAM PLC

 

-

-

-

BRUNSWICK ACCEPTANCE COMPANY, LLC

 

-

-

-

CARIBE GE INTERNATIONAL OF PUERTO RICO I...

 

-

-

-

CDF VENTURES, LLC

 

-

-

-

CONVERTEAM BRAZIL LTDA

 

-

-

-

CONVERTEAM EDC PRIVATE LTD

 

-

-

-

CONVERTEAM POWER CONVERSION SHANGHAI CO ...

 

-

-

-

CONVERTING CANADA INC

 

-

-

-

DASSAULT AERO SERVICE

 

-

-

-

DASSAULT AVIATION

 

-

-

-

DASSAULT AVIATION

 

-

-

-

DASSAULT AVIATION

 

-

-

-

DASSAULT FALCON DO BRASIL

 

-

-

-

DASSAULT FALCON JET

 

-

-

-

DASSAULT FALCON MIDDLE EAST

 

-

-

-

DASSAULT INTERNATIONAL

 

-

-

-

DASSAULT INTERNATIONAL (USA) INC

 

-

-

-

DASSAULT INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

 

-

-

-

DENNINGTON CHAMPS ELYSÉES BV

 

-

-

-

DENNINGTON HOLDING BV

 

-

-

-

DOW KOKAM

 

-

-

-

EMPRESARIOS AGRUPADOS

 

-

-

-

GE AVIATION SERVICE OPERATION LLP

 

-

-

-

GE AVIATION SYSTEMS NORTH AMERICA INC

 

-

-

-

GE BETZ INTERNATIONAL INC

 

-

-

-

GE CANADA COMPANY

 

-

-

-

GE CAPITAL BANK SA

 

-

-

-

GE CAPITAL GLOBAL FINANCIAL HOLDINGS INC

 

-

-

-

GE CAPITAL SOLUTIONS SERVICES SARL

 

-

-

-

GE CORPORATE FINANCIAL SERVICES SRL

 

-

-

-

GE ENERGY PRODUCTS

 

-

-

-

GE ENERGY USA LLC

 

-

-

-

GE ENGINE SERVICES DALLAS LP

 

-

-

-

GE ENGINE SERVICES UNC HOLDING I INC

 

-

-

-

GE EQUIPEMENT SERVICES SL

 

-

-

-

GE EUROPE HOLDINGS LLC

 

-

-

-

GE FANUC INTELLIGENT PLATFORMS EMBEDDED ...

 

-

-

-

GE FINANCEMENT PACIFIQUE

 

-

-

-

GE FINANCEMENT PACIFIQUE

 

-

-

-

GE FINANCIAL ASSURANCE HOLDINGS INC

 

-

-

-

GE GAS TURBINES (GREENVILLE) LLC

 

-

-

-

GE GLOBAL SOURCING LLC

 

-

-

-

GE HEALTHCARE JAPAN CORPORATION

 

-

-

-

GE HEALTHCARE USA HOLDING INC

 

-

-

-

GE HONDA AERO ENGINES LLC

 

-

-

-

GE HUNGARY KFT

 

-

-

-

GE INDUSTRIAL FINANCING IRELAND LTD

 

-

-

-

GE INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY LLC

 

-

-

-

GE INTELLIGENT PLATFORMS EMBEDDED SYSTEM...

 

-

-

-

GE INTELLIGENT PLATFORMS INC

 

-

-

-

GE INVESTMENTS INC

 

-

-

-

GE IONICS INC

 

-

-

-

GE JENBACHER DENMARK

 

-

-

-

GE JENBACHER GERMANY

 

-

-

-

GE JENBACHER GMBH & CO OHG

 

-

-

-

GE JENBACHER ITALY

 

-

-

-

GE JENBACHER NETHERLANDS

 

-

-

-

GE JENBACHER SOUTH AFRICA

 

-

-

-

GE JENBACHER SPAIN AND PORTUGAL

 

-

-

-

GE KEPPEL ENERGY SERVICES PTE LTD

 

-

-

-

GE MAINTENANCE SERVICES INC

 

-

-

-

GE MEDICAL HOLDING BELGIUM SPRL

 

-

-

-

GE MEDICAL SYSTEMS GLOBAL TECHNOLOGY COM...

 

-

-

-

GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOG...

 

-

-

-

GE MEDICAL SYSTEMS LLC

 

-

-

-

GE MEDICAL SYSTEMS ULTRASOUND & PRIMARY ...

 

-

-

-

GE MILITARY SYSTEMS

 

-

-

-

GE PACIFIC HOLDING PTE LTD

 

-

-

-

GE PACIFIC PTE LTD

 

-

-

-

GE TRANSPORTATION SYSTEMS GLOBAL SIGNALI...

 

-

-

-

GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES CANADA

 

-

-

-

GE WIND ENERGY LLC

 

-

-

-

GE YOKOGAWA MEDICAL SYSTEMS LTD

 

-

-

-

GE-HITACHI GLOBAL LASER ENRICHMENT LLC

 

-

-

-

GENE HOLDING LLC

 

-

-

-

GENERAL ELECTRIC (BERMUDA) LTD

 

-

-

-

GENERAL ELECTRIC AUSTRIA GMBH

 

-

-

-

GENERAL ELECTRIC CANADA COMPANY

 

-

-

-

GENERAL ELECTRIC EUROPE HOLDINGS CV

 

-

-

-

GENERAL ELECTRIC PLASTIC ABS EUROPE NV

 

-

-

-

GENERAL ELECTRIC SERVICES (BERMUDA) LTD

 

-

-

-

GENERAL ELECTRIC SERVICES LUXEMBOURGH SA...

 

-

-

-

INTERBANCA SPA

 

-

-

-

LUFKIN INDUSTRIES

 

-

-

-

MESSIER-BUGATTI-DOWTY SA

 

-

-

-

MIDWAY AIRCRAFT INSTRUMENT CORP.

 

-

-

-

MORPHO R.C.S.

 

-

-

-

NUCLEAR FUEL HOLDING CO INC

 

-

-

-

NUOVO PIGNONE HOLDING SPA

 

-

-

-

NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL HOLDING SA

 

-

-

-

PANAMETRICS LTD

 

-

-

-

SAFRAN SA

 

-

-

-

SCANWIND

 

-

-

-

SCHLEICHER & SCHUELL UK LIMITED

 

-

-

-

SEASTREAM JV AUSTRALIA PTY LIMITED

 

-

-

-

SEMINUS

 

-

-

-

SNC LUCIA CLUB SUISSE

 

-

-

-

SOCIÉTÉ ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS A...

 

-

-

-

VICEROY INC

 

-

-

-

VITAL SIGNS HOLDINGS LLC

 

-

-

-

WELLSTREAM AUSTRALIA PTY LIMITED

 

-

-

-

WELLSTREAM CANADA LIMITED

 

-

-

-

WELLSTREAM DO BRAZIL INDUSTRIA E SERVICO...

 

-

-

-

WELLSTREAM HOLDINGS PLC

 

-

-

-

WHATMAN ASIA PACIFIC PTE LIMITED

 

-

-

-

WHATMAN FINANCE

 

-

-

-

WHATMAN HOLDINGS IRELAND

 

-

-

-

WHATMAN HOLDINGS SINGAPORE PTE LIMITED

 

-

-

-

WHATMAN JAPAN KK

 

-

-

-

WHATMAN ONE LIMITED

 

-

-

-

WHATMAN XINHUA LIMITED

 

-

-

-

XPRO

 

-

-

-

 

FINANCIAL INFORMATION

 

Trading to Date

12/31/2011

12/31/2010

12/31/2009

 

Turnover

1,204,654,000 €

1,150,103,000 €

1,007,738,000 €

 

Gross Operating Surplus

-1,45 % Turnover

-3,56 % Turnover

-6,35 % Turnover

 

Shareholders’ equity

474,831,000 €

441,692,000 €

463,283,000 €

 

Net result

36,878,000 €

14,728,000 €

43,816,000 €

 

Employees

5 000+ employees

-

-

 

 

accounts

Active Account |  Passive Account |  Account Results

 

Synthesized Accounts

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

Comparison mode

Average

Median

 

 

Annual Accounts

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

Account period (month)

12

12

12

Account Type

Normal

Normal

Normal

Date of capture

06/06/2012

15/06/2011

24/06/2010

Activity Code

2651A

2651A

2651A

Employees

6059

6165

6082

 

Active account

Annual Accounts

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Sector Median 2011

 

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

446 620 000

6,2%

420 669 000

7,1%

392 888 000

157 950

282660,4%

- Intangible assets

6 129 000

65,0%

3 715 000

30,5%

2 847 000

4 862

125959,2%

- Tangible assets

211 976 000

7,2%

197 659 000

20,9%

163 431 000

37 961

558304,7%

- Financial assets

228 515 000

4,2%

219 295 000

-3,2%

226 610 000

2 310

9892324,2%

Net current assets

1 108 860 000

1,0%

1 098 414 000

-1,9%

1 119 275 000

519 251

213449,9%

- Stocks

399 195 000

8,4%

368 148 000

0,5%

366 305 000

66 106

603771,1%

- Advanced payments

10 871 000

1,0%

14 133 000

-37,9%

22 768 000

0

0%

- Receivables

697 427 000

-2,3%

713 884 000

-2,0%

728 757 000

248 421

280644,0%

- Securities and cash

1 367 000

-39,2%

2 249 000

55,6%

1 445 000

62 688

2080,6%

- Prepaid expenses

-

-

-

-

-

0

-

Accounts of regularization

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total Assets

1 555 481 000

2,4%

1 519 088 000

0,5%

1 512 164 000

894 717

173751,7%

 

Passive Account

Annual Accounts

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Sector Median 2011

 

Shareholders' equity

474 831 000

7,5%

441 692 000

-4,7%

463 283 000

260 634

182083,1%

Share capital

372 884 000

0%

372 884 000

0%

372 884 000

56 000

665764,3%

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

228 451 000

-8,0%

248 284 000

-7,6%

268 579 000

0

0%

Liabilities

852 199 000

2,8%

829 112 000

6,3%

780 302 000

449 585

189452,4%

- Financial liabilities

106 019 000

237,7%

31 397 000

-18,0%

38 267 000

49 711

213170,7%

- Advanced payments received

438 492 000

-9,2%

483 018 000

12,1%

430 750 000

0

0%

- Trade account payables

178 800 000

0,8%

177 308 000

10,4%

160 545 000

116 146

153844,2%

- Tax and social liabilities

97 168 000

-4,4%

101 655 000

12,9%

90 009 000

171 451

56573,9%

- Other debts and fixed assets liabilities

16 974 000

5,1%

16 152 000

3,1%

15 664 000

12 210

138917,2%

Account regularization

14 746 000

-24,7%

19 582 000

-56,5%

45 067 000

0

0%

Total liabilities

1 555 481 000

2,4%

1 519 088 000

0,5%

1 512 164 000

894 717

173751,7%

 

Results

Annual Accounts

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Sector Median 2011

 

Sales of Goods

1 348 591 000

5,4%

1 279 200 000

18,2%

1 082 581 000

678 058

198790,2%

Net turnover

1 204 654 000

4,7%

1 150 103 000

14,1%

1 007 738 000

650 489

185092,1%

- of which net export turnover

503 714 000

0%

0

0%

0

40 535

1242564,4%

Operating charges

1 384 739 000

4,5%

1 324 634 000

15,1%

1 151 236 000

975 567

141842,0%

Operating profit/loss

-36 148 000

20,4%

-45 434 000

33,8%

-68 655 000

22 986

-157360,9%

Financial income

54 171 000

150,0%

21 669 000

-79,3%

104 648 000

1 300

4166900%

Financial charges

5 134 000

625,1%

708 000

-93,7%

11 201 000

1 935

265223,0%

Financial profit/loss

49 037 000

133,9%

20 961 000

-77,6%

93 447 000

-171

28676708,2%

Pretax net operating income

12 889 000

152,7%

-24 473 000

-198,7%

24 792 000

27 119

47427,6%

Extraordinary income

712 000

-94,9%

13 995 000

0%

0

1 103

64451,2%

Extraordinary charges

9 566 000

40,9%

6 789 000

-51,7%

14 044 000

273

3503929,3%

Extraordinary profit/loss

-8 854 000

-222,9%

7 206 000

151,3%

-14 044 000

0

0%

Net result

36 878 000

150,4%

14 728 000

-66,4%

43 816 000

27 404

134471,6%


 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

 

Normal Account

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Months

 

12

 

12

 

12


Accounts - Active
Current Assets |  Equalization accounts |  Reference


Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Grand Total (I to VI)

Net

1 555 481 000

2,4%

1 519 088 000

0,5%

1 512 164 000

 

Gross

CO

1 951 844 000

3,0%

1 895 423 000

-0,2%

1 899 009 000

 

Amortisation

1A

396 363 000

5,3%

376 334 000

-2,7%

386 845 000

 

Non declared distributed capital (I)

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AA

0

0%

0

0%

0

 

Active fixed asset (II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Total Active fixed asset (II)

Net

446 620 000

6,2%

420 669 000

7,1%

392 888 000

 

Gross

BJ

798 893 000

6,8%

748 347 000

4,3%

717 356 000

 

Amortisation

BK

352 273 000

7,5%

327 678 000

1,0%

324 468 000

 

Intangilble fixed assets

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R & D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AE

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

5 030 000

35,4%

3 715 000

90,7%

1 948 000

 

Gross

AF

31 703 000

31,4%

24 127 000

17,0%

20 627 000

 

Amortisation

AG

26 673 000

30,7%

20 412 000

9,3%

18 679 000

Goodwill

Net

1 099 000

0%

0

0%

899 000

 

Gross

AH

1 099 000

0%

0

0%

899 000

 

Amortisation

AI

0

0%

0

0%

0

Other intangible fixed assets

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AJ

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AK

0

0%

0

0%

0

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible Assets

Net

6 129 000

65,0%

3 715 000

30,5%

2 847 000

 

Tangilble fixed assets

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Lands

Net

16 506 000

12,5%

14 675 000

-0,6%

14 771 000

 

Gross

AN

18 803 000

13,3%

16 599 000

0,6%

16 494 000

 

Amortisation

AO

2 297 000

19,4%

1 924 000

11,7%

1 723 000

Buildings

Net

73 098 000

114,1%

34 146 000

0,7%

33 900 000

 

Gross

AP

141 102 000

44,5%

97 643 000

-1,3%

98 917 000

 

Amortisation

AQ

68 004 000

7,1%

63 497 000

-2,3%

65 017 000

Plant

Net

83 705 000

17,6%

71 189 000

12,1%

63 528 000

 

Gross

AR

297 185 000

7,3%

276 964 000

2,9%

269 135 000

 

Amortisation

AS

213 480 000

3,7%

205 775 000

0,1%

205 607 000

Other tangible fixed assets

Net

14 950 000

2,2%

14 630 000

172,1%

5 376 000

 

Gross

AT

42 152 000

11,4%

37 837 000

47,0%

25 739 000

 

Amortisation

AU

27 202 000

17,2%

23 207 000

14,0%

20 363 000

Fixed assets in construction

Net

23 078 000

-62,6%

61 648 000

36,7%

45 102 000

 

Gross

AV

23 078 000

-62,6%

61 648 000

36,7%

45 102 000

 

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

639 000

-53,4%

1 371 000

81,8%

754 000

 

Gross

AX

639 000

-53,4%

1 371 000

41,3%

970 000

 

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

216 000

 

Sub Total Tangible asset

Net

211 976 000

 

197 659 000

 

163 431 000

 

Financial assets

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

217 775 000

4,6%

208 116 000

-3,0%

214 596 000

 

Gross

CU

231 644 000

5,2%

220 235 000

-2,9%

226 715 000

 

Amortisation

CV

13 869 000

14,4%

12 119 000

0%

12 119 000

Inter-company receivables

Net

300 000

0%

0

0%

0

 

Gross

BB

1 011 000

42,2%

711 000

0%

711 000

 

Amortisation

BC

711 000

0%

711 000

0%

711 000

Other investment securities

Net

22 000

0%

22 000

0%

22 000

 

Gross

BD

32 000

0%

32 000

0%

32 000

 

Amortisation

BE

10 000

0%

10 000

0%

10 000

Loans

Net

8 955 000

-8,0%

9 737 000

-7,3%

10 501 000

 

Gross

BF

8 955 000

0%

9 737 000

0%

10 501 000

 

Amortisation

BG

0

 

0

 

0

Other financial assets

Net

1 463 000

3,0%

1 420 000

-4,8%

1 491 000

 

Gross

BH

1 490 000

3,3%

1 443 000

-4,7%

1 514 000

 

Amortisation

BI

27 000

17,4%

23 000

0%

23 000

 

Sub Total Financial Assets

 

228 515 000

 

219 295 000

 

226 610 000

 

Current Assets (III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Total Assets

Net

1 108 860 000

1,0%

1 098 414 000

-1,9%

1 119 275 000

 

Gross

CJ

1 152 951 000

0,5%

1 147 073 000

-2,9%

1 181 651 000

 

Amortisation

CK

44 091 000

-9,4%

48 659 000

-22,0%

62 376 000

 

Stocks

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Raw materials

Net

65 706 000

-8,6%

71 924 000

-0,8%

72 539 000

 

Gross

BL

81 500 000

-6,1%

86 765 000

-5,6%

91 910 000

 

Amortisation

BM

15 794 000

6,4%

14 841 000

-23,4%

19 371 000

Work in progress (goods)

Net

171 499 000

9,3%

156 853 000

-5,0%

165 193 000

 

Gross

BN

174 677 000

8,7%

160 768 000

-6,5%

171 999 000

 

Amortisation

BO

3 178 000

-18,8%

3 915 000

-42,5%

6 806 000

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

161 990 000

16,2%

139 371 000

8,4%

128 573 000

 

Gross

BR

181 971 000

11,1%

163 740 000

4,5%

156 640 000

 

Amortisation

BS

19 981 000

-18,0%

24 369 000

-13,2%

28 067 000

Goods for resale

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

BT

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

BU

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Stocks

Net

399 195 000

8,4%

368 148 000

0,5%

366 305 000

 

Advance payments to suppliers

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Advance payments to suppliers

Net

10 871 000

-23,1%

14 133 000

-37,9%

22 768 000

 

Gross

BV

10 871 000

-23,1%

14 133 000

-37,9%

22 768 000

 

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0

 

Debtors

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Trade accounts receivable

Net

575 470 000

-4,7%

603 923 000

10,2%

547 860 000

 

Gross

BX

578 925 000

-4,7%

607 774 000

9,6%

554 544 000

 

Amortisation

BY

3 455 000

-10,3%

3 851 000

-42,4%

6 684 000

Other debtors

Net

118 519 000

10,8%

107 010 000

-40,2%

178 847 000

 

Gross

BZ

120 202 000

10,6%

108 693 000

-39,7%

180 295 000

 

Amortisation

CA

1 683 000

0%

1 683 000

16,2%

1 448 000

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Debtors

Net

693 989 000

-2,4%

710 933 000

-2,2%

726 707 000

 

Divers

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

 

Gross

CD

0

0%

0

0%

0

 

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

1 367 000

-39,2%

2 249 000

55,6%

1 445 000

 

Gross

CF

1 367 000

-39,2%

2 249 000

55,6%

1 445 000

 

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

 

Sub Total Divers

Net

1 367 000

-39,2%

2 249 000

55,6%

1 445 000

 

Prepaid expenses

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Prepaid expenses

Net

3 438 000

16,5%

2 951 000

44,0%

2 050 000

 

Gross

CH

3 438 000

16,5%

2 951 000

44,0%

2 050 000

 

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts (IV to VI)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Multi-period charges

CW3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

0%

0

 

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

0%

0

 

Currency differential gain

CN3

0

0%

0

0%

0

 

Gross

 

0

0%

0

0%

0

 

References

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

 

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Accounts - Passive
Other capital resources | Provisions for risks and charges | Liabilities | Translation loss | Equalization accounts | References


Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Grand Total (I to V)

EE

1 555 481 000

2,4%

1 519 088 000

0,5%

1 512 164 000

 

Shareholder Equity (I)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Total shareholders' equity (Total I)

DL

474 831 000

7,5%

441 692 000

-4,7%

463 283 000

 

Equity and shareholders' equity

DA

372 884 000

0%

372 884 000

0%

372 884 000

 

Issue and merger premiums

DB

5 503 000

0%

5 503 000

0%

5 503 000

 

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

 

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

 

Legal reserve

DD

5 880 000

14,3%

5 144 000

74,2%

2 953 000

 

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

 

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

 

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

 

Other reserves

DG

0

0%

0

0%

0

 

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

 

0

0%

0

 

Profits or losses brought forward

DH

7 673 000

25,6%

6 110 000

-23,5%

7 988 000

 

Profit or loss for the period

DI

36 878 000

150,4%

14 728 000

-66,4%

43 816 000

 

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

 

Special tax-allowable reserves

DK

46 013 000

23,3%

37 323 000

23,8%

30 139 000

 

Other capital resources (II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

 

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

 

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

 

Provisions for risks and charges (III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

228 451 000

-8,0%

248 284 000

-7,6%

268 579 000

 

Risk provisions

DP

147 528 000

-17,8%

179 568 000

-33,1%

268 579 000

 

Reserves for charges

DQ

80 923 000

17,8%

68 716 000

0%

0

 

Liabilities (IV)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Total Liabilities (Total IV)

EC

852 199 000

2,8%

829 112 000

6,3%

780 302 000

 

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

 

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

 

Bank loans and liabilities

DU

0

0%

0

0%

0

 

Sundry loans and financial liabilities

DV

106 019 000

237,7%

31 397 000

-18,0%

38 267 000

 

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

 

Advance payments received for current orders

DW

438 492 000

-9,2%

483 018 000

12,1%

430 750 000

 

Trade accounts payables

DX

178 800 000

0,8%

177 308 000

10,4%

160 545 000

 

Tax and social security liabilities

DY

97 168 000

-4,4%

101 655 000

12,9%

90 009 000

 

Fixed asset liabilities

DZ

6 939 000

-40,4%

11 636 000

-13,8%

13 495 000

 

Other debts

EA

10 035 000

122,2%

4 516 000

108,2%

2 169 000

 

Translation loss (V)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Translation loss (Total V)

ED

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Deferred income

EB

14 746 000

-24,7%

19 582 000

-56,5%

45 067 000

 

References

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

 

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

 

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Result account
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges | Financial income | Financial charges | Financial charges | Extraordinary charges | Employee profit sharing | Tax on profits | References


1- Operating result (I-II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Operating result (Total I-II)

GG

-36 148 000

20,4%

-45 434 000

33,8%

-68 655 000

 

2 - Financial result (V - VI)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Financial result (Total V-VI)

GV

49 037 000

133,9%

20 961 000

-77,6%

93 447 000

 

3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

12 889 000

152,7%

-24 473 000

-198,7%

24 792 000

 

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

-8 854 000

-222,9%

7 206 000

151,3%

-14 044 000

 

Profit or loss

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Profit or loss

HN

36 878 000

150,4%

14 728 000

-66,4%

43 816 000

 

Total Income (I+III+V+VII)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Total Income (I+III+V+VII)

HL

1 403 474 000

6,7%

1 314 864 000

10,8%

1 187 229 000

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

1 366 597 000

5,1%

1 300 136 000

13,7%

1 143 413 000

 

Operating income (I)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Total operating income (Total I)

FR

1 348 591 000

5,4%

1 279 200 000

18,2%

1 082 581 000

 

Operating income (details)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Sale of goods for resale

FC

0

0%

0

0%

0

 

France

FA

0

0%

0

0%

0

 

Export

FB

0

0%

0

0%

0

Sale of goods produced

FF

1 204 654 000

4,7%

1 150 103 000

14,1%

1 007 738 000

 

France

FD

700 940 000

-39,1%

1 150 103 000

14,1%

1 007 738 000

 

Export

FE

503 714 000

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

0

0%

0

0%

0

 

France

FG

0

0%

0

0%

0

 

Export

FH

0

0%

0

0%

0

Net turnover

FL

1 204 654 000

4,7%

1 150 103 000

14,1%

1 007 738 000

 

France

FJ

700 940 000

-39,1%

1 150 103 000

14,1%

1 007 738 000

 

Export

FK

503 714 000

0%

0

0%

0

 

Stocked production

FM

32 937 000

662,1%

4 322 000

149,4%

-8 754 000

 

Self-constructed assets

FN

15 570 000

17,8%

13 219 000

4,0%

12 714 000

 

Operating grants

FO

4 890 000

-2,5%

5 015 000

-12,9%

5 755 000

 

Release of reserves and provisions

FP

84 746 000

-10,5%

94 680 000

51,8%

62 355 000

 

Other income

FQ

5 794 000

-51,2%

11 861 000

327,7%

2 773 000

 

Operating charges (II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Total operating charges (Total II)

GF

1 384 739 000

4,5%

1 324 634 000

15,1%

1 151 236 000

 

Exploitation charges

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Purchase of goods for resale

FS

0

0%

0

0%

0

 

Change in stocks of goods for resale

FT

0

0%

0

0%

0

 

Purchase of raw materials

FU

374 188 000

31,4%

284 743 000

42,7%

199 600 000

 

Change in stocks of raw materials

FV

6 063 000

-16,7%

7 276 000

-64,7%

20 587 000

 

Other external purchases and charges

FW

420 658 000

-7,4%

454 162 000

7,3%

423 171 000

 

Tax, duty and similar payments

FX

30 215 000

2,2%

29 555 000

-10,7%

33 088 000

 

Payroll

FY

285 473 000

-0,5%

286 831 000

5,9%

270 759 000

 

Social security costs

FZ

158 920 000

5,2%

151 080 000

12,6%

134 192 000

 

Depreciation

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Depreciation of fixed assets

GA

33 339 000

24,2%

26 837 000

19,8%

22 402 000

 

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

0

 

Depreciation/amortisation of current assets

GC

4 340 000

-8,5%

4 744 000

-44,9%

8 615 000

 

Provisions for risks and charges

GD

56 007 000

0,2%

55 893 000

82,3%

30 656 000

 

Other charges

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Other charges

GE

15 536 000

-33,9%

23 513 000

187,9%

8 166 000

 

Operating charges (III-IV)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

 

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

 

Financial income (V)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Total financial income (Total V)

GP

54 171 000

150,0%

21 669 000

-79,3%

104 648 000

 

Share financial income

GJ

54 171 000

150,1%

21 661 000

-79,3%

104 648 000

 

Other investment income & capitalised receivables

GK

0

0%

0

0%

0

 

Other interest and similar income

GL

0

0%

8 000

0%

0

 

Released provisions and transferred charges

GM

0

0%

0

0%

0

 

Exchange gains

GN

0

0%

0

0%

0

 

Net income from disposal of investment securities

GO

0

0%

0

0%

0

 

Financial Charge (VI)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Total financial charge (Total VI)

GU

5 134 000

625,1%

708 000

-93,7%

11 201 000

 

Financial reserves and provisions

GQ

1 754 000

314,7%

423 000

-90,0%

4 220 000

 

Interest and similar charges

GR

3 219 000

0%

0

0%

6 591 000

 

Exchange losses

GS

161 000

-43,5%

285 000

-26,9%

390 000

 

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary income (VII)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Total extraordinary income (Total VII)

HD

712 000

-94,9%

13 995 000

0%

0

 

Extraordinary operating income

HA

712 000

-32,5%

1 055 000

0%

0

 

Extraordinary income from capital transactions

HB

0

0%

12 940 000

0%

0

 

Released provisions and transferred charges

HC

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary charges (VIII)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

9 566 000

40,9%

6 789 000

-51,7%

14 044 000

 

Extraordinary operating charges

HE

0

0%

0

0%

442 000

 

Extraordinary charges from capital transactions

HF

877 000

0%

0

0%

523 000

 

Extraordinary reserves and provisions

HG

8 689 000

28,0%

6 789 000

-48,1%

13 079 000

 

Employee profit sharing (IX)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

0

0%

0

0%

17 000

 

Tax on profits (X)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Tax on profits (Total X)

HK

-32 842 000

-2,6%

-31 995 000

3,3%

-33 085 000

 

References

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

 

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

 

Of which transferred charges

A1

0

0%

0

0%

0

 

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

 

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

 

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Other incomes tax return forms
Reserve for depreciation | Provisions included in balance sheet | State deadlines claims and debts at the end of period
Table allocation results and other information


Fixed Assets
Grand Total Fixed Assets (I to IV)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

OK2

13 521 000

-71,7%

47 791 000

-21,8%

61 102 000

 

Gross value at the end of period

OL

798 893 000

6,8%

748 350 000

4,3%

717 359 000

 

Research and development Charge (Total I)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

 

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

C01

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

C02

0

0%

0

0%

0

 

Gross value at the end of period

D0

0

0%

0

0%

0

 

Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Gross value at begin of period

KD

24 128 000

12,1%

21 527 000

23,2%

17 471 000

 

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

8 523 000

214,2%

2 713 000

-30,6%

3 908 000

 

Decreasess by budget item transfer

LV1

-400 000

-26,6%

-316 000

36,8%

-500 000

 

Decreasess by transfers

LV2

249 000

-41,8%

428 000

21,6%

352 000

 

Gross value at the end of period

LW

32 802 000

35,9%

24 128 000

12,1%

21 527 000

 

Tangible fixed assets (Total III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Gross value at begin of period

LN

492 063 000

7,8%

456 358 000

11,5%

409 175 000

 

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

43 753 000

-41,9%

75 254 000

-30,5%

108 344 000

 

Decreasess by budget item transfer

NG1

400 000

26,6%

316 000

-36,8%

500 000

 

Decreasess by transfers

NG2

12 457 000

-68,2%

39 233 000

-35,3%

60 661 000

 

Gross value at the end of period

NH

522 959 000

6,3%

492 063 000

7,8%

456 358 000

 

Fiancial assets (Total IV)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Gross value at begin of period

LQ

232 159 000

-3,1%

239 474 000

5,5%

226 947 000

 

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

 

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

11 788 000

1346,4%

815 000

-93,5%

12 616 000

 

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by transfers

NJ2

815 000

-90,0%

8 130 000

9034,8%

89 000

 

Gross value at the end of period

NK

243 132 000

4,7%

232 159 000

-3,1%

239 474 000

 

Reserve for depreciation
Situation and movement of reserve for depreciation
Grand total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Reserve for depreciation value at begin of period

0N

0

0%

0

0%

0

Increases

0P

0

0%

0

0%

0

Decreasess

0Q

0

0%

0

0%

0

 

Reserve for depreciation value at the end of period

0R

0

0%

0

0%

0

 

Research and development charge (Total I)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0

 

Other intangible assets (Total II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

0

0%

0

0%

0

Increases

PF

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PG

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

PH

0

0%

0

0%

0

 

Total fixed assets amotisation (Total III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

0

0%

0

0%

0

Increases

QV

0

0%

0

0%

0

Decreases

QW

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

QX

0

0%

0

0%

0


Movements during period affecting charge allocated over several period

Charges à répartir ou frais d'émission d'emprunt

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

 

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0

 

Premium refund of obligations

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Net value at begining of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

 

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

 

Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Value at begining of period

7C

298 469 000

6,0%

281 442 000

0%

0

Increases

UB

73 333 000

31,1%

55 946 000

0%

0

Decreases

UC

82 721 000

8,5%

76 242 000

0%

0

 

Value at the end of period

UD

289 081 000

10,7%

261 146 000

0%

0

Includes Total allocations

 

Operating

UE

56 007 000

4,3%

53 693 000

0%

0

 

Financial

UG

0

0%

53 000

0%

0

 

Exceptional

UJ

0

0%

0

0%

0

Includes Total Withdrawal

 

Operating

UF

75 839 000

0,0%

75 846 000

0%

0

 

Financial

UH

0

0%

0

0%

0

 

Exceptional

UK

0

0%

396 000

0%

0

 

Total regulated provisions (Total I)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Value at begining of period

3Z

37 323 000

0%

0

0%

0

Increases

TS

15 572 000

0%

0

0%

0

Decreases

TT

6 882 000

0%

0

0%

0

 

Value at the end of period

TU

46 013 000

0%

0

0%

0

 

Total risk and charge provisions (Total II)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Value at begining of period

5Z

248 283 000

-7,6%

268 579 000

0%

0

Increases

TV

56 007 000

0,1%

55 946 000

0%

0

Decreases

TW

75 839 000

-0,5%

76 242 000

0%

0

 

Value at the end of period

TX

228 451 000

-8,0%

248 283 000

0%

0

 

Total Provision for depreciation (Total III)

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Value at begining of period

7B

12 863 000

0%

12 863 000

0%

0

Increases

TY

1 754 000

0%

0

0%

0

Decreases

TZ

0

0%

0

0%

0

 

Value at the end of period

UA

14 617 000

13,6%

12 863 000

0%

0

 

State deadlines claims and debts at the end of period
State claims

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Gross value

VT

714 021 000

-2,4%

731 309 000

-1,1%

739 114 000

 

1 year at most

VU

636 398 000

-6,9%

683 773 000

-7,2%

736 701 000

 

More than one year

VV

77 623 000

63,3%

47 536 000

1870,0%

2 413 000

 

State of loans

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Claims related to holdings (gross)

UL

1 011 000

42,2%

711 000

0%

711 000

 

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

300 000

0%

0

0%

0

 

Loans (gross)

UP

8 955 000

-8,0%

9 737 000

0%

0

 

Loans (1 year at most)

UR

800 000

-87,7%

6 493 000

0%

0

 

Other financial assets (gross)

UT

1 490 000

3,3%

1 443 000

-4,7%

1 514 000

 

Other financial assets (1 year at most)

UV

26 000

-27,8%

36 000

-2,7%

37 000

 

Receivables statement of assets

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Customers doubtful or disputed

VA

0

0%

0

0%

0

 

Other claims customer

UX

578 925 000

-4,7%

607 774 000

9,6%

554 544 000

 

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

 

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

 

Personnel and associated accounts

UY

0

0%

0

0%

0

 

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

0

0%

0

 

Income taxes

VM

0

0%

0

0%

0

 

Value added tax

VB

0

0%

0

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

VN

0

0%

0

0%

0

 

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

0

0%

0

 

Group and Associates

VC

0

0%

0

0%

0

 

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

120 202 000

10,6%

108 693 000

-39,7%

180 295 000

 

Prepaid

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Prepaid

VS

3 438 000

16,5%

2 951 000

44,0%

2 050 000

 

State Debt

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Total debt (gross)

VY

413 707 000

19,5%

346 094 000

-1,0%

349 552 000

1 year at most

VZ2

386 632 000

23,0%

314 382 000

0,4%

313 262 000

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

5 138 000

-54,2%

11 208 000

-15,7%

13 291 000

More than 5 years

VZ4

21 937 000

7,0%

20 504 000

-10,8%

22 999 000

 

Details

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VG2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VH2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

106 019 000

237,7%

31 397 000

-18,0%

38 267 000

1 year at most

8A2

84 398 000

1369,1%

5 745 000

-33,5%

8 643 000

More than 1 year and 5 years at most

8A3

2 714 000

-69,1%

8 784 000

-19,2%

10 867 000

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

178 800 000

0,8%

177 308 000

10,4%

160 545 000

1 year at most

8B2

178 800 000

0,8%

177 308 000

10,4%

160 545 000

More than 1 year and 5 years at most

8B3

178 800 000

0,8%

177 308 000

10,4%

160 545 000

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8C2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

97 168 000

-4,4%

101 655 000

12,9%

90 009 000

1 year at most

8D2

97 168 000

-4,4%

101 655 000

12,9%

90 009 000

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (gross)

VW1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VW2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VQ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

6 939 000

-40,4%

11 636 000

-13,8%

13 495 000

1 year at most

8J2

6 939 000

-40,4%

11 636 000

-13,8%

13 495 000

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VI2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More 5 years

VI4

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

10 035 000

122,2%

4 516 000

108,2%

2 169 000

1 year at most

8K2

10 035 000

122,2%

4 516 000

108,2%

2 169 000

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

14 746 000

-24,7%

19 582 000

-56,5%

45 067 000

1 year at most

8L2

9 292 000

-31,3%

13 522 000

-64,8%

38 401 000

More than 1 year and 5 years at most

8L3

2 424 000

0%

2 424 000

0%

2 424 000

 

References

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Loans made during the period

VJ

0

0%

0

0%

0

 

Debt repaid during the period

VK

0

0%

0

0%

0

 

Table allocation results and other information
Dividends distributed

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0

 

Commitments

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Commitments leasing furniture

YQ

56 759

0%

0

0%

0

 

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

 

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0

 

Other charges Externes

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

 

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

 

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

 

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

 

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

 

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

 

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0

 

Taxes and Fees

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

 

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

 

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0

 

VAT

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

 

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0

 

Average number of employees

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Average number of employees

YP

6 059

-1,7%

6 165

1,4%

6 082

 

Groups and Shareholders

 

 

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

 

Groups and Shareholders

ZR

-

-

-

-

-

 

 

Display parameter

Comparison mode

Average

Median


Ratios
Structure and liquidity | Management or rotation | Profitability of the business | Return on capital


Structure and Liquidity

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Sector Median 2011

 

Fixed Asset Financing

1,45

3,6%

1,40

-8,5%

1,53

1,76

-17,6%

Global Debt

255 days

-1,9%

260 days

-6,8%

279 days

162 days

57,4%

Working Capital Fund overall net

108 days

14,9%

94 days

-30,4%

135 days

100 days

8,0%

Financial independence

%

-

%

-

%

950,68%

-

More ratios

Solvability

30,53%

5,0%

29,08%

-5,1%

30,64%

45,98%

-33,6%

Capacity debt futures

%

-

%

-

%

1680,34%

-

Coverage of current assets by net working capital overall

31,55%

20,1%

26,28%

-17,8%

31,98%

44,85%

-29,7%

General Liquidity

1,65

-24,0%

2,17

-7,7%

2,35

0,97

70,1%

Restricted Liquidity

1,65

-24,3%

2,18

-7,6%

2,36

1,38

19,6%

 

Management or rotation

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Sector Median 2011

 

Need background in operating working capital

111 days

12,1%

99 days

-34,0%

150 days

56 days

98,2%

Treasury

0 days

0%

1 days

0%

1 days

7 days

0%

Inventory turnover of goods

days

-

days

-

days

59 days

-

Average length of credit granted to customers

173 days

-8,9%

190 days

-4,0%

198 days

68 days

154,4%

Average length of credit obtained suppliers

80 days

-7,0%

86 days

-4,4%

90 days

82 days

-2,4%

More ratios

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

78 days

-29,1%

110 days

-33,7%

166 days

43 days

81,4%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

230 days

-1,7%

234 days

5,9%

221 days

418 days

-45,0%

Rotation tangible assets

230,35%

-1,4%

233,73%

5,8%

220,82%

592,09%

-61,1%

 

Profitability of the business

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Sector Median 2011

 

Margin trading

0%

0%

0%

0%

0

0%

0%

Profitability of the business

-1,45

59,3%

-3,56

43,9%

-6,35

5,38%

-127,0%

Net profit

3,06%

139,1%

1,28%

-70,6%

4,35%

3,34%

-8,4%

More ratios

Growth rate of turnover (excluding VAT)

4,74%

-66,5%

14,13%

-23,0%

18,36%

0%

0%

Rates integration

37,54%

2,4%

36,65%

0,3%

36,55%

36,55%

2,7%

Rate leasing furniture

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Work Factor

98,26%

-5,4%

103,90%

-5,5%

109,94%

77,38%

27,0%

Weight interests

0,43

616,7%

0,06%

-94,6%

1,11%

0,20%

115,0%

 

Return on capital

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Sector Median 2011

 

Cash flow from the overall profitability

0,47%

113,4%

-3,51%

-142,1%

8,34%

5,92%

-92,1%

Rates of economic profitability

-3%

66,7%

-9%

30,8%

-13%

12%

-125,0%

Financial profitability

474831000%

7,5%

441692000%

-4,7%

463283000%

260634%

182083,1%

Return on investment

7,23%

121,8%

3,26%

-70,3%

10,97%

13,06%

-44,6%

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

Comparison mode

Average

Median

 

Soldes Intermédiaires de Gestion

 

31/12/2011

 

31/12/2010

 

31/12/2009

Sector Median 2011

 

Turnover

1 204 654 000

4,7%

1 150 103 000

14,1%

1 007 738 000

650 489 € 

185092,1% 

 

Sales of goods

0

0%

0

0%

0

 

 

- Purchase of goods

0

0%

0

0%

0

 

 

+/- Stock of goods variation

0

0%

0

0%

0

 

 

Trading margin

0 €

0%

0 €

0%

0 €

0 € 

0% 

 

0,00 % CA

0%

0,00 % CA

0%

0,00 % CA

0 % CA 

0% 

 

Sale of goods produced

1 204 654 000

4,7%

1 150 103 000

14,1%

1 007 738 000

 

 

+/- Stocked production

32 937 000

662,1%

4 322 000

149,4%

-8 754 000

 

 

+ Self-constructed assets

15 570 000

17,8%

13 219 000

4,0%

12 714 000

 

 

Period production

1 253 161 000 €

7,3%

1 167 644 000 €

15,4%

1 011 698 000 €

356 989 € 

350936,3% 

 

104,03 % CA

2,5%

101,53 % CA

1,1%

100,39 % CA

100 % CA 

4,0% 

 

Trading margin

0

0%

0

0%

0

0% 

+ Period Production

1 253 161 000

7,3%

1 167 644 000

15,4%

1 011 698 000

356 989 

350936,3% 

- Purchase of raw materials

374 188 000

31,4%

284 743 000

42,7%

199 600 000

 

 

+/- Change in stocks of raw materiels

6 063 000

-16,7%

7 276 000

-64,7%

20 587 000

 

 

- Other external purchases and charges

420 658 000

-7,4%

454 162 000

7,3%

423 171 000

 

 

Added value

452 252 000 €

7,3%

421 463 000 €

14,4%

368 340 000 €

180 275 € 

250767,8% 

 

37,54 % CA

2,4%

36,65 % CA

0,3%

36,55 % CA

36,55 % CA 

2,7% 

 

Added value

452 252 000 €

7,3%

421 463 000 €

14,4%

368 340 000 €

180 275 € 

250767,8% 

+ Operating grants

4 890 000

-2,5%

5 015 000

-12,9%

5 755 000

 

 

- Tax, duty and similar payments

30 215 000

2,2%

29 555 000

-10,7%

33 088 000

 

 

- Personal charges

444 393 000

1,5%

437 911 000

8,1%

404 951 000

 

 

Gross operating surplus

-17 466 000 €

57,4%

-40 988 000 €

35,9%

-63 944 000 €

29 262 € 

-59788,3% 

 

-1,45 % CA

59,3%

-3,56 % CA

43,9%

-6,35 % CA

5,38 % CA 

-127,0% 

 

Gross operating surplus

-17 466 000 €

57,4%

-40 988 000 €

35,9%

-63 944 000 €

29 262 € 

-59788,3% 

+ Release of reserves and provisions

84 746 000

-10,5%

94 680 000

51,8%

62 355 000

 

 

+ Other operating income

5 794 000

-51,2%

11 861 000

327,7%

2 773 000

 

 

- Depreciation/Amortisation

93 686 000

7,1%

87 474 000

41,8%

61 673 000

 

 

- Other charges

15 536 000

-33,9%

23 513 000

187,9%

8 166 000

 

 

Operating result

-36 148 000 €

20,4%

-45 434 000 €

33,8%

-68 655 000 €

22 986 € 

-157360,9% 

 

-3,00 % CA

24,1%

-3,95 % CA

42,0%

-6,81 % CA

2,67 % CA 

-212,4% 

 

Operating result

-36 148 000 €

20,4%

-45 434 000 €

33,8%

-68 655 000 €

22 986 € 

-157360,9% 

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Financial income

54 171 000

150,0%

21 669 000

-79,3%

104 648 000

 

 

- Financial charges

5 134 000

625,1%

708 000

-93,7%

11 201 000

 

 

Pre-tax result

12 889 000 €

152,7%

-24 473 000 €

-198,7%

24 792 000 €

27 119 € 

47427,6% 

 

1,07 % CA

150,2%

-2,13 % CA

-186,6%

2,46 % CA

3,70 % CA 

-71,1% 

 

Extraordinary income

712 000

-94,9%

13 995 000

0%

0

1 103 

64451,2% 

- Extraordinary charges

9 566 000

40,9%

6 789 000

-51,7%

14 044 000

 

 

Extraordinary result

-8 854 000 €

-222,9%

7 206 000 €

151,3%

-14 044 000 €

0 € 

0% 

 

-0,73 % CA

-215,9%

0,63 % CA

145,3%

-1 % CA

0 % CA 

0% 

 

Pre-tax result

12 889 000 €

152,7%

-24 473 000 €

-198,7%

24 792 000 €

27 119 € 

47427,6% 

Extraordinary result

-8 854 000 €

-222,9%

7 206 000 €

151,3%

-14 044 000 €

0 € 

0% 

- Employee profit sharing

0

0%

0

0%

17 000

 

 

- Tax on profits

-32 842 000

-2,6%

-31 995 000

3,3%

-33 085 000

 

 

Net result

36 877 000 €

150,4%

14 728 000 €

-66,4%

43 816 000 €

27 403 € 

134472,9% 

3,06 % CA

139,1%

1,28 % CA

-70,6%

4,35 % CA

3,35 % CA 

-8,7% 

 

ADDITIONAL INFORMATION

 

 Trends

 

Profitability

Liquidity

Net worth

 

Company details

Company details

 

 

 

Activity (APE)

Manufacture of navigational aids (2651A)

 

RCS Registration

RCS Nanterre 1 480 107 911

Share capital

372,884,426 Euros

 

Registration Court

Nanterre (92)

Legal form

Public limited company with board of directors

 

Court Registry Number

20 1 3B06679

EUR VAT Number

FR39480107911

 

Incorporation Date

12/2004

Formation Date

05/2005

 

Deregistration Date

 

Last account Date

31/12/2011

 

Nationality

France

 

Establishment details

 

 

 

Activity (APE)

Fabrication d'équipements d'aide à la navigation (2651A)

Business Pages FT®

 

 

Postal Address

SAGEM DEFENSE SECURITE
18 AU 20
18 QUAI DU POINT DU JOUR
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Trading Address

18 QUAI DU POINT DU JOUR
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

 

Telephone

 

 

 

Other establishments

 

 

Branches

21 branch entities in this company

 

Head office

 
> SAGEM DEFENSE SECURITE <<<  - Fabrication d'équipements d'aide à la navigation (2651A)  in BOULOGNE BILLANCOURT  (92100)
 

 

Secondary establishments

>  SAGEM DEFENSE SECURITE  - Fabrication d'équipements d'aide à la navigation (2651A)  in DIJON  (21000)
>  SAGEM DEFENSE SECURITE  - Fabrication d'équipements d'aide à la navigation (2651A)  in MONTPELLIER  (34000)
>  SAGEM DEFENSE SECURITE  - Fabrication d'équipements d'aide à la navigation (2651A)  in MASSY  (91300)
>  SAGEM DEFENSE SECURITE  - Fabrication d'équipements d'aide à la navigation (2651A)  in PALAISEAU  (91120)
> ...

 

 

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas having at least 50% of workforce in same area

 

Mono-activity status

Legal unit having all establishments with the same main activity

 

Workforces

 

 

 

Workforce at address

250 to 499 employees

Company workforce

5 000+ employees

 

Event history

 

Status history

 

 

Date

Description

01/09/2013

Economically active

 

Company events history

 

 

Date

Description

04/03/2014

Collection of preferential rights for this company has been stopped by the Court

26/11/2013

Bodacc B: Various editing or changing

18/11/2013

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

18/11/2013

Minutes of Board meeting

18/11/2013

Changes to the Board of Directors

01/11/2013

Disengagement in other companies

21/10/2013

Legal Gazette: Appointment of the social representative

02/10/2013

Bodacc A : Registration

24/09/2013

Minutes of Board meeting

24/09/2013

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

24/09/2013

Updated articles of association

24/09/2013

Legal Gazette: Head Office Transfer

01/09/2013

Update of Company Head Office Identifier

01/09/2013

Transfer of Establishment

23/07/2013

Bodacc B: Various editing or changing

08/07/2013

Amendment

08/07/2013

Changes to the Board of Directors

08/07/2013

Appointment/resignation of company officers

05/07/2013

New subsidiarie(s) detected

05/07/2013

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

27/06/2013

Legal Gazette: Appointment of the social representative

17/06/2013

Bodacc C : Deposit accounts notice

22/05/2013

Invalid balance sheet

03/03/2013

Bodacc A : Sale and transfer

23/01/2013

Power of attorney

23/01/2013

Declaration of conformity

23/01/2013

Partial contribution

23/01/2013

Amendment

23/01/2013

Minutes of general meeting of shareholders

25/11/2012

Bodacc B: Various editing or changing

23/11/2012

Spin-off

23/11/2012

Private document

14/11/2012

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

09/11/2012

Changes to the Board of Directors

09/11/2012

Amendment

23/10/2012

New Filling of Tax Office preferential right

23/10/2012

Unfiling of a Tax Office preferential right

04/08/2012

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

25/06/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

02/03/2012

Update of participations in other companies

10/02/2012

Declaration of conformity

10/02/2012

Merger

10/02/2012

Minutes of general meeting of shareholders

11/01/2012

Appointment/resignation of company officers

11/01/2012

Office copy

31/12/2011

New accounts available

30/11/2011

Legal Gazette: Proposed merger

25/11/2011

Planned merger

23/11/2011

Unfiling of a Tax Office preferential right

23/11/2011

New Filling of Tax Office preferential right

04/11/2011

Disengagement in other companies

04/11/2011

New subsidiarie(s) detected

13/07/2011

Bodacc A : Sale and transfer

04/07/2011

Bodacc C : Deposit accounts notice

29/06/2011

Bodacc B: Various editing or changing

16/06/2011

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

14/06/2011

Changes to the Board of Directors

14/06/2011

New chairman (CEO, CoB)

14/06/2011

Amendment

07/06/2011

Legal Gazette: Appointment of the social representative

18/05/2011

Amendment

18/05/2011

Minutes of Board meeting

18/05/2011

Minutes of general meeting of shareholders

01/04/2011

Bodacc A : Sale and transfer

02/03/2011

Bodacc A : Sale and transfer

31/12/2010

New accounts available

31/12/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

15/11/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

09/07/2010

New subsidiarie(s) detected

08/07/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

16/06/2010

Bodacc B: Various editing or changing

06/06/2010

Bodacc A : Sale and transfer

28/05/2010

New auditor

28/05/2010

Acte modificatif

28/05/2010

Amendment

28/05/2010

Changement de Commissaire aux Comptes

28/05/2010

Minutes of Board meeting

28/05/2010

PV d'Assemblée

28/05/2010

Minutes of general meeting of shareholders

28/05/2010

Nomination/démission des organes de gestion

28/05/2010

Appointment/resignation of company officers

28/05/2010

Changes to the Board of Directors

28/05/2010

Modification du Conseil d'Administration

21/05/2010

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

06/05/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

11/02/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

25/01/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

31/12/2009

New accounts available

08/08/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

24/03/2009

Bodacc B: Various editing or changing

09/03/2009

Apport Partiel

09/03/2009

Partial contribution

09/03/2009

Augmentation de Capital

09/03/2009

Capital increase

09/03/2009

Réduction de Capital

09/03/2009

Capital reduction

09/03/2009

Private document

09/03/2009

Déclaration de conformité

09/03/2009

Declaration of conformity

09/03/2009

PV d'Assemblée

09/03/2009

Minutes of general meeting of shareholders

09/03/2009

Minutes of Board meeting

09/03/2009

Statuts mis à jour

09/03/2009

Updated articles of association

09/03/2009

Rapport des Commissaires ou du Gérant

09/03/2009

Audit or Management Report

09/03/2009

Power of attorney

09/03/2009

Procuration

09/03/2009

Acte modificatif

09/03/2009

Amendment

20/01/2009

Private document

20/01/2009

Audit or Management Report

20/01/2009

Rapport des Commissaires ou du Gérant

31/12/2008

New accounts available

23/12/2008

Partial contribution

23/12/2008

Planned merger

23/12/2008

Apport Partiel

23/12/2008

Private document

05/11/2008

Bodacc A : Sale and transfer

05/11/2008

New Bodacc A ads detected

27/08/2008

New Bodacc B ads detected

27/08/2008

Bodacc B: Various editing or changing

05/08/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

05/08/2008

New Bodacc B ads detected

05/08/2008

Bodacc B: Various editing or changing

28/07/2008

Appointment/resignation of company officers

28/07/2008

Private document

28/07/2008

Changes to the Board of Directors

28/07/2008

Updated articles of association

28/07/2008

Statuts mis à jour

28/07/2008

Minutes of general meeting of shareholders

28/07/2008

PV d'Assemblée

24/07/2008

Changes to the Board of Directors

24/07/2008

Private document

24/07/2008

Minutes of Board meeting

24/07/2008

Modification du Conseil d'Administration

24/07/2008

Amendment

24/07/2008

Acte modificatif

19/06/2008

Appointment/resignation of company officers

19/06/2008

Changes to the Board of Directors

19/06/2008

Private document

19/06/2008

Modification du Conseil d'Administration

19/06/2008

Minutes of general meeting of shareholders

19/06/2008

Acte modificatif

03/04/2008

Bodacc B: Various editing or changing

04/03/2008

Collection of preferential rights activated for this company

31/12/2007

New accounts available

15/11/2007

Changes to the Board of Directors

15/11/2007

Modification du Conseil d'Administration

15/11/2007

Private document

15/11/2007

Appointment/resignation of company officers

15/11/2007

PV du Conseil d'Administration

15/11/2007

Minutes of Board meeting

15/11/2007

Acte modificatif

19/10/2007

Appointment/resignation of company officers

19/10/2007

Nomination/démission des organes de gestion

19/10/2007

Private document

19/10/2007

Amendment

19/10/2007

Acte modificatif

19/10/2007

Changes to the Board of Directors

19/10/2007

Modification du Conseil d'Administration

19/10/2007

Changement de Président (PDG, PCA)

19/10/2007

Minutes of general meeting of shareholders

19/10/2007

New chairman (CEO, CoB)

12/07/2007

Minutes of Board meeting

12/07/2007

PV d'Assemblée

12/07/2007

Minutes of general meeting of shareholders

12/07/2007

Private document

12/07/2007

Capital increase

12/07/2007

Declaration of conformity

12/07/2007

Acte modificatif

12/07/2007

Procuration

23/05/2007

Acte sous seing privé

23/05/2007

Projet de Fusion

23/05/2007

Planned merger

23/05/2007

Private document

31/12/2006

New accounts available

05/12/2006

Changement de Président (PDG, PCA)

05/12/2006

New chairman (CEO, CoB)

05/12/2006

Acte modificatif

05/12/2006

Minutes of Board meeting

05/12/2006

Minutes of general meeting of shareholders

05/12/2006

Appointment/resignation of company officers

05/12/2006

Private document

05/12/2006

Changes to the Board of Directors

05/12/2006

Modification du Conseil d'Administration

09/03/2006

Nomination/démission des organes de gestion

09/03/2006

Appointment/resignation of company officers

09/03/2006

Minutes of Board meeting

09/03/2006

Private document

09/03/2006

Acte sous seing privé

09/03/2006

Acte modificatif

09/03/2006

PV du Conseil d'Administration

09/03/2006

Modification du Conseil d'Administration

31/12/2005

New accounts available

16/12/2005

Updated articles of association

16/12/2005

Modification du Conseil d'Administration

16/12/2005

PV d'Assemblée

16/12/2005

Minutes of general meeting of shareholders

16/12/2005

Changes to the Board of Directors

16/12/2005

Nomination/démission des organes de gestion

16/12/2005

Appointment/resignation of company officers

16/12/2005

Acte modificatif

16/12/2005

New chairman (CEO, CoB)

16/12/2005

Changement de Président (PDG, PCA)

16/12/2005

PV du Conseil d'Administration

16/12/2005

Private document

16/12/2005

Acte sous seing privé

16/12/2005

Minutes of Board meeting

16/12/2005

Statuts mis à jour

20/06/2005

PV du Conseil d'Administration

20/06/2005

Minutes of Board meeting

20/06/2005

PV d'Assemblée

20/06/2005

Minutes of general meeting of shareholders

20/06/2005

Nomination/démission des organes de gestion

20/06/2005

Appointment/resignation of company officers

20/06/2005

Déclaration de conformité

20/06/2005

Declaration of conformity

20/06/2005

Private document

20/06/2005

Acte sous seing privé

20/06/2005

Modification du Conseil d'Administration

20/06/2005

Changes to the Board of Directors

20/06/2005

Capital increase

20/06/2005

Augmentation de Capital

20/06/2005

Apport Partiel

20/06/2005

Acte modificatif

20/06/2005

Statuts mis à jour

20/06/2005

Updated articles of association

04/05/2005

Acte modificatif

04/05/2005

Modification du Conseil d'Administration

04/05/2005

Acte sous seing privé

04/05/2005

Private document

04/05/2005

Appointment/resignation of company officers

04/05/2005

Nomination/démission des organes de gestion

04/05/2005

Minutes of general meeting of shareholders

04/05/2005

PV d'Assemblée

04/05/2005

Minutes of Board meeting

04/05/2005

PV du Conseil d'Administration

04/05/2005

Statuts mis à jour

04/05/2005

Updated articles of association

03/05/2005

Modification de l'objet social

03/05/2005

Change to corporate purpose

03/05/2005

Statuts mis à jour

03/05/2005

Updated articles of association

03/05/2005

New company name

03/05/2005

PV d'Assemblée

03/05/2005

Acte sous seing privé

03/05/2005

Private document

03/05/2005

Changement de dénomination sociale

03/05/2005

Minutes of general meeting of shareholders

27/04/2005

Private document

27/04/2005

Acte sous seing privé

27/04/2005

New closing date

27/04/2005

Changement de date de clôture

27/04/2005

Prorogation de durée

27/04/2005

Statuts mis à jour

27/04/2005

Updated articles of association

27/04/2005

PV d'Assemblée

27/04/2005

Minutes of general meeting of shareholders

25/04/2005

Private document

25/04/2005

Acte sous seing privé

25/04/2005

Audit or Management Report

25/04/2005

Rapport des Commissaires ou du Gérant

07/04/2005

Acte sous seing privé

07/04/2005

Scission

07/04/2005

Projet de Fusion

07/04/2005

Planned merger

07/04/2005

Private document

31/12/2004

New accounts available

29/12/2004

Changement de Président (PDG, PCA)

29/12/2004

Acte sous seing privé

29/12/2004

Private document

29/12/2004

Certificat de dépôt des fonds

29/12/2004

Fund deposit certificate

29/12/2004

Appointment/resignation of company officers

29/12/2004

Nomination/démission des organes de gestion

29/12/2004

Minutes of Board meeting

29/12/2004

PV du Conseil d'Administration

29/12/2004

Articles of association

29/12/2004

Statuts

29/12/2004

Acte modificatif

29/12/2004

Company formation

29/12/2004

Formation de Société

 

 

Establishment events history

 

 

Date

Description

09/02/2014

Update Rating

31/10/2013

Update Rating

31/10/2013

Update Limit

01/09/2013

Formation of Head office (after transfer)


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.62.28

UK Pound

1

Rs.103.67

Euro

1

Rs.85.18

 

INFORMATION DETAILS

 

Report Prepared by :

MNL

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

New Business

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.