MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

20.02.2014

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

MIM

 

 

Registered Office :

18-24 ZI Senia 18 Rue Des Oliviers Bp 20145 94320 Thiais

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.03.2013

 

 

Date of Incorporation :

June 1972

 

 

Com. Reg. No.:

01996366

 

 

Legal Form :

Simplified joint stock company

 

 

Line of Business :

Retail sale of clothing in specialized stores

[We tried to confirm / obtain the detailed activity but the same is not available from any sources]

 

 

No. of Employees :

2020 (2012)

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

B

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

Small

 

Status :

Moderate

Payment Behaviour :

Slow but correct

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – September 30, 2013

 

Country Name

Previous Rating

(30.06.2013)

Current Rating

(30.09.2013)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 

FRANCE - ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With at least 79 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that reduce income disparity and the impact of free markets on public health and welfare. France's real GDP contracted 2.6% in 2009, but recovered somewhat in 2010 and 2011, before stagnating in 2012. The unemployment rate increased from 7.4% in 2008 to 10.3% in 2012. Youth unemployment shot up to 24.2% during the third quarter of 2012 in metropolitan France. Lower-than-expected growth and high unemployment costs have strained France's public finances. The budget deficit rose sharply from 3.4% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 4.8% of GDP in 2012, while France's public debt rose from 68% of GDP to 90% over the same period. Under President SARKOZY, Paris implemented some austerity measures to bring the budget deficit under the 3% euro-zone ceiling by 2013 and to highlight France's commitment to fiscal discipline at a time of intense financial market scrutiny of euro-zone debt. Socialist Party candidate Francois HOLLANDE won the May 2012 presidential election, after advocating pro-growth economic policies, the separation of banks' traditional deposit taking and lending activities from more speculative businesses, increasing the top corporate and personal tax rates, and hiring an additional 60,000 teachers during his five-year term. The government's attempt to introduce a 75% wealth tax on income over one million euros for two years was struck down by the French Constitutional Council in December 2012 because it applied to individuals rather than households. France ratified the EU fiscal stability treaty in October 2012 and HOLLANDE's government has maintained France's commitment to meeting the budget deficit target of 3% of GDP during 2013 even amid signs that economic growth will be lower than the government's forecast of 0.8%. Despite stagnant growth and fiscal challenges, France's borrowing costs declined during the second half of 2012 to euro-era lows

 

Source : CIA

 


Personal comment

 

COMPANY SUMMARY

 

Trade name

MIM

 

 

EUR VAT Number

FR20722033115

 

 

Activity (APE)

Retail sale of clothing in specialized stores (4771Z)

Legal form

Simplified joint stock company

 

 

Phone

05 34 25 71 91

RCS Registration

RCS Creteil 9 722 033 115

 

 

Fax

Share capital

905,280 Euros

 

 

Address

MIM
18-24 ZI SENIA
18 RUE DES OLIVIERS
BP 20145
94320 THIAIS

Incorporated Date

06/1972

 

 

Nationality

France

Status

Economically active

 

This company is not under monitoring

Ultimate Holding Company

Company Name

Company number

NEW LOOK

 

01996366

Current Directors

1

Trading to Date

03/31/2013

03/31/2012

03/31/2011

Turnover

182,246,722 €

186,114,237 €

196,709,355 €

Gross Operating Surplus

1,27 % Turnover

1,83 % Turnover

8,58 % Turnover

Shareholders’ equity

27,395,553 €

31,892,453 €

42,300,351 €

Net result

-4,430,790 €

-5,979,916 €

4,788,047 €

Employees

1 000 to 1 999 employees

-

-

 

 

Trends

 

Profitability

Liquidity

Net worth

company details

 

 

Company details

 

 

 

Activity (APE)

Retail sale of clothing in specialized stores

 

RCS Registration

RCS Creteil 9 722 033 115

Share capital

905,280 Euros

 

Registration Court

Creteil (94)

Legal form

Simplified joint stock company

 

Court Registry Number

19 9 6B03225

EUR VAT Number

FR20722033115

 

Incorporation Date

06/1972

Formation Date

01/1972

 

Deregistration Date

Last account Date

31/03/2013

 

Nationality

France

 

 

 

Establishment details

 

 

 

Trade name

MIM

 

Activity (APE)

Retail sale of clothing in specialized stores

Business Pages FT®

VETEMENTS POUR HOMMES ET DAMES (DETAIL)

 

Postal Address

MIM
18-24 ZI SENIA
18 RUE DES OLIVIERS
BP 20145
94320 THIAIS

Trading Address

18 RUE DES OLIVIERS
94320 THIAIS

 

Telephone

05 34 25 71 91

 

Fax

 

 

 

Type

Secondary establishment

Status

Economically active

 

Formation Date

01/2007

Reason for formation

Formation

 

Closure Date

Reason for closure

 

Reactivation Date

Production Role

 

Activity Nature

Activity Location

 

Location surface

Seasonality

 

 

 

Department

Val-de-Marne (94)

Region

Ile-de-France

 

District

Area

 

City

THIAIS

Size of urban area

 

 

Other establishments

 

 

Branches

279 branch entities in this company

 

Head office

 
> MIM <<<  - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z)  in THIAIS  (94320)
 

 

Secondary establishments

>  MIM  - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z)  in TOULOUSE  (31000)
>  MIM  - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z)  in BEAUVAIS  (60000)
>  MIM  - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z)  in ALBI  (81000)
>  MIM  - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z)  in NICE  (06000)
> ...

 

 

 

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas but no one grouping more than 50% of workforce

 

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which one activity grouping from 80 to 99% of workforce

 

 

 

Workforces

 

 

Workforce at address

200 to 249 employees

Company workforce

1000 to 1999 employees

 

 

 

accounts

Active Account |  Passive Account |  Account Results

 

Synthesized Accounts

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

Comparison mode

Average

Median

 

Annual Accounts

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Account period (month)

12

12

12

Account Type

Normal

Normal

Normal

Date of capture

28/01/2014

29/01/2013

11/01/2012

Activity Code

4771Z

4771Z

4771Z

Employees

0

2020

2088

 

Active account

Annual Accounts

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Sector Median 2013

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

44 475 628

-14,2%

51 834 595

-8,7%

56 776 703

93 686

47373,1%

- Intangible assets

17 475 399

-11,1%

19 652 680

4,7%

18 777 735

53 000

32872,5%

- Tangible assets

20 048 493

-24,1%

26 429 765

-14,8%

31 027 829

13 172

152105,4%

- Financial assets

6 951 736

1,2%

6 868 150

-1,5%

6 971 139

1 296

536299,4%

Net current assets

89 254 790

9,2%

81 719 544

1,2%

80 753 923

109 816

81176,7%

- Stocks

25 184 575

35,5%

18 580 174

-12,4%

21 210 290

54 352

46236,1%

- Advanced payments

0

9,2%

0

0%

0

0

0%

- Receivables

53 164 757

4,6%

50 849 038

4,2%

48 803 604

9 247

574840,6%

- Securities and cash

10 905 458

-11,3%

12 290 332

14,4%

10 740 029

16 475

66094,0%

- Prepaid expenses

-

-

-

-

-

823

-

Accounts of regularization

67 810

-1,4%

68 770

-67,9%

214 487

0

0%

Total Assets

133 798 228

0,1%

133 622 909

-3,0%

137 745 113

225 492

59236,1%

 

Passive Account

Annual Accounts

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Sector Median 2013

Shareholders' equity

27 395 553

-14,1%

31 892 453

-24,6%

42 300 351

59 079

46271,1%

Share capital

905 280

0%

905 280

0%

905 280

8 000

11216,0%

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

1 809 110

65,5%

1 093 170

69,3%

645 627

0

0%

Liabilities

104 593 565

3,9%

100 637 286

6,2%

94 799 135

138 896

75203,5%

- Financial liabilities

72 202 032

1,1%

71 447 154

11,2%

64 242 197

51 419

140319,0%

- Advanced payments received

298 485

0%

0

0%

0

0

0%

- Trade account payables

20 212 300

30,5%

15 492 947

3,4%

14 984 634

29 855

67601,6%

- Tax and social liabilities

9 698 406

-18,9%

11 965 860

-11,0%

13 437 934

19 370,50

49967,9%

- Other debts and fixed assets liabilities

1 379 875

49,5%

923 071

-44,3%

1 657 996

3 204

42967,3%

Account regularization

802 467

-0,7%

808 254

69,7%

476 374

0

0%

Total liabilities

133 798 228

0,1%

133 622 909

-3,0%

137 745 113

225 492

59236,1%

 

Results

Annual Accounts

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Sector Median 2013

Sales of Goods

186 426 637

-1,0%

188 297 778

-4,8%

197 740 128

277 214

67150,1%

Net turnover

182 246 722

-2,1%

186 114 237

-5,4%

196 709 355

273 021

66651,9%

- of which net export turnover

0

0%

0

0%

0

0

0%

Operating charges

190 449 415

-1,8%

193 977 829

2,4%

189 487 005

270 197

70385,4%

Operating profit/loss

-4 022 778

29,2%

-5 680 051

-168,8%

8 253 123

6 749

-59705,5%

Financial income

2 651 294

-31,7%

3 880 044

42,8%

2 717 234

06

44188133,3%

Financial charges

2 783 623

-5,9%

2 957 246

3,2%

2 866 801

1 742

159694,7%

Financial profit/loss

-132 329

-114,3%

922 798

717,0%

-149 567

-1 201

-10918,2%

Pretax net operating income

-4 155 107

12,7%

-4 757 253

-158,7%

8 103 556

4 697

-88563,0%

Extraordinary income

3 917 090

495,1%

658 261

-85,5%

4 530 139

0

0%

Extraordinary charges

4 192 773

171,3%

1 545 584

-53,0%

3 290 096

36

11646491,7%

Extraordinary profit/loss

-275 683

68,9%

-887 323

-171,6%

1 240 043

0

0%

Net result

-4 430 790

25,9%

-5 979 916

-224,9%

4 788 047

4 687

-94633,6%


 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

 

Normal Account

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Months

12

12

12


Accounts - Active
Current Assets |  Equalization accounts |  Reference

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Grand Total (I to VI)

Net

133 798 228

0,1%

133 622 909

-3,0%

137 745 113

Gross

CO

200 283 134

2,4%

195 576 326

1,3%

193 068 011

Amortisation

1A

66 484 906

7,3%

61 953 417

12,0%

55 322 898

 

Non declared distributed capital (I)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

Gross

AA

0

0%

0

0%

0

 

Active fixed asset (II)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Total Active fixed asset (II)

Net

44 475 628

-14,2%

51 834 595

-8,7%

56 776 703

Gross

BJ

110 167 635

-2,6%

113 124 934

1,6%

111 366 583

Amortisation

BK

65 692 007

7,2%

61 290 339

12,3%

54 589 880

 

Intangilble fixed assets

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R & D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AE

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

69 920

0%

69 920

1298,4%

5 000

Gross

AF

69 920

0%

69 920

1298,4%

5 000

Amortisation

AG

0

0%

0

0%

0

Goodwill

Net

15 989 495

-14,5%

18 691 232

2,3%

18 268 201

Gross

AH

17 209 495

-7,9%

18 691 232

-0,4%

18 770 201

Amortisation

AI

1 220 000

9,3%

1 116 000

122,3%

502 000

Other intangible fixed assets

Net

1 415 784

104,9%

691 008

39,5%

495 316

Gross

AJ

2 523 561

56,5%

1 612 304

29,6%

1 243 887

Amortisation

AK

1 107 777

20,2%

921 296

23,1%

748 571

Pre-payments and downpayments

Net

200

-99,9%

200 520

2075,3%

9 218

Gross

AL

200

-99,9%

200 520

2075,3%

9 218

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible Assets

Net

17 475 399

-11,1%

19 652 680

4,7%

18 777 735

 

Tangilble fixed assets

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Lands

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AN

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AO

0

0%

0

0%

0

Buildings

Net

116 844

-2,7%

120 092

13,7%

105 651

Gross

AP

129 721

0%

129 721

15,8%

112 031

Amortisation

AQ

12 877

33,7%

9 629

50,9%

6 380

Plant

Net

2 445 353

-42,1%

4 222 607

-19,7%

5 256 221

Gross

AR

20 068 927

-2,7%

20 628 624

3,1%

20 008 829

Amortisation

AS

17 623 574

7,4%

16 406 017

11,2%

14 752 608

Other tangible fixed assets

Net

17 320 030

-19,7%

21 577 425

-13,6%

24 986 037

Gross

AT

62 969 809

-2,1%

64 336 822

1,3%

63 488 358

Amortisation

AU

45 649 779

6,8%

42 759 397

11,1%

38 502 321

Fixed assets in construction

Net

0

0%

0

0%

679 920

Gross

AV

0

0%

0

0%

679 920

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

166 266

-67,4%

509 641

0%

0

Gross

AX

166 266

-67,4%

509 641

0%

0

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

Sub Total Tangible asset

Net

20 048 493

26 429 765

31 027 829

 

Financial assets

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

385 165

0%

385 165

0%

385 165

Gross

CU

463 165

0%

463 165

0%

463 165

Amortisation

CV

78 000

0%

78 000

0%

78 000

Inter-company receivables

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BC

0

0%

0

0%

0

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

Loans

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BF

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BG

0

0

0

Other financial assets

Net

6 566 571

1,3%

6 482 985

-1,6%

6 585 974

Gross

BH

6 566 571

1,3%

6 482 985

-1,6%

6 585 974

Amortisation

BI

0

0%

0

0%

0

Sub Total Financial Assets

6 951 736

6 868 150

6 971 139

 

Current Assets (III)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Total Assets

Net

89 254 790

9,2%

81 719 544

1,2%

80 753 923

Gross

CJ

90 047 690

9,3%

82 382 622

1,1%

81 486 941

Amortisation

CK

792 900

19,6%

663 078

-9,5%

733 018

 

Stocks

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Raw materials

Net

137 347

-33,1%

205 149

10,4%

185 905

Gross

BL

137 347

-33,1%

205 149

10,4%

185 905

Amortisation

BM

0

0%

0

0%

0

Work in progress (goods)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BN

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BR

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BS

0

0%

0

0%

0

Goods for resale

Net

25 047 228

36,3%

18 375 025

-12,6%

21 024 385

Gross

BT

25 713 128

36,0%

18 903 185

-12,6%

21 634 110

Amortisation

BU

665 900

26,1%

528 160

-13,4%

609 725

Sub Total Stocks

Net

25 184 575

35,5%

18 580 174

-12,4%

21 210 290

 

Advance payments to suppliers

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Advance payments to suppliers

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BV

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0

 

Debtors

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Trade accounts receivable

Net

4 104 813

26,6%

3 241 643

42,9%

2 269 195

Gross

BX

4 231 813

25,3%

3 376 561

41,1%

2 392 488

Amortisation

BY

127 000

-5,9%

134 918

9,4%

123 293

Other debtors

Net

44 192 304

7,6%

41 073 718

5,0%

39 114 839

Gross

BZ

44 192 304

7,6%

41 073 718

5,0%

39 114 839

Amortisation

CA

0

0%

0

0%

0

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

Sub Total Debtors

Net

48 297 117

9,0%

44 315 361

7,1%

41 384 034

 

Divers

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Investment securities

Net

290 635

0%

0

0%

5 715 156

Gross

CD

290 635

0%

0

0%

5 715 156

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

10 614 823

-13,6%

12 290 332

144,6%

5 024 873

Gross

CF

10 614 823

-13,6%

12 290 332

144,6%

5 024 873

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

Sub Total Divers

Net

10 905 458

-11,3%

12 290 332

14,4%

10 740 029

 

Prepaid expenses

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Prepaid expenses

Net

4 867 640

-25,5%

6 533 677

-11,9%

7 419 570

Gross

CH

4 867 640

-25,5%

6 533 677

-11,9%

7 419 570

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts (IV to VI)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Multi-period charges

CW3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Currency differential gain

CN3

67 810

-1,4%

68 770

-67,9%

214 487

Gross

67 810

-1,4%

68 770

-67,9%

214 487

 

References

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Accounts - Passive
Other capital resources | Provisions for risks and charges | Liabilities | Translation loss | Equalization accounts | References


Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Grand Total (I to V)

EE

133 798 228

0,1%

133 622 909

-3,0%

137 745 113

 

Shareholder Equity (I)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Total shareholders' equity (Total I)

DL

27 395 553

-14,1%

31 892 453

-24,6%

42 300 351

Equity and shareholders' equity

DA

905 280

0%

905 280

0%

905 280

Issue and merger premiums

DB

5 635 452

0%

5 635 452

0%

5 635 452

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

Legal reserve

DD

90 528

0%

90 528

0%

90 528

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

Other reserves

DG

30 447 632

0%

30 447 632

1,5%

30 001 984

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

0

0%

0

Profits or losses brought forward

DH

-5 925 828

-11056,1%

54 087

0%

54 087

Profit or loss for the period

DI

-4 430 790

25,9%

-5 979 916

-224,9%

4 788 047

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

Special tax-allowable reserves

DK

673 279

-8,9%

739 390

-10,4%

824 973

 

Other capital resources (II)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

 

Provisions for risks and charges (III)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

1 809 110

65,5%

1 093 170

69,3%

645 627

Risk provisions

DP

759 110

0%

0

0%

0

Reserves for charges

DQ

1 050 000

-3,9%

1 093 170

69,3%

645 627

 

Liabilities (IV)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Total Liabilities (Total IV)

EC

104 593 565

3,9%

100 637 286

6,2%

94 799 135

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

Bank loans and liabilities

DU

0

0%

0

0%

0

Sundry loans and financial liabilities

DV

72 202 032

1,1%

71 447 154

11,2%

64 242 197

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

Advance payments received for current orders

DW

298 485

0%

0

0%

0

Trade accounts payables

DX

20 212 300

30,5%

15 492 947

3,4%

14 984 634

Tax and social security liabilities

DY

9 698 406

-18,9%

11 965 860

-11,0%

13 437 934

Fixed asset liabilities

DZ

854 238

3,7%

823 438

-46,4%

1 535 733

Other debts

EA

525 637

427,6%

99 633

-18,5%

122 263

 

Translation loss (V)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Translation loss (Total V)

ED

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Deferred income

EB

802 467

-0,7%

808 254

69,7%

476 374

 

References

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Result account
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges | Financial income | Financial charges | Financial charges | Extraordinary charges | Employee profit sharing | Tax on profits | References


1- Operating result (I-II)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Operating result (Total I-II)

GG

-4 022 778

29,2%

-5 680 051

-168,8%

8 253 123

 

2 - Financial result (V - VI)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Financial result (Total V-VI)

GV

-132 329

-114,3%

922 798

717,0%

-149 567

 

3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

-4 155 107

12,7%

-4 757 253

-158,7%

8 103 556

 

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

-275 683

68,9%

-887 323

-171,6%

1 240 043

 

Profit or loss

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Profit or loss

HN

-4 430 790

25,9%

-5 979 916

-224,9%

4 788 047

 

Total Income (I+III+V+VII)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Total Income (I+III+V+VII)

HL

192 995 021

0,1%

192 836 083

-5,9%

204 987 501

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

197 425 811

-0,7%

198 815 999

-0,7%

200 199 454

 

Operating income (I)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Total operating income (Total I)

FR

186 426 637

-1,0%

188 297 778

-4,8%

197 740 128

 

Operating income (details)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Sale of goods for resale

FC

180 655 459

-2,5%

185 316 222

-5,1%

195 230 212

France

FA

180 655 459

-2,5%

185 316 222

-5,1%

195 230 212

Export

FB

0

0%

0

0%

0

Sale of goods produced

FF

1 105 514

85,9%

594 840

-45,9%

1 099 479

France

FD

1 105 514

85,9%

594 840

-45,9%

1 099 479

Export

FE

0

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

485 749

139,1%

203 175

-46,5%

379 664

France

FG

485 749

139,1%

203 175

-46,5%

379 664

Export

FH

0

0%

0

0%

0

Net turnover

FL

182 246 722

-2,1%

186 114 237

-5,4%

196 709 355

France

FJ

182 246 722

-2,1%

186 114 237

-5,4%

196 709 355

Export

FK

0

0%

0

0%

0

Stocked production

FM

0

0%

0

0%

0

Self-constructed assets

FN

0

0%

0

0%

0

Operating grants

FO

0

0%

818 059

0%

0

Release of reserves and provisions

FP

1 177 620

857,4%

123 008

-84,7%

803 362

Other income

FQ

3 002 295

141,6%

1 242 474

446,4%

227 411

 

Operating charges (II)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Total operating charges (Total II)

GF

190 449 415

-1,8%

193 977 829

2,4%

189 487 005

 

Exploitation charges

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Purchase of goods for resale

FS

86 586 767

6,9%

80 970 325

-5,4%

85 627 414

Change in stocks of goods for resale

FT

-6 809 942

-349,4%

2 730 926

150,0%

-5 458 087

Purchase of raw materials

FU

444 028

-33,3%

665 543

8,4%

613 823

Change in stocks of raw materials

FV

67 801

452,3%

-19 244

-362,6%

7 328

Other external purchases and charges

FW

50 780 013

-0,3%

50 946 671

4,0%

48 990 112

Tax, duty and similar payments

FX

5 195 105

-8,6%

5 681 804

8,7%

5 227 092

Payroll

FY

33 230 734

2,2%

32 506 982

-3,8%

33 808 445

Social security costs

FZ

10 436 807

3,9%

10 040 912

-8,8%

11 009 029

 

Depreciation

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Depreciation of fixed assets

GA

7 322 430

-10,7%

8 197 497

-3,6%

8 504 837

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

0

Depreciation/amortisation of current assets

GC

792 900

19,6%

663 078

-9,5%

733 018

Provisions for risks and charges

GD

100 600

-72,7%

368 300

202,8%

121 640

 

Other charges

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Other charges

GE

2 302 172

87,9%

1 225 035

305,2%

302 354

 

Operating charges (III-IV)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

 

Financial income (V)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Total financial income (Total V)

GP

2 651 294

-31,7%

3 880 044

42,8%

2 717 234

Share financial income

GJ

0

0%

0

0%

0

Other investment income & capitalised receivables

GK

0

0%

0

0%

0

Other interest and similar income

GL

1 856 350

-27,0%

2 542 706

2,2%

2 488 626

Released provisions and transferred charges

GM

0

0%

0

0%

0

Exchange gains

GN

794 944

-40,6%

1 337 338

485,0%

228 608

Net income from disposal of investment securities

GO

0

0%

0

0%

0

 

Financial Charge (VI)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Total financial charge (Total VI)

GU

2 783 623

-5,9%

2 957 246

3,2%

2 866 801

Financial reserves and provisions

GQ

67 810

-1,4%

68 770

-67,9%

214 487

Interest and similar charges

GR

2 079 112

-20,2%

2 606 531

2,8%

2 535 833

Exchange losses

GS

636 701

125,8%

281 945

142,1%

116 481

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary income (VII)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Total extraordinary income (Total VII)

HD

3 917 090

495,1%

658 261

-85,5%

4 530 139

Extraordinary operating income

HA

0

0%

0

0%

0

Extraordinary income from capital transactions

HB

3 145 000

471,8%

550 000

-87,1%

4 249 118

Released provisions and transferred charges

HC

772 090

613,2%

108 261

-61,5%

281 021

 

Extraordinary charges (VIII)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

4 192 773

171,3%

1 545 584

-53,0%

3 290 096

Extraordinary operating charges

HE

87 515

270,4%

23 624

-61,6%

61 454

Extraordinary charges from capital transactions

HF

1 481 737

171,8%

545 080

-82,0%

3 033 415

Extraordinary reserves and provisions

HG

2 623 521

168,6%

976 880

400,4%

195 227

 

Employee profit sharing (IX)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

0

0%

66 296

-94,6%

1 229 197

 

Tax on profits (X)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Tax on profits (Total X)

HK

0

0%

269 044

-91,9%

3 326 355

 

References

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

Of which transferred charges

A1

0

0%

0

0%

0

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

 

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro


Other incomes tax return forms
Reserve for depreciation | Provisions included in balance sheet | State deadlines claims and debts at the end of period
Table allocation results and other information

Fixed Assets
Grand Total Fixed Assets (I to IV)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

OK2

0

0%

0

0%

8 932 399

Gross value at the end of period

OL

0

0%

0

0%

111 366 586

 

Research and development Charge (Total I)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

C01

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

C02

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

D0

0

0%

0

0%

0

 

Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Gross value at begin of period

KD

0

0%

0

0%

21 545 872

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

0

0%

0

0%

201 261

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

LV2

0

0%

0

0%

1 718 825

Gross value at the end of period

LW

0

0%

0

0%

20 028 308

 

Tangible fixed assets (Total III)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Gross value at begin of period

LN

0

0%

0

0%

85 303 078

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

0

0%

0

0%

5 775 282

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NG2

0

0%

0

0%

6 789 221

Gross value at the end of period

NH

0

0%

0

0%

84 289 139

 

Fiancial assets (Total IV)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Gross value at begin of period

LQ

0

0%

0

0%

7 339 880

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

0

0%

0

0%

133 613

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NJ2

0

0%

0

0%

424 354

Gross value at the end of period

NK

0

0%

0

0%

7 049 139

 

Reserve for depreciation
Situation and movement of reserve for depreciation
Grand total (I-II-III)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Reserve for depreciation value at begin of period

0N

0

0%

0

0%

0

Increases

0P

0

0%

0

0%

0

Decreasess

0Q

0

0%

0

0%

0

Reserve for depreciation value at the end of period

0R

0

0%

0

0%

0

 

Research and development charge (Total I)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0

 

Other intangible assets (Total II)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

0

0%

0

0%

1 055 629

Increases

PF

0

0%

0

0%

269 066

Decreasess

PG

0

0%

0

0%

74 124

Decreasess by budget item transfer

PH

0

0%

0

0%

1 250 571

 

Total fixed assets amotisation (Total III)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

0

0%

0

0%

48 956 172

Increases

QV

0

0%

0

0%

8 347 772

Decreases

QW

0

0%

0

0%

4 043 537

Decreasess by budget item transfer

QX

0

0%

0

0%

53 260 407


Movements during period affecting charge allocated over several period

Charges à répartir ou frais d'émission d'emprunt

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0

 

Premium refund of obligations

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Net value at begining of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

 

Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Value at begining of period

7C

0

0%

0

0%

992 748

Increases

UB

0

0%

0

0%

1 084 145

Decreases

UC

0

0%

0

0%

620 248

Value at the end of period

UD

0

0%

0

0%

1 456 645

Includes Total allocations

Operating

UE

0

0%

0

0%

0

Financial

UG

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UJ

0

0%

0

0%

0

Includes Total Withdrawal

Operating

UF

0

0%

0

0%

0

Financial

UH

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UK

0

0%

0

0%

0

 

Total regulated provisions (Total I)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Value at begining of period

3Z

0

0%

0

0%

0

Increases

TS

0

0%

0

0%

0

Decreases

TT

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

TU

0

0%

0

0%

0

 

Total risk and charge provisions (Total II)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Value at begining of period

5Z

0

0%

0

0%

605 250

Increases

TV

0

0%

0

0%

351 127

Decreases

TW

0

0%

0

0%

310 750

Value at the end of period

TX

0

0%

0

0%

645 627

 

Total Provision for depreciation (Total III)

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Value at begining of period

7B

0

0%

0

0%

387 498

Increases

TY

0

0%

0

0%

733 018

Decreases

TZ

0

0%

0

0%

309 498

Value at the end of period

UA

0

0%

0

0%

811 018

 

State deadlines claims and debts at the end of period
State claims

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Gross value

VT

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VU

0

0%

0

0%

0

More than one year

VV

0

0%

0

0%

0

 

State of loans

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Claims related to holdings (gross)

UL

0

0%

0

0%

0

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

0%

0

0%

0

Loans (gross)

UP

0

0%

0

0%

0

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

0

0%

0

Other financial assets (gross)

UT

0

0%

0

0%

0

Other financial assets (1 year at most)

UV

0

0%

0

0%

0

 

Receivables statement of assets

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Customers doubtful or disputed

VA

0

0%

0

0%

0

Other claims customer

UX

0

0%

0

0%

0

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts

UY

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

0

0%

0

Income taxes

VM

0

0%

0

0%

0

Value added tax

VB

0

0%

0

0%

0

Other taxes and payments assimilated

VN

0

0%

0

0%

0

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

0

0%

0

Group and Associates

VC

0

0%

0

0%

0

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

0

0%

0

0%

0

 

Prepaid

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Prepaid

VS

0

0%

0

0%

0

 

State Debt

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Total debt (gross)

VY

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

VZ4

0

0%

0

0%

0

 

Details

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VG2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VH2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8A2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8A3

0

0%

0

0%

0

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8B2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8B3

0

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8C2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8D2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (gross)

VW1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VW2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VQ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8J2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VI2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More 5 years

VI4

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8K2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8L2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0

 

References

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Loans made during the period

VJ

0

0%

0

0%

0

Debt repaid during the period

VK

0

0%

0

0%

0

 

Table allocation results and other information
Dividends distributed

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0

 

Commitments

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0

 

Other charges Externes

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0

 

Taxes and Fees

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0

 

VAT

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0

 

Average number of employees

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Average number of employees

YP

0

0%

2 020

-3,3%

2 088

 

Groups and Shareholders

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Groups and Shareholders

ZR

0

-

0

-

-

 

 

 

Display parameter

Comparison mode

Average

Median


Ratios
Structure and liquidity | Management or rotation | Profitability of the business | Return on capital

Structure and Liquidity

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Sector Median 2013

Fixed Asset Financing

1,52

4,1%

1,46

0,7%

1,45

1,28

18,8%

Global Debt

207 days

6,2%

195 days

12,7%

173 days

171 days

21,1%

Working Capital Fund overall net

112 days

9,8%

102 days

10,9%

92 days

48 days

133,3%

Financial independence

%

-

%

-

%

117,06%

-

More ratios

Solvability

20,48%

-14,2%

23,87%

-22,3%

30,71%

29,54%

-30,7%

Capacity debt futures

%

-

%

-

%

451,02%

-

Coverage of current assets by net working capital overall

66,61%

-4,0%

69,35%

9,7%

63,19%

35,95%

85,3%

General Liquidity

-

-

0,09

-

Restricted Liquidity

-

-

0,34

-

 

Management or rotation

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Sector Median 2013

Need background in operating working capital

83 days

23,9%

67 days

11,7%

60 days

8 days

937,5%

Treasury

22 days

-8,3%

24 days

20,0%

20 days

4 days

450,0%

Inventory turnover of goods

116 days

43,2%

81 days

-16,5%

97 days

158 days

-26,6%

Average length of credit granted to customers

8 days

14,3%

7 days

75,0%

4 days

0 days

0%

Average length of credit obtained suppliers

56 days

36,6%

41 days

-2,4%

42 days

53 days

5,7%

More ratios

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

111 days

0%

111 days

1,8%

109 days

0 days

0%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

days

-

days

-

233 days

403,50 days

-

Rotation tangible assets

%

-

%

-

233,37%

484,04%

-

 

Profitability of the business

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Sector Median 2013

Margin trading

55,35%

1,4%

54,60%

-6,7%

58,49

41,86%

32,2%

Profitability of the business

1,27

-30,6%

1,83

-78,7%

8,58

4,83%

-73,7%

Net profit

-2,43%

24,3%

-3,21%

-232,1%

2,43%

1,79%

-235,8%

More ratios

Growth rate of turnover (excluding VAT)

-2,08%

61,4%

-5,39%

-182,8%

6,51%

-2%

-4,0%

Rates integration

28,08%

2,8%

27,31%

-19,7%

34,02%

25,32%

10,9%

Rate leasing furniture

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Work Factor

85,32%

1,9%

83,72%

25,0%

66,96%

73,03%

16,8%

Weight interests

1,53

-3,8%

1,59%

8,9%

1,46%

0,64%

139,1%

 

Return on capital

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Sector Median 2013

Cash flow from the overall profitability

2,15%

22,9%

1,75%

-72,4%

6,35%

4,24%

-49,3%

Rates of economic profitability

2%

-33,3%

3%

-81,2%

16%

10%

-80,0%

Financial profitability

27395553%

-14,1%

31892453%

-24,6%

42300351%

20661%

132495,5%

Return on investment

-1,65%

43,5%

-2,92%

-140,7%

7,18%

6,03%

-127,4%

 

 

Display parameter

Currency

Euro

Kilo Euro

Comparison mode

Average

Median

 

Soldes Intermédiaires de Gestion

31/03/2013

31/03/2012

31/03/2011

Sector Median 2013

Turnover

182 246 722

-2,1%

186 114 237

-5,4%

196 709 355

273 021 € 

66651,9% 

 

Sales of goods

180 655 459

-2,5%

185 316 222

-5,1%

195 230 212

 

 

- Purchase of goods

86 586 767

6,9%

80 970 325

-5,4%

85 627 414

 

 

+/- Stock of goods variation

-6 809 942

-349,4%

2 730 926

150,0%

-5 458 087

 

 

Trading margin

100 878 634 €

-0,7%

101 614 971 €

-11,7%

115 060 885 €

111 238 € 

90587,2% 

55,35 % CA

1,4%

54,60 % CA

-6,7%

58,49 % CA

42,14 % CA 

31,3% 

 

Sale of goods produced

1 591 263

99,4%

798 015

-46,0%

1 479 143

 

 

+/- Stocked production

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Self-constructed assets

0

0%

0

0%

0

 

 

Period production

1 591 263 €

99,4%

798 015 €

-46,0%

1 479 143 €

0 € 

0% 

0,87 % CA

102,3%

0,43 % CA

-42,7%

0,75 % CA

0 % CA 

0% 

 

Trading margin

100 878 634

-0,7%

101 614 971

-11,7%

115 060 885

111 238 

90587,2% 

+ Period Production

1 591 263

99,4%

798 015

-46,0%

1 479 143

0% 

- Purchase of raw materials

444 028

-33,3%

665 543

8,4%

613 823

 

 

+/- Change in stocks of raw materiels

67 801

452,3%

-19 244

-362,6%

7 328

 

 

- Other external purchases and charges

50 780 013

-0,3%

50 946 671

4,0%

48 990 112

 

 

Added value

51 178 055 €

0,7%

50 820 016 €

-24,1%

66 928 765 €

73 583 € 

69451,5% 

28,08 % CA

2,8%

27,31 % CA

-19,7%

34,02 % CA

25,32 % CA 

10,9% 

 

Added value

51 178 055 €

0,7%

50 820 016 €

-24,1%

66 928 765 €

73 583 € 

69451,5% 

+ Operating grants

0

0%

818 059

0%

0

 

 

- Tax, duty and similar payments

5 195 105

-8,6%

5 681 804

8,7%

5 227 092

 

 

- Personal charges

43 667 541

2,6%

42 547 894

-5,1%

44 817 474

 

 

Gross operating surplus

2 315 409 €

-32,1%

3 408 377 €

-79,8%

16 884 199 €

12 098 € 

19038,8% 

1,27 % CA

-30,6%

1,83 % CA

-78,7%

8,58 % CA

4,83 % CA 

-73,7% 

 

Gross operating surplus

2 315 409 €

-32,1%

3 408 377 €

-79,8%

16 884 199 €

12 098 € 

19038,8% 

+ Release of reserves and provisions

1 177 620

857,4%

123 008

-84,7%

803 362

 

 

+ Other operating income

3 002 295

141,6%

1 242 474

446,4%

227 411

 

 

- Depreciation/Amortisation

8 215 930

-11,0%

9 228 875

-1,4%

9 359 495

 

 

- Other charges

2 302 172

87,9%

1 225 035

305,2%

302 354

 

 

Operating result

-4 022 778 €

29,2%

-5 680 051 €

-168,8%

8 253 123 €

6 749 € 

-59705,5% 

-2,21 % CA

27,5%

-3,05 % CA

-172,6%

4,20 % CA

2,63 % CA 

-184,0% 

 

Operating result

-4 022 778 €

29,2%

-5 680 051 €

-168,8%

8 253 123 €

6 749 € 

-59705,5% 

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Financial income

2 651 294

-31,7%

3 880 044

42,8%

2 717 234

 

 

- Financial charges

2 783 623

-5,9%

2 957 246

3,2%

2 866 801

 

 

Pre-tax result

-4 155 107 €

12,7%

-4 757 253 €

-158,7%

8 103 556 €

4 696 € 

-88581,8% 

-2,28 % CA

10,9%

-2,56 % CA

-162,1%

4,12 % CA

1,88 % CA 

-221,3% 

 

Extraordinary income

3 917 090

495,1%

658 261

-85,5%

4 530 139

0% 

- Extraordinary charges

4 192 773

171,3%

1 545 584

-53,0%

3 290 096

 

 

Extraordinary result

-275 683 €

68,9%

-887 323 €

-171,6%

1 240 043 €

0 € 

0% 

-0,15 % CA

68,8%

-0,48 % CA

-176,2%

1 % CA

0 % CA 

0% 

 

Pre-tax result

-4 155 107 €

12,7%

-4 757 253 €

-158,7%

8 103 556 €

4 696 € 

-88581,8% 

Extraordinary result

-275 683 €

68,9%

-887 323 €

-171,6%

1 240 043 €

0 € 

0% 

- Employee profit sharing

0

0%

66 296

-94,6%

1 229 197

 

 

- Tax on profits

0

0%

269 044

-91,9%

3 326 355

 

 

Net result

-4 430 790 €

25,9%

-5 979 916 €

-224,9%

4 788 047 €

4 685 € 

-94674,0% 

-2,43 % CA

24,3%

-3,21 % CA

-232,1%

2,43 % CA

1,79 % CA 

-235,8% 

 

Group data

Ultimate parent company

NEW LOOK

Direct parent

NEW LOOK - 100 %

Group – Number of companies

5

Linkages – Number of companies

20

Number of countries

2

Group Structure

Go directly to the current company

Display only where participation % > 33 %

Display all participations

loading data...

Company Name

SIREN

Parts

Rating

Limit

Last account published

NEW LOOK LIMITED

 

01996366

-

96

160 000 £

30/03/2013

MIM

 

722033115

100%

65

895 000 €

31/03/2013

NEW LOOK HOLDINGS FRANCE

 

434249504

100%

55

650 000 €

31/03/2013

GEOMETRY PROPERTIES FRANCE

 

350426409

100%

32

500 €

-

NEW LOOK FRANCE

 

487493199

100%

19

0 €

31/03/2013

Shareholders

Type of shareholder

Shareholders

To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Adobe Flash Player.

Please download the free Flash Player and refresh the page.

Get Adobe Flash Player

Linkages

Ultimate parent company

NEW LOOK

Direct parent

NEW LOOK - 100 %

Group – Number of companies

5

Linkages – Number of companies

20

Number of countries

2

Company Name

SIREN

Last account

Rating

Limit

Turnover

HAMPERWOOD LIMITED

 

05014765

30/03/2013

93

1 000 £

0 £

NEW LOOK GROUP LIMITED

 

03113468

30/03/2013

96

8 050 000 £

0 £

NEW LOOK RETAIL GROUP LIMITED

 

05810406

30/03/2013

97

60 000 £

1 484 000 000 £

TRINITYBROOK LIMITED

 

04948095

30/03/2013

93

1 000 £

0 £

PEDALGREEN LIMITED

 

05810408

30/03/2013

92

1 000 £

0 £

GEOMETRY PROPERTIES LIMITED

 

02027827

30/03/2013

68

500 £

1 820 000 £

NEW LOOK RETAILERS LIMITED

 

01618428

30/03/2013

96

10 050 000 £

1 248 464 000 £

NEW LOOK OVERSEAS LIMITED

 

02074839

30/03/2013

59

500 £

0 £

CUSTOMER DIRECT LIMITED

 

01527051

30/03/2013

NC

-

-

FASHION FOCUS LIMITED

 

02049556

30/03/2013

NC

-

-

GEOMETRY PROPERTIES (TONYPANDY) LIMITED

 

02619122

30/03/2013

NC

-

-

NEW LOOK CARD SERVICES LIMITED

 

04439639

30/03/2013

NC

-

-

NEW LOOK TREASURY LIMITED

 

06847612

30/03/2013

NC

-

-

WEYMOUTH GATEWAY PROPERTY MANAGEMENT LIM...

 

07827059

30/03/2013

NC

-

-

NEW LOOK RETAILERS ( IRELAND ) LIMITED

 

IE374892

30/03/2013

NC

-

-

NL BOWLINE LIMITED

 

08172570

-

NC

-

-

NEW LOOK FINANCE LIMITED

 

08462233

-

68

1 000 £

-

NEW LOOK BONDCO I PLC

 

08462244

-

68

1 000 £

-

NEW LOOK BONDCO II PLC

 

08462246

-

NC

-

-

NEW LOOK FINANCE II PLC

 

08462259

-

68

1 000 £

-

event history

Status history

 

 

No Status History

 

Recent publications in Gazettes

 

 

Publication date

Gazette Name

Description

 

27/12/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

2344 - 722 033 115 RCS Créteil. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Octobre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Octobre 2007 Président : RUF Bernhard en fonction le 18 Décembre 2013. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant.

17/12/2013

JAL

Appointment of the social representative

 

Parisien (Le) /Edition du Val de Marne


Date de décision : 05/12/2013
Société faisant l'objet d'une nomination : 722033115 - MIM, MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Nominé : Monsieur Bernhard RUF, W142 AD LONDRES
En la fonction de : Président

17/12/2013

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

Parisien (Le) /Edition du Val de Marne


Date de décision : 05/12/2013
La société 722033115 - MIM, MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Fait l'objet du départ de Monsieur Xavier WILMES, 11 Allée des Châtillons, 91760, ITTEVILLE

25/11/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

12229 - 722033115 RCS. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers Zone Industrielle Sénia - Bp 20145 94321 Thiais Cedex. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/03/2013.

02/01/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

14898 - 722033115 RCS. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers Zone Industrielle Sénia - Bp 20145 94321 Thiais Cedex. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/03/2012.

17/10/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

2722 - 722 033 115 RCS Créteil. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Octobre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Octobre 2007 Président : WILMES Xavier en fonction le 09 Octobre 2012. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant.

11/10/2012

JAL

Appointment of the social representative

 

Parisien (Le) /Edition du Val de Marne


Date de décision : 14/09/2012
Société faisant l'objet d'une nomination : 722033115 - MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Nominé : Monsieur Xavier WILMES, 91760 ITTEVILLE
En la fonction de : Président

11/10/2012

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

Parisien (Le) /Edition du Val de Marne


Date de décision : 14/09/2012
La société 722033115 - MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Fait l'objet du départ de Monsieur Nigel DARWIN

20/03/2012

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

02 - AISNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

68 - 380 622 332 RCS Saint-Quentin. ARMAND THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT SAS. Capital : 25140540 EUR. Adresse : 2 bis rue de Villiers, 92309 Levallois-Perret.
Origine du fonds : Achat au prix stipulé de 150000,00 euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : Vente de prêt à porter féminin et accessoires s'y rapportant. Adresse : 7/9 rue des Toiles, 2100 Saint-Quentin.
Précédent propriétaire : MIM. 722 033 115 RCS Créteil.
Date de commencement de l’activité : 01/02/2012. Publication légale : Picardie La Gazette du 13/03/2012. Oppositions : SCP Dubois - Huissiers de Justice 3 bis boulevard Richelieu 02100 Saint-Quentin pour la validité, SCP Hb et associes - Me Gilles Hittinger-roux - Avocat 55 avenue Kléber 75116 Paris pour la correspondance . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

13/03/2012

JAL

Activity or goodwill cession

 

Picardie La Gazette


Date de décision : 01/02/2012
Cédant : 722033115 - MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 380622332 - ARMAND THIERY SAS, 2 B RUE VILLIERS, 92300 LEVALLOIS PERRET
Prix de vente : 150000 €
Date d’effet : 01/02/2012

28/02/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

2387 - 722 033 115 RCS Créteil. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Octobre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Octobre 2007 Président : DARWIN Nigel en fonction le 20 Février 2012. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant.

18/02/2012

JAL

Appointment of the social representative

 

Parisien (Le) /Edition du Val de Marne


Date de décision : 30/01/2012
Société faisant l'objet d'une nomination : 722033115 - MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Nominé : Monsieur Nigel DARWIN, 0X110ND OXFORDSHIRE
En la fonction de : Président

18/02/2012

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

Parisien (Le) /Edition du Val de Marne


Date de décision : 30/01/2012
La société 722033115 - MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Fait l'objet du départ de Monsieur William KERNAN

30/01/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

14083 - 722033115 RCS. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers Zone Industrielle Sénia - Bp 20145 94321 Thiais Cedex. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/03/2011.

31/03/2011

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

1772 - 487 493 199 RCS Meaux. NEW LOOK FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers, Z.I. Senia, BP 20145 94321 Thiais Cedex.
Origine du fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 94.459,00 EUR. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Vente de prêt à porter féminin et accessoires. Enseigne : NEW LOOK. Adresse : 38 Mail Est Boutique b82, Centre Commercial Bay 2, 77090 Collégien.
Précédent propriétaire : MIM. 722 033 115 RCS Meaux.
A dater du : 14/03/2011. Date de commencement de l’activité : 23/02/2011. Publication légale : LE PARISIEN du 15/03/2011. Oppositions : en l'étude SCP ROCHET BANCAUD 15b av Foch 77503 CHELLES et pour la correspondance chez Me Gilles HITTINGER ROUX 55 ave Kléber 75116 PARIS. Descriptif : Achat ou apport à la sté MIM rcs CRETEIL 722033115. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale. Date d’effet : 23/02/2011.

15/03/2011

JAL

Activity or goodwill cession

 

Parisien (Le) /Edition de Seine et Marne Sud


Date de décision : 17/02/2011
Cédant : 722033115 - MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 487493199 - NEW LOOK FRANCE, 18 RUE DES OLIVIERS, ZI SENIA 18 A 24, BP 20145, 94320 THIAIS
Prix de vente : 94459 €
Date d’effet : 19/02/2011

18/01/2011

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

12245 - 722033115 RCS. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers Zone Industrielle Sénia - Bp 20145 94321 Thiais Cedex. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/03/2010.

11/01/2011

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

33 - GIRONDE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

541 - Réctificatif.
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : . Date de parution : 26 décembre 2010. Numéro d’annonce : 760. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant.
487 493 199 RCS Bordeaux. NEW LOOK FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers, Zone Industrielle Sénia - Bp 20145, 94321 Thiais Cedex.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 392640 Euros. Etablissement : Etablissemennt complémentaire. Activité : vente de prêt à porter hommes femmes enfants et accessoires. Adresse : centre Commercial Bègles, Zac Bègles Tartifume, 33130 Begles.
Précédent propriétaire : MIM. 722 033 115 RCS Créteil.
Date de commencement de l’activité : 03/11/2010. Publication légale : Le Courrier Français du 12/11/2010. Oppositions : Au Mandataire SCP LENOIR 33 rue de ruat 33000 BORDEAUX pour la validité et pour la correspondance Maître Hittinger Roux SCP HB et Associés 55 avenue Kleber 75116 Paris. Descriptif : Etablissement secondaire/complémentaire acquis par achat. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

26/12/2010

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

979 - 487 493 199 RCS Valenciennes. NEW LOOK FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers, Z.I. Senia, BP 20145 94321 Thiais.
Origine du fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 227.931,00 EUR. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Vente de prêt à porter hommes, femmes, enfants et accessoires. Enseigne : NEW LOOK. Adresse : C.C. place d'Armes, 59300 Valenciennes.
Précédent propriétaire : M I M. 722 033 115 RCS Valenciennes.
A dater du : 03/12/2010. Date de commencement de l’activité : 06/11/2010. Publication légale : SYNDICAT AGRICOLE du 26/11/2010. Oppositions : Etude SCP DARRAS, HOUDAIN, GENON, 6 rue de la Poterne BP 13 59301 VALENCIENNES. Descriptif : Achat ou apport. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale. Date d’effet : 06/11/2010.

23/12/2010

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE

240 - 487 493 199 RCS Lille. NEW LOOK FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers, Z.I. Sénia - BP 20145, 94321 Thiais Cedex.
Origine du fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 387.812,00 EUR. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Vente de prêt à porter féminin et accessoires. Enseigne : NEW LOOK. Adresse : Centre Commercial Régional, Villeneuve 2, 59658 Villeneuve-d'Ascq.
Précédent propriétaire : MIM. 722 033 115 RCS Lille.
Précédent exploitant : MIM. 722 033 115 RCS Lille.
A dater du : 06/07/2007. Date de commencement de l’activité : 26/06/2007. Publication légale : Le Syndicat agricole du 03/12/2010. Oppositions : SCP Thierry Roy, Nicolas Lemoine, Jean-Noël Galy Huissiers 41 bd de Valmy BP 232 - 59654 Villeneuve d'Ascq. Descriptif : Inscription complémentaire suite à achat. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale. Date d’effet : 24/11/2010.

19/12/2010

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

21 - COTE-D'OR

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

359 - 487 493 199 RCS Créteil. NEW LOOK FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers, Zi Sénia BP 20145, 94321 Thiais Cédex.
Origine du fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 433718 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Vente de prêt à porter et accessoires. Adresse : Intersection Voie G. Pompidou - RN 74 Centre commercial La Toison d'Or, 21000 Dijon.
Précédent propriétaire : MIM. 722 033 115 RCS Créteil.
Date de commencement de l’activité : 30/10/2010. Publication légale : Terres de Bourgogne du 19/11/2010. Oppositions : Etude ASTRUC Jean-Paul et RIVAT Isabelle 19, avenue Albert Camus 21000 Dijon Pour la correspondance : Me Gilles HITTINGER-ROUX, avocat, 55 avenue Kléber 75116 PARIS. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

17/12/2010

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

83 - VAR

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON

1114 - 487 493 199 RCS Toulon. NEW LOOK FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers, Zone Industrielle Sénia - Bp 20145, 94321 Thiais Cedex.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 374558 Euros. Etablissement : Etablissemennt complémentaire. Activité : la vente de prêt à porter et accessoires de mode. Adresse : 6, 8, 10 rue Hoche, 8, 8bis Rue Andrieu, 83000 Toulon.
Précédent propriétaire : MIM. 722 033 115 RCS Créteil.
Date de commencement de l’activité : 25/10/2010. Publication légale : Le Var Information du 19/11/2010. Oppositions : Au Mandataire SCP BROUSSAIS VALIERGUE BROUSSAIS 97 avenue Vauban BP 5004 83091 TOULON CEDEX pour la validité et pour la correspondance ME Gilles HITTINGER-ROUX - SCP HB ET ASSOCIES 55 avenue Kléber 75116 PARIS. Descriptif : Etablissement secondaire/complémentaire acquis par achat. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

09/12/2010

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

14 - CALVADOS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

101 - 487 493 199 RCS Créteil. NEW LOOK FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18 - 24 rue des Oliviers, BP 20145 Zone Industrielle Sénia, 94321 Thiais.
Origine du fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 157397 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Vente de prêt à porter féminin et accessoires. Adresse : Centre Commercial Mondeville 2, 14120 Mondeville.
Précédent propriétaire : MIM SAS. 722 033 115 RCS Caen.
Précédent exploitant : MIM SAS. 722 033 115 RCS Caen.
Date de commencement de l’activité : 23/10/2010. Publication légale : L'agriculteur normand du 25/11/2010. Oppositions : SELARL ACTOJURIS, Me Sandra MAMERT et Me Aurélie BIDEL 10, rue du Château d'Eau 14000 Caen. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

03/12/2010

JAL

Activity or goodwill cession

 

Syndicat agricole (Le)


Date de décision : 25/11/2010
Cédant : 722033115 - MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 487493199 - NEW LOOK FRANCE, 18 RUE DES OLIVIERS, ZI SENIA 18 A 24, BP 20145, 94320 THIAIS
Prix de vente : 387812 €
Date d’effet : 24/11/2010

02/12/2010

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1137 - 487 493 199 RCS Créteil. NEW LOOK FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers Zi Sénia, BP 20145 94321 Thiais.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 1662488,00 euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Vente de prêt à porter féminin et accessoires. Adresse : 84 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris.
Précédent propriétaire : M.I.M. 722 033 115 RCS Paris.
A dater du : 21/05/2008. Date de commencement de l’activité : 06/11/2010. Publication légale : Le parisien libéré du 22/11/2010. Oppositions : SELARL CHERKI-RIGOT, Huissiers de Justice 119 av de Flandre 75019 Paris pour la validité , Maître HITTINGER-ROUX, avocat, SCP HB ET ASSOCIES 55 av Kléber 75116 Paris pour la correspondance . Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

26/11/2010

JAL

Activity or goodwill cession

 

Syndicat agricole (Le)


Date de décision : 04/11/2010
Cédant : 722033115 - MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 487493199 - NEW LOOK FRANCE, 18 RUE DES OLIVIERS, ZI SENIA 18 A 24, BP 20145, 94320 THIAIS
Prix de vente : 227931 €
Date d’effet : 10/11/2010

25/11/2010

JAL

Activity or goodwill cession

 

Agriculteur normand (L')/Edition du Calvados


Date de décision : 23/10/2010
Cédant : 722033115 - MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 487493199 - NEW LOOK FRANCE, 18 RUE DES OLIVIERS, ZI SENIA 18 A 24, BP 20145, 94320 THIAIS
Prix de vente : 157397 €
Date d’effet : 23/10/2010

22/11/2010

JAL

Activity or goodwill cession

 

Parisien (Le) /Edition de Paris


Date de décision : 04/11/2010
Cédant : 722033115 - MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 487493199 - NEW LOOK FRANCE, 18 RUE DES OLIVIERS, ZI SENIA 18 A 24, BP 20145, 94320 THIAIS
Prix de vente : 1662488 €
Date d’effet : 10/11/2010

19/11/2010

JAL

Activity or goodwill cession

 

Courrier Français/Edition de la Gironde


Date de décision : 29/10/2010
Cédant : 722033115 - MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 487493199 - NEW LOOK FRANCE, 18 RUE DES OLIVIERS, ZI SENIA 18 A 24, BP 20145, 94320 THIAIS
Prix de vente : 392640 €
Date d’effet : 03/11/2010

19/11/2010

JAL

Activity or goodwill cession

 

Var Information


Date de décision : 25/10/2010
Cédant : 722033115 - MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 487493199 - NEW LOOK FRANCE, 18 RUE DES OLIVIERS, ZI SENIA 18 A 24, BP 20145, 94320 THIAIS
Prix de vente : 374558 €
Date d’effet : 25/10/2010

19/11/2010

JAL

Activity or goodwill cession

 

Terres de Bourgogne


Date de décision : 29/10/2010
Cédant : 722033115 - MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 487493199 - NEW LOOK FRANCE, 18 RUE DES OLIVIERS, ZI SENIA 18 A 24, BP 20145, 94320 THIAIS
Prix de vente : 433718 €
Date d’effet : 03/11/2010

11/11/2010

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

 

76 - SEINE-MARITIME

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

635 - 487 493 199 RCS Créteil. NEW LOOK FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18 - 24 rue des Oliviers Zone Industrielle Sénia - BP 20145, 94321 Thiais Cedex.
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 509754 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Vente de prêt à porter femmes, hommes, enfants et accessoires s'y rapportant. Adresse : 71 rue du Gros Horloge, 76000 Rouen.
Précédent propriétaire : M I M. 722 033 115 RCS Créteil.
Précédent exploitant : M I M. 722 033 115 RCS Créteil.
Date de commencement de l’activité : 01/10/2010. Publication légale : Les Affiches de Normandie du 20/10/2010. Oppositions : SCP SAVOYE N., OLLAGNIER P., Huissiers de Justice, 41 quai du Havre 76000 Rouen et pour la correspondance, domicile est élu chez Maître Gilles HITTINGER-ROUX, SCP HB ET ASSOCIES 77, avenue Kléber 75116 Paris 16. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

20/10/2010

JAL

Activity or goodwill cession

 

Affiches de normandie (Les)


Date de décision : 01/10/2010
Cédant : 722033115 - MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 487493199 - NEW LOOK FRANCE, 18 RUE DES OLIVIERS, ZI SENIA 18 A 24, BP 20145, 94320 THIAIS
Prix de vente : 509754 €
Date d’effet : 30/10/2010

26/11/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

9663 - 722033115 RCS. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers Zone Industrielle Sénia - Bp 20145 94321 Thiais Cedex. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/03/2009.

28/10/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

3296 - 722 033 115 RCS Créteil. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Octobre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Octobre 2007 Président : KERNAN William en fonction le 19 Octobre 2009.
Commentaires : Modification de représentant.

10/02/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

9302 - 722033115 RCS. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers Zone Industrielle Sénia - Bp 20145, 94321 Thiais Cedex. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/03/2008.

27/07/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

3893 - 722 033 115 RCS Créteil. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT radiation le 06 Novembre 2007commissaire aux comptes suppléant : ANTOLA ANY radié le 06 Novembre 2007.
Commentaires : Modification de représentant.

23/07/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

3179 - 722 033 115 RCS Créteil. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Octobre 2007Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Octobre 2007. Président : LEMNER Michael en fonction le 11 Juillet 2008.
Commentaires : Modification de représentant.

08/02/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

4249 - 722 033 115 RCS Créteil. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Enseigne : M I M. Adresse de l’établissement principal : 18-24 rue des Oliviers, Zone Industrielle Sénia - Bp 20145, 94321 Thiais Cedex.
Adresse du siège social : 18-24 rue des Oliviers, Zone Industrielle Sénia - Bp 20145, 94321 Thiais Cedex.
Commentaires : Modification de l'adresse de l'établissement. Modification de l'adresse du siège.

16/12/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

13603 - 722 033 115. RCS Créteil M I M. Forme: Société par actions simplifiée. Adresse du siège social: 53/55 rue Hélène Muller 94320 Thiais. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 mars 2007.

20/11/2007

Bodacc A

Vente et cession

 

361 - RCS 722 033 115. S.A.S. MIM. Forme : S.A.S. Capital : 905 280 euros. Adresse du siège social : 53-55 rue Hélène-Muller, 94320 Thiais. Etablissement secondaire - Adresse : 102 boulevard de la République, 47000 Agen. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 650 000 euros. Date de début d'activité : 1er octobre 2007. Précédent propriétaire : S.A.R.L. MOUREY. RCS Agen 450 013 065. Publication légale : Le Courrier français du 12 octobre 2007. Oppositions : au fonds, 102 boulevard de la République, 47000 Agen.

19/01/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

8628 - RCS Créteil B 722 033 115. RC 96-B 3225. M I M. Forme: SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. Adresse du siège social: 53/55, rue Helene Muller,94320 Thiais. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 mars 2006.

30/04/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

5378 - RCS Créteil B 722 033 115. RC 96-B 3225. M I M. Forme: SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - SAS. Adresse du siège social: 53/55, rue Helene Muller,94320 Thiais. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 mars 2005.

18/09/2003

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS B 722033115 RC 94-B 936 MIM. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 53-55 rue Hélène-Muller, 94320 Thiais ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : en France et dans tous pays, commerce, achat, vente, fabrication et confection de tout tissu, de tous articles textiles de tous objets, de marchandises ou d'accessoires quelconques se rapportant à l' habillement en général. Adresse : 6-8 rue Andrieu et 6-10 rue Hoche, 83000 Toulon Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 55 000 euros Date de début d'activité: 22 juillet 2003. Précédent propriétaire : ETAM. RCS 552015307 Publication légale: Var-information du 13 juillet 2003. Oppositions : au fonds pour validité et pour la correspondance, Ordre des Avocats, 11 place Dauphine, 75053 Paris R.P.-S.P.

17/09/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Créteil B 722033115 RC 96-B 3225 M. I.M. Forme : S.A.S Nom commercial: M.I.M. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président partant : AMZALLAG (Charles). Commissaire aux comptes titulaire partant : COOPERS LYBRAND AUDIT. Nomination du président : McPHAIL (Carl) . Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT.

27/02/2003

Bodacc A

Vente et cession

 

RCS non encore inscrit. MIM LOOK S.A.S. Forme : S.A.S. Capital : 2 200 000 euros. Adresse du siège social : 55 rue Hélène- Muller, 94321 Thiais Cedex Etablissement principal: Activité : équipement de la personne, maroquinerie, chaussures et à titre accessoire, équipement de la maison bagagerie, accessoires de mode et articles cadeaux. Adresse : C.A. de Rosny, centre commercial Rosny II, avenue Charles-de- Gaulle, 93110 Rosny-sous-Bois Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 609 800 euros. Date d'effet : 1 e r février 2003. Précédent propriétaire : D.D.P. RCS 410089866 Publication légale: Le Publicateur légal du 17 février 2003. Oppositions : au fonds pour la validité et au Cabinet Xavier Chepeau, 17 rue de Rivière, B.P. 68, 33029 Bordeaux Cedex, pour la correspondance.

25/12/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Créteil B 722033115 RC 96-B 3225 M. I.M. Forme : S.A.S. Capital : 905 280 euros Nom commercial: M.I.M. Commentaires : modification survenue sur le capital ( augmentation).

24/08/2001

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS B 722033115 RC AP-B 2386 SOCIETE MIM. Forme : S.A.S. Capital : 5 924 800 F. Adresse du siège social : 55 rue Hélène- MÎller, 94300 Thiais Etablissement principal: Activité : vente de pret-à- porter pour hommes, femmes et enfants, chaussures ainsi que leurs accessoires. Adresse : 120 rue Rambuteau, 75001 Paris Etablissement principal acquis par cession au prix stipulé de 5 450 000 F. Date d'effet : 1 e r aout 2001. Précédent propriétaire : SARTO. RCS B 307982215 Publication légale: La Gazette du Palais du 4 aout 2001. Oppositions : au fonds.

18/04/2001

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS Limoges B 722033115 RC 78-B 37 M.I. M. Forme : S.A.S. Capital : 5 924 800 F Nom commercial: M.I.M. Adresse du siège social : 53-55 rue Hélène-Muller, 94320 Thiais ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Adresse : centre commercial de Beaubreuil, 87100 Limoges ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Enseigne : M.I.M. Activité : vente de pret- à-porter féminin et d'accessoires s'y rapportant. Adresse : centre commercial Saint-Martial, 39 bis avenue Garibaldi, 87000 Limoges Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 3 000 000 de F. Commentaires : modification survenue sur l'adresse de l'établissement principal et la date de début d'activité Date de début d' activité: 15 février 1978. Date d'effet : 28 février 2001. Précédent propriétaire : S.A. N.C.C. RCS Tours 387703853 Publication légale: Le Courrier français du 23 mars 2001. Oppositions : au siège de la société Fidal, 34 rue Ferdinant-Buisson, 87000 Limoges, pour la validité et au siège de la société Fidal, 9 rue de L'Ouvrage-à-Corne, B.P. 286, 17013 La Rochelle, pour la correspondance.

15/02/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Créteil B 722033115 RC 96-B 3225 M. I.M. Forme : S.A.S Nom commercial: M.I.M. Commentaires : modification survenue sur la forme juridique et l'administration. Administration : modification du président : AMZALLAG (Charles). Directeur général et administrateur partant : AMZALLAG (Emile). Directeur général non administrateur partant : BENOIT (Brigitte) ( Nom d'usage : AMZALLAG). Administrateur partant : SUNNUCKS (Stephen). Nomination d' administrateurs : NEW LOOK GROUP P.L.C. MILLER (Alastair). Commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : ANTOLA (Any).

04/02/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Créteil B 722033115 RC 96-B 3225 M. I.M. Forme : S.A Nom commercial: M.I.M. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateurs partants : AMZALLAG ( Claude) ( Nom d'usage : DOMINATI) AMZALLAG (Joelle) ( Nom d'usage : LEISERSON). Nomination d' administrateurs : SUNNUCKS (Stéphen) NEW LOOK GROUP P.L.C. MILLER ( Alastair).

22/10/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Créteil B 722033115 RC 96-B 3225 M. I.M. Forme : S.A Nom commercial: M.I.M. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : commissaire aux comptes titulaire partant : BLIAH (Bernard). Nomination du commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant partant : BLIAH ( Françoise). Nomination du commissaire aux comptes suppléant : ANTOLA (Any).

15/10/2000

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS B 722033115 A dater du: 25 septembre 2000 RC 00-B 189 M.I.M. Forme : S.A. à conseil d'administration. Adresse du siège social : 53-55 rue Hélène- Muller, 94320 Thiais Etablissement principal: Adresse : 53-55 rue Hélène- Muller, 94320 Thiais ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : confection pour hommes, femmes et enfants. Adresse : 3 rue Gambetta et 3 place Surchamp (angle) 33500 Libourne Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 700 000 F. Date d'effet : 22 aout 2000. Précédent propriétaire : ALIX S.A.R.L. RCS B 331647214 Publication légale: Sud- Ouest du 5 septembre 2000. Oppositions : M e Boireau, notaire, 38 allée Robert- Boulin, 33500 Libourne.

02/12/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

*. RCS Créteil B 722 033 115 RC 96-B 3225 M.I.M. Forme : S.A Nom commercial: M. I.M. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination en qualité d'administrateur : BENOIT (Brigitte), ( nom d'usage : AMZALLAG).

06/08/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Créteil B 722033115 RC 96-B 03225 M. I.M. Forme : S.A. Capital : 5 924 800 F Nom commercial: M.I.M. Activité : commerce de tous articles pour hommes, femmes et enfants, de textiles, d'habillement et de vetements en tout genre tissu, bonneterie, pret-à-porter, nouveautés, exclusivités, articles chaussants neufs et articles hors cours, chaussures, maroquinerie et accessoires. Adresse du siège social : 53-55 rue Hélène-Muller, 94320 Thiais. Administration : nomination du président du conseil d' administration : AMZALLAG (Charles). Nomination du directeur général et administrateur : AMZALLAG (Emile). Nomination d'administrateurs : AMZALLAG (Joelle) ( Nom d'usage : LEISERSON) AMZALLAG (Claude) ( Nom d'usage : DOMINATI). Nomination du commissaire aux comptes titulaire : BLIAH (Bernard). Nomination du commissaire aux comptes suppléant : BLIAH (Françoise), à compter du 4 juin 1999. Commentaires : modification survenue sur sur l' activité, le capital, l'adresse du siège social, l'adresse de l' établissement principal et l' administration. Ancienne adresse : 17- 23 rue Alphonse-Pluchet, 92220 Bagneux.

11/07/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Nanterre B 722033115 RC 93-B 4354 M. I.M. Forme : S.A Nom commercial: M.I.M. Adresse du siège social : 17-23 rue Alphonse-Pluchet, 92220 Bagneux Date de radiation: 25 juin 1999.

11/06/1999

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS Versailles B 722033115 RC 94-B 2997 M.I.M. Forme : S.A. Capital : 5 924 800 F. Adresse du siège social : 17-23, rue Pluchet 92220 Bagneux Etablissement principal: Activité : commerce de tous articles pour hommes, dames et enfants, textiles et habillement de vetements en tous genres, tissus, bonneterie, pret-à- porter, nouveautés, exclusivités, chaussant neufs et articles hors cours, chaussures, maroquinerie et accessoires. Adresse : centre Leclerc, 11, avenue Jean-Jaurès 78390 Bois-d'Arcy Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 450 000 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE immatriculé au. RCS : Versailles. Adresse : centre commercial de Flins, local n° 67 78410 Flins-sur-Seine. Activité : pret-à-porter Date de début d'activité: 28 octobre 1994. Précédent propriétaire : DANHER. RCS B 389426248 Publication légale: Les Petites A Jches de Seine-et-Oise du 25 février 1999. Oppositions : au fonds.

12/03/1999

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS *. RCS Versailles B 722 033 115 MIM. Forme : S.A. Capital : 5 924 800 F. Adresse du siège social : 17-23, rue Alphonse- Pluchet 92220 Bagneux Etablissement principal: Activité : vente de pret-à- porter. Adresse : centre commercial de Flins, local 67 78410 Flins Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 450 000 F. Date d'effet : 1er février 1999. Précédent propriétaire : : DANHER. RCS RCS B 389 426 248 Publication légale: La Semaine de l' Ile-de-France du 25 février 1999. Oppositions : Me Michel Culang, 103, rue la Boétie, 75008 Paris et au fonds pour la validité.

28/02/1999

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS Meaux B 421 464 850 A dater du: 4 février 1999 RC 99-B 153 MATOC. Forme : S. A.R.L. Capital : 50 000 F. Adresse du siège social : 65 avenue de la Résistance 77500 Chelles. Administration : gérant : OUANOUNOU (Eric, David) Etablissement principal: Activité : toutes opérations industrielles, commerciales se rapportant à la vente et à la fabrication du textile. Adresse : 65 avenue de la Résistance 77500 Chelles Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 100 000 F. Commentaires : transfert du siège social. Ancienne adresse : 2 bis rue des Deux- Frères, 93250 Villemomble. Date d'effet : 26 janvier 1999. Précédent propriétaire : MIM. RCS B 722 033 115 Publication légale: Le Moniteur de Seine-et-Marne du 6 février 1999. Oppositions : au fonds.

30/10/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS *. RCS Nanterre B 722 033 115 RC RC 93-B 4354 M.I.M. Forme : S.A Nom commercial: M.I.M. Administration : suppression : commissaire aux comptes titulaire : BAYLAC (Jeanine). Modification : commissaire aux comptes titulaire : BLIAH (Bernard). Nomination en qualité de commissaire aux comptes suppléant : BLIAH ( Françoise). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

13/08/1998

Bodacc A

Création d'établissement

 

Rectificatif: Annonce numéro: 177 Date de parution: 14 juin 1998 Page: 12 Numéro de parution: 111A Au lieu de : Adresse de l'établissement principal : centre commercial Bordeaux - Ouest, centre Leclerc, 33000 Bordeaux, lire : RCS B 722 033 115 MIM S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : avenue Descartes, centre commercial Bordeaux- Ouest, centre Leclerc 33160 Saint- Médard-en-Jalles.

14/06/1998

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS B 722 033 115 MIM. Forme : S.A. Capital : 5 924 800 F. Adresse du siège social : 17-23 rue Alphonse-Pluchet 92220 Bagneux Etablissement principal: Activité : vente au détail de vetements et de pret-à-porter. Adresse : centre commercial Bordeaux-Ouest, centre Leclerc, avenue Descartes 33000 Bordeaux Cession de l'établissement principal au prix stipulé de 550 000 F. Date d'effet : 17 mars 1998. Précédent propriétaire : SOCIETE DE VETEMENTS TEXTILE. RCS B 402 284 202 Publication légale: Les Echos judiciaires girondins du 22 mai 1998. Oppositions : Me Leblond, 74 avenue Pasteur, 33600 Pessac.

09/06/1998

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS Créteil B 722 033 115 M.I.M. Forme : S.A. Capital : 5 924 800 F. Adresse du siège social : 17-23 rue Alphonse- Pluchet 92220 Bagneux Etablissement principal: Activité : confection. Adresse : centre commercial de Belle Epine 94320 Thiais Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 3 380 000 F. Date d'effet : 30 avril 1998. Précédent propriétaire : MAD. RCS B 350 080 115 Publication légale: Le Publicateur légal du 18 mai 1998. Oppositions : au fonds pour la validité et pour la correspondance, au Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats, 11 place Dauphine, 75001 Paris.

03/03/1998

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS Nanterre B 722 035 115 SOCIETE MIM. Forme : S.A. Capital : 5 924 800 F. Adresse du siège social : 17-23 rue Alphonse-Pluchet, 92000 Bagneux. Administration : président-directeur général : AMZALLAG (Charles) Fonds principal acquis par achat au prix stipulé de 850 000 F Etablissement principal: Activité : pret-à-porter hommes, femmes, enfants et accessoires. Adresse : centre commercial Caluire 2, 53 avenue Général-Leclerc, 69300 Caluire. Date d'effet : 17 janvier 1998 Précédente propriétaire SOBAC MAILLE S. A. RCS Lyon B 388 361 305 Publication légale: Inform. Agricole Rhone du 22 janvier 1998. Oppositions : S.C.P. Boyer Clément, 119 avenue Saxe, 69003 Lyon.

08/11/1997

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS Nanterre B 722 033 115 RC 94-B 218 MIM. Forme : S.A. Enseigne : Mim. Adresse du siège social : 17-23 rue Alphonse- Pluchet, 92220 Bagneux Fonds acquis par achat, au prix stipulé de 480 000 F Etablissement principal: Activité : vente de vetements de femmes. Adresse : centre commercial Balaruc-Centre, 34540 Balaruc-les-Bains. Date d'effet : 1er septembre 1997 Précédente propriétaire F.L. DIFFUSION S.A.R.L. RCS Montpellier B 335 338 075 RC 92-B 246 Publication légale: L'Hérault judiciaire et commercial du 18 septembre 1997. Oppositions : Me Spinelli, 1 rue Honoré-Euzet, 34200 Sète.

11/07/1997

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS Nanterre B 722 033 115 MIM. Forme : S. A. Capital : 5 924 800 F. Adresse du siège social : 17/23, rue Alphonse- Pluchet, 92220 Bagneux Fonds principal acquis par achat au prix stipulé de 650 000 F Etablissement principal: Adresse : 32, rue de la Marne et 1, quai des Arts, 51000 Chalons-en-Champagne. Activité : pret-à-porter féminin. Date d'effet : 23 mai 1997 Précédente propriétaire PROMOD. RCS Roubaix B 685 420 606 Publication légale: Les Petites Affiches Matot-Braine du 13 juin 1997. Oppositions : Me Delattre Géry, 56, rue du Maréchal-Foch, 59100 Roubaix et pour la validité, au fonds vendu.

04/07/1997

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS B 722 033 115 MIM. Forme : S.A. Capital : 5 924 800 F. Adresse du siège social : 17-23 rue Alphonse-Pluchet 92220 Bagneux Etablissement principal: Activité : vente de pret-à-porter féminin et d'accessoires. Adresse : centre commercial Saint-Christoly, local n° 25 33000 Bordeaux Cession de l' établissement principal au prix stipulé de 500 000 F. Date d'effet : 23 mai 1997. Précédent propriétaire : PROMOD. RCS B 685 420 606 Publication légale: Les Echos judiciaires girondins du 20 juin 1997. Oppositions : Me Delattre-Géry, 56 rue du Maréchal-Foch, 59-Roubaix pour la correspondance et au fonds pour la validité.

29/06/1997

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS B 722 033 115 M.I.M. Forme : S.A. Capital : 5 924 800 F. Adresse du siège social : 17-23 rue Pluchet 92220 Bagneux Etablissement principal: Activité : pret- à-porter féminin et accessoires. Adresse : centre commercial Euromarché, Galerie marchande 78410 Flins Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 700 000 F. Date d'effet : 23 mai 1997. Précédent propriétaire : PROMOD S.A. RCS B 685 420 606 Publication légale: Les Petites affiches du 12 juin 1997. Oppositions : Me Delattre, 56 rue du Maréchal-Foch, 59-Roubaix et pour la validité au fonds.

01/06/1997

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS B 722 033 115 RC 97-B 00199 M.I.M. Forme : S.A. Capital : Nom commercial: M.I. M. Adresse du siège social : 17-23 rue Alphonse-Pluchet 92220 Bagneux Etablissement principal: Adresse : centre commercial Evry 2 91000 Evry. Activité : commerce de tous articles pour hommes, femmes et enfants, de textiles, d'habillement, de vetements en tout genre tissu, bonneterie, pret- à-porter, nouveautés, exclusivités, articles chaussants neufs et hors cours, chaussures, maroquinerie et accessoires Etablissement principal acquis par par apport au montant évalué à 105 627 F Date de début d'activité: 31 octobre 1996. Précédent propriétaire : SOCIETE ETHY FROC. RCS B 304 423 619 Publication légale: Le Publicateur légal du 15 novembre 1996 déclaration de créances: au tribunal de commerce de Corbeil- Essonnes.

23/06/1995

Bodacc A

Vente et cession

 

RCS Non encore inscrit au. RCS MIM. Forme : S.A. Capital : 5 924 800 F. Adresse du siège social : 17 à 23, rue Alphonse- Pluchet 92220 Bagneux Etablissement Complémentaire. Adresse : galerie marchande, Grande-Tour 33560 Sainte- Eulalie Fonds complémentaire acquis par cession au prix stipulé de 440 000 F. Date d'effet : 4 mai 1995. Précédent propriétaire : : S.A. MC'IN. RCS RCS B 381 873 512 Publication légale: Les Echos Judiciaires Girondins du 12 mai 1995. Oppositions : au fonds.

23/06/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS. RCS B 395 305 410 RC RC 94-B 1225 MERCURE RHONE-ALPES MEDITERRANEE. Forme : S.A. Capital : 250 000 F. Adresse du siège social : 2, rue de la Mare-Neuve 91000 Evry Mise en activité suite à la reprise en location-gérance du fonds principal Etablissement principal: Activité : gestion de toutes activités d' hotellerie et restauration. Adresse : 2, rue de la Mare-Neuve 91000 Evry Date de début d'activité: 13 octobre 1994 Propriétaire : SOCIETE MIM.

07/01/1995

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS Nanterre B 722 033 115 A dater du: 2 décembre 1994 M.I.M. Forme : S.A. Nom commercial: M.I.M. Adresse du siège social : 17-23 rue Alphonse-Pluchet, 92200 Bagneux ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Fréjus 94-B 398. Activité : commerce de tous articles (pour hommes, dames, enfants), textiles et habillement, vetements en tout genre, tissus, bonneterie, pret-à-porter, nouveautés, exclusivités chaussants neufs et articles hors cours, chaussures, maroquinerie et accessoires. Enseigne : M.I.M. Adresse : centre commercial Continent, 83480 Puget-sur-Argens Fonds secondaire acquis par fusion, au montant évalué à 1 625 138 F Date de début d'activité: 30 juin 1994 Précédente propriétaire CAPUCINES 17 S. A.R.L. RCS B 342 378 429 RC 91-B 432 Publication légale: Le Publicateur légal du 2 aout 1994 déclaration de créances: au greffe du tribunal de commerce de Nanterre.

Company events history

 

 

Date

Description

31/01/2014

Update Rating

31/01/2014

Update Limit

31/01/2014

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

27/12/2013

Bodacc B: Various editing or changing

18/12/2013

New chairman (CEO, CoB)

18/12/2013

Minutes of general meeting of shareholders

17/12/2013

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

05/12/2013

Legal Gazette: Appointment of the social representative

25/11/2013

Bodacc C : Deposit accounts notice

19/10/2013

Update Limit

19/10/2013

Update Rating

31/03/2013

New accounts available

31/01/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

02/01/2013

Bodacc C : Deposit accounts notice

17/10/2012

Bodacc B: Various editing or changing

11/10/2012

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

09/10/2012

Minutes of general meeting of shareholders

09/10/2012

New chairman (CEO, CoB)

14/09/2012

Legal Gazette: Appointment of the social representative

31/03/2012

New accounts available

20/03/2012

Bodacc A : Sale and transfer

28/02/2012

Bodacc B: Various editing or changing

20/02/2012

Minutes of general meeting of shareholders

20/02/2012

New chairman (CEO, CoB)

18/02/2012

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

01/02/2012

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

30/01/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

30/01/2012

Legal Gazette: Appointment of the social representative

14/01/2012

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

01/07/2011

Other modification of Establishment

01/07/2011

Formation of Establishment

31/03/2011

New accounts available

31/03/2011

Bodacc A : Sale and transfer

17/02/2011

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

18/01/2011

Bodacc C : Deposit accounts notice

11/01/2011

Bodacc A : Sale and transfer

26/12/2010

Bodacc A : Sale and transfer

23/12/2010

Bodacc A : Sale and transfer

19/12/2010

Bodacc A : Sale and transfer

17/12/2010

Bodacc A : Sale and transfer

09/12/2010

Bodacc A : Sale and transfer

02/12/2010

Bodacc A : Sale and transfer

25/11/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

11/11/2010

Bodacc A : Sale and transfer

04/11/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

29/10/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

25/10/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

23/10/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

01/10/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

24/08/2010

Payment incident closed

21/07/2010

Payment incident detected

12/05/2010

Formation of Establishment

05/05/2010

Formation of Establishment

31/03/2010

Other modification of Establishment

31/03/2010

Formation of Establishment

31/03/2010

New accounts available

08/02/2010

Payment incident closed

26/11/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

28/10/2009

Bodacc B: Various editing or changing

19/10/2009

Changement de Président (PDG, PCA)

19/10/2009

New chairman (CEO, CoB)

19/10/2009

Acte modificatif

19/10/2009

Amendment

23/07/2009

Payment incident detected

15/05/2009

Other modification of Establishment

15/05/2009

Formation of Establishment

10/04/2009

Formation of Establishment

31/03/2009

New accounts available

10/02/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

23/01/2009

Other modification of Establishment

30/12/2008

Payment incident closed

06/12/2008

Closure of Establishment

20/10/2008

Payment incident detected

15/10/2008

Formation of Establishment

01/10/2008

Formation of Establishment

20/09/2008

Formation of Establishment

12/09/2008

Formation of Establishment

30/08/2008

Formation of Establishment

01/08/2008

Formation of Establishment

27/07/2008

New Bodacc B ads detected

27/07/2008

Bodacc B: Various editing or changing

23/07/2008

New Bodacc B ads detected

23/07/2008

Bodacc B: Various editing or changing

11/07/2008

Changement de Président (PDG, PCA)

11/07/2008

Minutes of general meeting of shareholders

11/07/2008

PV d'Assemblée

11/07/2008

New chairman (CEO, CoB)

11/07/2008

Private document

11/07/2008

Appointment/resignation of company officers

11/07/2008

Changes to the Board of Directors

31/03/2008

New accounts available

29/03/2008

Formation of Establishment

21/03/2008

Formation of Establishment

08/02/2008

New Bodacc B ads detected

08/02/2008

Bodacc B: Various editing or changing

07/02/2008

Amendment

07/02/2008

Acte modificatif

07/02/2008

Updated articles of association

07/02/2008

Statuts mis à jour

07/02/2008

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

07/02/2008

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

06/11/2007

Changement de Commissaire aux Comptes

06/11/2007

Amendment

06/11/2007

Acte modificatif

06/11/2007

Minutes of general meeting of shareholders

06/11/2007

Private document

31/10/2007

Minutes of general meeting of shareholders

31/10/2007

PV d'Assemblée

31/10/2007

Appointment/resignation of company officers

31/10/2007

Private document

31/03/2007

New accounts available

17/01/2007

Transfer of Establishment

17/01/2007

Update of Company Head Office Identifier

12/05/2006

Acte sous seing privé

12/05/2006

Private document

12/05/2006

Appointment/resignation of company officers

12/05/2006

Nomination/démission des organes de gestion

12/05/2006

Minutes of general meeting of shareholders

12/05/2006

PV d'Assemblée

12/05/2006

Statuts mis à jour

12/05/2006

Updated articles of association

12/05/2006

Acte modificatif

31/03/2006

New accounts available

31/03/2005

New accounts available

13/09/2004

Planned merger

13/09/2004

Projet de Fusion

13/09/2004

Fusion

13/09/2004

Acte sous seing privé

13/09/2004

Private document

13/09/2004

Déclaration de conformité

13/09/2004

Minutes of general meeting of shareholders

13/09/2004

PV d'Assemblée

13/09/2004

Acte modificatif

16/07/2004

Acte sous seing privé

16/07/2004

Rapport des Commissaires ou du Gérant

16/07/2004

Audit or Management Report

16/07/2004

Private document

01/07/2004

Amendment

01/07/2004

Planned merger

01/07/2004

Acte modificatif

01/07/2004

Projet de Fusion

01/07/2004

Private document

01/07/2004

Acte sous seing privé

16/06/2004

Acte modificatif

16/06/2004

Application and court order

16/06/2004

Requête et Ordonnance

31/03/2004

New accounts available

05/09/2003

PV d'Assemblée

05/09/2003

Nomination/démission des organes de gestion

05/09/2003

Acte sous seing privé

05/09/2003

Statuts mis à jour

05/09/2003

Changement de Président (PDG, PCA)

05/09/2003

Changement de Commissaire aux Comptes

05/09/2003

Acte modificatif

31/03/2003

New accounts available

26/11/2001

Acte modificatif

26/11/2001

Conversion du Capital Social en Euros

26/11/2001

Acte sous seing privé

26/11/2001

Statuts mis à jour

26/11/2001

Augmentation de Capital

26/11/2001

PV d'Assemblée

31/01/2001

Rapport des Commissaires ou du Gérant

31/01/2001

Changement de Commissaire aux Comptes

31/01/2001

Statuts mis à jour

31/01/2001

PV d'Assemblée

31/01/2001

Nomination/démission des organes de gestion

31/01/2001

Acte sous seing privé

31/01/2001

Modification du Conseil d'Administration

31/01/2001

Changement de Président (PDG, PCA)

31/01/2001

Prorogation de durée

31/01/2001

Changement de Forme Juridique avec changement de catégorie

31/01/2001

Changement de Forme Juridique sans changement de catégorie

31/01/2001

Acte modificatif

18/01/2001

Statuts mis à jour

18/01/2001

Changement de date de clôture

18/01/2001

Modification du Conseil d'Administration

18/01/2001

Acte sous seing privé

18/01/2001

Nomination/démission des organes de gestion

18/01/2001

PV d'Assemblée

06/10/2000

Acte sous seing privé

06/10/2000

Changement de Commissaire aux Comptes

06/10/2000

Acte modificatif

06/10/2000

PV d'Assemblée

06/10/2000

Nomination/démission des organes de gestion

17/11/1999

Acte sous seing privé

17/11/1999

Modification du Conseil d'Administration

17/11/1999

PV du Conseil d'Administration

17/11/1999

Nomination/démission des organes de gestion

17/11/1999

Acte modificatif

03/06/1999

Immatriculation suite à transfert

03/06/1999

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

03/06/1999

Acte modificatif

03/06/1999

Statuts mis à jour

03/06/1999

PV d'Assemblée

03/06/1999

Acte sous seing privé

07/01/1999

Déclaration de conformité

07/01/1999

Fusion

07/01/1999

PV d'Assemblée

07/01/1999

Acte sous seing privé

18/12/1998

Rapport des Commissaires ou du Gérant

18/12/1998

Acte sous seing privé

30/11/1998

Acte sous seing privé

30/11/1998

Projet de Fusion

05/11/1998

Acte modificatif

05/11/1998

Nomination/démission des organes de gestion

05/11/1998

Requête et Ordonnance

12/10/1998

Acte sous seing privé

12/10/1998

PV d'Assemblée

12/10/1998

Nomination/démission des organes de gestion

12/10/1998

Changement de Commissaire aux Comptes

08/01/1998

Acte modificatif

08/01/1998

Acte sous seing privé

08/01/1998

PV d'Assemblée

08/01/1998

Fusion

08/01/1998

Déclaration de conformité

18/12/1997

Acte sous seing privé

18/12/1997

Rapport des Commissaires ou du Gérant

24/11/1997

Acte sous seing privé

24/11/1997

Projet de Fusion

17/09/1997

Acte sous seing privé

17/09/1997

Acte modificatif

17/09/1997

Requête et Ordonnance

05/12/1996

PV d'Assemblée

05/12/1996

Acte modificatif

05/12/1996

Fusion

05/12/1996

Acte sous seing privé

05/12/1996

Déclaration de conformité

22/10/1996

Rapport des Commissaires ou du Gérant

22/10/1996

Acte modificatif

27/06/1996

Projet de Fusion

27/06/1996

Acte modificatif

13/06/1996

Acte modificatif

13/06/1996

Requête et Ordonnance

08/09/1994

Modification du Conseil d'Administration

08/09/1994

Statuts mis à jour

08/09/1994

Acte modificatif

08/09/1994

PV d'Assemblée

08/09/1994

Fusion

08/09/1994

Déclaration de conformité

08/09/1994

Changement de dénomination sociale

08/09/1994

Acte sous seing privé

21/06/1994

Acte modificatif

21/06/1994

Rapport des Commissaires ou du Gérant

30/05/1994

Acte modificatif

30/05/1994

Acte sous seing privé

30/05/1994

Projet de Fusion

22/04/1994

Acte modificatif

22/04/1994

Requête et Ordonnance

12/10/1993

PV d'Assemblée

12/10/1993

Statuts

12/10/1993

Immatriculation suite à transfert

12/10/1993

Déclaration de conformité

12/10/1993

Statuts mis à jour

12/10/1993

PV du Conseil d'Administration

16/09/1993

Transfert du Siège hors du ressort du Tribunal de Commerce

16/09/1993

PV du Conseil d'Administration

16/09/1993

Acte modificatif

24/07/1992

Statuts mis à jour

24/07/1992

PV d'Assemblée

24/07/1992

Acte modificatif

24/07/1992

Modification de l'objet social

24/07/1992

Déclaration de conformité

28/03/1991

Requête et Ordonnance

 

 

Establishment events history

 

 

Date

Description

01/02/2014

Update Limit

01/02/2014

Update Rating

04/01/2014

Update Limit

06/12/2013

Update Rating

31/01/2013

Update Limit

31/01/2013

Update Rating

13/01/2013

Update of phone numbers

05/01/2013

Update Limit

04/12/2012

Update Rating

14/01/2012

Update Limit

07/01/2012

Update Limit

01/07/2011

Modification of Head office

08/01/2011

Update Rating

01/12/2010

Update Rating

24/08/2010

Update Limit

24/08/2010

Update Rating

19/08/2010

Update of phone numbers

06/08/2010

Update Limit

06/08/2010

Update Rating

12/05/2010

Modification of Head office

05/05/2010

Modification of Head office

31/03/2010

Update of Establishment Workforce

31/03/2010

Modification of Head office

08/02/2010

Update Rating

08/02/2010

Update Limit

10/08/2009

Update Limit

10/08/2009

Update Rating

15/05/2009

Modification of Head office

10/04/2009

Modification of Head office

09/02/2009

Update Limit

09/02/2009

Update Rating

23/01/2009

Modification of Head office

06/01/2009

Update Limit

30/12/2008

Update Rating

30/12/2008

Update Limit

06/12/2008

Modification of Head office

05/11/2008

Update Limit

05/11/2008

Update Rating

15/10/2008

Modification of Head office

01/10/2008

Modification of Head office

20/09/2008

Modification of Head office

12/09/2008

Modification of Head office

30/08/2008

Modification of Head office

01/08/2008

Modification of Head office

14/04/2008

Update of phone numbers

29/03/2008

Modification of Head office

21/03/2008

Modification of Head office

17/01/2007

Formation of Head office (after transfer)

 

directors

 

Name

M. RUF BERNHARD

 

Manager position

President

Date of birth

15/01/1967

 

Place of birth

RASTTAT(ALLEMAGNE)

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

Previous Directors

 

View the directors history for this company
If you want to view the directors history, please click on the link view details.

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

President

M NIGEL DARWIN

21/06/1970 - BUXTON(ROYAUME-UNI)

President

M WILLIAM KERNAN

13/06/1969 - POOLE(ROYAUME-UNI)

President

M WILLIAM KERNAN

13/06/1969 - POOLE(ROYAUME-UNI)

President

M MICHAEL LEMNER

- - -

President

M MICHAEL LEMNER

07/08/1957 - DANDERYD SUEDE

President

M MICHAEL LEMNER

07/08/1957 - DANDERYD(SUEDE)

President

M CARL MC PHAIL

- - -

President

M XAVIER WILMES

14/06/1968 - CHARLEVILLE MEZIERES

President

M XAVIER WILMES

14/06/1968 - CHARLEVILLE MEZIERES

Bottom of Form

 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.62.12

UK Pound

1

Rs.103.93

Euro

1

Rs.85.17

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Report Prepared by :

NIS

 

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

----

NB

New Business

----

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.