|
Active Account | Passive Account | Account
Results
|
|
Synthesized Accounts
|
Annual Accounts
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
|
|
Account period (month)
|
12
|
|
12
|
|
12
|
|
|
|
Account Type
|
Normal
|
|
Normal
|
|
Normal
|
|
|
|
Date of capture
|
28/01/2014
|
|
29/01/2013
|
|
11/01/2012
|
|
|
|
Activity Code
|
4771Z
|
|
4771Z
|
|
4771Z
|
|
|
|
Employees
|
0
|
|
2020
|
|
2088
|
|
|
Active account
|
Annual
Accounts
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
Sector
Median 2013
|
|
|
Capital not
called
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0
|
0%
|
|
Total fixed
assets
|
44 475 628
|
-14,2%
|
51 834 595
|
-8,7%
|
56 776 703
|
93 686
|
47373,1%
|
|
- Intangible
assets
|
17 475 399
|
-11,1%
|
19 652 680
|
4,7%
|
18 777 735
|
53 000
|
32872,5%
|
|
- Tangible
assets
|
20 048 493
|
-24,1%
|
26 429 765
|
-14,8%
|
31 027 829
|
13 172
|
152105,4%
|
|
- Financial
assets
|
6 951 736
|
1,2%
|
6 868 150
|
-1,5%
|
6 971 139
|
1 296
|
536299,4%
|
|
Net current
assets
|
89 254 790
|
9,2%
|
81 719 544
|
1,2%
|
80 753 923
|
109 816
|
81176,7%
|
|
- Stocks
|
25 184 575
|
35,5%
|
18 580 174
|
-12,4%
|
21 210 290
|
54 352
|
46236,1%
|
|
- Advanced
payments
|
0
|
9,2%
|
0
|
0%
|
0
|
0
|
0%
|
|
-
Receivables
|
53 164 757
|
4,6%
|
50 849 038
|
4,2%
|
48 803 604
|
9 247
|
574840,6%
|
|
- Securities
and cash
|
10 905 458
|
-11,3%
|
12 290 332
|
14,4%
|
10 740 029
|
16 475
|
66094,0%
|
|
- Prepaid
expenses
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
823
|
-
|
|
Accounts of
regularization
|
67 810
|
-1,4%
|
68 770
|
-67,9%
|
214 487
|
0
|
0%
|
|
Total Assets
|
133 798 228
|
0,1%
|
133 622 909
|
-3,0%
|
137 745 113
|
225 492
|
59236,1%
|
Passive
Account
|
Annual
Accounts
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
Sector
Median 2013
|
|
|
Shareholders'
equity
|
27 395 553
|
-14,1%
|
31 892 453
|
-24,6%
|
42 300 351
|
59 079
|
46271,1%
|
|
Share
capital
|
905 280
|
0%
|
905 280
|
0%
|
905 280
|
8 000
|
11216,0%
|
|
Other
capital resources
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0
|
0%
|
|
Risk
Provisions
|
1 809 110
|
65,5%
|
1 093 170
|
69,3%
|
645 627
|
0
|
0%
|
|
Liabilities
|
104 593 565
|
3,9%
|
100 637 286
|
6,2%
|
94 799 135
|
138 896
|
75203,5%
|
|
- Financial
liabilities
|
72 202 032
|
1,1%
|
71 447 154
|
11,2%
|
64 242 197
|
51 419
|
140319,0%
|
|
- Advanced
payments received
|
298 485
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0
|
0%
|
|
- Trade
account payables
|
20 212 300
|
30,5%
|
15 492 947
|
3,4%
|
14 984 634
|
29 855
|
67601,6%
|
|
- Tax and
social liabilities
|
9 698 406
|
-18,9%
|
11 965 860
|
-11,0%
|
13 437 934
|
19 370,50
|
49967,9%
|
|
- Other
debts and fixed assets liabilities
|
1 379 875
|
49,5%
|
923 071
|
-44,3%
|
1 657 996
|
3 204
|
42967,3%
|
|
Account
regularization
|
802 467
|
-0,7%
|
808 254
|
69,7%
|
476 374
|
0
|
0%
|
|
Total
liabilities
|
133 798 228
|
0,1%
|
133 622 909
|
-3,0%
|
137 745 113
|
225 492
|
59236,1%
|
Results
|
Annual Accounts
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
Sector Median 2013
|
|
|
Sales of Goods
|
186 426 637
|
-1,0%
|
188 297 778
|
-4,8%
|
197 740 128
|
277 214
|
67150,1%
|
|
Net turnover
|
182 246 722
|
-2,1%
|
186 114 237
|
-5,4%
|
196 709 355
|
273 021
|
66651,9%
|
|
- of which net export turnover
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0
|
0%
|
|
Operating charges
|
190 449 415
|
-1,8%
|
193 977 829
|
2,4%
|
189 487 005
|
270 197
|
70385,4%
|
|
Operating profit/loss
|
-4 022 778
|
29,2%
|
-5 680 051
|
-168,8%
|
8 253 123
|
6 749
|
-59705,5%
|
|
Financial income
|
2 651 294
|
-31,7%
|
3 880 044
|
42,8%
|
2 717 234
|
06
|
44188133,3%
|
|
Financial charges
|
2 783 623
|
-5,9%
|
2 957 246
|
3,2%
|
2 866 801
|
1 742
|
159694,7%
|
|
Financial profit/loss
|
-132 329
|
-114,3%
|
922 798
|
717,0%
|
-149 567
|
-1 201
|
-10918,2%
|
|
Pretax net operating income
|
-4 155 107
|
12,7%
|
-4 757 253
|
-158,7%
|
8 103 556
|
4 697
|
-88563,0%
|
|
Extraordinary income
|
3 917 090
|
495,1%
|
658 261
|
-85,5%
|
4 530 139
|
0
|
0%
|
|
Extraordinary charges
|
4 192 773
|
171,3%
|
1 545 584
|
-53,0%
|
3 290 096
|
36
|
11646491,7%
|
|
Extraordinary profit/loss
|
-275 683
|
68,9%
|
-887 323
|
-171,6%
|
1 240 043
|
0
|
0%
|
|
Net result
|
-4 430 790
|
25,9%
|
-5 979 916
|
-224,9%
|
4 788 047
|
4 687
|
-94633,6%
|
|
|
|
Normal
Account
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Months
|
|
12
|
|
12
|
|
12
|
Accounts - Active
Current Assets | Equalization accounts | Reference
Grand Total - Passive Accounts (I to IV)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Grand Total
(I to VI)
|
Net
|
133 798 228
|
0,1%
|
133 622 909
|
-3,0%
|
137 745 113
|
|
Gross
|
CO
|
200 283 134
|
2,4%
|
195 576 326
|
1,3%
|
193 068 011
|
|
Amortisation
|
1A
|
66 484 906
|
7,3%
|
61 953 417
|
12,0%
|
55 322 898
|
Non declared
distributed capital (I)
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Non declared
distributed capital (I)
|
AA3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Gross
|
AA
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Active fixed
asset (II)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Total Active
fixed asset (II)
|
Net
|
44 475 628
|
-14,2%
|
51 834 595
|
-8,7%
|
56 776 703
|
|
Gross
|
BJ
|
110 167 635
|
-2,6%
|
113 124 934
|
1,6%
|
111 366 583
|
|
Amortisation
|
BK
|
65 692 007
|
7,2%
|
61 290 339
|
12,3%
|
54 589 880
|
Intangilble
fixed assets
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Start-up
cost
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Gross
|
AB
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Amortisation
|
AC
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
R & D
expenses
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Gross
|
CX
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Amortisation
|
AE
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Distributorships,
patents
|
Net
|
69 920
|
0%
|
69 920
|
1298,4%
|
5 000
|
|
Gross
|
AF
|
69 920
|
0%
|
69 920
|
1298,4%
|
5 000
|
|
Amortisation
|
AG
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Goodwill
|
Net
|
15 989 495
|
-14,5%
|
18 691 232
|
2,3%
|
18 268 201
|
|
Gross
|
AH
|
17 209 495
|
-7,9%
|
18 691 232
|
-0,4%
|
18 770 201
|
|
Amortisation
|
AI
|
1 220 000
|
9,3%
|
1 116 000
|
122,3%
|
502 000
|
|
 
|
Other
intangible fixed assets
|
Net
|
1 415 784
|
104,9%
|
691 008
|
39,5%
|
495 316
|
|
Gross
|
AJ
|
2 523 561
|
56,5%
|
1 612 304
|
29,6%
|
1 243 887
|
|
Amortisation
|
AK
|
1 107 777
|
20,2%
|
921 296
|
23,1%
|
748 571
|
|
 
|
Pre-payments
and downpayments
|
Net
|
200
|
-99,9%
|
200 520
|
2075,3%
|
9 218
|
|
Gross
|
AL
|
200
|
-99,9%
|
200 520
|
2075,3%
|
9 218
|
|
Amortisation
|
AM
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Sub Total
Intangible Assets
|
Net
|
17 475 399
|
-11,1%
|
19 652 680
|
4,7%
|
18 777 735
|
Tangilble
fixed assets
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Lands
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Gross
|
AN
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Amortisation
|
AO
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Buildings
|
Net
|
116 844
|
-2,7%
|
120 092
|
13,7%
|
105 651
|
|
Gross
|
AP
|
129 721
|
0%
|
129 721
|
15,8%
|
112 031
|
|
Amortisation
|
AQ
|
12 877
|
33,7%
|
9 629
|
50,9%
|
6 380
|
|
 
|
Plant
|
Net
|
2 445 353
|
-42,1%
|
4 222 607
|
-19,7%
|
5 256 221
|
|
Gross
|
AR
|
20 068 927
|
-2,7%
|
20 628 624
|
3,1%
|
20 008 829
|
|
Amortisation
|
AS
|
17 623 574
|
7,4%
|
16 406 017
|
11,2%
|
14 752 608
|
|
 
|
Other
tangible fixed assets
|
Net
|
17 320 030
|
-19,7%
|
21 577 425
|
-13,6%
|
24 986 037
|
|
Gross
|
AT
|
62 969 809
|
-2,1%
|
64 336 822
|
1,3%
|
63 488 358
|
|
Amortisation
|
AU
|
45 649 779
|
6,8%
|
42 759 397
|
11,1%
|
38 502 321
|
|
 
|
Fixed assets
in construction
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
679 920
|
|
Gross
|
AV
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
679 920
|
|
Amortisation
|
AW
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Advances and
payments on account
|
Net
|
166 266
|
-67,4%
|
509 641
|
0%
|
0
|
|
Gross
|
AX
|
166 266
|
-67,4%
|
509 641
|
0%
|
0
|
|
Amortisation
|
AY
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Sub Total
Tangible asset
|
Net
|
20 048 493
|
|
26 429 765
|
|
31 027 829
|
Financial
assets
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Associates
at equity
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Gross
|
CS
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Amortisation
|
CT
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Other
participations
|
Net
|
385 165
|
0%
|
385 165
|
0%
|
385 165
|
|
Gross
|
CU
|
463 165
|
0%
|
463 165
|
0%
|
463 165
|
|
Amortisation
|
CV
|
78 000
|
0%
|
78 000
|
0%
|
78 000
|
|
 
|
Inter-company
receivables
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Gross
|
BB
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Amortisation
|
BC
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Other
investment securities
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Gross
|
BD
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Amortisation
|
BE
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Loans
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Gross
|
BF
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Amortisation
|
BG
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
 
|
Other
financial assets
|
Net
|
6 566 571
|
1,3%
|
6 482 985
|
-1,6%
|
6 585 974
|
|
Gross
|
BH
|
6 566 571
|
1,3%
|
6 482 985
|
-1,6%
|
6 585 974
|
|
Amortisation
|
BI
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Sub Total
Financial Assets
|
|
6 951 736
|
|
6 868 150
|
|
6 971 139
|
Current Assets (III)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Total Assets
|
Net
|
89 254 790
|
9,2%
|
81 719 544
|
1,2%
|
80 753 923
|
|
Gross
|
CJ
|
90 047 690
|
9,3%
|
82 382 622
|
1,1%
|
81 486 941
|
|
Amortisation
|
CK
|
792 900
|
19,6%
|
663 078
|
-9,5%
|
733 018
|
Stocks
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Raw materials
|
Net
|
137 347
|
-33,1%
|
205 149
|
10,4%
|
185 905
|
|
Gross
|
BL
|
137 347
|
-33,1%
|
205 149
|
10,4%
|
185 905
|
|
Amortisation
|
BM
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Work in progress (goods)
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Gross
|
BN
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Amortisation
|
BO
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Work in progress (services)
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Gross
|
BP
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Amortisation
|
BQ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Semi-finished and finished products
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Gross
|
BR
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Amortisation
|
BS
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Goods for resale
|
Net
|
25 047 228
|
36,3%
|
18 375 025
|
-12,6%
|
21 024 385
|
|
Gross
|
BT
|
25 713 128
|
36,0%
|
18 903 185
|
-12,6%
|
21 634 110
|
|
Amortisation
|
BU
|
665 900
|
26,1%
|
528 160
|
-13,4%
|
609 725
|
|
Sub Total Stocks
|
Net
|
25 184 575
|
35,5%
|
18 580 174
|
-12,4%
|
21 210 290
|
Advance payments to suppliers
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Advance payments to suppliers
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Gross
|
BV
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Amortisation
|
BW
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Debtors
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Trade accounts receivable
|
Net
|
4 104 813
|
26,6%
|
3 241 643
|
42,9%
|
2 269 195
|
|
Gross
|
BX
|
4 231 813
|
25,3%
|
3 376 561
|
41,1%
|
2 392 488
|
|
Amortisation
|
BY
|
127 000
|
-5,9%
|
134 918
|
9,4%
|
123 293
|
|
 
|
Other debtors
|
Net
|
44 192 304
|
7,6%
|
41 073 718
|
5,0%
|
39 114 839
|
|
Gross
|
BZ
|
44 192 304
|
7,6%
|
41 073 718
|
5,0%
|
39 114 839
|
|
Amortisation
|
CA
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Capital subscribed and called up
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Gross
|
CB
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Amortisation
|
CC
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Sub Total Debtors
|
Net
|
48 297 117
|
9,0%
|
44 315 361
|
7,1%
|
41 384 034
|
Divers
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Investment securities
|
Net
|
290 635
|
0%
|
0
|
0%
|
5 715 156
|
|
Gross
|
CD
|
290 635
|
0%
|
0
|
0%
|
5 715 156
|
|
Amortisation
|
CE
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Cash and cash equivalents
|
Net
|
10 614 823
|
-13,6%
|
12 290 332
|
144,6%
|
5 024 873
|
|
Gross
|
CF
|
10 614 823
|
-13,6%
|
12 290 332
|
144,6%
|
5 024 873
|
|
Amortisation
|
CG
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Sub Total Divers
|
Net
|
10 905 458
|
-11,3%
|
12 290 332
|
14,4%
|
10 740 029
|
Prepaid expenses
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Prepaid expenses
|
Net
|
4 867 640
|
-25,5%
|
6 533 677
|
-11,9%
|
7 419 570
|
|
Gross
|
CH
|
4 867 640
|
-25,5%
|
6 533 677
|
-11,9%
|
7 419 570
|
|
Amortisation
|
CI
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Equalization accounts (IV to VI)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Multi-period charges
|
CW3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Gross
|
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Premiums on redemption of bonds
|
CM3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Gross
|
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Currency differential gain
|
CN3
|
67 810
|
-1,4%
|
68 770
|
-67,9%
|
214 487
|
|
Gross
|
|
67 810
|
-1,4%
|
68 770
|
-67,9%
|
214 487
|
References
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Due within one year
|
CP
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Due after one year
|
CR
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
|
|
Accounts - Passive
Other capital resources | Provisions for risks and charges |
Liabilities | Translation loss | Equalization accounts |
References
Grand Total -
Passive Accounts (I to IV)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Grand Total
(I to V)
|
EE
|
133 798 228
|
0,1%
|
133 622 909
|
-3,0%
|
137 745 113
|
Shareholder
Equity (I)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Total
shareholders' equity (Total I)
|
DL
|
27 395 553
|
-14,1%
|
31 892 453
|
-24,6%
|
42 300 351
|
|
Equity and
shareholders' equity
|
DA
|
905 280
|
0%
|
905 280
|
0%
|
905 280
|
|
Issue and
merger premiums
|
DB
|
5 635 452
|
0%
|
5 635 452
|
0%
|
5 635 452
|
|
Revaluation
differentials
|
DC
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Of which equity
differential
|
EK
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Legal
reserve
|
DD
|
90 528
|
0%
|
90 528
|
0%
|
90 528
|
|
Statutory or
contractual reserve
|
DE
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Special
regulated reserves
|
DF
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Of which
special reserve of provisions for current fluctuation
|
B1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Other
reserves
|
DG
|
30 447 632
|
0%
|
30 447 632
|
1,5%
|
30 001 984
|
|
Of which
reserve for buying originals works from alive artists
|
EJ
|
0
|
|
0
|
0%
|
0
|
|
Profits or
losses brought forward
|
DH
|
-5 925 828
|
-11056,1%
|
54 087
|
0%
|
54 087
|
|
Profit or
loss for the period
|
DI
|
-4 430 790
|
25,9%
|
-5 979 916
|
-224,9%
|
4 788 047
|
|
Investment
grants
|
DJ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Special
tax-allowable reserves
|
DK
|
673 279
|
-8,9%
|
739 390
|
-10,4%
|
824 973
|
Other capital resources (II)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Total other capital resources (Total II)
|
DO
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Income from participating securities
|
DM
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Conditional loans
|
DN
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Provisions for risks and charges (III)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Total provisions for risks and charges (Total
III)
|
DR
|
1 809 110
|
65,5%
|
1 093 170
|
69,3%
|
645 627
|
|
Risk provisions
|
DP
|
759 110
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Reserves for charges
|
DQ
|
1 050 000
|
-3,9%
|
1 093 170
|
69,3%
|
645 627
|
Liabilities (IV)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Total Liabilities (Total IV)
|
EC
|
104 593 565
|
3,9%
|
100 637 286
|
6,2%
|
94 799 135
|
|
Convertible debentures
|
DS
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Other debentures
|
DT
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Bank loans and liabilities
|
DU
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Sundry loans and financial liabilities
|
DV
|
72 202 032
|
1,1%
|
71 447 154
|
11,2%
|
64 242 197
|
|
Of which participating loans
|
EI
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Advance payments received for current orders
|
DW
|
298 485
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Trade accounts payables
|
DX
|
20 212 300
|
30,5%
|
15 492 947
|
3,4%
|
14 984 634
|
|
Tax and social security liabilities
|
DY
|
9 698 406
|
-18,9%
|
11 965 860
|
-11,0%
|
13 437 934
|
|
Fixed asset liabilities
|
DZ
|
854 238
|
3,7%
|
823 438
|
-46,4%
|
1 535 733
|
|
Other debts
|
EA
|
525 637
|
427,6%
|
99 633
|
-18,5%
|
122 263
|
Translation loss (V)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Translation loss (Total V)
|
ED
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Equalization accounts
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Deferred income
|
EB
|
802 467
|
-0,7%
|
808 254
|
69,7%
|
476 374
|
References
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Of which tax-allowable reserve
|
EF
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Deferred income and liabilities
|
EG
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Of which current bank facilities
|
EH
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
|
|
Result account
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges |
Financial income | Financial charges | Financial charges |
Extraordinary charges | Employee profit sharing | Tax on
profits | References
1- Operating
result (I-II)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Operating
result (Total I-II)
|
GG
|
-4 022 778
|
29,2%
|
-5 680 051
|
-168,8%
|
8 253 123
|
2 - Financial
result (V - VI)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Financial
result (Total V-VI)
|
GV
|
-132 329
|
-114,3%
|
922 798
|
717,0%
|
-149 567
|
3 - Pre-tax
net operating income result (I - VI)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Pre-tax net
operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)
|
GW
|
-4 155 107
|
12,7%
|
-4 757 253
|
-158,7%
|
8 103 556
|
4 -
Extraordinary result (VII-VIII)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Extraordinary
result (Total VII-VIII)
|
HI
|
-275 683
|
68,9%
|
-887 323
|
-171,6%
|
1 240 043
|
Profit or loss
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Profit or
loss
|
HN
|
-4 430 790
|
25,9%
|
-5 979 916
|
-224,9%
|
4 788 047
|
Total Income
(I+III+V+VII)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Total Income
(I+III+V+VII)
|
HL
|
192 995 021
|
0,1%
|
192 836 083
|
-5,9%
|
204 987 501
|
Total charges
(Total II+IV+VI+VIII+IX+X)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Total
charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)
|
HM
|
197 425 811
|
-0,7%
|
198 815 999
|
-0,7%
|
200 199 454
|
Operating
income (I)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Total operating
income (Total I)
|
FR
|
186 426 637
|
-1,0%
|
188 297 778
|
-4,8%
|
197 740 128
|
Operating
income (details)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Sale of
goods for resale
|
FC
|
180 655 459
|
-2,5%
|
185 316 222
|
-5,1%
|
195 230 212
|
|
France
|
FA
|
180 655 459
|
-2,5%
|
185 316 222
|
-5,1%
|
195 230 212
|
|
Export
|
FB
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Sale of
goods produced
|
FF
|
1 105 514
|
85,9%
|
594 840
|
-45,9%
|
1 099 479
|
|
France
|
FD
|
1 105 514
|
85,9%
|
594 840
|
-45,9%
|
1 099 479
|
|
Export
|
FE
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Sale of
services
|
FI
|
485 749
|
139,1%
|
203 175
|
-46,5%
|
379 664
|
|
France
|
FG
|
485 749
|
139,1%
|
203 175
|
-46,5%
|
379 664
|
|
Export
|
FH
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Net turnover
|
FL
|
182 246 722
|
-2,1%
|
186 114 237
|
-5,4%
|
196 709 355
|
|
France
|
FJ
|
182 246 722
|
-2,1%
|
186 114 237
|
-5,4%
|
196 709 355
|
|
Export
|
FK
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Stocked
production
|
FM
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Self-constructed
assets
|
FN
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Operating
grants
|
FO
|
0
|
0%
|
818 059
|
0%
|
0
|
|
Release of
reserves and provisions
|
FP
|
1 177 620
|
857,4%
|
123 008
|
-84,7%
|
803 362
|
|
Other income
|
FQ
|
3 002 295
|
141,6%
|
1 242 474
|
446,4%
|
227 411
|
Operating
charges (II)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Total
operating charges (Total II)
|
GF
|
190 449 415
|
-1,8%
|
193 977 829
|
2,4%
|
189 487 005
|
Exploitation
charges
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Purchase of
goods for resale
|
FS
|
86 586 767
|
6,9%
|
80 970 325
|
-5,4%
|
85 627 414
|
|
Change in
stocks of goods for resale
|
FT
|
-6 809 942
|
-349,4%
|
2 730 926
|
150,0%
|
-5 458 087
|
|
Purchase of
raw materials
|
FU
|
444 028
|
-33,3%
|
665 543
|
8,4%
|
613 823
|
|
Change in
stocks of raw materials
|
FV
|
67 801
|
452,3%
|
-19 244
|
-362,6%
|
7 328
|
|
Other
external purchases and charges
|
FW
|
50 780 013
|
-0,3%
|
50 946 671
|
4,0%
|
48 990 112
|
|
Tax, duty
and similar payments
|
FX
|
5 195 105
|
-8,6%
|
5 681 804
|
8,7%
|
5 227 092
|
|
Payroll
|
FY
|
33 230 734
|
2,2%
|
32 506 982
|
-3,8%
|
33 808 445
|
|
Social
security costs
|
FZ
|
10 436 807
|
3,9%
|
10 040 912
|
-8,8%
|
11 009 029
|
Depreciation
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Depreciation
of fixed assets
|
GA
|
7 322 430
|
-10,7%
|
8 197 497
|
-3,6%
|
8 504 837
|
|
Amortisation
of fixed assets
|
GB
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Depreciation/amortisation
of current assets
|
GC
|
792 900
|
19,6%
|
663 078
|
-9,5%
|
733 018
|
|
Provisions
for risks and charges
|
GD
|
100 600
|
-72,7%
|
368 300
|
202,8%
|
121 640
|
Other charges
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Other
charges
|
GE
|
2 302 172
|
87,9%
|
1 225 035
|
305,2%
|
302 354
|
Operating
charges (III-IV)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Share of
joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)
|
GH
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Share of joint
venture transferred from other partner(s) (Total IV)
|
GI
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Financial
income (V)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Total
financial income (Total V)
|
GP
|
2 651 294
|
-31,7%
|
3 880 044
|
42,8%
|
2 717 234
|
|
Share financial
income
|
GJ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Other
investment income & capitalised receivables
|
GK
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Other
interest and similar income
|
GL
|
1 856 350
|
-27,0%
|
2 542 706
|
2,2%
|
2 488 626
|
|
Released
provisions and transferred charges
|
GM
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Exchange
gains
|
GN
|
794 944
|
-40,6%
|
1 337 338
|
485,0%
|
228 608
|
|
Net income
from disposal of investment securities
|
GO
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Financial Charge
(VI)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Total
financial charge (Total VI)
|
GU
|
2 783 623
|
-5,9%
|
2 957 246
|
3,2%
|
2 866 801
|
|
Financial
reserves and provisions
|
GQ
|
67 810
|
-1,4%
|
68 770
|
-67,9%
|
214 487
|
|
Interest and
similar charges
|
GR
|
2 079 112
|
-20,2%
|
2 606 531
|
2,8%
|
2 535 833
|
|
Exchange
losses
|
GS
|
636 701
|
125,8%
|
281 945
|
142,1%
|
116 481
|
|
Net loss
from disposal of investment securities
|
GT
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Extraordinary
income (VII)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Total
extraordinary income (Total VII)
|
HD
|
3 917 090
|
495,1%
|
658 261
|
-85,5%
|
4 530 139
|
|
Extraordinary
operating income
|
HA
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Extraordinary
income from capital transactions
|
HB
|
3 145 000
|
471,8%
|
550 000
|
-87,1%
|
4 249 118
|
|
Released
provisions and transferred charges
|
HC
|
772 090
|
613,2%
|
108 261
|
-61,5%
|
281 021
|
Extraordinary
charges (VIII)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Total
extraordinary charges (Total VIII)
|
HH
|
4 192 773
|
171,3%
|
1 545 584
|
-53,0%
|
3 290 096
|
|
Extraordinary
operating charges
|
HE
|
87 515
|
270,4%
|
23 624
|
-61,6%
|
61 454
|
|
Extraordinary
charges from capital transactions
|
HF
|
1 481 737
|
171,8%
|
545 080
|
-82,0%
|
3 033 415
|
|
Extraordinary
reserves and provisions
|
HG
|
2 623 521
|
168,6%
|
976 880
|
400,4%
|
195 227
|
Employee
profit sharing (IX)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Employee
profit sharing (Total IX)
|
HJ
|
0
|
0%
|
66 296
|
-94,6%
|
1 229 197
|
Tax on profits
(X)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Tax on
profits (Total X)
|
HK
|
0
|
0%
|
269 044
|
-91,9%
|
3 326 355
|
References
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Of which
equipment leases
|
HP
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Of which
property leases
|
HQ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Of which
transferred charges
|
A1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Of which
trader's own contributions
|
A2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Of which royalties
on licences and patents (income)
|
A3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Of which
royalties on licences and patents (charges)
|
A4
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
|
|
Other incomes tax return forms
Reserve for depreciation | Provisions included in balance sheet |
State deadlines claims and debts at the end of period
Table allocation results and other information
Fixed Assets
Grand Total Fixed Assets (I to IV)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Gross value
at begin of period
|
OG
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Increasess
due to revaluation
|
OH
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Decreasess,
acquisitions, creations, contributions
|
OJ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Decreasess
by budget item transfer
|
OK1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Decreasess
by transfers
|
OK2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
8 932 399
|
|
Gross value at
the end of period
|
OL
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
111 366 586
|
Research and
development Charge (Total I)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Gross value
at begin of period
|
CZ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Increasess
due to revaluation
|
KB
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Increasess,
acquisitions, creations, contributions
|
KC
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Decreasess
by budget item transfer
|
C01
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Decreasess
by transfers
|
C02
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Gross value
at the end of period
|
D0
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Other budget
item from Intangible fixed assets (Total II)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Gross value
at begin of period
|
KD
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
21 545 872
|
|
Increasess
due to revaluation
|
KE
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Increasess,
acquisitions, creations, contributions
|
KF
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
201 261
|
|
Decreasess
by budget item transfer
|
LV1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Decreasess
by transfers
|
LV2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
1 718 825
|
|
Gross value
at the end of period
|
LW
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
20 028 308
|
Tangible fixed
assets (Total III)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Gross value
at begin of period
|
LN
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
85 303 078
|
|
Increasess
due to revaluation
|
LO
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Increasess, acquisitions,
creations, contributions
|
LP
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
5 775 282
|
|
Decreasess
by budget item transfer
|
NG1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Decreasess
by transfers
|
NG2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
6 789 221
|
|
Gross value
at the end of period
|
NH
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
84 289 139
|
Fiancial
assets (Total IV)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Gross value
at begin of period
|
LQ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
7 339 880
|
|
Increasess
due to revaluation
|
LR
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Increasess,
acquisitions, creations, contributions
|
LS
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
133 613
|
|
Decreasess
by budget item transfer
|
NJ1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Decreasess
by transfers
|
NJ2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
424 354
|
|
Gross value
at the end of period
|
NK
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
7 049 139
|
Reserve for
depreciation
Situation and movement of reserve for depreciation
Grand total (I-II-III)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Reserve for depreciation value at
begin of period
|
0N
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Increases
|
0P
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Decreasess
|
0Q
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Reserve for depreciation value at the
end of period
|
0R
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Research and development charge (Total I)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Reserve for depreciation value at
begin of period
|
CY
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Increases
|
PB
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Decreasess
|
PC
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Decreasess by budget item transfer
|
PD
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Other intangible assets (Total II)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Reserve for depreciation value at
begin of period
|
PE
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
1 055 629
|
|
Increases
|
PF
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
269 066
|
|
Decreasess
|
PG
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
74 124
|
|
Decreasess by budget item transfer
|
PH
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
1 250 571
|
Total fixed assets amotisation (Total III)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Reserve for depreciation value at
begin of period
|
QU
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
48 956 172
|
|
Increases
|
QV
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
8 347 772
|
|
Decreases
|
QW
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
4 043 537
|
|
Decreasess by budget item transfer
|
QX
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
53 260 407
|
Movements during period affecting charge allocated over several period
Charges à répartir ou frais d'émission
d'emprunt
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Gross value at begin of period
|
Z91
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Increases
|
Z92
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Depreciation of fixed assets during
period
|
Z9
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Decreasess by budget item transfer
|
B1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Premium refund of obligations
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Net value at begining of period
|
SP1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Increases
|
SP2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Depreciation of fixed assets during
period
|
SP
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Net value at the end of period
|
SR
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Value at begining of period
|
7C
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
992 748
|
|
Increases
|
UB
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
1 084 145
|
|
Decreases
|
UC
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
620 248
|
|
Value at the end of period
|
UD
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
1 456 645
|
Includes Total allocations
|
Operating
|
UE
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Financial
|
UG
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Exceptional
|
UJ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Includes Total Withdrawal
|
Operating
|
UF
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Financial
|
UH
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Exceptional
|
UK
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Total regulated provisions (Total I)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Value at begining of period
|
3Z
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Increases
|
TS
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Decreases
|
TT
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Value at the end of period
|
TU
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Total risk and charge provisions (Total II)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Value at begining of period
|
5Z
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
605 250
|
|
Increases
|
TV
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
351 127
|
|
Decreases
|
TW
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
310 750
|
|
Value at the end of period
|
TX
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
645 627
|
Total Provision for depreciation (Total III)
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Value at begining of period
|
7B
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
387 498
|
|
Increases
|
TY
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
733 018
|
|
Decreases
|
TZ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
309 498
|
|
Value at the end of period
|
UA
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
811 018
|
State
deadlines claims and debts at the end of period
State claims
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Gross value
|
VT
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
VU
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than one year
|
VV
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
State of loans
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Claims related to holdings (gross)
|
UL
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Claims related to shareholdings (1 year at
most)
|
UM
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Loans (gross)
|
UP
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Loans (1 year at most)
|
UR
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Other financial assets (gross)
|
UT
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Other financial assets (1 year at most)
|
UV
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Receivables statement of assets
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Customers doubtful or disputed
|
VA
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Other claims customer
|
UX
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Receivables represent Loaned Securities
|
UU
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Provision for depreciation previously
established
|
UQ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Personnel and associated accounts
|
UY
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Social Security and other social
organizations
|
UZ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Income taxes
|
VM
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Value added tax
|
VB
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Other taxes and payments assimilated
|
VN
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
State and other public - Miscellaneous
|
VP
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Group and Associates
|
VC
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Accounts receivable (including claims
relating to the operation of pension titles)
|
VR
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Prepaid
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Prepaid
|
VS
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
State Debt
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Total debt (gross)
|
VY
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
VZ2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
VZ3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 5 years
|
VZ4
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Details
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
 
|
Convertible bonds (gross)
|
7Y1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
7Y2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
7Y3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Other bonds (gross)
|
7Z1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
7Z2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
7Z3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Borrowing & debts to 1 year maximum at
the origin (gross)
|
VG1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
VG2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
VG3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Borrowing & debts to more than 1 year at
the origin (gross)
|
VH1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
VH2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
VH3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Loans and various financial liabilities
(gross)
|
8A1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
8A2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
8A3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Suppliers and associated accounts (gross)
|
8B1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
8B2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
8B3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Personnel and associated accounts (gross)
|
8C1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
8C2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
8C3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Social Security and other social
organizations (gross)
|
8D1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
8D2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
8D3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Taxes on profits (gross)
|
8E1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
8E2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
8E3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
VAT (gross)
|
VW1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
VW2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
VW3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Backed Obligations (gross)
|
VX1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
VX2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
VX3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Other taxes and assimilated (gross)
|
VQ1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
VQ2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
VQ3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Assets and liabilities associated accounts
(gross)
|
8J1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
8J2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
8J3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 5 years
|
8J4
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Groups and associates (gross)
|
VI1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
VI2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
VI3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More 5 years
|
VI4
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Other liabilities (gross)
|
8K1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
8K2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
8K3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Debt representative of borrowed securities
(gross)
|
SZ1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
SZ2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
SZ3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Products in advance (gross)
|
8L1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
8L2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
8L3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
References
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Loans made during the period
|
VJ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Debt repaid during the period
|
VK
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Table
allocation results and other information
Dividends distributed
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Dividends
|
ZE
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Commitments
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Commitments leasing furniture
|
YQ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Commitments Real Estate Leasing
|
YR
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Effects brought to the discount and
unmatured
|
YS
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Other charges Externes
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Subcontracting
|
YT
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Rentals, rental charges and
condominiums
|
XQ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Staff outside the company
|
YU
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Remuneration intermediaries and fees
(excluding fees)
|
SS
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Fees, commissions and brokerage
|
YV
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Other accounts
|
ST
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Total Other purchases and external
|
ZJ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Taxes and Fees
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Business tax
|
YW
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Other taxes and payments assimilated
|
9Z
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Total taxes and fees
|
YX
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
VAT
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Amount VAT collected
|
YY
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Total VAT on goods and services
|
YZ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Average number of employees
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Average number of employees
|
YP
|
0
|
0%
|
2 020
|
-3,3%
|
2 088
|
Groups and Shareholders
|
|
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
|
Groups and Shareholders
|
ZR
|
0
|
-
|
0
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Ratios
Structure and liquidity | Management or rotation | Profitability
of the business | Return on capital
Structure and Liquidity
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
Sector Median 2013
|
|
|
Fixed Asset Financing
|

|
1,52
|
4,1%
|
1,46
|
0,7%
|
1,45
|
1,28
|
18,8%
|
|
Global Debt
|

|
207 days
|
6,2%
|
195 days
|
12,7%
|
173 days
|
171 days
|
21,1%
|
|
Working Capital Fund overall net
|

|
112 days
|
9,8%
|
102 days
|
10,9%
|
92 days
|
48 days
|
133,3%
|
|
Financial independence
|

|
%
|
-
|
%
|
-
|
%
|
117,06%
|
-
|
|
More ratios
|
|
Solvability
|

|
20,48%
|
-14,2%
|
23,87%
|
-22,3%
|
30,71%
|
29,54%
|
-30,7%
|
|
Capacity debt futures
|

|
%
|
-
|
%
|
-
|
%
|
451,02%
|
-
|
|
Coverage of current assets by net working
capital overall
|

|
66,61%
|
-4,0%
|
69,35%
|
9,7%
|
63,19%
|
35,95%
|
85,3%
|
|
General Liquidity
|

|
|
-
|
|
-
|
|
0,09
|
-
|
|
Restricted Liquidity
|

|
|
-
|
|
-
|
|
0,34
|
-
|
Management or rotation
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
Sector Median 2013
|
|
|
Need background in operating working capital
|

|
83 days
|
23,9%
|
67 days
|
11,7%
|
60 days
|
8 days
|
937,5%
|
|
Treasury
|

|
22 days
|
-8,3%
|
24 days
|
20,0%
|
20 days
|
4 days
|
450,0%
|
|
Inventory turnover of goods
|

|
116 days
|
43,2%
|
81 days
|
-16,5%
|
97 days
|
158 days
|
-26,6%
|
|
Average length of credit granted to customers
|

|
8 days
|
14,3%
|
7 days
|
75,0%
|
4 days
|
0 days
|
0%
|
|
Average length of credit obtained suppliers
|

|
56 days
|
36,6%
|
41 days
|
-2,4%
|
42 days
|
53 days
|
5,7%
|
|
 More
ratios
|
|
Inventory turnover of raw materials in
industrial enterprises
|

|
111 days
|
0%
|
111 days
|
1,8%
|
109 days
|
0 days
|
0%
|
|
Inventory turnover of intermediate and
finished products in the industrial enterprise
|

|
days
|
-
|
days
|
-
|
233 days
|
403,50 days
|
-
|
|
Rotation tangible assets
|

|
%
|
-
|
%
|
-
|
233,37%
|
484,04%
|
-
|
Profitability of the business
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
Sector Median 2013
|
|
|
Margin trading
|

|
55,35%
|
1,4%
|
54,60%
|
-6,7%
|
58,49
|
41,86%
|
32,2%
|
|
Profitability of the business
|

|
1,27
|
-30,6%
|
1,83
|
-78,7%
|
8,58
|
4,83%
|
-73,7%
|
|
Net profit
|

|
-2,43%
|
24,3%
|
-3,21%
|
-232,1%
|
2,43%
|
1,79%
|
-235,8%
|
|
 More ratios
|
|
Growth rate of turnover (excluding VAT)
|

|
-2,08%
|
61,4%
|
-5,39%
|
-182,8%
|
6,51%
|
-2%
|
-4,0%
|
|
Rates integration
|

|
28,08%
|
2,8%
|
27,31%
|
-19,7%
|
34,02%
|
25,32%
|
10,9%
|
|
Rate leasing furniture
|

|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
Work Factor
|

|
85,32%
|
1,9%
|
83,72%
|
25,0%
|
66,96%
|
73,03%
|
16,8%
|
|
Weight interests
|

|
1,53
|
-3,8%
|
1,59%
|
8,9%
|
1,46%
|
0,64%
|
139,1%
|
Return on capital
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
Sector Median 2013
|
|
|
Cash flow from the overall profitability
|

|
2,15%
|
22,9%
|
1,75%
|
-72,4%
|
6,35%
|
4,24%
|
-49,3%
|
|
Rates of economic profitability
|

|
2%
|
-33,3%
|
3%
|
-81,2%
|
16%
|
10%
|
-80,0%
|
|
Financial profitability
|

|
27395553%
|
-14,1%
|
31892453%
|
-24,6%
|
42300351%
|
20661%
|
132495,5%
|
|
Return on investment
|

|
-1,65%
|
43,5%
|
-2,92%
|
-140,7%
|
7,18%
|
6,03%
|
-127,4%
|
|
|
|
|
Soldes Intermédiaires
de Gestion
|
31/03/2013
|
|
31/03/2012
|
|
31/03/2011
|
Sector
Median 2013
|
|
|
Turnover
|
182 246 722
|
-2,1%
|
186 114 237
|
-5,4%
|
196 709 355
|
273 021
€
|
66651,9%
|
|
Sales of
goods
|
180 655 459
|
-2,5%
|
185 316 222
|
-5,1%
|
195 230 212
|
|
|
|
- Purchase
of goods
|
86 586 767
|
6,9%
|
80 970 325
|
-5,4%
|
85 627 414
|
|
|
|
+/- Stock of
goods variation
|
-6 809 942
|
-349,4%
|
2 730 926
|
150,0%
|
-5 458 087
|
|
|
|
Trading margin
|
100 878 634
€
|
-0,7%
|
101 614 971
€
|
-11,7%
|
115 060 885
€
|
111 238
€
|
90587,2%
|
|
55,35 % CA
|
1,4%
|
54,60 % CA
|
-6,7%
|
58,49 % CA
|
42,14 %
CA
|
31,3%
|
|
Sale of
goods produced
|
1 591 263
|
99,4%
|
798 015
|
-46,0%
|
1 479 143
|
|
|
|
+/- Stocked
production
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
|
+
Self-constructed assets
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
|
Period
production
|
1 591 263
€
|
99,4%
|
798 015
€
|
-46,0%
|
1 479 143
€
|
0 €
|
0%
|
|
0,87 % CA
|
102,3%
|
0,43 % CA
|
-42,7%
|
0,75 % CA
|
0 % CA
|
0%
|
|
Trading
margin
|
100 878 634
|
-0,7%
|
101 614 971
|
-11,7%
|
115 060 885
|
111 238
|
90587,2%
|
|
+ Period
Production
|
1 591 263
|
99,4%
|
798 015
|
-46,0%
|
1 479 143
|
0
|
0%
|
|
- Purchase
of raw materials
|
444 028
|
-33,3%
|
665 543
|
8,4%
|
613 823
|
|
|
|
+/- Change
in stocks of raw materiels
|
67 801
|
452,3%
|
-19 244
|
-362,6%
|
7 328
|
|
|
|
- Other external
purchases and charges
|
50 780 013
|
-0,3%
|
50 946 671
|
4,0%
|
48 990 112
|
|
|
|
Added value
|
51 178 055
€
|
0,7%
|
50 820 016
€
|
-24,1%
|
66 928 765
€
|
73 583
€
|
69451,5%
|
|
28,08 % CA
|
2,8%
|
27,31 % CA
|
-19,7%
|
34,02 % CA
|
25,32 %
CA
|
10,9%
|
|
Added value
|
51 178 055
€
|
0,7%
|
50 820 016
€
|
-24,1%
|
66 928 765
€
|
73 583
€
|
69451,5%
|
|
+ Operating
grants
|
0
|
0%
|
818 059
|
0%
|
0
|
|
|
|
- Tax, duty
and similar payments
|
5 195 105
|
-8,6%
|
5 681 804
|
8,7%
|
5 227 092
|
|
|
|
- Personal
charges
|
43 667 541
|
2,6%
|
42 547 894
|
-5,1%
|
44 817 474
|
|
|
|
Gross
operating surplus
|
2 315 409
€
|
-32,1%
|
3 408 377
€
|
-79,8%
|
16 884 199
€
|
12 098
€
|
19038,8%
|
|
1,27 % CA
|
-30,6%
|
1,83 % CA
|
-78,7%
|
8,58 % CA
|
4,83 %
CA
|
-73,7%
|
|
Gross
operating surplus
|
2 315 409
€
|
-32,1%
|
3 408 377
€
|
-79,8%
|
16 884 199
€
|
12 098
€
|
19038,8%
|
|
+ Release of
reserves and provisions
|
1 177 620
|
857,4%
|
123 008
|
-84,7%
|
803 362
|
|
|
|
+ Other
operating income
|
3 002 295
|
141,6%
|
1 242 474
|
446,4%
|
227 411
|
|
|
|
-
Depreciation/Amortisation
|
8 215 930
|
-11,0%
|
9 228 875
|
-1,4%
|
9 359 495
|
|
|
|
- Other
charges
|
2 302 172
|
87,9%
|
1 225 035
|
305,2%
|
302 354
|
|
|
|
Operating
result
|
-4 022 778
€
|
29,2%
|
-5 680 051
€
|
-168,8%
|
8 253 123
€
|
6 749
€
|
-59705,5%
|
|
-2,21 % CA
|
27,5%
|
-3,05 % CA
|
-172,6%
|
4,20 % CA
|
2,63 %
CA
|
-184,0%
|
|
Operating
result
|
-4 022 778
€
|
29,2%
|
-5 680 051
€
|
-168,8%
|
8 253 123
€
|
6 749
€
|
-59705,5%
|
|
+/- Result
of joint-venture transferred from/to other partners
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
|
+ Financial
income
|
2 651 294
|
-31,7%
|
3 880 044
|
42,8%
|
2 717 234
|
|
|
|
- Financial
charges
|
2 783 623
|
-5,9%
|
2 957 246
|
3,2%
|
2 866 801
|
|
|
|
Pre-tax
result
|
-4 155 107
€
|
12,7%
|
-4 757 253
€
|
-158,7%
|
8 103 556
€
|
4 696
€
|
-88581,8%
|
|
-2,28 % CA
|
10,9%
|
-2,56 % CA
|
-162,1%
|
4,12 % CA
|
1,88 %
CA
|
-221,3%
|
|
Extraordinary
income
|
3 917 090
|
495,1%
|
658 261
|
-85,5%
|
4 530 139
|
0
|
0%
|
|
-
Extraordinary charges
|
4 192 773
|
171,3%
|
1 545 584
|
-53,0%
|
3 290 096
|
|
|
|
Extraordinary
result
|
-275 683
€
|
68,9%
|
-887 323
€
|
-171,6%
|
1 240 043
€
|
0 €
|
0%
|
|
-0,15 % CA
|
68,8%
|
-0,48 % CA
|
-176,2%
|
1 % CA
|
0 % CA
|
0%
|
|
Pre-tax
result
|
-4 155 107
€
|
12,7%
|
-4 757 253
€
|
-158,7%
|
8 103 556
€
|
4 696
€
|
-88581,8%
|
|
Extraordinary
result
|
-275 683
€
|
68,9%
|
-887 323
€
|
-171,6%
|
1 240 043
€
|
0 €
|
0%
|
|
- Employee
profit sharing
|
0
|
0%
|
66 296
|
-94,6%
|
1 229 197
|
|
|
|
- Tax on
profits
|
0
|
0%
|
269 044
|
-91,9%
|
3 326 355
|
|
|
|
Net result
|
-4 430 790
€
|
25,9%
|
-5 979 916
€
|
-224,9%
|
4 788 047
€
|
4 685
€
|
-94674,0%
|
|

|
-2,43 % CA
|
24,3%
|
-3,21 % CA
|
-232,1%
|
2,43 % CA
|
1,79 %
CA
|
-235,8%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Publication date
|
Gazette Name
|
Description
|
|
|
27/12/2013
|
Bodacc B
|
Modification et mutation diverse
|
|
|
|
94 -
VAL-DE-MARNE
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
2344 - 722
033 115 RCS Créteil. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Commissaire
aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Octobre 2007
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
modification le 31 Octobre 2007 Président : RUF Bernhard en fonction le
18 Décembre 2013. Activité : .
Commentaires : Modification
de représentant.
|
|
17/12/2013
|
JAL
|
Appointment
of the social representative
|
|
|
|
Parisien
(Le) /Edition du Val de Marne
Date de décision : 05/12/2013
Société faisant l'objet d'une
nomination : 722033115 - MIM, MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI
SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Nominé : Monsieur
Bernhard RUF, W142 AD LONDRES
En la fonction de : Président
|
|
17/12/2013
|
JAL
|
Resignation
/ Revocation of the social representative
|
|
|
|
Parisien
(Le) /Edition du Val de Marne
Date de décision : 05/12/2013
La société 722033115 -
MIM, MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Fait l'objet du départ de Monsieur
Xavier WILMES, 11 Allée des Châtillons, 91760, ITTEVILLE
|
|
25/11/2013
|
Bodacc C
|
Comptes
annuels et rapports
|
|
|
|
94 -
VAL-DE-MARNE
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
12229 -
722033115 RCS. M I M. Forme
: Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers Zone Industrielle Sénia
- Bp 20145 94321 Thiais Cedex. Commentaires
: Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le :
31/03/2013.
|
|
02/01/2013
|
Bodacc C
|
Comptes
annuels et rapports
|
|
|
|
94 -
VAL-DE-MARNE
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
14898 -
722033115 RCS. M I M. Forme
: Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers Zone Industrielle Sénia
- Bp 20145 94321 Thiais Cedex. Commentaires
: Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le :
31/03/2012.
|
|
17/10/2012
|
Bodacc B
|
Modification
et mutation diverse
|
|
|
|
94 -
VAL-DE-MARNE
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
2722 - 722
033 115 RCS Créteil. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Commissaire
aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Octobre 2007
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
modification le 31 Octobre 2007 Président : WILMES Xavier en fonction
le 09 Octobre 2012. Activité :
.
Commentaires : Modification
de représentant.
|
|
11/10/2012
|
JAL
|
Appointment
of the social representative
|
|
|
|
Parisien
(Le) /Edition du Val de Marne
Date de décision : 14/09/2012
Société faisant l'objet d'une
nomination : 722033115 - MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI
SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Nominé : Monsieur
Xavier WILMES, 91760 ITTEVILLE
En la fonction de : Président
|
|
11/10/2012
|
JAL
|
Resignation
/ Revocation of the social representative
|
|
|
|
Parisien
(Le) /Edition du Val de Marne
Date de décision : 14/09/2012
La société 722033115 -
MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Fait l'objet du départ de Monsieur
Nigel DARWIN
|
|
20/03/2012
|
Bodacc A
|
Vente et cession
: Vendeur
|
|
|
|
02 - AISNE
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
68 - 380
622 332 RCS Saint-Quentin. ARMAND THIERY SAS. Forme : Société par actions
simplifiée. Sigle : AT
SAS. Capital : 25140540
EUR. Adresse : 2 bis rue
de Villiers, 92309 Levallois-Perret.
Origine du fonds : Achat
au prix stipulé de 150000,00 euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : Vente de prêt à
porter féminin et accessoires s'y rapportant. Adresse : 7/9 rue des Toiles, 2100 Saint-Quentin.
Précédent propriétaire : MIM.
722 033 115 RCS Créteil.
Date de commencement de
l’activité : 01/02/2012. Publication
légale : Picardie La Gazette du 13/03/2012. Oppositions
: SCP Dubois - Huissiers de Justice 3 bis boulevard Richelieu
02100 Saint-Quentin pour la validité, SCP Hb et associes - Me Gilles
Hittinger-roux - Avocat 55 avenue Kléber 75116 Paris pour la
correspondance . Commentaires
: Achat d'un fonds par une personne morale (insertion
provisoire).
|
|
13/03/2012
|
JAL
|
Activity
or goodwill cession
|
|
|
|
Picardie
La Gazette
Date de décision : 01/02/2012
Cédant : 722033115 -
MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 380622332
- ARMAND THIERY SAS, 2 B RUE VILLIERS, 92300 LEVALLOIS PERRET
Prix de vente : 150000
€
Date d’effet : 01/02/2012
|
|
28/02/2012
|
Bodacc B
|
Modification
et mutation diverse
|
|
|
|
94 -
VAL-DE-MARNE
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
2387 - 722
033 115 RCS Créteil. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Commissaire
aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Octobre 2007
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
modification le 31 Octobre 2007 Président : DARWIN Nigel en fonction le
20 Février 2012. Activité : .
Commentaires : Modification
de représentant.
|
|
18/02/2012
|
JAL
|
Appointment
of the social representative
|
|
|
|
Parisien
(Le) /Edition du Val de Marne
Date de décision : 30/01/2012
Société faisant l'objet d'une
nomination : 722033115 - MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI
SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Nominé : Monsieur Nigel
DARWIN, 0X110ND OXFORDSHIRE
En la fonction de : Président
|
|
18/02/2012
|
JAL
|
Resignation
/ Revocation of the social representative
|
|
|
|
Parisien
(Le) /Edition du Val de Marne
Date de décision : 30/01/2012
La société 722033115 -
MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Fait l'objet du départ de Monsieur
William KERNAN
|
|
30/01/2012
|
Bodacc C
|
Comptes
annuels et rapports
|
|
|
|
94 -
VAL-DE-MARNE
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
14083 -
722033115 RCS. M I M. Forme
: Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers Zone Industrielle Sénia
- Bp 20145 94321 Thiais Cedex. Commentaires
: Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le :
31/03/2011.
|
|
31/03/2011
|
Bodacc A
|
Vente et
cession : Vendeur
|
|
|
|
77 - SEINE-ET-MARNE
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
1772 - 487
493 199 RCS Meaux. NEW LOOK FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des
Oliviers, Z.I. Senia, BP 20145 94321 Thiais Cedex.
Origine du fonds : Etablissement
secondaire acquis par achat au prix stipulé de 94.459,00 EUR. Etablissement : Etablissement
secondaire. Activité : Vente
de prêt à porter féminin et accessoires. Enseigne : NEW LOOK. Adresse : 38 Mail Est Boutique b82, Centre Commercial
Bay 2, 77090 Collégien.
Précédent propriétaire : MIM.
722 033 115 RCS Meaux.
A dater du : 14/03/2011.
Date de commencement de
l’activité : 23/02/2011. Publication
légale : LE PARISIEN du
15/03/2011. Oppositions : en
l'étude SCP ROCHET BANCAUD 15b av Foch 77503 CHELLES et pour la
correspondance chez Me Gilles HITTINGER ROUX 55 ave Kléber 75116 PARIS.
Descriptif : Achat ou
apport à la sté MIM rcs CRETEIL 722033115. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou
complémentaire par une personne morale. Date d’effet : 23/02/2011.
|
|
15/03/2011
|
JAL
|
Activity
or goodwill cession
|
|
|
|
Parisien
(Le) /Edition de Seine et Marne Sud
Date de décision : 17/02/2011
Cédant : 722033115 -
MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 487493199
- NEW LOOK FRANCE, 18 RUE DES OLIVIERS, ZI SENIA 18 A 24, BP 20145,
94320 THIAIS
Prix de vente : 94459 €
Date d’effet : 19/02/2011
|
|
18/01/2011
|
Bodacc C
|
Comptes
annuels et rapports
|
|
|
|
94 -
VAL-DE-MARNE
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CRÉTEIL
12245 -
722033115 RCS. M I M. Forme
: Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers Zone Industrielle Sénia
- Bp 20145 94321 Thiais Cedex. Commentaires
: Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le :
31/03/2010.
|
|
11/01/2011
|
Bodacc A
|
Vente et
cession : Vendeur
|
|
|
|
33 -
GIRONDE
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
541 - Réctificatif.
Parution avis précédent : BODACC
A. Numéro de parution : .
Date de parution : 26 décembre 2010.
Numéro d’annonce : 760.
Cet avis est annulé et remplacé par le suivant.
487 493 199 RCS Bordeaux. NEW LOOK FRANCE. Forme : Société par actions
simplifiée. Adresse : 18-24
rue des Oliviers, Zone Industrielle Sénia - Bp 20145, 94321 Thiais
Cedex.
Origine du fonds : Achat
d'un fonds de commerce au prix stipulé de 392640 Euros. Etablissement : Etablissemennt
complémentaire. Activité : vente
de prêt à porter hommes femmes enfants et accessoires. Adresse : centre Commercial
Bègles, Zac Bègles Tartifume, 33130 Begles.
Précédent propriétaire : MIM.
722 033 115 RCS Créteil.
Date de commencement de
l’activité : 03/11/2010. Publication
légale : Le Courrier Français du 12/11/2010. Oppositions
: Au Mandataire SCP LENOIR 33 rue de ruat 33000 BORDEAUX pour la
validité et pour la correspondance Maître Hittinger Roux SCP HB et
Associés 55 avenue Kleber 75116 Paris. Descriptif : Etablissement secondaire/complémentaire
acquis par achat. Commentaires
: Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une
personne morale.
|
|
26/12/2010
|
Bodacc A
|
Vente et
cession : Vendeur
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
979 - 487
493 199 RCS Valenciennes. NEW LOOK FRANCE. Forme : Société par actions
simplifiée. Adresse : 18-24
rue des Oliviers, Z.I. Senia, BP 20145 94321 Thiais.
Origine du fonds : Etablissement
secondaire acquis par achat au prix stipulé de 227.931,00 EUR. Etablissement : Etablissement
secondaire. Activité : Vente
de prêt à porter hommes, femmes, enfants et accessoires. Enseigne : NEW LOOK. Adresse : C.C. place d'Armes,
59300 Valenciennes.
Précédent propriétaire : M
I M. 722 033 115 RCS Valenciennes.
A dater du : 03/12/2010.
Date de commencement de
l’activité : 06/11/2010. Publication
légale : SYNDICAT AGRICOLE du 26/11/2010. Oppositions
: Etude SCP DARRAS, HOUDAIN, GENON, 6 rue de la Poterne BP 13
59301 VALENCIENNES. Descriptif
: Achat ou apport. Commentaires
: Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une
personne morale. Date d’effet
: 06/11/2010.
|
|
23/12/2010
|
Bodacc A
|
Vente et
cession : Vendeur
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
240 - 487
493 199 RCS Lille. NEW LOOK FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers,
Z.I. Sénia - BP 20145, 94321 Thiais Cedex.
Origine du fonds : Etablissement
secondaire acquis par achat au prix stipulé de 387.812,00 EUR. Etablissement : Etablissement
secondaire. Activité : Vente
de prêt à porter féminin et accessoires. Enseigne : NEW LOOK. Adresse : Centre Commercial Régional, Villeneuve 2,
59658 Villeneuve-d'Ascq.
Précédent propriétaire : MIM.
722 033 115 RCS Lille.
Précédent exploitant : MIM.
722 033 115 RCS Lille.
A dater du : 06/07/2007.
Date de commencement de
l’activité : 26/06/2007. Publication
légale : Le Syndicat agricole du 03/12/2010. Oppositions
: SCP Thierry Roy, Nicolas Lemoine, Jean-Noël Galy Huissiers 41
bd de Valmy BP 232 - 59654 Villeneuve d'Ascq. Descriptif : Inscription complémentaire suite à achat. Commentaires : Achat d'un
établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale. Date d’effet : 24/11/2010.
|
|
19/12/2010
|
Bodacc A
|
Vente et
cession : Vendeur
|
|
|
|
21 -
COTE-D'OR
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
359 - 487
493 199 RCS Créteil. NEW LOOK FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des
Oliviers, Zi Sénia BP 20145, 94321 Thiais Cédex.
Origine du fonds : Etablissement
secondaire acquis par achat au prix stipulé de 433718 Euros. Etablissement : Etablissement
secondaire. Activité : Vente
de prêt à porter et accessoires. Adresse
: Intersection Voie G. Pompidou - RN 74 Centre commercial La
Toison d'Or, 21000 Dijon.
Précédent propriétaire : MIM.
722 033 115 RCS Créteil.
Date de commencement de
l’activité : 30/10/2010. Publication
légale : Terres de Bourgogne du 19/11/2010. Oppositions
: Etude ASTRUC Jean-Paul et RIVAT Isabelle 19, avenue Albert
Camus 21000 Dijon Pour la correspondance : Me Gilles HITTINGER-ROUX,
avocat, 55 avenue Kléber 75116 PARIS. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou
complémentaire par une personne morale.
|
|
17/12/2010
|
Bodacc A
|
Vente et
cession : Vendeur
|
|
|
|
83 - VAR
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
1114 - 487
493 199 RCS Toulon. NEW LOOK FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des
Oliviers, Zone Industrielle Sénia - Bp 20145, 94321 Thiais Cedex.
Origine du fonds : Achat
d'un fonds de commerce au prix stipulé de 374558 Euros. Etablissement : Etablissemennt
complémentaire. Activité : la
vente de prêt à porter et accessoires de mode. Adresse : 6, 8, 10 rue Hoche, 8, 8bis Rue Andrieu, 83000
Toulon.
Précédent propriétaire : MIM.
722 033 115 RCS Créteil.
Date de commencement de
l’activité : 25/10/2010. Publication
légale : Le Var Information du 19/11/2010. Oppositions
: Au Mandataire SCP BROUSSAIS VALIERGUE BROUSSAIS 97 avenue
Vauban BP 5004 83091 TOULON CEDEX pour la validité et pour la
correspondance ME Gilles HITTINGER-ROUX - SCP HB ET ASSOCIES 55 avenue
Kléber 75116 PARIS. Descriptif
: Etablissement secondaire/complémentaire acquis par achat. Commentaires : Achat d'un
établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.
|
|
09/12/2010
|
Bodacc A
|
Vente et cession
: Vendeur
|
|
|
|
14 -
CALVADOS
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
101 - 487
493 199 RCS Créteil. NEW LOOK FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18 - 24 rue des Oliviers,
BP 20145 Zone Industrielle Sénia, 94321 Thiais.
Origine du fonds : Etablissement
secondaire acquis par achat au prix stipulé de 157397 Euros. Etablissement : Etablissement
secondaire. Activité : Vente
de prêt à porter féminin et accessoires. Adresse : Centre Commercial Mondeville 2, 14120
Mondeville.
Précédent propriétaire : MIM
SAS. 722 033 115 RCS Caen.
Précédent exploitant : MIM
SAS. 722 033 115 RCS Caen.
Date de commencement de
l’activité : 23/10/2010. Publication
légale : L'agriculteur normand du 25/11/2010. Oppositions
: SELARL ACTOJURIS, Me Sandra MAMERT et Me Aurélie BIDEL 10, rue
du Château d'Eau 14000 Caen. Commentaires
: Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une
personne morale.
|
|
03/12/2010
|
JAL
|
Activity or
goodwill cession
|
|
|
|
Syndicat
agricole (Le)
Date de décision : 25/11/2010
Cédant : 722033115 -
MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 487493199
- NEW LOOK FRANCE, 18 RUE DES OLIVIERS, ZI SENIA 18 A 24, BP 20145,
94320 THIAIS
Prix de vente : 387812
€
Date d’effet : 24/11/2010
|
|
02/12/2010
|
Bodacc A
|
Vente et
cession : Vendeur
|
|
|
|
75 - PARIS
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1137 - 487
493 199 RCS Créteil. NEW LOOK FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des
Oliviers Zi Sénia, BP 20145 94321 Thiais.
Origine du fonds : Fonds
acquis par achat au prix stipulé de 1662488,00 euros. Etablissement : Etablissement
complémentaire. Activité : Vente
de prêt à porter féminin et accessoires. Adresse : 84 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris.
Précédent propriétaire : M.I.M.
722 033 115 RCS Paris.
A dater du : 21/05/2008.
Date de commencement de l’activité
: 06/11/2010. Publication
légale : Le parisien libéré du 22/11/2010. Oppositions
: SELARL CHERKI-RIGOT, Huissiers de Justice 119 av de Flandre
75019 Paris pour la validité , Maître HITTINGER-ROUX, avocat, SCP HB ET
ASSOCIES 55 av Kléber 75116 Paris pour la correspondance . Commentaires : Achat d'un
établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.
|
|
26/11/2010
|
JAL
|
Activity
or goodwill cession
|
|
|
|
Syndicat
agricole (Le)
Date de décision : 04/11/2010
Cédant : 722033115 -
MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 487493199
- NEW LOOK FRANCE, 18 RUE DES OLIVIERS, ZI SENIA 18 A 24, BP 20145,
94320 THIAIS
Prix de vente : 227931
€
Date d’effet : 10/11/2010
|
|
25/11/2010
|
JAL
|
Activity
or goodwill cession
|
|
|
|
Agriculteur
normand (L')/Edition du Calvados
Date de décision : 23/10/2010
Cédant : 722033115 -
MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 487493199
- NEW LOOK FRANCE, 18 RUE DES OLIVIERS, ZI SENIA 18 A 24, BP 20145,
94320 THIAIS
Prix de vente : 157397
€
Date d’effet : 23/10/2010
|
|
22/11/2010
|
JAL
|
Activity
or goodwill cession
|
|
|
|
Parisien
(Le) /Edition de Paris
Date de décision : 04/11/2010
Cédant : 722033115 -
MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 487493199
- NEW LOOK FRANCE, 18 RUE DES OLIVIERS, ZI SENIA 18 A 24, BP 20145,
94320 THIAIS
Prix de vente : 1662488
€
Date d’effet : 10/11/2010
|
|
19/11/2010
|
JAL
|
Activity
or goodwill cession
|
|
|
|
Courrier
Français/Edition de la Gironde
Date de décision : 29/10/2010
Cédant : 722033115 -
MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 487493199
- NEW LOOK FRANCE, 18 RUE DES OLIVIERS, ZI SENIA 18 A 24, BP 20145,
94320 THIAIS
Prix de vente : 392640
€
Date d’effet : 03/11/2010
|
|
19/11/2010
|
JAL
|
Activity
or goodwill cession
|
|
|
|
Var
Information
Date de décision : 25/10/2010
Cédant : 722033115 -
MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 487493199
- NEW LOOK FRANCE, 18 RUE DES OLIVIERS, ZI SENIA 18 A 24, BP 20145,
94320 THIAIS
Prix de vente : 374558
€
Date d’effet : 25/10/2010
|
|
19/11/2010
|
JAL
|
Activity
or goodwill cession
|
|
|
|
Terres de
Bourgogne
Date de décision : 29/10/2010
Cédant : 722033115 -
MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 487493199
- NEW LOOK FRANCE, 18 RUE DES OLIVIERS, ZI SENIA 18 A 24, BP 20145,
94320 THIAIS
Prix de vente : 433718
€
Date d’effet : 03/11/2010
|
|
11/11/2010
|
Bodacc A
|
Vente et
cession : Vendeur
|
|
|
|
76 -
SEINE-MARITIME
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE ROUEN
635 - 487
493 199 RCS Créteil. NEW LOOK FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 18 - 24 rue des
Oliviers Zone Industrielle Sénia - BP 20145, 94321 Thiais Cedex.
Origine du fonds : acquis
par achat au prix stipulé de 509754 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Vente de prêt à
porter femmes, hommes, enfants et accessoires s'y rapportant. Adresse : 71 rue du Gros
Horloge, 76000 Rouen.
Précédent propriétaire : M
I M. 722 033 115 RCS Créteil.
Précédent exploitant : M
I M. 722 033 115 RCS Créteil.
Date de commencement de
l’activité : 01/10/2010. Publication
légale : Les Affiches de Normandie du 20/10/2010. Oppositions
: SCP SAVOYE N., OLLAGNIER P., Huissiers de Justice, 41 quai du Havre
76000 Rouen et pour la correspondance, domicile est élu chez Maître
Gilles HITTINGER-ROUX, SCP HB ET ASSOCIES 77, avenue Kléber 75116 Paris
16. Commentaires : Autre
achat, apport, attribution.
|
|
20/10/2010
|
JAL
|
Activity
or goodwill cession
|
|
|
|
Affiches
de normandie (Les)
Date de décision : 01/10/2010
Cédant : 722033115 -
MIM, 18 RUE DES OLIVIERS, 18-24 ZI SENIA, BP 20145, 94320 THIAIS
Cessionnaire : 487493199
- NEW LOOK FRANCE, 18 RUE DES OLIVIERS, ZI SENIA 18 A 24, BP 20145, 94320
THIAIS
Prix de vente : 509754
€
Date d’effet : 30/10/2010
|
|
26/11/2009
|
Bodacc C
|
Comptes
annuels et rapports
|
|
|
|
94 -
VAL-DE-MARNE
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
9663 -
722033115 RCS. M I M. Forme
: Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers Zone Industrielle Sénia
- Bp 20145 94321 Thiais Cedex. Commentaires
: Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le :
31/03/2009.
|
|
28/10/2009
|
Bodacc B
|
Modification
et mutation diverse
|
|
|
|
94 -
VAL-DE-MARNE
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
3296 - 722
033 115 RCS Créteil. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Commissaire
aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Octobre 2007
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
modification le 31 Octobre 2007 Président : KERNAN William en fonction
le 19 Octobre 2009.
Commentaires : Modification
de représentant.
|
|
10/02/2009
|
Bodacc C
|
Comptes
annuels et rapports
|
|
|
|
94 -
VAL-DE-MARNE
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
9302 -
722033115 RCS. M I M. Forme
: Société par actions simplifiée. Adresse : 18-24 rue des Oliviers Zone Industrielle Sénia
- Bp 20145, 94321 Thiais Cedex. Commentaires
: Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le :
31/03/2008.
|
|
27/07/2008
|
Bodacc B
|
Modification
et mutation diverse
|
|
|
|
94 -
VAL-DE-MARNE
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
3893 - 722
033 115 RCS Créteil. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : commissaire
aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT radiation le 06
Novembre 2007commissaire aux comptes suppléant : ANTOLA ANY radié le 06
Novembre 2007.
Commentaires : Modification
de représentant.
|
|
23/07/2008
|
Bodacc B
|
Modification
et mutation diverse
|
|
|
|
94 -
VAL-DE-MARNE
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
3179 - 722
033 115 RCS Créteil. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Commissaire
aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Octobre
2007Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
modification le 31 Octobre 2007. Président : LEMNER Michael en fonction
le 11 Juillet 2008.
Commentaires : Modification
de représentant.
|
|
08/02/2008
|
Bodacc B
|
Modification
et mutation diverse
|
|
|
|
94 -
VAL-DE-MARNE
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
4249 - 722
033 115 RCS Créteil. M I M. Forme : Société par actions simplifiée. Enseigne : M I M. Adresse de l’établissement principal
: 18-24 rue des Oliviers, Zone Industrielle Sénia - Bp 20145,
94321 Thiais Cedex.
Adresse du siège social : 18-24
rue des Oliviers, Zone Industrielle Sénia - Bp 20145, 94321 Thiais
Cedex.
Commentaires : Modification
de l'adresse de l'établissement. Modification de l'adresse du siège.
|
|
16/12/2007
|
Bodacc C
|
Avis de
dépôt des comptes
|
|
|
|
13603 - 722
033 115. RCS Créteil M I M. Forme: Société par actions simplifiée.
Adresse du siège social: 53/55 rue Hélène Muller 94320 Thiais. Comptes
annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 mars 2007.
|
|
20/11/2007
|
Bodacc A
|
Vente et
cession
|
|
|
|
361 - RCS
722 033 115. S.A.S. MIM. Forme : S.A.S. Capital : 905 280 euros.
Adresse du siège social : 53-55 rue Hélène-Muller, 94320 Thiais.
Etablissement secondaire - Adresse : 102 boulevard de la République,
47000 Agen. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé
de 650 000 euros. Date de début d'activité : 1er octobre 2007.
Précédent propriétaire : S.A.R.L. MOUREY. RCS Agen 450 013 065.
Publication légale : Le Courrier français du 12 octobre 2007.
Oppositions : au fonds, 102 boulevard de la République, 47000 Agen.
|
|
19/01/2007
|
Bodacc C
|
Avis de
dépôt des comptes
|
|
|
|
8628 - RCS
Créteil B 722 033 115. RC 96-B 3225. M I M. Forme: SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE. Adresse du siège social: 53/55, rue Helene Muller,94320 Thiais.
Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 mars 2006.
|
|
30/04/2006
|
Bodacc C
|
Avis de
dépôt des comptes
|
|
|
|
5378 - RCS
Créteil B 722 033 115. RC 96-B 3225. M I M. Forme: SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
- SAS. Adresse du siège social: 53/55, rue Helene Muller,94320 Thiais.
Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 mars 2005.
|
|
18/09/2003
|
Bodacc A
|
Création
d'établissement
|
|
|
|
RCS B 722033115
RC 94-B 936 MIM. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 53-55 rue
Hélène-Muller, 94320 Thiais ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : en
France et dans tous pays, commerce, achat, vente, fabrication et
confection de tout tissu, de tous articles textiles de tous objets, de
marchandises ou d'accessoires quelconques se rapportant à l'
habillement en général. Adresse : 6-8 rue Andrieu et 6-10 rue Hoche,
83000 Toulon Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé
de 55 000 euros Date de début d'activité: 22 juillet 2003. Précédent
propriétaire : ETAM. RCS 552015307 Publication légale: Var-information
du 13 juillet 2003. Oppositions : au fonds pour validité et pour la
correspondance, Ordre des Avocats, 11 place Dauphine, 75053 Paris
R.P.-S.P.
|
|
17/09/2003
|
Bodacc B
|
Modifications
et mutations diverses
|
|
|
|
RCS
Créteil B 722033115 RC 96-B 3225 M. I.M. Forme : S.A.S Nom commercial:
M.I.M. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration
: président partant : AMZALLAG (Charles). Commissaire aux comptes
titulaire partant : COOPERS LYBRAND AUDIT. Nomination du président :
McPHAIL (Carl) . Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire :
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT.
|
|
27/02/2003
|
Bodacc A
|
Vente et
cession
|
|
|
|
RCS non
encore inscrit. MIM LOOK S.A.S. Forme : S.A.S. Capital : 2 200 000
euros. Adresse du siège social : 55 rue Hélène- Muller, 94321 Thiais Cedex
Etablissement principal: Activité : équipement de la personne,
maroquinerie, chaussures et à titre accessoire, équipement de la maison
bagagerie, accessoires de mode et articles cadeaux. Adresse : C.A. de
Rosny, centre commercial Rosny II, avenue Charles-de- Gaulle, 93110
Rosny-sous-Bois Etablissement principal acquis par achat au prix
stipulé de 609 800 euros. Date d'effet : 1 e r février 2003. Précédent
propriétaire : D.D.P. RCS 410089866 Publication légale: Le Publicateur
légal du 17 février 2003. Oppositions : au fonds pour la validité et au
Cabinet Xavier Chepeau, 17 rue de Rivière, B.P. 68, 33029 Bordeaux
Cedex, pour la correspondance.
|
|
25/12/2001
|
Bodacc B
|
Modifications
et mutations diverses
|
|
|
|
RCS Créteil
B 722033115 RC 96-B 3225 M. I.M. Forme : S.A.S. Capital : 905 280 euros
Nom commercial: M.I.M. Commentaires : modification survenue sur le
capital ( augmentation).
|
|
24/08/2001
|
Bodacc A
|
Création
d'établissement
|
|
|
|
RCS B 722033115
RC AP-B 2386 SOCIETE MIM. Forme : S.A.S. Capital : 5 924 800 F. Adresse
du siège social : 55 rue Hélène- MÎller, 94300 Thiais Etablissement
principal: Activité : vente de pret-à- porter pour hommes, femmes et
enfants, chaussures ainsi que leurs accessoires. Adresse : 120 rue
Rambuteau, 75001 Paris Etablissement principal acquis par cession au
prix stipulé de 5 450 000 F. Date d'effet : 1 e r aout 2001. Précédent
propriétaire : SARTO. RCS B 307982215 Publication légale: La Gazette du
Palais du 4 aout 2001. Oppositions : au fonds.
|
|
18/04/2001
|
Bodacc A
|
Création
d'établissement
|
|
|
|
RCS
Limoges B 722033115 RC 78-B 37 M.I. M. Forme : S.A.S. Capital : 5 924
800 F Nom commercial: M.I.M. Adresse du siège social : 53-55 rue Hélène-Muller,
94320 Thiais ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Adresse : centre commercial de
Beaubreuil, 87100 Limoges ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Enseigne : M.I.M.
Activité : vente de pret- à-porter féminin et d'accessoires s'y
rapportant. Adresse : centre commercial Saint-Martial, 39 bis avenue
Garibaldi, 87000 Limoges Etablissement secondaire acquis par achat au
prix stipulé de 3 000 000 de F. Commentaires : modification survenue
sur l'adresse de l'établissement principal et la date de début
d'activité Date de début d' activité: 15 février 1978. Date d'effet :
28 février 2001. Précédent propriétaire : S.A. N.C.C. RCS Tours
387703853 Publication légale: Le Courrier français du 23 mars 2001.
Oppositions : au siège de la société Fidal, 34 rue Ferdinant-Buisson,
87000 Limoges, pour la validité et au siège de la société Fidal, 9 rue
de L'Ouvrage-à-Corne, B.P. 286, 17013 La Rochelle, pour la
correspondance.
|
|
15/02/2001
|
Bodacc B
|
Modifications
et mutations diverses
|
|
|
|
RCS Créteil
B 722033115 RC 96-B 3225 M. I.M. Forme : S.A.S Nom commercial: M.I.M.
Commentaires : modification survenue sur la forme juridique et
l'administration. Administration : modification du président : AMZALLAG
(Charles). Directeur général et administrateur partant : AMZALLAG
(Emile). Directeur général non administrateur partant : BENOIT
(Brigitte) ( Nom d'usage : AMZALLAG). Administrateur partant : SUNNUCKS
(Stephen). Nomination d' administrateurs : NEW LOOK GROUP P.L.C. MILLER
(Alastair). Commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG AUDIT.
Commissaire aux comptes suppléant : ANTOLA (Any).
|
|
04/02/2001
|
Bodacc B
|
Modifications
et mutations diverses
|
|
|
|
RCS
Créteil B 722033115 RC 96-B 3225 M. I.M. Forme : S.A Nom commercial: M.I.M.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.
Administration : administrateurs partants : AMZALLAG ( Claude) ( Nom
d'usage : DOMINATI) AMZALLAG (Joelle) ( Nom d'usage : LEISERSON).
Nomination d' administrateurs : SUNNUCKS (Stéphen) NEW LOOK GROUP
P.L.C. MILLER ( Alastair).
|
|
22/10/2000
|
Bodacc B
|
Modifications
et mutations diverses
|
|
|
|
RCS
Créteil B 722033115 RC 96-B 3225 M. I.M. Forme : S.A Nom commercial: M.I.M.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.
Administration : commissaire aux comptes titulaire partant : BLIAH
(Bernard). Nomination du commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET
YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant partant : BLIAH (
Françoise). Nomination du commissaire aux comptes suppléant : ANTOLA
(Any).
|
|
15/10/2000
|
Bodacc A
|
Création d'établissement
|
|
|
|
RCS B 722033115 A dater du: 25 septembre 2000 RC 00-B 189 M.I.M.
Forme : S.A. à conseil d'administration. Adresse du siège social :
53-55 rue Hélène- Muller, 94320 Thiais Etablissement principal: Adresse
: 53-55 rue Hélène- Muller, 94320 Thiais ETABLISSEMENT SECONDAIRE.
Activité : confection pour hommes, femmes et enfants. Adresse : 3 rue
Gambetta et 3 place Surchamp (angle) 33500 Libourne Etablissement
secondaire acquis par achat au prix stipulé de 700 000 F. Date d'effet
: 22 aout 2000. Précédent propriétaire : ALIX S.A.R.L. RCS B 331647214
Publication légale: Sud- Ouest du 5 septembre 2000. Oppositions : M e
Boireau, notaire, 38 allée Robert- Boulin, 33500 Libourne.
|
|
02/12/1999
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
*. RCS Créteil B 722 033 115 RC 96-B 3225 M.I.M. Forme : S.A Nom
commercial: M. I.M. Commentaires : modification survenue sur
l'administration. Administration : nomination en qualité
d'administrateur : BENOIT (Brigitte), ( nom d'usage : AMZALLAG).
|
|
06/08/1999
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
RCS Créteil B 722033115 RC 96-B 03225 M. I.M. Forme : S.A.
Capital : 5 924 800 F Nom commercial: M.I.M. Activité : commerce de
tous articles pour hommes, femmes et enfants, de textiles,
d'habillement et de vetements en tout genre tissu, bonneterie,
pret-à-porter, nouveautés, exclusivités, articles chaussants neufs et
articles hors cours, chaussures, maroquinerie et accessoires. Adresse
du siège social : 53-55 rue Hélène-Muller, 94320 Thiais. Administration
: nomination du président du conseil d' administration : AMZALLAG
(Charles). Nomination du directeur général et administrateur : AMZALLAG
(Emile). Nomination d'administrateurs : AMZALLAG (Joelle) ( Nom d'usage
: LEISERSON) AMZALLAG (Claude) ( Nom d'usage : DOMINATI). Nomination du
commissaire aux comptes titulaire : BLIAH (Bernard). Nomination du
commissaire aux comptes suppléant : BLIAH (Françoise), à compter du 4
juin 1999. Commentaires : modification survenue sur sur l' activité, le
capital, l'adresse du siège social, l'adresse de l' établissement
principal et l' administration. Ancienne adresse : 17- 23 rue
Alphonse-Pluchet, 92220 Bagneux.
|
|
11/07/1999
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
RCS Nanterre B 722033115 RC 93-B 4354 M. I.M. Forme : S.A Nom commercial:
M.I.M. Adresse du siège social : 17-23 rue Alphonse-Pluchet, 92220
Bagneux Date de radiation: 25 juin 1999.
|
|
11/06/1999
|
Bodacc A
|
Création d'établissement
|
|
|
|
RCS Versailles B 722033115 RC 94-B 2997 M.I.M. Forme : S.A. Capital
: 5 924 800 F. Adresse du siège social : 17-23, rue Pluchet 92220
Bagneux Etablissement principal: Activité : commerce de tous articles
pour hommes, dames et enfants, textiles et habillement de vetements en
tous genres, tissus, bonneterie, pret-à- porter, nouveautés,
exclusivités, chaussant neufs et articles hors cours, chaussures,
maroquinerie et accessoires. Adresse : centre Leclerc, 11, avenue
Jean-Jaurès 78390 Bois-d'Arcy Etablissement secondaire acquis par achat
au prix stipulé de 450 000 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE immatriculé au.
RCS : Versailles. Adresse : centre commercial de Flins, local n° 67
78410 Flins-sur-Seine. Activité : pret-à-porter Date de début
d'activité: 28 octobre 1994. Précédent propriétaire : DANHER. RCS B
389426248 Publication légale: Les Petites A Jches de Seine-et-Oise du
25 février 1999. Oppositions : au fonds.
|
|
12/03/1999
|
Bodacc A
|
Création d'établissement
|
|
|
|
RCS *. RCS Versailles B 722 033 115 MIM. Forme : S.A. Capital : 5
924 800 F. Adresse du siège social : 17-23, rue Alphonse- Pluchet 92220
Bagneux Etablissement principal: Activité : vente de pret-à- porter.
Adresse : centre commercial de Flins, local 67 78410 Flins
Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 450 000 F.
Date d'effet : 1er février 1999. Précédent propriétaire : : DANHER. RCS
RCS B 389 426 248 Publication légale: La Semaine de l' Ile-de-France du
25 février 1999. Oppositions : Me Michel Culang, 103, rue la Boétie,
75008 Paris et au fonds pour la validité.
|
|
28/02/1999
|
Bodacc A
|
Création d'établissement
|
|
|
|
RCS Meaux B 421 464 850 A dater du: 4 février 1999 RC 99-B 153
MATOC. Forme : S. A.R.L. Capital : 50 000 F. Adresse du siège social : 65
avenue de la Résistance 77500 Chelles. Administration : gérant :
OUANOUNOU (Eric, David) Etablissement principal: Activité : toutes
opérations industrielles, commerciales se rapportant à la vente et à la
fabrication du textile. Adresse : 65 avenue de la Résistance 77500
Chelles Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 100
000 F. Commentaires : transfert du siège social. Ancienne adresse : 2
bis rue des Deux- Frères, 93250 Villemomble. Date d'effet : 26 janvier
1999. Précédent propriétaire : MIM. RCS B 722 033 115 Publication
légale: Le Moniteur de Seine-et-Marne du 6 février 1999. Oppositions :
au fonds.
|
|
30/10/1998
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
RCS *. RCS Nanterre B 722 033 115 RC RC 93-B 4354 M.I.M. Forme :
S.A Nom commercial: M.I.M. Administration : suppression : commissaire
aux comptes titulaire : BAYLAC (Jeanine). Modification : commissaire
aux comptes titulaire : BLIAH (Bernard). Nomination en qualité de
commissaire aux comptes suppléant : BLIAH ( Françoise). Commentaires :
modification survenue sur l'administration.
|
|
13/08/1998
|
Bodacc A
|
Création d'établissement
|
|
|
|
Rectificatif: Annonce numéro: 177 Date de parution: 14 juin 1998
Page: 12 Numéro de parution: 111A Au lieu de : Adresse de
l'établissement principal : centre commercial Bordeaux - Ouest, centre
Leclerc, 33000 Bordeaux, lire : RCS B 722 033 115 MIM S.A. Forme : S.A.
Adresse du siège social : avenue Descartes, centre commercial Bordeaux-
Ouest, centre Leclerc 33160 Saint- Médard-en-Jalles.
|
|
14/06/1998
|
Bodacc A
|
Création d'établissement
|
|
|
|
RCS B 722 033 115 MIM. Forme : S.A. Capital : 5 924 800 F.
Adresse du siège social : 17-23 rue Alphonse-Pluchet 92220 Bagneux
Etablissement principal: Activité : vente au détail de vetements et de
pret-à-porter. Adresse : centre commercial Bordeaux-Ouest, centre
Leclerc, avenue Descartes 33000 Bordeaux Cession de l'établissement
principal au prix stipulé de 550 000 F. Date d'effet : 17 mars 1998.
Précédent propriétaire : SOCIETE DE VETEMENTS TEXTILE. RCS B 402 284
202 Publication légale: Les Echos judiciaires girondins du 22 mai 1998.
Oppositions : Me Leblond, 74 avenue Pasteur, 33600 Pessac.
|
|
09/06/1998
|
Bodacc A
|
Création d'établissement
|
|
|
|
RCS Créteil B 722 033 115 M.I.M. Forme : S.A. Capital : 5 924 800
F. Adresse du siège social : 17-23 rue Alphonse- Pluchet 92220 Bagneux
Etablissement principal: Activité : confection. Adresse : centre
commercial de Belle Epine 94320 Thiais Etablissement principal acquis
par achat au prix stipulé de 3 380 000 F. Date d'effet : 30 avril 1998.
Précédent propriétaire : MAD. RCS B 350 080 115 Publication légale: Le
Publicateur légal du 18 mai 1998. Oppositions : au fonds pour la
validité et pour la correspondance, au Séquestre Juridique de l'Ordre
des Avocats, 11 place Dauphine, 75001 Paris.
|
|
03/03/1998
|
Bodacc A
|
Création d'établissement
|
|
|
|
RCS Nanterre B 722 035 115 SOCIETE MIM. Forme : S.A. Capital : 5
924 800 F. Adresse du siège social : 17-23 rue Alphonse-Pluchet, 92000 Bagneux.
Administration : président-directeur général : AMZALLAG (Charles) Fonds
principal acquis par achat au prix stipulé de 850 000 F Etablissement
principal: Activité : pret-à-porter hommes, femmes, enfants et
accessoires. Adresse : centre commercial Caluire 2, 53 avenue
Général-Leclerc, 69300 Caluire. Date d'effet : 17 janvier 1998
Précédente propriétaire SOBAC MAILLE S. A. RCS Lyon B 388 361 305
Publication légale: Inform. Agricole Rhone du 22 janvier 1998.
Oppositions : S.C.P. Boyer Clément, 119 avenue Saxe, 69003 Lyon.
|
|
08/11/1997
|
Bodacc A
|
Création d'établissement
|
|
|
|
RCS Nanterre B 722 033 115 RC 94-B 218 MIM. Forme : S.A.
Enseigne : Mim. Adresse du siège social : 17-23 rue Alphonse- Pluchet, 92220
Bagneux Fonds acquis par achat, au prix stipulé de 480 000 F
Etablissement principal: Activité : vente de vetements de femmes.
Adresse : centre commercial Balaruc-Centre, 34540 Balaruc-les-Bains.
Date d'effet : 1er septembre 1997 Précédente propriétaire F.L.
DIFFUSION S.A.R.L. RCS Montpellier B 335 338 075 RC 92-B 246
Publication légale: L'Hérault judiciaire et commercial du 18 septembre
1997. Oppositions : Me Spinelli, 1 rue Honoré-Euzet, 34200 Sète.
|
|
11/07/1997
|
Bodacc A
|
Création d'établissement
|
|
|
|
RCS Nanterre B 722 033 115 MIM. Forme : S. A. Capital : 5 924
800 F. Adresse du siège social : 17/23, rue Alphonse- Pluchet, 92220
Bagneux Fonds principal acquis par achat au prix stipulé de 650 000 F
Etablissement principal: Adresse : 32, rue de la Marne et 1, quai des
Arts, 51000 Chalons-en-Champagne. Activité : pret-à-porter féminin.
Date d'effet : 23 mai 1997 Précédente propriétaire PROMOD. RCS Roubaix
B 685 420 606 Publication légale: Les Petites Affiches Matot-Braine du
13 juin 1997. Oppositions : Me Delattre Géry, 56, rue du Maréchal-Foch,
59100 Roubaix et pour la validité, au fonds vendu.
|
|
04/07/1997
|
Bodacc A
|
Création d'établissement
|
|
|
|
RCS B 722 033 115 MIM. Forme : S.A. Capital : 5 924 800 F.
Adresse du siège social : 17-23 rue Alphonse-Pluchet 92220 Bagneux
Etablissement principal: Activité : vente de pret-à-porter féminin et
d'accessoires. Adresse : centre commercial Saint-Christoly, local n° 25
33000 Bordeaux Cession de l' établissement principal au prix stipulé de
500 000 F. Date d'effet : 23 mai 1997. Précédent propriétaire : PROMOD.
RCS B 685 420 606 Publication légale: Les Echos judiciaires girondins
du 20 juin 1997. Oppositions : Me Delattre-Géry, 56 rue du
Maréchal-Foch, 59-Roubaix pour la correspondance et au fonds pour la
validité.
|
|
29/06/1997
|
Bodacc A
|
Création d'établissement
|
|
|
|
RCS B 722 033 115 M.I.M. Forme : S.A. Capital : 5 924 800 F. Adresse
du siège social : 17-23 rue Pluchet 92220 Bagneux Etablissement
principal: Activité : pret- à-porter féminin et accessoires. Adresse :
centre commercial Euromarché, Galerie marchande 78410 Flins
Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 700 000 F.
Date d'effet : 23 mai 1997. Précédent propriétaire : PROMOD S.A. RCS B
685 420 606 Publication légale: Les Petites affiches du 12 juin 1997.
Oppositions : Me Delattre, 56 rue du Maréchal-Foch, 59-Roubaix et pour
la validité au fonds.
|
|
01/06/1997
|
Bodacc A
|
Création d'établissement
|
|
|
|
RCS B 722 033 115 RC 97-B 00199 M.I.M. Forme : S.A. Capital :
Nom commercial: M.I. M. Adresse du siège social : 17-23 rue
Alphonse-Pluchet 92220 Bagneux Etablissement principal: Adresse : centre
commercial Evry 2 91000 Evry. Activité : commerce de tous articles pour
hommes, femmes et enfants, de textiles, d'habillement, de vetements en
tout genre tissu, bonneterie, pret- à-porter, nouveautés, exclusivités,
articles chaussants neufs et hors cours, chaussures, maroquinerie et
accessoires Etablissement principal acquis par par apport au montant
évalué à 105 627 F Date de début d'activité: 31 octobre 1996. Précédent
propriétaire : SOCIETE ETHY FROC. RCS B 304 423 619 Publication légale:
Le Publicateur légal du 15 novembre 1996 déclaration de créances: au
tribunal de commerce de Corbeil- Essonnes.
|
|
23/06/1995
|
Bodacc A
|
Vente et cession
|
|
|
|
RCS Non encore inscrit au. RCS MIM. Forme : S.A. Capital : 5 924
800 F. Adresse du siège social : 17 à 23, rue Alphonse- Pluchet 92220
Bagneux Etablissement Complémentaire. Adresse : galerie marchande,
Grande-Tour 33560 Sainte- Eulalie Fonds complémentaire acquis par
cession au prix stipulé de 440 000 F. Date d'effet : 4 mai 1995.
Précédent propriétaire : : S.A. MC'IN. RCS RCS B 381 873 512
Publication légale: Les Echos Judiciaires Girondins du 12 mai 1995.
Oppositions : au fonds.
|
|
23/06/1995
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
RCS. RCS B 395 305 410 RC RC 94-B 1225 MERCURE RHONE-ALPES
MEDITERRANEE. Forme : S.A. Capital : 250 000 F. Adresse du siège social
: 2, rue de la Mare-Neuve 91000 Evry Mise en activité suite à la
reprise en location-gérance du fonds principal Etablissement principal:
Activité : gestion de toutes activités d' hotellerie et restauration.
Adresse : 2, rue de la Mare-Neuve 91000 Evry Date de début d'activité:
13 octobre 1994 Propriétaire : SOCIETE MIM.
|
|
07/01/1995
|
Bodacc A
|
Création d'établissement
|
|
|
|
RCS Nanterre B 722 033 115 A dater du: 2 décembre 1994 M.I.M.
Forme : S.A. Nom commercial: M.I.M. Adresse du siège social : 17-23 rue
Alphonse-Pluchet, 92200 Bagneux ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Fréjus 94-B
398. Activité : commerce de tous articles (pour hommes, dames,
enfants), textiles et habillement, vetements en tout genre, tissus,
bonneterie, pret-à-porter, nouveautés, exclusivités chaussants neufs et
articles hors cours, chaussures, maroquinerie et accessoires. Enseigne
: M.I.M. Adresse : centre commercial Continent, 83480 Puget-sur-Argens
Fonds secondaire acquis par fusion, au montant évalué à 1 625 138 F
Date de début d'activité: 30 juin 1994 Précédente propriétaire
CAPUCINES 17 S. A.R.L. RCS B 342 378 429 RC 91-B 432 Publication
légale: Le Publicateur légal du 2 aout 1994 déclaration de créances: au
greffe du tribunal de commerce de Nanterre.
|
|
|
|
|
Date
|
Description
|
|
31/01/2014
|
Update Rating
|
|
31/01/2014
|
Update Limit
|
|
31/01/2014
|
Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of
this company's creditworthiness
|
|
27/12/2013
|
Bodacc B: Various editing or changing
|
|
18/12/2013
|
New chairman (CEO, CoB)
|
|
18/12/2013
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
17/12/2013
|
Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social
representative
|
|
05/12/2013
|
Legal Gazette: Appointment of the social representative
|
|
25/11/2013
|
Bodacc C : Deposit accounts notice
|
|
19/10/2013
|
Update Limit
|
|
19/10/2013
|
Update Rating
|
|
31/03/2013
|
New accounts available
|
|
31/01/2013
|
Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment
of this company's creditworthiness
|
|
02/01/2013
|
Bodacc C : Deposit accounts notice
|
|
17/10/2012
|
Bodacc B: Various editing or changing
|
|
11/10/2012
|
Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social
representative
|
|
09/10/2012
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
09/10/2012
|
New chairman (CEO, CoB)
|
|
14/09/2012
|
Legal Gazette: Appointment of the social representative
|
|
31/03/2012
|
New accounts available
|
|
20/03/2012
|
Bodacc A : Sale and transfer
|
|
28/02/2012
|
Bodacc B: Various editing or changing
|
|
20/02/2012
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
20/02/2012
|
New chairman (CEO, CoB)
|
|
18/02/2012
|
Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social
representative
|
|
01/02/2012
|
Legal Gazette: Activity or goodwill cession
|
|
30/01/2012
|
Bodacc C : Deposit accounts notice
|
|
30/01/2012
|
Legal Gazette: Appointment of the social representative
|
|
14/01/2012
|
Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment
of this company's creditworthiness
|
|
01/07/2011
|
Other modification of Establishment
|
|
01/07/2011
|
Formation of Establishment
|
|
31/03/2011
|
New accounts available
|
|
31/03/2011
|
Bodacc A : Sale and transfer
|
|
17/02/2011
|
Legal Gazette: Activity or goodwill cession
|
|
18/01/2011
|
Bodacc C : Deposit accounts notice
|
|
11/01/2011
|
Bodacc A : Sale and transfer
|
|
26/12/2010
|
Bodacc A : Sale and transfer
|
|
23/12/2010
|
Bodacc A : Sale and transfer
|
|
19/12/2010
|
Bodacc A : Sale and transfer
|
|
17/12/2010
|
Bodacc A : Sale and transfer
|
|
09/12/2010
|
Bodacc A : Sale and transfer
|
|
02/12/2010
|
Bodacc A : Sale and transfer
|
|
25/11/2010
|
Legal Gazette: Activity or goodwill cession
|
|
11/11/2010
|
Bodacc A : Sale and transfer
|
|
04/11/2010
|
Legal Gazette: Activity or goodwill cession
|
|
29/10/2010
|
Legal Gazette: Activity or goodwill cession
|
|
25/10/2010
|
Legal Gazette: Activity or goodwill cession
|
|
23/10/2010
|
Legal Gazette: Activity or goodwill cession
|
|
01/10/2010
|
Legal Gazette: Activity or goodwill cession
|
|
24/08/2010
|
Payment incident closed
|
|
21/07/2010
|
Payment incident detected
|
|
12/05/2010
|
Formation of Establishment
|
|
05/05/2010
|
Formation of Establishment
|
|
31/03/2010
|
Other modification of Establishment
|
|
31/03/2010
|
Formation of Establishment
|
|
31/03/2010
|
New accounts available
|
|
08/02/2010
|
Payment incident closed
|
|
26/11/2009
|
Bodacc C : Deposit accounts notice
|
|
28/10/2009
|
Bodacc B: Various editing or changing
|
|
19/10/2009
|
Changement de Président (PDG, PCA)
|
|
19/10/2009
|
New chairman (CEO, CoB)
|
|
19/10/2009
|
Acte modificatif
|
|
19/10/2009
|
Amendment
|
|
23/07/2009
|
Payment incident detected
|
|
15/05/2009
|
Other modification of Establishment
|
|
15/05/2009
|
Formation of Establishment
|
|
10/04/2009
|
Formation of Establishment
|
|
31/03/2009
|
New accounts available
|
|
10/02/2009
|
Bodacc C : Deposit accounts notice
|
|
23/01/2009
|
Other modification of Establishment
|
|
30/12/2008
|
Payment incident closed
|
|
06/12/2008
|
Closure of Establishment
|
|
20/10/2008
|
Payment incident detected
|
|
15/10/2008
|
Formation of Establishment
|
|
01/10/2008
|
Formation of Establishment
|
|
20/09/2008
|
Formation of Establishment
|
|
12/09/2008
|
Formation of Establishment
|
|
30/08/2008
|
Formation of Establishment
|
|
01/08/2008
|
Formation of Establishment
|
|
27/07/2008
|
New Bodacc B ads detected
|
|
27/07/2008
|
Bodacc B: Various editing or changing
|
|
23/07/2008
|
New Bodacc B ads detected
|
|
23/07/2008
|
Bodacc B: Various editing or changing
|
|
11/07/2008
|
Changement de Président (PDG, PCA)
|
|
11/07/2008
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
11/07/2008
|
PV d'Assemblée
|
|
11/07/2008
|
New chairman (CEO, CoB)
|
|
11/07/2008
|
Private document
|
|
11/07/2008
|
Appointment/resignation of company officers
|
|
11/07/2008
|
Changes to the Board of Directors
|
|
31/03/2008
|
New accounts available
|
|
29/03/2008
|
Formation of Establishment
|
|
21/03/2008
|
Formation of Establishment
|
|
08/02/2008
|
New Bodacc B ads detected
|
|
08/02/2008
|
Bodacc B: Various editing or changing
|
|
07/02/2008
|
Amendment
|
|
07/02/2008
|
Acte modificatif
|
|
07/02/2008
|
Updated articles of association
|
|
07/02/2008
|
Statuts mis à jour
|
|
07/02/2008
|
Registered office transferred inside jurisdiction of the
Commercial Court
|
|
07/02/2008
|
Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce
|
|
06/11/2007
|
Changement de Commissaire aux Comptes
|
|
06/11/2007
|
Amendment
|
|
06/11/2007
|
Acte modificatif
|
|
06/11/2007
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
06/11/2007
|
Private document
|
|
31/10/2007
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
31/10/2007
|
PV d'Assemblée
|
|
31/10/2007
|
Appointment/resignation of company officers
|
|
31/10/2007
|
Private document
|
|
31/03/2007
|
New accounts available
|
|
17/01/2007
|
Transfer of Establishment
|
|
17/01/2007
|
Update of Company Head Office Identifier
|
|
12/05/2006
|
Acte sous seing privé
|
|
12/05/2006
|
Private document
|
|
12/05/2006
|
Appointment/resignation of company officers
|
|
12/05/2006
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
12/05/2006
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
12/05/2006
|
PV d'Assemblée
|
|
12/05/2006
|
Statuts mis à jour
|
|
12/05/2006
|
Updated articles of association
|
|
12/05/2006
|
Acte modificatif
|
|
31/03/2006
|
New accounts available
|
|
31/03/2005
|
New accounts available
|
|
13/09/2004
|
Planned merger
|
|
13/09/2004
|
Projet de Fusion
|
|
13/09/2004
|
Fusion
|
|
13/09/2004
|
Acte sous seing privé
|
|
13/09/2004
|
Private document
|
|
13/09/2004
|
Déclaration de conformité
|
|
13/09/2004
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
13/09/2004
|
PV d'Assemblée
|
|
13/09/2004
|
Acte modificatif
|
|
16/07/2004
|
Acte sous seing privé
|
|
16/07/2004
|
Rapport des Commissaires ou du Gérant
|
|
16/07/2004
|
Audit or Management Report
|
|
16/07/2004
|
Private document
|
|
01/07/2004
|
Amendment
|
|
01/07/2004
|
Planned merger
|
|
01/07/2004
|
Acte modificatif
|
|
01/07/2004
|
Projet de Fusion
|
|
01/07/2004
|
Private document
|
|
01/07/2004
|
Acte sous seing privé
|
|
16/06/2004
|
Acte modificatif
|
|
16/06/2004
|
Application and court order
|
|
16/06/2004
|
Requête et Ordonnance
|
|
31/03/2004
|
New accounts available
|
|
05/09/2003
|
PV d'Assemblée
|
|
05/09/2003
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
05/09/2003
|
Acte sous seing privé
|
|
05/09/2003
|
Statuts mis à jour
|
|
05/09/2003
|
Changement de Président (PDG, PCA)
|
|
05/09/2003
|
Changement de Commissaire aux Comptes
|
|
05/09/2003
|
Acte modificatif
|
|
31/03/2003
|
New accounts available
|
|
26/11/2001
|
Acte modificatif
|
|
26/11/2001
|
Conversion du Capital Social en Euros
|
|
26/11/2001
|
Acte sous seing privé
|
|
26/11/2001
|
Statuts mis à jour
|
|
26/11/2001
|
Augmentation de Capital
|
|
26/11/2001
|
PV d'Assemblée
|
|
31/01/2001
|
Rapport des Commissaires ou du Gérant
|
|
31/01/2001
|
Changement de Commissaire aux Comptes
|
|
31/01/2001
|
Statuts mis à jour
|
|
31/01/2001
|
PV d'Assemblée
|
|
31/01/2001
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
31/01/2001
|
Acte sous seing privé
|
|
31/01/2001
|
Modification du Conseil d'Administration
|
|
31/01/2001
|
Changement de Président (PDG, PCA)
|
|
31/01/2001
|
Prorogation de durée
|
|
31/01/2001
|
Changement de Forme Juridique avec changement de catégorie
|
|
31/01/2001
|
Changement de Forme Juridique sans changement de catégorie
|
|
31/01/2001
|
Acte modificatif
|
|
18/01/2001
|
Statuts mis à jour
|
|
18/01/2001
|
Changement de date de clôture
|
|
18/01/2001
|
Modification du Conseil d'Administration
|
|
18/01/2001
|
Acte sous seing privé
|
|
18/01/2001
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
18/01/2001
|
PV d'Assemblée
|
|
06/10/2000
|
Acte sous seing privé
|
|
06/10/2000
|
Changement de Commissaire aux Comptes
|
|
06/10/2000
|
Acte modificatif
|
|
06/10/2000
|
PV d'Assemblée
|
|
06/10/2000
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
17/11/1999
|
Acte sous seing privé
|
|
17/11/1999
|
Modification du Conseil d'Administration
|
|
17/11/1999
|
PV du Conseil d'Administration
|
|
17/11/1999
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
17/11/1999
|
Acte modificatif
|
|
03/06/1999
|
Immatriculation suite à transfert
|
|
03/06/1999
|
Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce
|
|
03/06/1999
|
Acte modificatif
|
|
03/06/1999
|
Statuts mis à jour
|
|
03/06/1999
|
PV d'Assemblée
|
|
03/06/1999
|
Acte sous seing privé
|
|
07/01/1999
|
Déclaration de conformité
|
|
07/01/1999
|
Fusion
|
|
07/01/1999
|
PV d'Assemblée
|
|
07/01/1999
|
Acte sous seing privé
|
|
18/12/1998
|
Rapport des Commissaires ou du Gérant
|
|
18/12/1998
|
Acte sous seing privé
|
|
30/11/1998
|
Acte sous seing privé
|
|
30/11/1998
|
Projet de Fusion
|
|
05/11/1998
|
Acte modificatif
|
|
05/11/1998
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
05/11/1998
|
Requête et Ordonnance
|
|
12/10/1998
|
Acte sous seing privé
|
|
12/10/1998
|
PV d'Assemblée
|
|
12/10/1998
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
12/10/1998
|
Changement de Commissaire aux Comptes
|
|
08/01/1998
|
Acte modificatif
|
|
08/01/1998
|
Acte sous seing privé
|
|
08/01/1998
|
PV d'Assemblée
|
|
08/01/1998
|
Fusion
|
|
08/01/1998
|
Déclaration de conformité
|
|
18/12/1997
|
Acte sous seing privé
|
|
18/12/1997
|
Rapport des Commissaires ou du Gérant
|
|
24/11/1997
|
Acte sous seing privé
|
|
24/11/1997
|
Projet de Fusion
|
|
17/09/1997
|
Acte sous seing privé
|
|
17/09/1997
|
Acte modificatif
|
|
17/09/1997
|
Requête et Ordonnance
|
|
05/12/1996
|
PV d'Assemblée
|
|
05/12/1996
|
Acte modificatif
|
|
05/12/1996
|
Fusion
|
|
05/12/1996
|
Acte sous seing privé
|
|
05/12/1996
|
Déclaration de conformité
|
|
22/10/1996
|
Rapport des Commissaires ou du Gérant
|
|
22/10/1996
|
Acte modificatif
|
|
27/06/1996
|
Projet de Fusion
|
|
27/06/1996
|
Acte modificatif
|
|
13/06/1996
|
Acte modificatif
|
|
13/06/1996
|
Requête et Ordonnance
|
|
08/09/1994
|
Modification du Conseil d'Administration
|
|
08/09/1994
|
Statuts mis à jour
|
|
08/09/1994
|
Acte modificatif
|
|
08/09/1994
|
PV d'Assemblée
|
|
08/09/1994
|
Fusion
|
|
08/09/1994
|
Déclaration de conformité
|
|
08/09/1994
|
Changement de dénomination sociale
|
|
08/09/1994
|
Acte sous seing privé
|
|
21/06/1994
|
Acte modificatif
|
|
21/06/1994
|
Rapport des Commissaires ou du Gérant
|
|
30/05/1994
|
Acte modificatif
|
|
30/05/1994
|
Acte sous seing privé
|
|
30/05/1994
|
Projet de Fusion
|
|
22/04/1994
|
Acte modificatif
|
|
22/04/1994
|
Requête et Ordonnance
|
|
12/10/1993
|
PV d'Assemblée
|
|
12/10/1993
|
Statuts
|
|
12/10/1993
|
Immatriculation suite à transfert
|
|
12/10/1993
|
Déclaration de conformité
|
|
12/10/1993
|
Statuts mis à jour
|
|
12/10/1993
|
PV du Conseil d'Administration
|
|
16/09/1993
|
Transfert du Siège hors du ressort du Tribunal de Commerce
|
|
16/09/1993
|
PV du Conseil d'Administration
|
|
16/09/1993
|
Acte modificatif
|
|
24/07/1992
|
Statuts mis à jour
|
|
24/07/1992
|
PV d'Assemblée
|
|
24/07/1992
|
Acte modificatif
|
|
24/07/1992
|
Modification de l'objet social
|
|
24/07/1992
|
Déclaration de conformité
|
|
28/03/1991
|
Requête et Ordonnance
|
|
Date
|
Description
|
|
01/02/2014
|
Update Limit
|
|
01/02/2014
|
Update Rating
|
|
04/01/2014
|
Update Limit
|
|
06/12/2013
|
Update Rating
|
|
31/01/2013
|
Update Limit
|
|
31/01/2013
|
Update Rating
|
|
13/01/2013
|
Update of phone numbers
|
|
05/01/2013
|
Update Limit
|
|
04/12/2012
|
Update Rating
|
|
14/01/2012
|
Update Limit
|
|
07/01/2012
|
Update Limit
|
|
01/07/2011
|
Modification of Head office
|
|
08/01/2011
|
Update Rating
|
|
01/12/2010
|
Update Rating
|
|
24/08/2010
|
Update Limit
|
|
24/08/2010
|
Update Rating
|
|
19/08/2010
|
Update of phone numbers
|
|
06/08/2010
|
Update Limit
|
|
06/08/2010
|
Update Rating
|
|
12/05/2010
|
Modification of Head office
|
|
05/05/2010
|
Modification of Head office
|
|
31/03/2010
|
Update of Establishment Workforce
|
|
31/03/2010
|
Modification of Head office
|
|
08/02/2010
|
Update Rating
|
|
08/02/2010
|
Update Limit
|
|
10/08/2009
|
Update Limit
|
|
10/08/2009
|
Update Rating
|
|
15/05/2009
|
Modification of Head office
|
|
10/04/2009
|
Modification of Head office
|
|
09/02/2009
|
Update Limit
|
|
09/02/2009
|
Update Rating
|
|
23/01/2009
|
Modification of Head office
|
|
06/01/2009
|
Update Limit
|
|
30/12/2008
|
Update Rating
|
|
30/12/2008
|
Update Limit
|
|
06/12/2008
|
Modification of Head office
|
|
05/11/2008
|
Update Limit
|
|
05/11/2008
|
Update Rating
|
|
15/10/2008
|
Modification of Head office
|
|
01/10/2008
|
Modification of Head office
|
|
20/09/2008
|
Modification of Head office
|
|
12/09/2008
|
Modification of Head office
|
|
30/08/2008
|
Modification of Head office
|
|
01/08/2008
|
Modification of Head office
|
|
14/04/2008
|
Update of phone numbers
|
|
29/03/2008
|
Modification of Head office
|
|
21/03/2008
|
Modification of Head office
|
|
17/01/2007
|
Formation of Head office (after transfer)
|
|
|
|