MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

08.03.2014

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

MOVITEX DAXON

 

 

Registered Office :

68 Rue Christophe Colomb, Bp 122, 59443 Wasquehal Cedex

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2012

 

 

Date of Incorporation :

January 1974

 

 

Com. Reg. No.:

RCS 7 756 200 150

 

 

Legal Form :

Public Limited Company with Board of Directors

 

 

Line of Business :

Engaged in Sales through Specialized Catalog

 

Subject is specialist in clothing for women, men, seniors and large sizes, offers a collection of ready to wear woman, lingerie, homewares & wellness products.

 

 

No. of Employees

765 (31.12.2011)

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory 

 

 

Payment Behaviour :

Slow but Correct  

 

 

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – december 01, 2013

 

Country Name

Previous Rating

(30.09.2013)

Current Rating

(01.12.2013)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 

france ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With at least 79 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that reduce income disparity and the impact of free markets on public health and welfare. France's real GDP contracted 2.6% in 2009, but recovered somewhat in 2010 and 2011, before stagnating in 2012. The unemployment rate increased from 7.4% in 2008 to 10.3% in 2012. Youth unemployment shot up to 24.2% during the third quarter of 2012 in metropolitan France. Lower-than-expected growth and high unemployment costs have strained France's public finances. The budget deficit rose sharply from 3.4% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 4.5% of GDP in 2012, while France's public debt rose from 68% of GDP to 89% over the same period. Under President SARKOZY, Paris implemented some austerity measures to bring the budget deficit under the 3% euro-zone ceiling by 2013 and to highlight France's commitment to fiscal discipline at a time of intense financial market scrutiny of euro-zone debt. Socialist Party candidate Francois HOLLANDE won the May 2012 presidential election, after advocating pro-growth economic policies, the separation of banks' traditional deposit taking and lending activities from more speculative businesses, increasing the top corporate and personal tax rates, and hiring an additional 60,000 teachers during his five-year term. The government's attempt to introduce a 75% wealth tax on income over one million euros for two years was struck down by the French Constitutional Council in December 2012 because it applied to individuals rather than households. France ratified the EU fiscal stability treaty in October 2012 and HOLLANDE's government has maintained France's commitment to meeting the budget deficit target of 3% of GDP during 2013 even amid signs that economic growth will be lower than the government's forecast of 0.8%. Despite stagnant growth and fiscal challenges, France's borrowing costs declined during the second half of 2012 to euro-era lows.

 

Source : CIA

 

 

 


company summary

 

Name

MOVITEX

SIRET

756 200 150 00040

 

 

 

 

EUR VAT Number

FR61756200150

 

 

Activity (APE)

Engaged in Sales through Specialized Catalog

 

Subject is specialist in clothing for women, men, seniors and large sizes, offers a collection of ready to wear woman, lingerie, homewares & wellness products.

Legal form

Public limited company with board of directors

 

 

Phone

03 20 01 20 01

RCS Registration

RCS 7 756 200 150

 

 

Fax

Share capital

1,376,700 Euros

 

 

Address

MOVITEX
DAXON


68 RUE CHRISTOPHE COLOMB
BP 122

59443 WASQUEHAL CEDEX

 

Incorporated Date

06/1974

 

 

Nationality

France

Status

Economically active

 

 

No social security and tax office preferential right to date

 

 

Current Directors

3

Trading to Date

12/31/2012

12/31/2011

12/31/2010

Turnover

191,183,406 €

202,896,407 €

224,079,756 €

Gross Operating Surplus

-5,78 % Turnover

-6,47 % Turnover

0,23 % Turnover

Shareholders’ equity

1,216,052 €

-6,865,335 €

6,330,326 €

Net result

2,679,979 €

-13,709,069 €

808,265 €

Employees

765 (31.12.2011)

-

-

 

 

company details

 

 

 

Activity (APE)

Engaged in Sales through Specialized Catalog

 

Subject is specialist in clothing for women, men, seniors and large sizes, offers a collection of ready to wear woman, lingerie, homewares & wellness products.

 

RCS Registration

RCS 7 756 200 150

Share capital

1,376,700 Euros

 

Registration Court

(59)

Legal form

Public limited company with board of directors

 

Court Registry Number

19 7 4B20058

EUR VAT Number

FR61756200150

 

Incorporation Date

06/1974

Formation Date

01/1974

 

Deregistration Date

Last account Date

31/12/2012

 

Nationality

France

 

 

 

 

 

 

Ultimate Parent

1 ultimate parent company for this company 
>  KERING  - Activités des sièges sociaux (7010Z)  in PARIS 8  (75008)

 

 

Establishment details

 

 

 

 

Activity (APE)

Vente à distance sur catalogue spécialisé (4791B)

Business Pages FT®

VENTES PAR CORRESPONDANCE ET A DISTANCE

 

Postal Address

MOVITEX 
DAXON 
68 RUE CHRISTOPHE COLOMB 
BP 122 
59443 WASQUEHAL CEDEX

Trading Address

68 RUE CHRISTOPHE COLOMB 
59290 WASQUEHAL

 

Telephone

03 20 01 20 01

 

Fax

 

 

 

Type

Head office

Status

Economically active

 

Formation Date

Reason for formation

Formation

 

Closure Date

Reason for closure

 

Reactivation Date

Production Role

 

Activity Nature

-

Activity Location

N/R

 

Location surface

Seasonality

 

 

 

Department

Nord (59)

Region

Nord-Pas-de-Calais

 

District

5

Area

54

 

City

WASQUEHAL

Size of urban area

Urban unit with 200 000 to 1 999 999 inhabitants

 

 

 

Other establishments

 

 

 

 

Branches

3 branch entities in this company

 

Head office

 
> MOVITEX <<<  - Vente à distance sur catalogue spécialisé (4791B)  in WASQUEHAL  (59290) 
 

 

Secondary establishments

>  MOVITEX  - Vente à distance sur catalogue spécialisé (4791B)  in FRETIN  (59273) 
>  MOVITEX  - Vente à distance sur catalogue spécialisé (4791B)  in LEERS  (59115) 
>  MOVITEX  - Vente à distance sur catalogue spécialisé (4791B)  in LENS  (62300) 
>  MOVITEX  - Vente à distance sur catalogue spécialisé (4791B)  in TOURCOING  (59200)

 

 

 

 

Regionality

Legal unit with all establishments in same area

 

Mono-activity status

Legal unit having all establishments with the same main activity

 

 

 

 

Workforces

 

 

 

 

Workforce at address

250 to 499 employees

Company workforce

765 (31.12.2011)

 

accounts

Active Account |  Passive Account |  Account Results

 

 

Synthesized Accounts 

Display parameter

Currency

 Euro

 Kilo Euro

Comparison mode

 Average

 Median

 

Annual Accounts

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Account period (month)

12

12

12

Account Type

Normal

Normal

Normal

Date of capture

06/05/2013

09/05/2013

28/03/2013

Activity Code

4791B

4791B

4791B

Employees

0

765

0

 

Active account

Annual Accounts

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Sector Median 2012

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

3 464 458

22,4%

2 831 034

-11,7%

3 206 708

4 146

83461,5%

- Intangible assets

1 240 179

205,5%

406 015

356,2%

89 003

215

576727,4%

- Tangible assets

2 196 560

-7,8%

2 381 453

-22,2%

3 062 609

674

325799,1%

- Financial assets

27 719

-36,4%

43 566

-20,9%

55 096

0

0%

Net current assets

57 306 037

-18,2%

70 085 844

-12,5%

80 116 429

42 499

134740,9%

- Stocks

27 304 105

-22,5%

35 234 030

1,4%

34 732 165

8 610

317020,8%

- Advanced payments

236 863

-18,2%

138 908

-70,8%

475 242

0

0%

- Receivables

29 232 474

-11,1%

32 874 850

-22,8%

42 561 478

6 961

419846,5%

- Securities and cash

532 595

-71,0%

1 838 056

-21,7%

2 347 544

9 039

5792,2%

- Prepaid expenses

-

-

-

-

-

0

-

Accounts of regularization

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total Assets

60 770 495

-16,7%

72 916 880

-12,5%

83 323 138

53 566

113349,8%

 

Passive Account

Annual Accounts

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Sector Median2012

Shareholders' equity

1 216 052

117,7%

-6 865 335

-208,5%

6 330 326

10 022

12033,8%

Share capital

1 376 700

0%

1 376 700

0%

1 376 700

7 650

17896,1%

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

2 716 062

-40,9%

4 595 989

4,6%

4 395 887

0

0%

Liabilities

56 838 381

-24,4%

75 186 226

3,6%

72 596 925

41 694

136222,7%

- Financial liabilities

1 623 195

9,1%

1 488 101

684,9%

189 580

4 167

38853,6%

- Advanced payments received

9 694 971

-55,3%

21 704 007

-12,2%

24 706 820

0

0%

- Trade account payables

34 998 473

-1,8%

35 649 249

-4,0%

37 140 940

8 748

399974,0%

- Tax and social liabilities

9 457 126

-1,2%

9 572 680

-5,6%

10 144 032

6 632,50

142487,7%

- Other debts and fixed assets liabilities

1 064 616

-84,3%

6 772 189

1529,7%

415 553

1 962

54161,8%

Account regularization

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total liabilities

60 770 495

-16,7%

72 916 879

-12,5%

83 323 137

53 566

113349,8%

 

Results

Annual Accounts

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Sector Median 2012

Sales of Goods

210 501 258

-0,3%

211 076 604

-8,8%

231 540 433

94 069

223673,2%

Net turnover

191 183 406

-5,8%

202 896 407

-9,5%

224 079 756

92 168

207329,3%

- of which net export turnover

22 386 636

-9,1%

24 616 967

2,4%

24 044 855

0

0%

Operating charges

206 482 924

-6,5%

220 759 540

-3,9%

229 811 828

96 512

213845,3%

Operating profit/loss

4 018 334

141,5%

-9 682 936

-660,2%

1 728 605

381

1054580,8%

Financial income

1 820 815

2,1%

1 783 661

-21,6%

2 274 992

0

0%

Financial charges

1 679 742

-3,5%

1 740 560

-15,0%

2 048 516

55

3053976,4%

Financial profit/loss

141 073

227,3%

43 101

-81,0%

226 476

0

0%

Pretax net operating income

4 159 407

143,1%

-9 639 835

-593,1%

1 955 081

312

1333043,3%

Extraordinary income

3 623 583

595,2%

521 210

82,6%

285 438

0

0%

Extraordinary charges

4 265 138

-11,8%

4 836 710

989,8%

443 810

0

0%

Extraordinary profit/loss

-641 555

85,1%

-4 315 500

-2624,9%

-158 372

0

0%

Net result

2 679 979

119,5%

-13 709 069

-1796,1%

808 265

491

545720,6%


 

 

Display parameter

Currency

 Euro

 Kilo Euro

 

Normal Account

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Months

12

12

12


Accounts - Active 
Current Assets |  Equalization accounts |  Reference 

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

 

Grand Total (I to VI)

Net

60 770 495

-16,7%

72 916 880

-12,5%

83 323 138

Gross

CO

85 292 350

-13,0%

98 051 745

-9,3%

108 080 597

Amortisation

1A

24 521 855

-2,4%

25 134 865

1,5%

24 757 459

 

Non declared distributed capital (I)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

Gross

AA

0

-

-

-

-

 

Active fixed asset (II)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total Active fixed asset (II)

Net

3 464 458

22,4%

2 831 034

-11,7%

3 206 708

Gross

BJ

23 821 155

4,0%

22 899 693

-2,0%

23 372 095

Amortisation

BK

20 356 697

1,4%

20 068 659

-0,5%

20 165 387

 

Intangible fixed assets

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R & D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AE

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AF

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AG

0

0%

0

0%

0

Goodwill

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AH

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AI

0

0%

0

0%

0

Other intangible fixed assets

Net

1 240 179

205,5%

406 015

356,2%

89 003

Gross

AJ

2 909 661

53,7%

1 893 281

4,0%

1 820 194

Amortisation

AK

1 669 482

12,3%

1 487 266

-14,1%

1 731 191

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible Assets

Net

1 240 179

205,5%

406 015

356,2%

89 003

 

Tangible fixed assets

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Lands

Net

126 478

0%

126 478

0%

126 478

Gross

AN

126 478

0%

126 478

0%

126 478

Amortisation

AO

0

0%

0

0%

0

Buildings

Net

133 729

-18,7%

164 583

-20,9%

208 100

Gross

AP

3 293 404

0%

3 293 404

0%

3 293 404

Amortisation

AQ

3 159 675

1,0%

3 128 821

1,4%

3 085 304

Plant

Net

724 587

-27,1%

993 981

-4,5%

1 041 298

Gross

AR

8 856 611

-3,7%

9 193 143

3,4%

8 886 731

Amortisation

AS

8 132 024

-0,8%

8 199 162

4,5%

7 845 433

Other tangible fixed assets

Net

773 864

-27,0%

1 060 135

-22,7%

1 371 357

Gross

AT

7 998 224

-1,8%

8 142 389

-6,4%

8 703 660

Amortisation

AU

7 224 360

2,0%

7 082 254

-3,4%

7 332 303

Fixed assets in construction

Net

437 902

1107,1%

36 276

-88,5%

315 376

Gross

AV

437 902

1107,1%

36 276

-88,5%

315 376

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AX

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

Sub Total Tangible asset

Net

2 196 560

2 381 453

3 062 609

 

Financial assets

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

620

0%

620

0%

620

Gross

CU

171 776

0%

171 776

0%

171 776

Amortisation

CV

171 156

0%

171 156

0%

171 156

Inter-company receivables

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BC

0

0%

0

0%

0

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

Loans

Net

21 299

-42,7%

37 146

-23,7%

48 676

Gross

BF

21 299

0%

37 146

0%

48 676

Amortisation

BG

0

0

0

Other financial assets

Net

5 800

0%

5 800

0%

5 800

Gross

BH

5 800

0%

5 800

0%

5 800

Amortisation

BI

0

0%

0

0%

0

Sub Total Financial Assets

27 719

43 566

55 096

  

Current Assets (III)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total Assets

Net

57 306 037

-18,2%

70 085 844

-12,5%

80 116 429

Gross

CJ

61 471 195

-18,2%

75 152 052

-11,3%

84 708 501

Amortisation

CK

4 165 158

-17,8%

5 066 208

10,3%

4 592 072

 

Stocks

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Raw materials

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BL

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BM

0

0%

0

0%

0

Work in progress (goods)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BN

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BR

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BS

0

0%

0

0%

0

Goods for resale

Net

27 304 105

-22,5%

35 234 030

1,4%

34 732 165

Gross

BT

28 950 246

-22,8%

37 483 688

2,3%

36 648 333

Amortisation

BU

1 646 141

-26,8%

2 249 658

17,4%

1 916 168

Sub Total Stocks

Net

27 304 105

-22,5%

35 234 030

1,4%

34 732 165

 

Advance payments to suppliers

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Advance payments to suppliers

Net

236 863

70,5%

138 908

-70,8%

475 242

Gross

BV

236 863

70,5%

138 908

-70,8%

475 242

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0

 

Debtors

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Trade accounts receivable

Net

13 598 848

-13,7%

15 751 508

63,3%

9 646 685

Gross

BX

14 527 273

-14,8%

17 054 938

58,5%

10 757 537

Amortisation

BY

928 425

-28,8%

1 303 430

17,3%

1 110 852

Other debtors

Net

10 602 444

-5,4%

11 209 606

-55,0%

24 924 776

Gross

BZ

12 193 036

-4,2%

12 722 726

-52,0%

26 489 828

Amortisation

CA

1 590 592

5,1%

1 513 120

-3,3%

1 565 052

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

Sub Total Debtors

Net

24 201 292

-10,2%

26 961 114

-22,0%

34 571 461

 

Divers

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CD

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

532 595

-71,0%

1 838 056

-21,7%

2 347 544

Gross

CF

532 595

-71,0%

1 838 056

-21,7%

2 347 544

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

Sub Total Divers

Net

532 595

-71,0%

1 838 056

-21,7%

2 347 544

 

Prepaid expenses

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Prepaid expenses

Net

5 031 182

-14,9%

5 913 736

-26,0%

7 990 017

Gross

CH

5 031 182

-14,9%

5 913 736

-26,0%

7 990 017

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

  

Equalization accounts (IV to VI)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Multi-period charges

CW3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Currency differential gain

CN3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

  

References

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Due within one year

CP

5 361

0%

0

0%

13 703

Due after one year

CR

21 738

0%

0

0%

41 025

 

 

Display parameter

Currency

 Euro

 Kilo Euro


Accounts - Passive 
Other capital resources | Provisions for risks and charges | Liabilities | Translation loss | Equalization accounts | References 


Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Grand Total (I to V)

EE

60 770 495

-16,7%

72 916 879

-12,5%

83 323 137

 

Shareholder Equity (I)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total shareholders' equity (Total I)

DL

1 216 052

117,7%

-6 865 335

-208,5%

6 330 326

Equity and shareholders' equity

DA

1 376 700

0%

1 376 700

0%

1 376 700

Issue and merger premiums

DB

7 236

0%

7 236

0%

7 236

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

Legal reserve

DD

137 670

0%

137 670

0%

137 670

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

Other reserves

DG

3 647 033

0%

3 647 033

0,0%

3 646 068

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

0

0%

0

Profits or losses brought forward

DH

-8 708 824

0%

0

0%

0

Profit or loss for the period

DI

2 679 980

119,5%

-13 709 069

-1796,1%

808 265

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

Special tax-allowable reserves

DK

2 076 257

23,9%

1 675 095

372,7%

354 387

  

Other capital resources (II)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

  

Provisions for risks and charges (III)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

2 716 062

-40,9%

4 595 989

4,6%

4 395 887

Risk provisions

DP

0

0%

0

0%

0

Reserves for charges

DQ

2 716 062

-40,9%

4 595 989

4,6%

4 395 887

  

Liabilities (IV)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total Liabilities (Total IV)

EC

56 838 381

-24,4%

75 186 226

3,6%

72 596 925

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

Bank loans and liabilities

DU

1 608 195

9,2%

1 473 101

743,8%

174 580

Sundry loans and financial liabilities

DV

15 000

0%

15 000

0%

15 000

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

Advance payments received for current orders

DW

9 694 971

-55,3%

21 704 007

-12,2%

24 706 820

Trade accounts payables

DX

34 998 473

-1,8%

35 649 249

-4,0%

37 140 940

Tax and social security liabilities

DY

9 457 126

-1,2%

9 572 680

-5,6%

10 144 032

Fixed asset liabilities

DZ

340 390

316,2%

81 779

-70,6%

278 064

Other debts

EA

724 226

-89,2%

6 690 410

4766,1%

137 489

  

Translation loss (V)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Translation loss (Total V)

ED

0

0%

0

0%

0

  

Equalization accounts

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Deferred income

EB

0

0%

0

0%

0

  

References

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

Deferred income and liabilities

EG

47 128 411

-11,9%

53 482 218

11,7%

47 875 105

Of which current bank facilities

EH

1 608 195

9,2%

1 473 101

743,8%

174 580

 

 

Display parameter

Currency

 Euro

 Kilo Euro


Result account 
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges | Financial income | Financial charges | Financial charges | Extraordinary charges | Employee profit sharing | Tax on profits | References 


1- Operating result (I-II)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Operating result (Total I-II)

GG

4 018 334

141,5%

-9 682 936

-660,2%

1 728 605

 

2 - Financial result (V - VI)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Financial result (Total V-VI)

GV

141 073

227,3%

43 101

-81,0%

226 476

 

3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

4 159 407

143,1%

-9 639 835

-593,1%

1 955 081

 

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

-641 555

85,1%

-4 315 500

-2624,9%

-158 372

 

Profit or loss

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Profit or loss

HN

2 679 979

119,5%

-13 709 069

-1796,1%

808 265

 

Total Income (I+III+V+VII)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total Income (I+III+V+VII)

HL

215 945 656

1,2%

213 381 475

-8,9%

234 100 863

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

213 265 676

-6,1%

227 090 544

-2,7%

233 292 595

 

Operating income (I)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total operating income (Total I)

FR

210 501 258

-0,3%

211 076 604

-8,8%

231 540 433

 

Operating income (details)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Sale of goods for resale

FC

169 156 006

-5,4%

178 793 798

-11,0%

200 953 865

France

FA

150 779 143

-5,1%

158 925 249

-11,0%

178 540 493

Export

FB

18 376 863

-7,5%

19 868 549

-11,4%

22 413 372

Sale of goods produced

FF

0

0%

0

0%

0

France

FD

0

0%

0

0%

0

Export

FE

0

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

22 027 400

-8,6%

24 102 609

4,2%

23 125 891

France

FG

18 017 627

-6,9%

19 354 191

-10,0%

21 494 408

Export

FH

4 009 773

-15,6%

4 748 418

191,0%

1 631 483

Net turnover

FL

191 183 406

-5,8%

202 896 407

-9,5%

224 079 756

France

FJ

168 796 770

-5,3%

178 279 440

-10,9%

200 034 901

Export

FK

22 386 636

-9,1%

24 616 967

2,4%

24 044 855

Stocked production

FM

0

0%

0

0%

0

Self-constructed assets

FN

198 920

0%

0

0%

0

Operating grants

FO

0

0%

0

0%

0

Release of reserves and provisions

FP

5 514 333

20,3%

4 584 321

43,5%

3 194 959

Other income

FQ

13 604 599

278,3%

3 595 876

-15,7%

4 265 718

 

Operating charges (II)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total operating charges (Total II)

GF

206 482 924

-6,5%

220 759 540

-3,9%

229 811 828

 

Exploitation charges

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Purchase of goods for resale

FS

69 748 695

-15,0%

82 053 023

-12,7%

93 980 083

Change in stocks of goods for resale

FT

8 533 443

1121,5%

-835 355

92,0%

-10 504 644

Purchase of raw materials

FU

0

0%

0

0%

0

Change in stocks of raw materials

FV

0

0%

0

0%

0

Other external purchases and charges

FW

92 188 380

-10,3%

102 773 779

-5,2%

108 461 804

Tax, duty and similar payments

FX

2 791 346

-4,3%

2 917 852

-15,3%

3 445 495

Payroll

FY

19 755 192

-3,7%

20 506 806

0,1%

20 486 056

Social security costs

FZ

9 410 414

9,4%

8 601 432

11,8%

7 696 356

 

Depreciation

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Depreciation of fixed assets

GA

890 657

-13,0%

1 023 916

-0,7%

1 030 936

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

0

Depreciation/amortisation of current assets

GC

1 928 430

-18,5%

2 365 097

-3,3%

2 445 732

Provisions for risks and charges

GD

262 596

215,7%

83 185

-95,6%

1 904 247

 

Other charges

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Other charges

GE

973 771

-23,3%

1 269 805

46,7%

865 763

  

Operating charges (III-IV)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

  

Financial income (V)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total financial income (Total V)

GP

1 820 815

2,1%

1 783 661

-21,6%

2 274 992

Share financial income

GJ

0

0%

250 816

0%

0

Other investment income & capitalised receivables

GK

750

-34,8%

1 151

-25,5%

1 544

Other interest and similar income

GL

306 352

-51,8%

635 473

-46,3%

1 183 852

Released provisions and transferred charges

GM

104 772

-59,0%

255 569

293,2%

65 000

Exchange gains

GN

1 408 941

119,9%

640 652

-37,5%

1 024 596

Net income from disposal of investment securities

GO

0

0%

0

0%

0

  

 

Financial Charge (VI)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total financial charge (Total VI)

GU

1 679 742

-3,5%

1 740 560

-15,0%

2 048 516

Financial reserves and provisions

GQ

122 455

4098,0%

2 917

-98,9%

266 014

Interest and similar charges

GR

376 810

37,1%

274 926

55,6%

176 638

Exchange losses

GS

1 180 477

-19,3%

1 462 717

-8,9%

1 605 864

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

  

Extraordinary income (VII)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total extraordinary income (Total VII)

HD

3 623 583

595,2%

521 210

82,6%

285 438

Extraordinary operating income

HA

519 088

-0,4%

521 210

0%

0

Extraordinary income from capital transactions

HB

0

0%

0

0%

17 478

Released provisions and transferred charges

HC

3 104 495

0%

0

0%

267 960

  

Extraordinary charges (VIII)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

4 265 138

-11,8%

4 836 710

989,8%

443 810

Extraordinary operating charges

HE

2 660 028

309,2%

650 016

272,8%

174 354

Extraordinary charges from capital transactions

HF

13 225

227,2%

4 042

-96,3%

110 232

Extraordinary reserves and provisions

HG

1 591 885

-61,9%

4 182 652

2526,9%

159 224

  

Employee profit sharing (IX)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

145 643

853,5%

-19 328

-104,4%

441 713

  

Tax on profits (X)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Tax on profits (Total X)

HK

692 229

405,0%

-226 938

-141,5%

546 728

  

References

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Of which equipment leases

HP

462 925

0%

0

0%

0

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

Of which transferred charges

A1

2 273 918

0%

0

0%

0

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

998 410

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

86 252

0%

0

0%

0

 

 

 

Display parameter

Currency

 Euro

 Kilo Euro


Other incomes tax return forms 
Reserve for depreciation | Provisions included in balance sheet | State deadlines claims and debts at the end of period
Table allocation results and other information 

Fixed Assets
Grand Total Fixed Assets (I to IV)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

OK2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

OL

0

0%

0

0%

0

 

Research and development Charge (Total I)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

C01

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

C02

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

D0

0

0%

0

0%

0

 

Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Gross value at begin of period

KD

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

LV2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

LW

0

0%

0

0%

0

 

Tangible fixed assets (Total III)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Gross value at begin of period

LN

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NG2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

NH

0

0%

0

0%

0

 

Fiancial assets (Total IV)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Gross value at begin of period

LQ

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NJ2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

NK

0

0%

0

0%

0

  

Reserve for depreciation
Situation and movement of reserve for depreciation
Grand total (I-II-III)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Reserve for depreciation value at begin of period

0N

0

0%

0

0%

0

Increases

0P

0

0%

0

0%

0

Decreasess

0Q

0

0%

0

0%

0

Reserve for depreciation value at the end of period

0R

0

0%

0

0%

0

 

Research and development charge (Total I)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0

 

Other intangible assets (Total II)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

0

0%

0

0%

0

Increases

PF

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PG

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

PH

0

0%

0

0%

0

 

Total fixed assets amotisation (Total III)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

0

0%

0

0%

0

Increases

QV

0

0%

0

0%

0

Decreases

QW

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

QX

0

0%

0

0%

0


Movements during period affecting charge allocated over several period 

Charges à répartir ou frais d'émission d'emprunt

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0

 

Premium refund of obligations

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Net value at begining of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

  

Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Value at begining of period

7C

0

0%

0

0%

0

Increases

UB

0

0%

0

0%

0

Decreases

UC

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

UD

0

0%

0

0%

0

Includes Total allocations

Operating

UE

0

0%

0

0%

0

Financial

UG

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UJ

0

0%

0

0%

0

Includes Total Withdrawal

Operating

UF

0

0%

0

0%

0

Financial

UH

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UK

0

0%

0

0%

0

 

Total regulated provisions (Total I)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Value at begining of period

3Z

0

0%

0

0%

0

Increases

TS

0

0%

0

0%

0

Decreases

TT

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

TU

0

0%

0

0%

0

 

Total risk and charge provisions (Total II)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Value at begining of period

5Z

0

0%

0

0%

0

Increases

TV

0

0%

0

0%

0

Decreases

TW

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

TX

0

0%

0

0%

0

 

Total Provision for depreciation (Total III)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Value at begining of period

7B

0

0%

0

0%

0

Increases

TY

0

0%

0

0%

0

Decreases

TZ

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

UA

0

0%

0

0%

0

  

State deadlines claims and debts at the end of period
State claims

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Gross value

VT

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VU

0

0%

0

0%

0

More than one year

VV

0

0%

0

0%

0

 

State of loans

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Claims related to holdings (gross)

UL

0

0%

0

0%

0

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

0%

0

0%

0

Loans (gross)

UP

0

0%

0

0%

0

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

0

0%

0

Other financial assets (gross)

UT

0

0%

0

0%

0

Other financial assets (1 year at most)

UV

0

0%

0

0%

0

 

Receivables statement of assets

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Customers doubtful or disputed

VA

0

0%

0

0%

0

Other claims customer

UX

0

0%

0

0%

0

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts

UY

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

0

0%

0

Income taxes

VM

0

0%

0

0%

0

Value added tax

VB

0

0%

0

0%

0

Other taxes and payments assimilated

VN

0

0%

0

0%

0

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

0

0%

0

Group and Associates

VC

0

0%

0

0%

0

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

0

0%

0

0%

0

 

Prepaid

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Prepaid

VS

0

0%

0

0%

0

 

State Debt

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total debt (gross)

VY

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

VZ4

0

0%

0

0%

0

 

Details

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VG2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VH2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8A2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8A3

0

0%

0

0%

0

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8B2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8B3

0

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8C2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8D2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (gross)

VW1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VW2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VQ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8J2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VI2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More 5 years

VI4

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8K2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8L2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0

 

References

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Loans made during the period

VJ

0

0%

0

0%

0

Debt repaid during the period

VK

0

0%

0

0%

0

  

Table allocation results and other information 
Dividends distributed

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0

 

Commitments

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0

 

Other charges Externes

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0

 

Taxes and Fees

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0

 

VAT

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0

 

Average number of employees

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Average number of employees

YP

0

0%

765

0%

0

 

Groups and Shareholders

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Groups and Shareholders

ZR

0

0%

0

-

-

 

 

 

Display parameter

Comparison mode

 Average

 Median


Ratios 
Structure and liquidity | Management or rotation | Profitability of the business | Return on capital 

Structure and Liquidity

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Sector Median2012

Fixed Asset Financing

1,02

30,8%

0,78

-40,9%

1,32

2,18

-53,2%

Global Debt

107 days

-19,5%

133 days

13,7%

117 days

127 days

-15,7%

Working Capital Fund overall net

1 days

111,1%

-9 days

-175,0%

12 days

46,50days

-97,8%

Financial independence

75,62%

116,2%

-466,05%

-112,9%

3626,03%

90,44%

-16,4%

 More ratios

Solvability

2%

121,2%

-9,42%

-223,9%

7,60%

22,82%

-91,2%

Capacity debt futures

%

-

%

-

%

322,34%

-

Coverage of current assets by net working capital overall

0,86%

111,7%

-7,34%

-174,7%

9,82%

37,86%

-97,7%

General Liquidity

-

-

0,22

-

Restricted Liquidity

-

-

0,67

-

 

Management or rotation

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Sector Median2012

Need background in operating working capital

-7 days

65,0%

-20 days

-400%

-4 days

0 days

0%

Treasury

-2 days

-300%

1 days

-66,7%

3 days

5 days

-140,0%

Inventory turnover of goods

133 days

-19,9%

166 days

5,1%

158 days

84 days

58,3%

Average length of credit granted to customers

27 days

-10,0%

30 days

76,5%

17 days

6 days

350,0%

Average length of credit obtained suppliers

74 days

5,7%

70 days

0%

70 days

41 days

80,5%

More ratios

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

0 days

0%

0 days

0%

0 days

0 days

0%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

days

-

days

-

days

1239 days

-

Rotation tangible assets

%

-

%

-

%

2184,92%

-

 

Profitability of the business

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Sector Median2012

Margin trading

47,53%

-1,2%

48,09%

-8,3%

52,43

34,26%

38,7%

Profitability of the business

-5,78

10,7%

-6,47

-2913,0%

0,23

1,73%

-434,1%

Net profit

1,40%

120,7%

-6,76%

-1977,8%

0,36%

0,71%

97,2%

 More ratios

Growth rate of turnover (excluding VAT)

-14,68%

-55,3%

-9,45%

42,6%

-16,45%

3,03%

-584,5%

Rates integration

10,94%

17,4%

9,32%

-35,0%

14,34%

12,76%

-14,3%

Rate leasing furniture

0,24%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Work Factor

139,47%

-9,4%

153,97%

75,6%

87,68%

24,07%

479,4%

Weight interests

0,88

2,3%

0,86%

-5,5%

0,91%

0,05%

1660,0%

 

Return on capital

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Sector Median 2012

Cash flow from the overall profitability

2,77%

166,1%

-4,19%

-499,0%

1,05%

1,96%

41,3%

Rates of economic profitability

-389%

-259,4%

244%

2950,0%

8%

14%

-2878,6%

Financial profitability

1216052%

117,7%

-6865335%

-208,5%

6330326%

110,02%

1105200,9%

Return on investment

153,55%

-31,0%

222,58%

407,9%

43,82%

9,63%

1494,5%

 

 

Display parameter

Currency

 Euro

 Kilo Euro

Comparison mode

 Average

 Median

 

Soldes Intermédiaires de Gestion 

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Sector Median 2012

Turnover

191 183 406

-5,8%

202 896 407

-9,5%

224 079 756

92 168 € 

207329,3% 

 

Sales of goods

169 156 006

-5,4%

178 793 798

-11,0%

200 953 865

 

 

- Purchase of goods

69 748 695

-15,0%

82 053 023

-12,7%

93 980 083

 

 

+/- Stock of goods variation

8 533 443

1121,5%

-835 355

92,0%

-10 504 644

 

 

Trading margin

90 873 868 €

-6,9%

97 576 130 €

-16,9%

117 478 426 €

22 825 € 

398033,0% 

47,53 % CA

-1,2%

48,09 % CA

-8,3%

52,43 % CA

35,09 % CA 

35,5% 

 

Sale of goods produced

22 027 400

-8,6%

24 102 609

4,2%

23 125 891

 

 

+/- Stocked production

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Self-constructed assets

198 920

0%

0

0%

0

 

 

Period production

22 226 320 €

-7,8%

24 102 609 €

4,2%

23 125 891 €

2 839 € 

782792,6% 

11,63 % CA

-2,1%

11,88 % CA

15,1%

10,32 % CA

6,48 % CA 

79,5% 

 

Trading margin

90 873 868

-6,9%

97 576 130

-16,9%

117 478 426

22 825 

398033,0% 

+ Period Production

22 226 320

-7,8%

24 102 609

4,2%

23 125 891

2 839 

782792,6% 

- Purchase of raw materials

0

0%

0

0%

0

 

 

+/- Change in stocks of raw materiels

0

0%

0

0%

0

 

 

- Other external purchases and charges

92 188 380

-10,3%

102 773 779

-5,2%

108 461 804

 

 

Added value

20 911 808 €

10,6%

18 904 960 €

-41,2%

32 142 513 €

11 077 € 

188685,8% 

10,94 % CA

17,4%

9,32 % CA

-35,0%

14,34 % CA

12,76 % CA 

-14,3% 

 

Added value

20 911 808 €

10,6%

18 904 960 €

-41,2%

32 142 513 €

11 077 € 

188685,8% 

+ Operating grants

0

0%

0

0%

0

 

 

- Tax, duty and similar payments

2 791 346

-4,3%

2 917 852

-15,3%

3 445 495

 

 

- Personal charges

29 165 606

0,2%

29 108 238

3,3%

28 182 412

 

 

Gross operating surplus

-11 045 144 €

15,8%

-13 121 130 €

-2649,7%

514 606 €

1 463 € 

-755065,4% 

-5,78 % CA

10,7%

-6,47 % CA

-2913,0%

0,23 % CA

1,73 % CA 

-434,1% 

 

Gross operating surplus

-11 045 144 €

15,8%

-13 121 130 €

-2649,7%

514 606 €

1 463 € 

-755065,4% 

+ Release of reserves and provisions

5 514 333

20,3%

4 584 321

43,5%

3 194 959

 

 

+ Other operating income

13 604 599

278,3%

3 595 876

-15,7%

4 265 718

 

 

- Depreciation/Amortisation

3 081 683

-11,2%

3 472 198

-35,5%

5 380 915

 

 

- Other charges

973 771

-23,3%

1 269 805

46,7%

865 763

 

 

Operating result

4 018 334 €

141,5%

-9 682 936 €

-660,2%

1 728 605 €

381 € 

1054580,8% 

2,10 % CA

144,0%

-4,77 % CA

-719,5%

0,77 % CA

0,76 % CA 

176,3% 

 

Operating result

4 018 334 €

141,5%

-9 682 936 €

-660,2%

1 728 605 €

381 € 

1054580,8% 

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Financial income

1 820 815

2,1%

1 783 661

-21,6%

2 274 992

 

 

- Financial charges

1 679 742

-3,5%

1 740 560

-15,0%

2 048 516

 

 

Pre-tax result

4 159 407 €

143,1%

-9 639 835 €

-593,1%

1 955 081 €

312 € 

1333043,3% 

2,18 % CA

145,9%

-4,75 % CA

-646,0%

0,87 % CA

0,61 % CA 

257,4% 

 

Extraordinary income

3 623 583

595,2%

521 210

82,6%

285 438

0% 

- Extraordinary charges

4 265 138

-11,8%

4 836 710

989,8%

443 810

 

 

Extraordinary result

-641 555 €

85,1%

-4 315 500 €

-2624,9%

-158 372 €

0 € 

0% 

-0,34 % CA

84,0%

-2,13 % CA

-2942,9%

0 % CA

0 % CA 

0% 

 

Pre-tax result

4 159 407 €

143,1%

-9 639 835 €

-593,1%

1 955 081 €

312 € 

1333043,3% 

Extraordinary result

-641 555 €

85,1%

-4 315 500 €

-2624,9%

-158 372 €

0 € 

0% 

- Employee profit sharing

145 643

853,5%

-19 328

-104,4%

441 713

 

 

- Tax on profits

692 229

405,0%

-226 938

-141,5%

546 728

 

 

Net result

2 679 980 €

119,5%

-13 709 069 €

-1796,1%

808 268 €

491 € 

545720,8% 

1,40 % CA

120,7%

-6,76 % CA

-1977,8%

0,36 % CA

0,72 % CA 

94,4% 

 

 

Commentary

 

The comments are ordered according to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative for another or can change depending on its value. This is a purely statistical decision.

The liabilities are 56,838,381 €

The net current assets are 57,306,037 €

The net turnover is 191,183,406 €

The pre-tax profit is 3,372,208 €

The risk provisions are 2,716,062 €

The total assets are 60,770,495 €

Low risk workforce size

The company has 5 directors

Department code with medium risk rating

Industry code with medium risk rating

The shareholder's equity is 1,216,052 €

The sales to current assets ratio is 3,34

The creditor days are 66.82

The return on total assets employed is 5,55

The ratio total assets to total liabilities is 1,02

The stock to turnover ratio is 14.28

The increase in the gearing percentage over the last two accounting periods is 503 %

 

 

judgements

Collective procedures

 

No judgment information for the company

 

   Social security, pension funds preferential rights | Tax office preferential rights

Preferential rights details and history

Summary of preferential rights

Company monitored since

04/11/2008

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

 

 

Group data

Ultimate parent company

KERING

Direct parent

REDCATS - 100 %

Group – Number of companies

445

Linkages – Number of companies

104

Number of countries

16

 

Group Structure

 

Go directly to the current company

Display only where participation % > 33 %

Display all participations

Company Name

SIREN

Parts

Last account published

 KERING

 

552075020

-

31/12/2008

 REDCATS

 

321164253

100%

31/12/2010

 CYRILLUS (SUISSE) SA

 

238927

100%

-

 ELLOS GROUP AB

 

5562171925

100%

31/12/2012

 REDCATS

 

US00978216

100%

-

 BARBICAN BV

 

-

100%

-

 SAS LES AUBAINES MAGASINS

 

421206749

100%

31/12/2012

 CYRILLUS

 

421022997

100%

28/03/2013

 CYRILLUS JAPON

 

-

100%

-

 CYRILLUS BENELUX SA

 

442112340

100%

31/12/2012

 SOMEWHERE

 

414872903

100%

31/12/2011

 CYRILLUS DEUTSCHLAND GMBH

 

HRB 14099

100%

31/12/2010

 REDOUTE VERSAND GMBH

 

-

100%

-

 REDCATS BETEILIGUNG GMBH

 

-

100%

-

 LA REDOUTE MAG

 

414872747

100%

31/12/2012

 VBMAG

 

397555327

100%

28/03/2013

 CYRILLUS (UK) LIMITED

 

03132565

100%

31/12/2012

 REDCATS ASIA LIMITED

 

-

100%

-

 THOMAS INDUSTRIES

 

353202369

100%

28/03/2013

 REDCATS INTERNATIONAL HOLDING

 

642000343

100%

31/12/2011

 REDCATS PORTUGAL

 

-

100%

-

 REDCATS SUISSE SA

 

753397

100%

-

 LA REDOUTE

 

477180186

100%

31/12/2012

 REDOUTE NORWAY AS

 

-

100%

-

 REDOUTE RUSSIE

 

-

100%

-

 RELAIS COLIS

 

785792433

100%

31/12/2012

 MERKURE SA NV

 

-

90%

-

 MOVITEX

 

756200150

100%

31/12/2012

 MOVITEX (UK) LIMITED

 

00400458

100%

31/12/2012

 LES TROUVAILLES

 

421305186

100%

31/12/2012

 LA REDOUTE CATALOGUE BENELUX SA

 

404047956

100%

31/12/2012

 REDCATS (UK) LIMITED

 

00106691

100%

31/12/2012

 REDCATS

 

US00978216

100%

-

 REDOUTE UK

 

-

100%

-

 EMPIRE STORES (BRADFORD) LIMITED

 

00222350

100%

31/12/2003

 EMPIRE STORES MERCHANDISE LTD

 

-

100%

-

 REDCATS 2013 LIMITED

 

00142234

100%

31/12/2012

 EMPIRE CATALOGUES LTD

 

-

100%

-

 EMPIRE DIRECT LTD

 

-

100%

-

 EMPIRE HOME SHOPPING LTD

 

-

100%

-

 REDCATS FINANCE LIMITED

 

02842457

100%

31/12/2012

 EMPIRE SHOPPER LTD

 

-

100%

-

 HOLDSWORTH COLLECTIONS LIMITED

 

00146336

100%

31/12/2012

 REDCATS INTERNATIONAL

 

421237082

100%

31/12/2011

 REDCATS MANAGEMENT SERVICES

 

421232513

100%

31/12/2011

 REDCATS ESPAÑA

 

8310

100%

31/12/2012

 DIAM

 

414594531

100%

31/12/2011

 LA REDOUTE SVERIGE AB

 

5565520813

100%

31/12/2012

 REDCATS ITALY SOCIETA' A RESPONSAB...

 

MI1851506

100%

31/12/2010

 REDOUTE HELLAS

 

-

100%

-

 ELLOS FINLAND OY

 

14421316

100%

31/12/2011

 SADAS

 

414766576

100%

28/03/2013

 SNC LES DEFIS DE VERT BAUDET

 

393327309

99.99%

28/03/2013

 VERTBAUDET DEUTSCHLAND GMBH

 

HRB 10908

50%

31/12/2011

 VERTBAUDET GMBH & CO

 

-

50%

-

 REDCATS INTERNATIONAL HOLDING B.V.

 

24274960

100%

31/12/2009

 REDCATS FINANS AB

 

5563115301

100%

31/12/2012

 REDCATS DO BRASIL

 

-

100%

-

 REDCATS

 

US00978216

100%

-

 REDCATS USA DROP SHIP

 

-

100%

-

 VLP CORPORATION

 

-

100%

-

 S.P.S. INVESTMENT, LLC

 

US15125528

100%

-

 BNY SERVICE CORPORATION

 

-

100%

-

 REDCATS USA MANAGEMENT SERVICES LP

 

-

100%

-

 JESSICA LONDON INC

 

-

100%

-

 UNITED RETAIL HOLDING CORP

 

US03774304

100%

-

 UNITED RETAIL DISTRIBUTION SERVICES INC.

 

-

100%

-

 UNITED RETAIL INC.

 

-

100%

-

 UNITED RETAIL LOGISTIC OPERATION INC.

 

-

100%

-

 AVENUE GIFT CARDS INC.

 

-

100%

-

 REDCATS MANAGEMENT CONSULTING (SHANGHAI)

 

-

100%

-

 REDCATS INDIA PRIVATE LIMITED

 

-

100%

-

 REDCATS TEKSTIL ITHALAT VE IHRACAT TICAR...

 

-

100%

-

 REF BRESIL

 

403876501

99.90%

31/12/2010

 REDCATS (BRANDS) LIMITED

 

00110433

100%

31/12/2012

 REDCATS USA GIFT CARD

 

-

100%

-

 TGW MANAGEMENT SERVICES INC

 

-

100%

-

 THE SPORTMAN'S GUIDE OUTLET INC

 

-

100%

-

 TSG MANAGEMENT SERVICES, INC

 

US00863803

100%

-

 REDCATS ASIA GLOBAL SOURCING SERVICES

 

-

100%

-

 GIORNICA

 

513469981

100%

31/12/2011

 RUSA TEXAS LLC

 

-

100%

-

 REDCATS BUSINESS DEVELOPMENT

 

533214433

100%

31/12/2011

 REDCATS USA CANADA HOLDING INC

 

-

100%

-

 REDCATS COMMERCE ET TRADING

 

-

100%

-

 PUMA

 

-

80%

-

 PUMA VERTRIEB GMBH

 

HRB 8762

100%

-

 PUMA FRANCE SAS

 

578504102

100%

31/12/2006

 PUMA SPEEDCAT

 

479989360

100%

-

 PUMA SPRINT GMBH

 

HRB 10302

100%

-

 PUMA AVANTI GMBH

 

HRB 10303

100%

-

 PUMA MOSTRO GMBH

 

HRB 10321

100%

-

 PREMIER FLUG GMBH & CO. KG

 

HRA 14726

50%

31/12/2012

 AUSTRIA PUMA DASSLER GES. MBH

 

-

100%

-

 PUMA BULGARIA EOOD

 

-

100%

-

 PUMA SPORT HRVATSKA DOO

 

-

100%

-

 PUMA DENMARK A/S

 

-

100%

-

 PUMA ESTONIA

 

-

100%

-

 PUMA FINLAND OY

 

17520782

100%

31/12/2011

 TRETORN FINLAND OY

 

17016666

100%

31/12/2011

 PUMA UNITED KINGDOM LTD

 

03712972

100%

31/12/2012

 PUMA PREMIER LTD

 

05347587

100%

31/12/2012

 PUMA HELLAS SA

 

-

100%

-

 PUMA HUNGARY KFT.

 

-

100%

-

 TRETORN R&D LTD

 

-

100%

-

 PUMA ITALIA S.R.L.

 

MI1509441

100%

31/12/2012

 PUMA BALTIC UAB

 

-

100%

-

 PUMA MALTA LTD

 

-

100%

-

 PUMA BLUE SEA LTD

 

-

100%

-

 PUMA RACING LTD

 

-

100%

-

 PUMA NORWAY AS

 

982719747

100%

31/12/2012

 PUMA BENELUX B.V.

 

27149853

100%

31/12/2011

 PUMA POLSKA SPOLKA ZOO

 

-

100%

-

 PUMA PORTUGAL ARTIGOS DESPORTIVOS LDA

 

-

100%

-

 PUMA CZECH REPUBLIC SRO

 

-

100%

-

 PUMA SPORT ROMANIA SRL

 

-

100%

-

 PUMA-RUS GMBH

 

-

100%

-

 PUMA SLOVAKIA SRO

 

-

100%

-

 PUMA LJUBLJANA TRGOVINA DOO

 

-

100%

-

 HUNT SPORT AKTIEBOLAG

 

5561798959

100%

31/12/2012

 TRETORN AKTIEBOLAG

 

5560068792

100%

31/12/2012

 PUMA NORDIC AB

 

5562337880

100%

31/12/2012

 TRETORN SWEDEN AB

 

5561537621

100%

31/12/2012

 MOUNT PUMA AG

 

241794

100%

-

 PUMA RETAIL AG

 

4995049

100%

-

 PUMA SCHWEIZ AG

 

-

100%

-

 PUMA UKRAINE LTD

 

-

100%

-

 UNISOL SA

 

-

100%

-

 PUMA SPORTS LTDA

 

-

100%

-

 PUMA CANADA INC.

 

-

100%

-

 PUMA CHILE SA

 

-

100%

-

 PUMA SUÈDE HOLDING INC.

 

-

100%

-

 PUMA NORTH AMERICA, INC

 

US43784313

100%

-

 LIBERTY CHINA HOLDING LTD

 

-

100%

-

 PUMA MEXICO SPORT SA DE CV

 

-

100%

-

 SERVICIOS PROFESIONALES RDS

 

-

100%

-

 DISTRUIBUIDORA DEPORTIVA PUMA SAC

 

-

100%

-

 PUMA SPORTS LA

 

-

100%

-

 PUMA SPORTS DISTRIBUTORS (PTY) LIMITED

 

-

100%

-

 PUMA SPORTS S.A.

 

-

100%

-

 PUMA AUSTRALIA PTY LTD

 

-

100%

-

 WHITE DIAMOND AUSTRALIA PTY LTD

 

-

100%

-

 WHITE DIAMOND PROPERTIES

 

-

100%

-

 KALOLA PTY LTD

 

-

100%

-

 PUMA NEW ZEALAND LTD

 

-

100%

-

 PUMA MIDDLE EAST FZ LLC

 

-

100%

-

 PUMA UAE LLC

 

-

100%

-

 PUMA SPOR GIYIM SANANYI VE TICARET

 

-

100%

-

 PUMA CHINA LTD

 

-

100%

-

 WORLD CAT LTD

 

-

100%

-

 DEVELOPMENT SERVICES LTD

 

-

100%

-

 PUMA ASIA PACIFIC LTD

 

-

100%

-

 PUMA HONG KONG LTD

 

-

100%

-

 PUMA SPORTS INDIA PVT LTD

 

-

100%

-

 WORLD CAT SOURCING INDIA LTD

 

-

100%

-

 PUMA JAPAN KK

 

-

100%

-

 PUMA KOREA LTD

 

-

100%

-

 PUMA SPORTS GOODS SDN. BHD.

 

-

100%

-

 PUMA SPORTS SINGAPORE PTE LTD

 

-

100%

-

 PUMA TAIWAN SPORTS LTD

 

-

100%

-

 BRANDON COMPANY AB

 

5567065213

100%

31/12/2012

 PUMA CYPRUS LTD

 

-

100%

-

 PUMA SERVICIOS SPA

 

-

100%

-

 WORLD CAT VIETNAM CO LTD

 

-

100%

-

 DOBOTEX INTERNATIONAL B.V.

 

16079471

100%

31/12/2012

 DOBOTEX FRANCE

 

515379444

100%

31/12/2012

 PUMA SERBIA DOO

 

-

100%

-

 DOBOTEX ÖSTERREICH GMBH

 

-

100%

-

 BRANDON GERMANY GMBH

 

HRB 12941

100%

31/12/2012

 DOBOTEX DEUTSCHLAND GMBH

 

HRB 62785

100%

31/12/2012

 BRANDON MERCHANDISING UK

 

-

100%

-

 DOBOTEX B.V.

 

16068007

100%

31/12/2012

 DOBO LOGIC B.V.

 

17199298

100%

31/12/2012

 DOBOTEX LICENSING HOLDING B.V.

 

17199290

100%

31/12/2012

 BRANDON AS

 

988254231

100%

03/12/2012

 BRANDON AB

 

5564470390

100%

31/12/2012

 2EXPRESSIONS MERCHANDISE SVENSKA A...

 

5566450499

100%

31/12/2012

 BRANDON SERVICES AB

 

5565733374

51.20%

31/12/2012

 BRANDON STOCKHOLM AB

 

5563671311

100%

31/12/2011

 BRANDON LOGISTICS AB

 

5566770540

100%

31/12/2011

 BRANDON OY

 

15133906

100%

31/12/2009

 DOBOTEX SWITZERLAND AG

 

-

100%

-

 S C COMMUNICATION

 

US25390627

100%

-

 DOBOTEX CHINA LTD

 

-

100%

-

 DOBOTEX LTD

 

-

100%

-

 DOBO CAT

 

-

100%

-

 DOBOTEX ITALIA S.R.L.

 

MI1908646

100%

31/12/2012

 COBRA GOLF INCORPORATED

 

US16344676

100%

-

 BRANDON GERMANY GMBH

 

HRB 12941

100%

31/12/2012

 TRETORN NORWAY AS

 

-

100%

-

 PUMA IBERIA

 

4192450

100%

31/12/2012

 IMPORTACIONES RDS S.A. DE C.V

 

-

100%

-

 PUMA INDIA RETAIL PVT

 

-

100%

-

 DOBOTEX KOREA LTD

 

-

100%

-

 DOBOTEX (UK) LIMITED

 

05481641

100%

31/12/2012

 DOBOTEX SPAIN

 

5095705

100%

-

 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA TACNA S.A.C

 

-

100%

-

 PUMA WHEAT ACCESSORIES LTD

 

-

51%

-

 JANED LLC

 

-

51%

-

 GUANGZHOU WORLD CAT INFORMATION CONSULTI...

 

-

100%

-

 TREMI

 

414819342

99.80%

31/12/2011

 CULTURA COMUNIZACIONE SA

 

-

100%

-

 PPR INTERNATIONAL

 

-

40%

-

 PPR ASIA

 

-

92.86%

-

 KERING FINANCE

 

410255665

100%

31/12/2012

 SOCIETE CIVILE BERGSON

 

424844264

Min blocking

-

 MELITTE

 

424773695

99.83%

31/12/2012

 KERING NETHERLANDS B.V.

 

33168497

100%

31/12/2010

 REXCOURTA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

 

MI1432452

100%

31/12/2011

 KERING PURCHASING

 

419021191

50%

31/12/2011

 KERING HOLLAND N.V.

 

33223151

99.93%

31/12/2012

 BALENCIAGA S A

 

775668122

100%

31/12/2012

 GG LUXURY GOODS GMBH

 

HRB 140451 B

100%

31/12/2011

 YVES SAINT LAURENT GERMANY GMBH

 

HRB 79733 B

100%

31/12/2011

 BOTTEGA VENETA GERMANY GMBH

 

HRB 87204 B

100%

31/12/2012

 GG LUXURY GOODS MAXIMILIANSTRASS...

 

HRB 140247 B

100%

31/12/2010

 GUCCI AMERICA INC

 

US45570981

100%

-

 SERGIO ROSSI

 

US19353678

100%

-

 STELLA MCCARTNEY AMERICA, INC

 

US44709540

100%

-

 YVES SAINT LAURENT AMÉRICA INC.

 

-

100%

-

 YVES SAINT LAURENT AMERICA HOLDING INC.

 

-

100%

-

 BALENCIAGA AMERICA INC.

 

-

100%

-

 GUCCI NORTH AMERICA HOLDINGS INC.

 

-

100%

-

 LUXURY GOODS SPAIN

 

491260

100%

31/12/2012

 LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA

 

45083

100%

31/12/2011

 YVES SAINT LAURENT SPAIN

 

561430

100%

31/12/2012

 BOTTEGA VENETA ESPAÑA

 

723009

100%

31/12/2012

 NOGA LUXE

 

2305551

100%

31/12/2012

 SERGIO ROSSI ESPANA SL

 

-

100%

-

 GUCCI INTERNATIONAL N.V.

 

33231651

100%

-

 GEMINI ARUBA NV

 

-

100%

-

 GUCCI PARTICIPATION B.V.

 

34136213

100%

-

 OLIMA B.V.

 

33195050

100%

-

 GUCCI NETHERLANDS B.V.

 

33302171

100%

-

 GUCCI ASIAN HOLDING B.V.

 

34215817

100%

-

 GUCCIO GUCCI S.P.A.

 

FI438090

100%

31/12/2011

 GUCCI LOGISTICA SOCIETA' PER AZI...

 

FI478423

100%

31/12/2011

 PAOLETTI SRL

 

-

100%

-

 GUCCI IMMOBILIARE LECCIO SRL

 

FI515531

100%

31/12/2011

 SERGIO ROSSI SPA

 

FO287636

100%

31/12/2012

 REGAIN 1957 S.R.L.

 

FI520108

100%

31/12/2011

 G.F. SERVICES S.R.L.

 

MB1857529

100%

31/12/2012

 GUCCI GROUP ITALIA HOLDING SPA

 

-

100%

-

 BLU TONIC SPA

 

-

51%

-

 TIGER FLEX S.R.L.

 

FI523600

100%

31/12/2011

 CAPRI GROUP S.R.L.

 

NA577727

100%

31/12/2010

 PIGINI S.R.L.

 

AN130167

100%

31/12/2012

 DESIGN MANAGEMENT S.R.L.

 

FI515822

100%

31/12/2011

 LUXURY GOODS ITALIA S.P.A.

 

FI478430

100%

31/12/2011

 G.F. LOGISTICA S.R.L..

 

NO197202

100%

31/12/2011

 CARAVEL PELLI PREGIATE S.P.A.

 

PI149310

100%

31/12/2011

 YVES SAINT LAURENT DEVELOPMENT S...

 

FI515255

100%

31/12/2011

 BARUFFI S.R.L.

 

MN233780

100%

31/12/2012

 LUXURY GOODS OUTLET S.R.L.

 

FI208448

100%

31/12/2011

 GAUGUIN S.R.L.

 

BO449153

100%

31/12/2012

 GUCCI FINANZIARIA SPA

 

-

100%

-

 SERGIO ROSSI MANUFACTURING S.R.L...

 

FO309941

100%

31/12/2012

 SERGIO ROSSI RETAIL S.R.L.

 

FO309939

100%

31/12/2012

 GGW ITALIA S.R.L.

 

FI563542

100%

31/12/2011

 GRG S.R.L.

 

FI576015

100%

31/12/2011

 LUXURY GOODS OUTLET EUROPE SAGL

 

-

100%

-

 LUXURY TIMEPIECES (CANADA) INC

 

-

100%

-

 LUXURY GOODS INTERNATIONAL SA

 

-

100%

-

 LUXURY GOODS OPÉRATIONS

 

-

51%

-

 LUXURY TIMEPIECES INTERNATIONAL ...

 

822577

100%

-

 LUXURY GOODS LOGISTIC SA

 

-

51%

-

 GUCCI GROUP WATCHES TAIWAN LIMITED

 

-

100%

-

 GUCCI SHOPS OF CANADA INC.

 

-

100%

-

 YVES SAINT LAURENT UK LIMITED

 

02664806

100%

31/12/2012

 GUCCI GROUP GUAM INC.

 

-

100%

-

 GUCCI AUSTRIA GMBH

 

-

100%

-

 GUCCI AUSTRALIA PTY LTD

 

-

100%

-

 GUCCI IRELAND LIMITED

 

IE349045

100%

28/02/2013

 SAM YVES SAINT LAURENT OF MONACO

 

-

100%

-

 GUCCI SAM

 

-

100%

-

 GUCCI LIMITED

 

00710688

100%

31/12/2012

 SERGIO ROSSI UK LIMITED

 

02707792

100%

31/12/2012

 BIRDSWAN SOLUTIONS LIMITED

 

03060995

100%

31/12/2012

 STELLA MCCARTNEY LTD

 

04169969

100%

31/12/2012

 ALEXANDER MCQUEEN TRADING LIMITE...

 

04438273

100%

31/12/2012

 KERING UK SERVICES LIMITED

 

03611027

100%

31/12/2012

 LUXURY TIMEPIECES (UK) LTD

 

03471623

100%

31/12/2012

 PAINTGATE LIMITED

 

04134338

100%

31/12/2012

 AUTUMNPAPER LIMITED

 

04099265

100%

31/12/2012

 BALENCIAGA UK LTD

 

06277236

100%

31/12/2012

 GUCCI (MALAYSIA) SDN BHD

 

-

100%

-

 GUCCI SINGAPORE PTE LIMITED

 

-

100%

-

 GUCCI BELGIUM SA

 

458944018

100%

31/12/2012

 LA MERIDIANA FASHION SA

 

449057639

100%

31/12/2012

 GUCCI GROUP KOREA LTD

 

-

100%

-

 GUCCI BOUTIQUES INC

 

-

100%

-

 G COMMERCE EUROPE S.P.A.

 

FI515256

100%

31/12/2011

 GUCCI LUXEMBOURG S.A.

 

B69008

100%

31/12/2010

 SERGIO ROSSI INTERNATIONAL S.À R...

 

B74072

100%

31/12/2010

 GG FRANCE HOLDING

 

421025891

100%

31/12/2012

 GUCCI FRANCE

 

632032348

100%

31/12/2011

 GUCCI GROUP WATCHES FRANCE

 

440231488

100%

31/12/2011

 BOTTEGA VENETA FRANCE

 

696920545

100%

31/12/2012

 YVES SAINT LAURENT PARFUMS

 

329746945

100%

31/12/2012

 YVES SAINT LAURENT

 

342547361

100%

31/12/2012

 YVES ST LAURENT BOUTIQUE F...

 

429057276

100%

31/12/2012

 SAPRODIS SERVICES

 

439225178

100%

31/12/2012

 C.MENDES

 

582019063

100%

31/12/2012

 YSL BEAUTE CONSULTING

 

439533522

100%

31/12/2012

 YSL VENTES PRIVEES FRANCE

 

493323232

100%

31/12/2012

 GG FRANCE SERVICES

 

440226876

100%

31/12/2012

 GG FRANCE 10

 

487516759

100%

31/12/2012

 GG FRANCE 11

 

493323406

100%

31/12/2012

 BOUCHERON HOLDING

 

572034932

100%

31/12/2012

 BOUCHERON LUXEMBOURG S.À R.L.

 

B76526

100%

31/12/2010

 BOUCHERON TAÏWAN CO LTD

 

-

100%

-

 BOUCHERON JOAILLERIE (USA) INC

 

-

100%

-

 BOUCHERON

 

330160367

100%

31/12/2012

 LES BOUTIQUES BOUCHERON

 

339290439

100%

31/12/2012

 BOUCHERON (UK) LIMITED

 

00311702

100%

31/12/2012

 GG FRANCE 13

 

501501365

100%

31/12/2011

 BOUCHERON PARFUMS SAS

 

509544086

100%

31/12/2012

 GUCCI THAÏLAND CO. LTD

 

-

100%

-

 GUCCI GROUP (HONG KONG) LIMITED

 

-

100%

-

 LUXURY TIMEPIECES (HONG KONG) LIMITED

 

-

100%

-

 GUCCI GROUP JAPAN HOLDING LIMITED

 

-

100%

-

 GUCCI YUGEN KAISHA

 

-

100%

-

 LUXURY TIMEPIECES JAPAN LIMITED

 

-

100%

-

 GUCCI GROUP JAPAN LIMITED

 

-

100%

-

 BOTTEGA VENETA S.R.L.

 

VI187708

100%

31/12/2012

 BOTTEGA VENETA GUAM

 

-

100%

-

 BOTTEGA VENETA INC

 

US43179869

100%

-

 B.V. SERVIZI S.R.L.

 

VI278222

100%

31/12/2012

 B.V. ITALIA S.R.L.

 

VI269749

100%

31/12/2012

 BOTTEGA VENETA U.K. CO. LIMITED

 

02892235

100%

31/12/2012

 BOTTEGA VENETA SINGAPORE PRIVATE LTD

 

-

100%

-

 BOTTEGA VENETA HONG KONG LTD

 

-

100%

-

 BOTTEGA VENETA KOREA LTD

 

-

100%

-

 BOTTEGA VENETA JAPAN LTD

 

-

100%

-

 BOTTEGA VENETA INTERNATIONAL S.À...

 

B75815

100%

31/12/2009

 GUCCI HUNGARY KFT

 

-

100%

-

 G.T. S.R.L.

 

RN246125

100%

31/12/2012

 BOUCHERON SAM

 

-

100%

-

 BOTTEGA VENETA ASIAN TRADE B.V.

 

-

100%

-

 LUXURY GOODS CZECH REPUBLIC SRO

 

-

100%

-

 BOUCHERON (SUISSE) SA

 

5568159

100%

-

 GUCCI GROUP WATCHES INC.

 

-

100%

-

 GUCCI CARIBBEAN INC.

 

-

100%

-

 LUXURY HOLDINGS, INC

 

US12158153

100%

-

 GUCCI MEXICO SA DE CV

 

-

100%

-

 GUCCI IMPORTACIONES SA DE CV

 

-

100%

-

 RETAIL LUXURY SERVICIOS SA DE CV

 

-

100%

-

 GUCCI (CHINA) TRADING LIMITED

 

-

100%

-

 GUCCI INDIA PRIVATE LIMITED

 

-

100%

-

 BOTTEGA VENETA MALAYSIA SDN BHD

 

-

100%

-

 B.V. OUTLETS

 

-

100%

-

 STELLA MCCARTNEY ITALIA SRL

 

FI523825

100%

31/12/2011

 SOWIND GROUP S.A.

 

396132

50%

-

 GUCCI SWEDEN AB

 

5565568754

100%

31/12/2012

 GUCCI BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD...

 

-

100%

-

 GUCCI NEW ZEALAND LTD

 

-

100%

-

 BOTTEGA VENETA CHINA TRADING LTD

 

-

100%

-

 BOTTEGA VENETA MACAU LTD

 

-

100%

-

 GUCCI MACAU LIMITED

 

-

100%

-

 BALENCIAGA JAPAN LTD

 

-

100%

-

 SERGIO ROSSI BELGIUM SPRL

 

807803033

100%

31/12/2011

 BALENCIAGA FASHION SHANGAI CO LTD

 

-

100%

-

 GPA S.R.L.

 

TO953054

100%

31/12/2010

 BOTTEGA VENETA HOLDING B.V.

 

34212746

100%

-

 BOTTEGA VENETA MEXICO S DE RL DE CV

 

-

100%

-

 BOTTEGA VENETA AUSTRALIA PTY LTD

 

-

100%

-

 BALENCIAGA ASIA PACIFIC LIMITED

 

-

100%

-

 GUCCI GROUP ASIA PACIFIC LIMITED

 

-

100%

-

 YVES SAINT LAURENT (SHANGHAI) TRADING LI...

 

-

100%

-

 LUXURY GOODS RETAIL PRIVATE LGR

 

-

51%

-

 LUXURY GOODS KUWAIT WLL

 

-

49%

-

 LUXURY GOODS QATAR LLC

 

-

49%

-

 PPR LATIN AMERICA

 

-

99.76%

-

 STELLA MAC CARTNEY FRANCE

 

441532504

100%

31/12/2012

 PRODISTRI

 

393444195

100%

31/12/2011

 SNC SAVOISIENNE

 

301690202

99%

31/12/2012

 DISCODIS

 

324951060

100%

31/12/2011

 BUYCO

 

434015988

100%

31/12/2011

 PPR INTERNATIONAL

 

-

60%

-

 PPR ASIA

 

-

92.86%

-

 SOCIETE CIVILE BERGSON

 

424844264

Min blocking

-

 KERING PURCHASING

 

419021191

50%

31/12/2011

 SOC COMMERCE FINANCEMENT PROMOTION

 

552100604

100%

31/12/2009

 DISCODIS INTERNATIONAL SA

 

13143

40%

-

 PRINTEMPS RÉASSURANCE

 

B33692

100%

31/12/2012

 MAREMMA

 

414819367

60%

31/12/2012

 PPR LUXEMBOURG

 

B67593

100%

-

 SNC CONSEIL ET ASSISTANCE

 

394382808

100%

31/12/2011

 AUGUSTIN

 

433627213

99%

31/12/2011

 ALORIS

 

390633774

99%

31/12/2010

 SAPARDIS SE

 

393443601

100%

31/12/2012

 BILLETTERIE HOLDING

 

-

100%

-

 LUMINOSA

 

501339907

99.80%

31/12/2009

 SOCIETE CIVILE ZINNIA

 

433627304

99%

-

 VOLCOM, INC

 

US16676389

100%

-

 VOLCOM RETAIL INC.

 

-

100%

-

 VOLCOM ENTERTAINMENT, INC

 

US17829395

100%

-

 LS&S RETAIL INC.

 

-

100%

-

 VOLCOM OUTLET

 

US47308370

100%

-

 ELECTRIC VISUAL ÉVOLUTION LLC

 

-

100%

-

 VOLCOM INTERNATIONAL SÀRL

 

5312503

100%

-

 VOLCOM SAS

 

488298621

100%

31/12/2011

 VOLCOM RETAIL FRANCE

 

502775869

100%

31/12/2012

 WELCOM DISTRIBUTION SARL

 

820330

100%

-

 VOLCOM DISTRIBUTION SPAIN

 

5070049

100%

31/12/2011

 ELECTRIC VISUAL ÉVOLUTION SPAIN

 

-

100%

-

 ELECTRIC EUROPE

 

432822161

100%

31/12/2012

 VOLCOM DISTRIBUTION (UK) LIMITED

 

06655109

100%

31/12/2012

 VOLCOM RETAIL (UK) LIMITED

 

06629608

100%

31/12/2012

 VOLCOM AUSTRALIA HOLDING COMPANY PTY LTD

 

-

100%

-

 VOLCOM AUSTRALIA PTY LTD

 

-

100%

-

 ELECTRIC VISUAL ÉVOLUTION AUSTRALIA PTY ...

 

-

100%

-

 VOLCOM NEW ZEALAND LIMITED

 

-

100%

-

 ELECTRIC VISUAL EVOLUTION NEW ZEALAND LI...

 

-

100%

-

 VOLCOM JAPAN GODOGAISHIYA

 

-

100%

-

 BRIONI S.P.A.

 

PE24301

100%

31/12/2012

 SOWIND FRANCE

 

517745501

50%

31/12/2012

 TRADEMA GMBH

 

-

50%

-

 GARPE S.R.L.

 

FI563541

100%

31/12/2011

 GJP S.R.L.

 

MI1425635

100%

31/12/2011

 MANIFATTURA VENETA PELLETTERIE S.R.L...

 

VI345856

51%

31/12/2012

 CASTERA SARL

 

-

100%

-

 GG MIDDLE EAST B.V.

 

34394188

100%

-

 SOWIND ITALIA S.R.L.

 

TO663416

50%

31/12/2012

 SOWIND S.A.

 

6639

50%

-

 TRAMOR S.R.L.

 

FI608513

100%

31/12/2011

 BOTTEGA VENETA HOLDING LTDA

 

-

100%

-

 BOTTEGA VENETA SHANGAI COMMERCIAL ENTERP...

 

-

100%

-

 GUCCI (SHANGAI) ENTERPRISE MANAGEMENT LT...

 

-

100%

-

 GUCCI WATCHES MARKETING CONSULTING (SHAN...

 

-

100%

-

 SERGIO ROSSI (SHANGAI) TRADING LTD

 

-

100%

-

 SOWIND ASIA LTD

 

-

50%

-

 BOTTEGA VENETA SERVICIOS S. DE R.L. DE C...

 

-

100%

-

 ALEXANDER MCQUEEN (HONG KONG) LIMITED

 

-

51%

-

 LUXURY GOODS GULF LLC

 

-

49%

-

 LUXURY GOODS GREECE AE

 

-

51%

-

 LUXURY GOODS SERVICES SA

 

6389059

100%

-

 PPR ASIA LIMITED

 

-

100%

-

 PPR AMERICAS

 

US03819241

100%

-

 BLITZSTART

 

-

100%

-

 KERING ITALIA S.P.A.

 

FI523826

100%

31/12/2011

 KERING SERVICE ITALIA S.P.A.

 

FI523599

100%

31/12/2011

 CHRISTOPHER KANE LIMITED

 

06009791

51%

31/12/2012

 FRANCE CROCO

 

501766547

Majority

-

 KERNIC-MET B.V.

 

34137593

100%

31/12/2012

 POMELLATO SPA

 

-

Majority

-

Shareholders

 

Type of shareholder

Shareholders

 

Linkages

Ultimate parent company

KERING

Direct parent

REDCATS - 100 %

Group – Number of companies

445

Linkages – Number of companies

104

Number of countries

16

 

 

 

Company Name

SIREN

Last account

Turnover

FINANCIERE MAROTHI

 

320915572

31/12/2011

0 €

PUMA SE

 

HRB 13085

31/12/2012

3 289 900 000 €

B.V. CALZATURE S.R.L.

 

PD412414

-

-

ELLOS AB

 

5560440264

31/12/2012

2 145 929 KSEK

FNAC SA

 

775661390

31/12/2011

2 373 967 779 €

ACCO-REXEL GROUP SERVICES LIMITED

 

00479410

31/12/2012

0 £

NOBO GROUP LIMITED

 

01965241

31/12/2012

0 £

ROMAN STYLE S.P.A.

 

PE140748

31/12/2012

71 082 876 €

ELLOS NORWAY HOLDING AS

 

879478642

31/12/2012

0 KNOK

SFORZA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA...

 

BO333935

31/12/2012

20 860 870 €

BURINI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI...

 

BG363059

31/12/2012

8 662 318 €

ACCO EUROPE LIMITED

 

02142066

31/12/2012

0 £

ACCO BENELUX B.V.

 

30037899

31/12/2011

-

CONCERIA BLUTONIC S.P.A.

 

PI138394

31/12/2011

27 506 528 €

LA REDOUTE NORWAY AS

 

987180595

31/12/2012

61 776 KNOK

ACUSHNET GMBH

 

HRB 1915

31/12/2012

21 082 716 €

BRIONI UK LIMITED

 

04571931

31/12/2012

4 185 451 £

BRIONI RETAIL EUROPA S.R.L.

 

MI1564405

31/12/2012

2 074 913 €

NEGOZI RICHARD GINORI S.R.L.

 

FI587391

31/12/2012

3 584 873 €

ACUSHNET SVERIGE AKTIEBOLAG

 

5564887866

31/12/2012

139 381 KSEK

ARDORA SRL

 

MI688911

31/12/2012

959 260 €

TRETORN NORWAY AS

 

996241203

31/12/2012

14 523 KNOK

GT S.R.L.

 

FI591428

31/12/2011

14 287 545 €

BV OUTLET S.R.L.

 

VI331205

31/12/2012

18 250 752 €

ALTO VICENTINO PELLETTERIE S.R.L. UNIPER...

 

VI350242

-

2 674 002 €

GAUGUIN S.R.L.

 

FI523822

31/12/2011

437 972 €

YVES SAINT LAURENT INTERNATIONAL B.V.

 

24275112

31/12/2012

-

BRIONI RETAIL SPAGNA S.R.L.

 

MI1978794

-

6 290 196 €

MAXXIUM WORLDWIDE B.V.

 

34118132

31/03/2013

-

JOTEX SWEDEN AB

 

5562497106

31/12/2012

260 506 KSEK

G.F. SERVICES SRL

 

NO197200

31/12/2011

31 995 437 €

CYRILLUS INTERNATIONAL

 

308336023

31/12/2006

88 229 742 €

ACCO-REXEL LIMITED

 

IE026213

31/12/2012

5 391 026 €

TRADEMA GMBH

 

HRB 159439

31/12/2012

-

PIGINI S.R.L.

 

FI520111

31/12/2011

40 842 142 €

CALZATURIFICIO FLORA S.R.L.

 

FI523602

31/12/2011

17 259 706 €

GPA S.R.L.

 

FI523823

31/12/2011

13 801 780 €

ACUSHNET NEDERLAND B.V.

 

20073854

31/12/2012

-

WILDLIFE WORKS CARBON B.V.

 

54994616

31/12/2012

-

BOURBON WAREHOUSE NETHERLANDS B.V.

 

34117850

31/12/2012

-

JIM BEAM BRANDS NETHERLANDS B.V.

 

34117852

31/12/2012

-

RICHARD GINORI EUROPE S.R.L.

 

FI623597

-

-

BRIONI RETAIL S.R.L.

 

MI1933351

31/12/2012

1 667 294 €

BRANDON MERCHANDISING UK LIMITED

 

06412020

31/12/2012

1 779 531 £

LA REDOUTE (UK) LIMITED

 

00192243

31/12/2012

-

ACCO EASTLIGHT LIMITED

 

00475543

31/12/2012

-

NOBO (UK) LIMITED

 

01161038

31/12/2009

-

SOWIND UK LIMITED

 

05957494

31/03/2012

-

ELLOS TILI OY

 

14421666

-

-

ACINO HOLDING AG

 

14961

-

-

JEANRICHARD S.A.

 

397295

-

-

MOVITEX EN LIQUIDATION SA

 

419611013

31/12/2008

14 844 518 €

SADAS BELGIQUE SA

 

439640721

31/12/1999

-

GG OTHER TERRITORIES B.V.

 

57412081

-

-

TOMAS MAIER INTERNATIONAL B.V.

 

58748660

-

-

SOWIND SERVICES S.A.

 

597477

-

-

SOWIND MANUFACTURES S.A.

 

6804

-

-

ATELIERS BAUTTE S.A.

 

707893

-

-

PUMA NORDIC AB

 

886659962

-

-

YSL BEAUTE GMBH

 

HRB 105554

-

-

NHB INDUSTRIES, INC

 

US08382541

-

3 261 000 $

BEAM INC

 

US12107162

-

3 070 100 000 $

BOONE INTERNATIONAL INC

 

US12250104

-

26 000 000 $

CAPITAL CABINET CORP

 

US16820588

-

6 440 000 $

OSP GROUP, INC

 

US17212039

-

0 $

ELECTRIC VISUAL EVOLUTION LLC

 

US22616276

-

23 500 000 $

WILD HORSE WINERY & VINEYARDS

 

US22953913

-

14 445 000 $

L S & S ALISO VIEJO INC

 

US23484139

-

2 143 000 $

BOUCHERON JOALLERIE INC

 

US25060071

-

158 000 $

BARGAIN CATALOG OUTLET

 

US27305754

-

0 $

ALC HOLDING CORP

 

US28461681

-

99 000 $

SERGIO ROSSI USA, INC

 

US34512089

-

1 184 000 $

ALEXANDER MCQUEEN TRADING LIMITED

 

US35437830

-

0 $

TRETORN

 

US44231768

-

38 000 $

BRIONI ROMAN STYLE USA CORP

 

US44903241

-

3 201 000 $

THE MCNEILL GROUP, LIMITED PARTNERSHIP

 

US45722239

-

2 006 000 $

UNITED RETAIL INCORPORATED

 

US46200837

-

438 738 000 $

YSL BEAUTE, INC

 

US46395521

-

0 $

FORTUNE BRANDS HOME & HARDWARE LLC

 

US48753439

-

0 $

BOURBON WAREHOUSE RECEIPTS INC

 

US49131461

-

30 000 000 $

VOLCOM RETAIL, INC

 

US62005474

-

2 316 000 $

OSP GROUP, L.P

 

US62463893

-

0 $

UNITED RETAIL GROUP, INC

 

US62540436

-

0 $

VOLCOM RETAIL OUTLETS, INC

 

US62575732

-

0 $

GUCCI GROUP WATCHES, INC

 

US62665809

-

0 $

GUCCI GROUP WATCHES, INC

 

US69226080

-

0 $

BOUCHERON HOLDING SA

 

-

-

-

BRANDON CO AB

 

-

-

-

BRANDON HONGKONG LTD

 

-

-

-

BRANDON USA INC

 

-

-

-

ELLOS A/S

 

-

-

-

GIRARD-PERREGAUX

 

-

-

-

KERING SA

 

-

-

-

PINAULT-PRINTEMPS REDOUTE SA

 

-

-

-

PPR SA

 

-

-

-

PUMA DENMARK A/S

 

-

-

-

REDCATS SUISSE SA

 

-

-

-

SOWIND JAPON KK

 

-

-

-

TRADEMA DEUTSCHLAND GMBH

 

-

-

-

TRADEMA OF AMERICA INC

 

-

-

-

TRETORN RESEARCH & DEVELOPMENT LTD

 

-

-

-

VOLCOM INC

 

-

-

-

YVES SAINT LAUENT SAS REGISTER NR. 342 5...

 

-

-

-

YVES SAINT LAURENT SAS

 

-

-

-

event history

Status history

 

 

No Status History

 

 

 

Recent publications in Gazettes

 

 

 

Publication date

Gazette Name

Description

 

26/09/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

689 - 756 200 150 RCS Lille Métropole. MOVITEX. Forme : Société anonyme. Capital : 1376700 EUR. Activité : En France ou à l'international la fabrication, l'achat, le commerce de détail et la distribution par correspondance, à distance ou par vente directe de marchandises et de produits les plus variés, et notamment la vente de produits d'habillement, de chaussures et Accessoirres, d'équipements de la maison, ainsi que la fourniture de tous services aux particuliers et aux professionnels... Le courtage d'assurance et toute autre activité D'intermédiation en assurance. Adresse de l’établissement principal : 68 rue Christophe Colomb, 59290 Wasquehal. 
Adresse du siège social : 68 rue Christophe Colomb, 59290 Wasquehal. 
Commentaires : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal.

10/06/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

7970 - 756200150 RCS. MOVITEXForme : Société anonyme. Adresse : 68 rue Christophe Colomb 59290 Wasquehal. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2012.

10/06/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

7969 - 756200150 RCS. MOVITEXForme : Société anonyme. Adresse : 68 rue Christophe Colomb 59290 Wasquehal. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011.

24/04/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

8273 - 756200150 RCS. MOVITEXForme : Société anonyme. Adresse : 68 rue Christophe Colomb 59290 Wasquehal. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

24/04/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

8275 - 756200150 RCS. MOVITEXForme : Société anonyme. Adresse : 68 rue Christophe Colomb 59290 Wasquehal. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2010.

24/04/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

8274 - 756200150 RCS. MOVITEXForme : Société anonyme. Adresse : 68 rue Christophe Colomb 59290 Wasquehal. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

11/01/2013

JAL

Modification of the share capital

 

Syndicat agricole (Le)


Date de décision : 14/12/2012
La société : 756200150 - MOVITEX, 68 RUE CHRISTOPHE COLOMB, BP 122, 59290 WASQUEHAL a subi une augmentation de son capital social désormais de 1 376 700 € 
Date d'effet : 14/12/2012

05/10/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1705 - 756 200 150 RCS Roubaix-Tourcoing. MOVITEX. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Administration : Président du conseil d'administration : HUBER Jean-Joel Directeur général administrateur : HUBER Jean-Joel Administrateur : REDCATS, représenté par M COURTEILLE Eric Administrateur : NAESSENS Stéphanie Administrateur : DUMEZ Pascale Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Capital : 1376700 EUR. Activité : Fabrication, achat, commerce de détail et distribution par correspondance et à distance de marchandises et de produits les plus variés, ainsi que la fourniture de tous services aux particuliers et aux professionnels... le courtage d'assurance et toute autre activité d'intermédiation en assurance. Adresse de l’établissement principal : 68 rue Christophe Colomb, 59290 Wasquehal. 
Adresse du siège social : 68 rue Christophe Colomb, 59290 Wasquehal. 
Commentaires : Changement de l'objet et de l'activité. Date de commencement de l’activité : 01/07/1974. Date d’effet : 12/04/2011.

31/08/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

999 - 756 200 150 RCS Roubaix-Tourcoing. MOVITEX. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Administration : Président du conseil d'administration : HUBER Jean-Joel Directeur général administrateur : HUBER Jean-Joel Administrateur : REDCATS, représenté par M COURTEILLE Eric Administrateur : NAESSENS Stéphanie Administrateur : DUMEZ Pascale Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Capital : 1376700 EUR. Activité : Fabrication, achat, vente, notamment pär correspondance de tous articles de bonneterie lingerie, sous-vêtements et autres textiles.... Le courtage d'assurance et toute autre activité d'intermédiation en assurance. Adresse de l’établissement principal : 68 rue Christophe Colomb, 59290 Wasquehal. 
Adresse du siège social : 68 rue Christophe Colomb, 59290 Wasquehal. 
Commentaires : Changement de président du conseil d'administration Changement de directeur général. Date de commencement de l’activité : 01/07/1974. Date d’effet : 11/03/2011.

30/08/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

828 - 756 200 150 RCS Roubaix-Tourcoing. MOVITEX. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Administration : Président du conseil d'administration : CAMBIER Benoît Directeur général administrateur : CAMBIER Benoît Administrateur : REDCATS, représenté par M COURTEILLE Eric Administrateur : NAESSENS Stéphanie Administrateur : DUMEZ Pascale Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Capital : 1376700 EUR. Activité : Fabrication, achat, vente, notamment pär correspondance de tous articles de bonneterie lingerie, sous-vêtements et autres textiles.... Le courtage d'assurance et toute autre activité d'intermédiation en assurance. Adresse de l’établissement principal : 68 rue Christophe Colomb, 59290 Wasquehal. 
Adresse du siège social : 68 rue Christophe Colomb, 59290 Wasquehal. 
Commentaires : Nomination d'un administrateur. Date de commencement de l’activité : 01/07/1974. Date d’effet : 14/09/2010.

26/08/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1325 - 756 200 150 RCS Roubaix-Tourcoing. MOVITEX. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Administration : Président du conseil d'administration : CAMBIER Benoît Directeur général administrateur : CAMBIER Benoît Administrateur : REDCATS, représenté par M COURTEILLE Eric Administrateur : DUMEZ Pascale Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Capital : 1376700 EUR. Activité : Fabrication, achat, vente, notamment pär correspondance de tous articles de bonneterie lingerie, sous-vêtements et autres textiles.... Le courtage d'assurance et toute autre activité d'intermédiation en assurance. Adresse de l’établissement principal : 68 rue Christophe Colomb, 59290 Wasquehal. 
Adresse du siège social : 68 rue Christophe Colomb, 59290 Wasquehal. 
Commentaires : Départ d'un administrateur. Date de commencement de l’activité : 01/07/1974. Date d’effet : 03/02/2010.

27/07/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

816 - 756 200 150 RCS Roubaix-Tourcoing. MOVITEX. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Administration : Président du conseil d'administration : CAMBIER Benoît Directeur général administrateur : CAMBIER Benoît Administrateur : REDCATS, représenté par M COURTEILLE Eric Administrateur : TERRIER Patrick Administrateur : DUMEZ Pascale Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Capital : 1376700 EUR. Activité : Fabrication, achat, vente, notamment pär correspondance de tous articles de bonneterie lingerie, sous-vêtements et autres textiles.... Le courtage d'assurance et toute autre activité d'intermédiation en assurance. Adresse de l’établissement principal : 68 rue Christophe Colomb, 59290 Wasquehal. 
Adresse du siège social : 68 rue Christophe Colomb, 59290 Wasquehal. 
Commentaires : Changement de président directeur général et de directeur général Changement d'administrateur. Date de commencement de l’activité : 01/07/1974. Date d’effet : 10/09/2009.

16/07/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

LE SYNDICAT AGRICOLE


Société faisant l'objet d'une nomination : 756200150 - MOVITEX, 68 RUE CHRISTOPHE COLOMB, BP 122, 59290 WASQUEHAL 
Nominé : Monsieur Benoit CAMBIER, 93 B AVENUE 93 B AVENUE FOCH, 59700 MARCQ EN BAROEUL
En la fonction de : DG - Directeur Général

16/07/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

LE SYNDICAT AGRICOLE


Société faisant l'objet d'une nomination : 756200150 - MOVITEX, 68 RUE CHRISTOPHE COLOMB, BP 122, 59290 WASQUEHAL 
Nominé : Monsieur Benoit CAMBIER, 93 B AVENUE 93 B AVENUE FOCH, 59700 MARCQ EN BAROEUL
En la fonction de : Président du Conseil d'Administration

16/07/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

LE SYNDICAT AGRICOLE


Société faisant l'objet d'une nomination : 756200150 - MOVITEX, 68 RUE CHRISTOPHE COLOMB, BP 122, 59290 WASQUEHAL 
Nominé : Madame Pascale JAWORSKA, 7 RUE 7 RUE DU PONT, 59236 FRELINGHIEN
En la fonction de : Administrateur

16/07/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

LE SYNDICAT AGRICOLE


Société faisant l'objet d'une nomination : 756200150 - MOVITEX, 68 RUE CHRISTOPHE COLOMB, BP 122, 59290 WASQUEHAL 
Nominé : Monsieur Patrick TERRIER, 14 CHEMIN 14 CHEMIN DES DAMES, 59700 MARCQ EN BAROEUL
En la fonction de : Administrateur

16/07/2010

JAL

Appointment of the social representative

 

LE SYNDICAT AGRICOLE


Société faisant l'objet d'une nomination : 756200150 - MOVITEX, 68 RUE CHRISTOPHE COLOMB, BP 122, 59290 WASQUEHAL 
Nominé : Monsieur Eric COURTEILLE, 34 RUE 34 RUE PIERRE BROSSOLETTE, 92140 CLAMART

16/07/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

LE SYNDICAT AGRICOLE


Date de décision : 24/08/2009
La société 756200150 - MOVITEX, 68 RUE CHRISTOPHE COLOMB, BP 122, 59290 WASQUEHAL 
Fait l'objet du départ de Monsieur Bernard ANSART 

16/07/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

LE SYNDICAT AGRICOLE


Date de décision : 24/08/2009
La société 756200150 - MOVITEX, 68 RUE CHRISTOPHE COLOMB, BP 122, 59290 WASQUEHAL 
Fait l'objet du départ de Monsieur Nicolas BERNARD 

16/07/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

LE SYNDICAT AGRICOLE


Date de décision : 24/08/2009
La société 756200150 - MOVITEX, 68 RUE CHRISTOPHE COLOMB, BP 122, 59290 WASQUEHAL 
Fait l'objet du départ de Monsieur Nicolas BERNARD 

12/01/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

5745 - 756200150 RCS. MOVITEXForme : Société Anonyme à conseil d'administration. Adresse : 68 rue Christophe Colomb 59290 Wasquehal. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

20/11/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

7311 - 756 200 150. RCS Roubaix MOVITEX. Forme: Société Anonyme à conseil d'administration. Adresse du siège social: 68 rue Christophe Colomb 59290 Wasquehal. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

18/10/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

2145 - RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150. RC 74-B 58. MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 1 376 700 euros. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb,, 59290 Administration : président du conseil d'administration : BERNARD (Nicolas). Directeur général et administrateur : CAMBIER (Benoît). Administrateurs : REDCATS BERNARD (Nicolas) GAUTIER (Philippe). Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES-BEAS. Ancienne administration : ancien commissaire aux comptes titulaire : STE FIDUCIAIRE JURIDIQUE & FISCALE DE FRANCE. Ancien commissaire aux comptes suppléant : S.C.P. JEAN-CLAUDE ANDRE ET AUTRES. Etablissement principal - Activité : fabrication, achat, vente, notamment par correspondance de tous articles de bonneterie, de lingerie, de sous-vêtements et d'autres textiles courtage d'assurances et toutes autres activités d'intermédiation en assurances . Adresse : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Date d'effet : 11 mai 2007.

14/10/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

1540 - RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150. RC 74-B 58. MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 1 376 700 euros. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb,, 59290 Administration : président du conseil d'administration : BERNARD (Nicolas). Directeur général et administrateur : CAMBIER (Benoît). Administrateurs : REDCATS BERNARD (Nicolas) GAUTIER (Philippe). Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE-FIDAL. Commissaire aux comptes suppléant : S.C.P. JEAN-CLAUDE ANDRE ET AUTRES. Ancienne administration : ancien administrateur : Mme DOUCET, née CHOCRON (Catherine). Etablissement principal - Activité : fabrication, achat, vente, notamment par correspondance de tous articles de bonneterie, de lingerie, de sous-vêtements et d'autre textile courtage d'assurances et toutes autres activités d'intermédiation en assurance . Adresse : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Date d'effet : 9 février 2007.

13/07/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

1354 - RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150. RC 74-B 58. MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 1 376 700 euros. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb,, 59290 Etablissement principal - Activité : fabrication, achat, vente, notamment par correspondance, de tous articles de bonneterie, de lingerie, de sous-vêtements et d'autres textiles. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Etablissement principal - nouvelle situation - Adjonction d'activité : courtage d'assurances et toutes autres activités d'intermédiation en assurances. Date d'effet : 23 avril 2007.

18/11/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

3817 - RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150. RC 74-B 58. MOVITEX. Forme: S.A. à conseil d'administration . Adresse du siège social: 68, rue Christophe Colomb,59290 Wasquehal. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

01/03/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

3095 - RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150. RC 74-B 58. MOVITEX. Forme: S.A. à conseil d'administration . Adresse du siège social: 68, rue Christophe Colomb,59290 Wasquehal. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

11/10/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

911 - RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150. RC 74-B 58. MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 1 376 700 euros. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb,, 59290 Administration : président du conseil d'administration : BERNARD (Nicolas). Directeur général et administrateur : CAMBIER (Benoît). Administrateurs : REDCATS BERNARD (Nicolas) Mme DOUCET, née CHOCRON (Catherine). Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE-FIDAL. Commissaire aux comptes suppléant : S.C.P. JEAN-CLAUDE ANDRE ET AUTRES. Ancienne administration : ancien commissaire aux comptes suppléant : PETIT (Patrick, Hubert). Etablissement principal - Activité : fabrication, achat, vente, notamment par correspondance, de tous articles de bonneterie, de lingerie, de sous-vêtements et autres textiles. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Date d'effet : 9 mai 2005.

28/07/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

1714 - RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150. RC 74-B 58. MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 1 376 700 euros. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb,, 59290 Administration : président du conseil d'administration : BERNARD (Nicolas). Directeur général et administrateur : CAMBIER (Benoît). Administrateurs : REDCATS BERNARD (Nicolas) Mme DOUCET, née CHOCRON (Catherine). Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE-FIDAL. Commissaire aux comptes suppléant : PETIT (Patrick, Hubert). Ancienne administration : ancien directeur général et administrateur : GLARMET (Jean, Pierre). Etablissement principal - Activité : fabrication, achat, vente, notamment par correspondance, de tous articles de bonneterie, de lingerie, de sous-vêtements et autres textiles. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Date d'effet : 10 juin 2005.

02/03/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

1341 - RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150. RC 74-B 58. MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 1 376 700 euros. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb,, 59290 Administration : président du conseil d'administration : BERNARD (Nicolas). Directeur général et administrateur : GLARMET (Jean-Pierre). Administrateurs : REDCATS BERNARD (Nicolas) Mme DOUCET, née CHOCRON (Catherine). Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE-FIDAL. Commissaire aux comptes suppléant : PETIT (Patrick, Hubert). Ancienne administration : ancien président du conseil d'administration : GLARMET (Jean-Pierre). Anciens administrateurs : STE SOGEP STE LA REDOUTE. Etablissement principal - Activité : fabrication, achat, vente, notamment par correspondance de tous articles de bonneterie, de lingerie, de sous-vêtements et autres textiles. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Date d'effet : 25 octobre 2004.

31/01/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

3516 - RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150. RC 74-B 58. MOVITEX. Forme: S.A. à conseil d'administration . Adresse du siège social: 68, rue Christophe Colomb,59290 Wasquehal. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2003.

16/03/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 756200150 RC 74- B 58 MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 1 376 700 euros. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Administration : P.-D.G. : GLARMET (Jean- Pierre). Administrateurs : LA REDOUTE REDCATS STE GENERALE DE PRESTATIONS DE SERVICES. Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE-FIDAL. Commissaire aux comptes suppléant : PETIT (Patrick, Hubert). Changement de représentant permanent de la S.A.S. SOGEP, administrateur. Ancien : TERRIER ( Patrick). Nouveau : LE NORMAND (Eric) Etablissement principal: Activité : fabrication, achat, vente, notamment par correspondance de tous articles de bonneterie, de lingerie, de sous- vetements et autres textiles. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Date d'effet : 16 septembre 2002.

06/09/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 756200150 RC 74- B 58 MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 1 376 700 euros. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Administration : P.-D.G. : GLARMET (Jean- Pierre). Administrateurs : STE GENERALE DE PRESTATIONS DE SERVICES LA REDOUTE REDCATS. Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE-FIDAL. Commissaire aux comptes suppléant : PETIT (Patrick, Hubert). Ancien président du conseil d' administration : GLARMET (Jean-Pierre) Etablissement principal: Activité : fabrication, achat, vente, notamment par correspondance de tous articles de bonneterie, de lingerie, de sous- vetements et autres textiles. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Date d'effet : 29 avril 2002.

04/07/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 756200150 RC 74- B 58 MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 1 376 700 euros. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Administration : président du conseil d' administration : GLARMET (Jean-Pierre). Administrateurs : REDCATS STE GENERALE DE PRESTATIONS DE SERVICES LA REDOUTE. Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE, FIDAL. Commissaire aux comptes suppléant : PETIT (Patrick, Hubert). Changement de représentant permanent de la STE REDCATS, administrateur. Ancien : BRUN (Jacques). Nouveau : LUCHEZ (Alain) Etablissement principal: Activité : fabrication, achat, vente, notamment par correspondance, de tous articles de bonneterie, de lingerie, de sous-vetements et autres textiles. Adresse : 68 rue Christophe- Colomb, 59290 Wasquehal. Date d'effet : 19 avril 2002.

07/12/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 756200150 RC 74-B 58 MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 9 009 000 F. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Administration : président du conseil d'administration : GLARMET (Jean-Pierre). Administrateurs : REDCATS STE GENERALE DE PRESTATIONS DE SERVICES LA REDOUTE. Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE-FIDAL. Commissaire aux comptes suppléant : PETIT (Patrick, Hubert) Nouvelle situation du siège social. Capital : 1 376 700 euros Etablissement principal: Activité : fabrication, achat, vente, notamment par correspondance, de tous articles de bonneterie, de lingerie, de sous-vetements et autres textiles. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Commentaires : augmentation du capital. Date d'effet : 15 octobre 2001.

08/04/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 756200150 RC 74- B 58 MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 9 009 000 F. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Administration : président du conseil d' administration : GLARMET (Jean-Pierre). Administrateurs : REDCATS, représentée par BRUN (Jacques), en remplacement de VINOT (Bertrand) STE GENERALE DE PRESTATIONS DE SERVICES LA REDOUTE. Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE-FIDAL. Commissaire aux comptes suppléant : PETIT (Patrick, Hubert) Etablissement principal: Activité : fabrication, achat, vente, notamment par correspondance, de tous articles de bonneterie, de lingerie, de sous- vetements et autres textiles. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Date d'effet : 9 février 2001.

21/01/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 756200150 RC 74- B 58 MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 9 009 000 F. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Administration : président du conseil d' administration : GLARMET (Jean-Pierre). Administrateurs : REDCATS STE GENERALE DE PRESTATIONS DE SERVICES LA REDOUTE. Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE, FIDAL. Commissaire aux comptes suppléant : PETIT (Patrick, Hubert). Ancien président du conseil d' administration et administrateur : KRAMER (Hartmut) Etablissement principal: Activité : fabrication, achat et vente notamment, par correspondance, de tous articles de bonneterie, de lingerie, de sous- vetements et d'autre textile. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Date d'effet : 15 septembre 2000.

09/11/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 756200150 RC 74- B 58 MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 9 009 000 F. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Administration : président du conseil d' administration : KRAMER (Hartmut). Directeur général et administrateur : GLARMET (Jean-Pierre). Administrateurs : REDCATS STE GENERALE DE PRESTATIONS DE SERVICES KRAMER (Hartmut). Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE-FIDAL. Commissaire aux comptes suppléant : PETIT (Patrick, Hubert). Ancien commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ (Eric) Etablissement principal: Activité : fabrication, achat, vente, notamment par correspondance, de tous articles de bonneterie, de lingerie, de sous-vetements et d'autres textiles. Adresse : 68 rue Christophe- Colomb, 59290 Wasquehal. Date d'effet : 18 mai 2000.

11/06/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 756200150 RC 74- B 58 MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 9 009 000 F. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Administration : président du conseil d' administration : KRAMER (Hartmut). Directeur général et administrateur : GLARMET (Jean-Pierre). Administrateurs : REDCATS STE GENERALE DE PRESTATIONS DE SERVICES KRAMER (Hartmut). Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE-FIDAL. Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ (Eric). Ancien administrateur : METZGER (Antoine) Etablissement principal: Activité : fabrication, achat, vente, notamment par correspondance de tous articles de bonneterie, de lingerie, de sous- vetements et d'autres textiles. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Date d'effet : 24 janvier 2000.

02/03/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

o. RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150 RC 1974-B 58 MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 9 009 000 F. Adresse du siège social : 68, rue Christophe-Colomb 59290 Wasquehal. Commentaires : apport par MOVITEX d'un fonds de commerce de vente par correspondance à la S.N.C. LES TROUVAILLES Etablissement principal: Activité : fabrication, achat, vente notamment par correspondance de tous articles de bonneterie, lingerie, sous- vetements et autres textiles. Adresse : 68, rue Christophe-Colomb 59290 Wasquehal. Date d'effet : 31 décembre 1999 Date de début d'activité: 1er juillet 1974.

08/02/2000

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS B 421 305 186 SOCIETE EN NOM COLLECTIF LES AUBAINES. Forme : S.N.C. Capital : 515 000 F. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Administration : gérante S.A. MOVITEX Fonds principal et complémentaire acquis par apport au montant global évalué à 505 000 F Etablissement principal: Activité : vente par correspondance d' articles de second choix et d'écoulement de surstocks. Adresse : 68 rue Christophe- Colomb, 59290 Wasquehal Etablissement Complémentaire. Activité : vente par magasin d' articles de second choix et d'écoulement de surstocks. Adresse : 30-32 Grande-Rue, 59100 Roubaix. Date d'effet : 1er janvier 2000 Précédente propriétaire-exploitante MOVITEX. RCS B 726 200 150 Publication légale: La Gazette du Nord du 15 janvier 2000 déclaration de créances: au greffe du triunal de commerce de Roubaix- Tourcoing.

12/12/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 756200150 RC 74- B 58 MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 9 009 000 F. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Administration : président du conseil d' administration : KRAMER (Hartmut). Nouveau directeur général et administrateur : GLARMET (Jean-Pierre). Administrateurs : METZGER (Antoine) STE GENERALE DE PRESTATIONS DE SERVICES KRAMER (Hartmut). Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE-FIDAL. Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ (Eric). Ancien administrateur : STE NOUVELLE D'EXPANSION REDOUTE Etablissement principal: Activité : fabrication, achat, vente, notamment par correspondance de tous articles de bonneterie, de lingerie, de sous- vetements et autres textiles. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Date d'effet : 8 septembre 1999.

30/09/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

o. RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150 RC 74-B 58 MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 9 009 000 F. Adresse du siège social : 68, rue Christophe-Colomb 59290 Wasquehal. Commentaires : ancienne dénomination : ETABLISSEMENTS MOVITEX Etablissement principal: Activité : fabrication, achat, vente, notamment par correspondance de tous articles de bonneterie, lingerie, sous-vetements et autres textiles. Adresse : 68, rue Christophe-Colomb 59290 Wasquehal. Date d'effet : 20 mai 1999 Date de début d'activité: 1er juillet 1974.

22/09/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 756200150 RC 74- B 58 ETABLISSEMENTS MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 9 009 000 F. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Administration : président du conseil d' administration : KRAMER (Hartmut). Administrateurs : STE NOUVELLE D' EXPANSION REDOUTE, représentée par BRUN (Jacques), en remplacement de KRAMER ( Hartmut) METZGER (Antoine) STE GENERALE DE PRESTATIONS DE SERVICES KRAMER (Hartmut). Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE-FIDAL. Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ (Eric). président du conseil d' administration : DUQUESNE (Pascal) Etablissement principal: Activité : vente au détail d'articles textiles, en cuir, annexe du catalogue de vente par correspondance de la S.A . MOVITEX. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Date d'effet : 29 juillet 1999.

11/08/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 756200150 RC 74- B 58 ETABLISSEMENTS MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 9 009 000 F. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Administration : président du conseil d' administration : DUQUESNE (Pascal). Administrateurs : DUQUESNE (Pascal) METZGER (Antoine) STE GENERALE DE PRESTATIONS DE SERVICES. Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE-FIDAL. Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ (Eric). Nouveau représentant permanent de la STE NOUVELLE D' EXPANSION REDOUTE-S.N.E.R. : KRAMER ( Hartmut). Ancien représentant permanent de la STE NOUVELLE D'EXPANSION REDOUTE- S.N.E.R. : PEMET (Alain) Etablissement principal: Activité : vente au détail d' articles textiles, en cuir et annexes du catalogue de vente par correspondance de la S.A . MOVITEX. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb, 59290 Wasquehal. Date d'effet : 15 septembre 1998.

14/06/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150 RC 74-B 58 ETABLISSEMENTS MOVITEX. Forme : S. A. à conseil d'administration. Capital : 9 009 000 F. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb 59290 Wasquehal Etablissement principal: Enseigne : Celaia. Activité : textile, cuir et annexes du catalogue de vente par correspondance de la S.A. MOVITEX. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb 59290 Wasquehal. Commentaires : adjonction d' une enseigne. Date d'effet : 1er mai 1998.

29/03/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150 RC 74-B 58 ETABLISSEMENTS MOVITEX. Forme : S. A. à conseil d'administration. Capital : 9 009 000 F. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb 59290 Wasquehal. Administration : président du conseil d' administration : DUQUESNE (Pascal). Administrateurs : DUQUESNE (Pascal) METZGER (Antoine) STE GENERALE DE PRESTATIONS DE SERVICES. Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ (Eric). Ancien représentant permanent de la STE NOUVELLE D' EXPANSION REDOUTE-S.N.E.R., administrateur : BLANCHARD (Jean-Pierre) . Nouveau représentant permanent de la STE NOUVELLE D'EXPANSION REDOUTE-S.N.E. R., administrateur : PENET (Alain) Etablissement principal: Activité : textile, cuir et annexes du catalogue de vente par correspondance de la S.A. MOVITEX. Adresse : 68 rue Christophe- Colomb 59290 Wasquehal. Date d'effet : 22 janvier 1998.

07/12/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150 RC 74-B 58 ETABLISSEMENTS MOVITEX. Forme : S. A. à conseil d'administration. Capital : 9 009 000 F. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb 59290 Wasquehal. Administration : président du conseil d' administration : DUQUESNE (Pascal). Administrateurs : STE NOUVELLE D' EXPANSION REDOUTE DUQUESNE (Pascal) METZGER (Antoine) STE GENERALE DE PRESTATIONS DE SERVICES. Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ (Eric). Ancien administrateur : SAVEUSE (Joel) Etablissement principal: Activité : textile, cuir et annexes du catalogue de vente par correspondance de la S.A. Motivex. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb 59290 Wasquehal. Date d'effet : 29 aout 1997.

12/10/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150 RC 74-B 58 ETABLISSEMENTS MOVITEX. Forme : S. A. à conseil d'administration. Capital : 9 009 000 F. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb 59290 Wasquehal. Administration : président du conseil d' administration : DUQUESNE (Pascal). Administrateurs : STE NOUVELLE D' EXPANSION REDOUTE DUQUESNE (Pascal) METZGER (Antoine) SAVEUSE (Joel). Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ (Eric). Ancien commissaire aux comptes suppléant : MALLET (Jean, Pierre) Etablissement principal: Activité : textiles, cuirs et annexes du catalogue de vente par correspondance de la S.A. MOVITEX. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb 59290 Wasquehal. Date d'effet : 16 mai 1997.

06/10/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150 RC 74-B 58 ETABLISSEMENTS MOVITEX. Forme : S. A. Capital : 9 009 000 F. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb 59290 Wasquehal. Administration : président du conseil d'administration : DUQUESNE ( Pascal). Administrateurs : STE NOUVELLE D'EXPANSION REDOUTE DUQUESNE (Pascal) METZGER (Antoine) SAVEUSE (Joel). Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : MALLET (Jean, Pierre). Ancien administrateur : TEFRA (Jean, Baptiste) Etablissement principal: Activité : textiles, cuirs et annexes du catalogue de vente par correspondance de la S.A. MOVITEX. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb 59290 Wasquehal. Date d'effet : 9 juillet 1996.

02/10/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS o. RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150 RC RC 74-B 58 ETABLISSEMENTS MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 9 009 000 F. Adresse du siège social : 68, rue Christophe-Colomb 59290 Wasquehal. Administration : président du conseil d' administration et administrateur : DUQUESNE (Pascal) Administrateurs : SOCIETE NOUVELLE D'EXPANSION REDOUTE METZGER (Antoine) TEFRA (Jean- Baptiste, Edouard). Nouvel administrateur : SAVEUSE (Joel). Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : MALLET (Jean, Pierre) Etablissement principal: Activité : textiles, cuirs et annexes du catalogue de vente par correspondance de la S.A. MOVITEX. Adresse : 68, rue Christophe- Colomb 59290 Wasquehal Date de début d' activité: 1er juillet 1974. Date d'effet : 17 mai 1996.

24/08/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS o. RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150 RC RC 74-B 58 ETABLISSEMENTS MOVITEX. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 9 009 000 F. Adresse du siège social : 68, rue Christophe-Colomb 59290 Wasquehal. Administration : président du conseil d' administration et administrateur : DUQUESNE (Pascal) Administrateurs : SOCIETE NOUVELLE D'EXPANSION REDOUTE DUQUESNE (Pascal) METZGER (Antoine) TEFRA (Jean-Baptiste, Edouard). Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : MALLET (Jean, Pierre). Ancien président du conseil d' administration : DAISGNES (Thierry) Etablissement principal: Activité : textiles, cuirs et annexes du catalogue de vente par correspondance de la S.A. Movitex. Adresse : 68, rue Christophe- Colomb 59290 Wasquehal Date de début d' activité: 1er juillet 1974. Date d'effet : 30 janvier 1996.

28/07/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Roubaix-Tourcoing B 756 200 150 RC 74-B 58 ETABLISSEMENTS MOVITEX. Forme : S. A. Capital : 9 009 000 F. Adresse du siège social : 68 rue Christophe-Colomb 59290 Wasquehal. Administration : président du conseil d'administration : DAIGNES ( Thierry). Administrateurs : METZGER ( Antoine) TEFRA (Jean-Baptiste, Edouard). Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : MALLET (Jean, Pierre). Anciens administrateurs : LE SAUX (André) SARAZIN (Jean, Claude). Ancien commissaire aux comptes suppléant : CABINET DELOITTE TOUCHE TOHMATSU. Ancien commissaire aux comptes titulaire : CABINET DE BOIS DIETERLE ET ASSOCIES. Ancien président du conseil d'administration : SARAZIN ( Jean, Claude) Etablissement principal: Activité : textiles, cuirs annexes du catalogue de vente par correspondance de la S.A. MOVITEX. Adresse : 68 rue Christophe-Colomb 59290 Wasquehal. Date d'effet : 23 juin 1995.

 

 

Company events history

 

 

 

Date

Description

19/02/2014

Changes to the Board of Directors

19/02/2014

Amendment

19/10/2013

Update Rating

19/10/2013

Update Limit

26/09/2013

Bodacc B: Various editing or changing

11/09/2013

Change to corporate purpose

11/09/2013

Updated articles of association

11/09/2013

Minutes of general meeting of shareholders

18/07/2013

Update Rating

18/07/2013

Update Limit

10/06/2013

Bodacc C : Deposit accounts notice

11/05/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

07/05/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

24/04/2013

Bodacc C : Deposit accounts notice

13/04/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

29/03/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

14/03/2013

Minutes of general meeting of shareholders

14/03/2013

Capital increase

31/12/2012

New accounts available

14/12/2012

Legal Gazette: Modification of the share capital

31/12/2011

New accounts available

07/10/2011

New subsidiarie(s) detected

05/10/2011

Bodacc B: Various editing or changing

26/09/2011

Change to corporate purpose

26/09/2011

Updated articles of association

26/09/2011

Minutes of general meeting of shareholders

31/08/2011

Bodacc B: Various editing or changing

30/08/2011

Bodacc B: Various editing or changing

26/08/2011

Bodacc B: Various editing or changing

22/08/2011

Amendment

22/08/2011

Minutes of general meeting of shareholders

22/08/2011

Appointment/resignation of company officers

22/08/2011

Changes to the Board of Directors

22/08/2011

New chairman (CEO, CoB)

19/08/2011

Minutes of general meeting of shareholders

19/08/2011

Changes to the Board of Directors

17/08/2011

Amendment

17/08/2011

Changes to the Board of Directors

17/08/2011

Minutes of Board meeting

12/04/2011

Update of Company Activity

12/04/2011

Modification of Company Activity

31/12/2010

New accounts available

27/07/2010

Bodacc B: Various editing or changing

16/07/2010

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

13/07/2010

Minutes of general meeting of shareholders

13/07/2010

PV d'Assemblée

13/07/2010

Minutes of Board meeting

13/07/2010

Acte modificatif

13/07/2010

Amendment

13/07/2010

Nomination/démission des organes de gestion

13/07/2010

Appointment/resignation of company officers

13/07/2010

Modification du Conseil d'Administration

13/07/2010

Changes to the Board of Directors

13/07/2010

New chairman (CEO, CoB)

13/07/2010

Changement de Président (PDG, PCA)

09/07/2010

Disengagement in other companies

31/12/2009

Update of Company Activity

31/12/2009

Update of Company Workforce

31/12/2009

New accounts available

31/12/2009

Modification of Company Activity

10/09/2009

Legal Gazette: Appointment of the social representative

24/08/2009

Legal Gazette: Appointment of the social representative

12/01/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

31/12/2008

New accounts available

04/11/2008

Collection of preferential rights activated for this company

31/12/2007

New accounts available

19/09/2007

PV d'Assemblée

19/09/2007

New auditor

19/09/2007

Changement de Commissaire aux Comptes

19/09/2007

Minutes of general meeting of shareholders

19/09/2007

Appointment/resignation of company officers

19/09/2007

Private document

13/09/2007

Minutes of Board meeting

13/09/2007

Private document

13/09/2007

PV du Conseil d'Administration

13/09/2007

Appointment/resignation of company officers

13/09/2007

Acte modificatif

13/09/2007

Modification du Conseil d'Administration

13/09/2007

Changes to the Board of Directors

20/06/2007

Private document

20/06/2007

Change to corporate purpose

20/06/2007

Modification de l'objet social

20/06/2007

Updated articles of association

20/06/2007

Minutes of general meeting of shareholders

20/06/2007

PV d'Assemblée

20/06/2007

Statuts mis à jour

31/12/2006

New accounts available

31/12/2005

New accounts available

22/09/2005

Private document

22/09/2005

Minutes of general meeting of shareholders

22/09/2005

PV d'Assemblée

22/09/2005

New auditor

22/09/2005

Changement de Commissaire aux Comptes

22/09/2005

Appointment/resignation of company officers

08/07/2005

Private document

08/07/2005

Changes to the Board of Directors

08/07/2005

Modification du Conseil d'Administration

08/07/2005

Appointment/resignation of company officers

08/07/2005

Acte modificatif

08/07/2005

Minutes of Board meeting

08/07/2005

PV du Conseil d'Administration

08/07/2005

Nomination/démission des organes de gestion

02/02/2005

Modification du Conseil d'Administration

02/02/2005

PV du Conseil d'Administration

02/02/2005

Minutes of Board meeting

02/02/2005

Acte modificatif

02/02/2005

Amendment

02/02/2005

Appointment/resignation of company officers

02/02/2005

Changes to the Board of Directors

02/02/2005

Acte sous seing privé

02/02/2005

Private document

02/02/2005

Changement de Président (PDG, PCA)

02/02/2005

New chairman (CEO, CoB)

31/12/2004

New accounts available

31/12/2003

New accounts available

03/03/2003

Acte modificatif

03/03/2003

Acte sous seing privé

03/03/2003

PV du Conseil d'Administration

23/08/2002

Changement de Président (PDG, PCA)

23/08/2002

Modification du Conseil d'Administration

23/08/2002

Acte sous seing privé

23/08/2002

Nomination/démission des organes de gestion

23/08/2002

PV du Conseil d'Administration

23/08/2002

Acte modificatif

31/07/2002

PV d'Assemblée

31/07/2002

Statuts mis à jour

31/07/2002

Acte sous seing privé

21/06/2002

Acte sous seing privé

21/06/2002

Nomination/démission des organes de gestion

26/11/2001

Augmentation de Capital

26/11/2001

Statuts mis à jour

26/11/2001

Conversion du Capital Social en Euros

26/11/2001

PV d'Assemblée

26/11/2001

Acte sous seing privé

22/03/2001

Nomination/démission des organes de gestion

22/03/2001

Acte sous seing privé

05/01/2001

Acte sous seing privé

05/01/2001

Modification du Conseil d'Administration

05/01/2001

PV du Conseil d'Administration

05/01/2001

Acte modificatif

05/01/2001

Nomination/démission des organes de gestion

05/01/2001

Changement de Président (PDG, PCA)

24/10/2000

PV d'Assemblée

24/10/2000

Acte sous seing privé

24/10/2000

Nomination/démission des organes de gestion

24/10/2000

Changement de Commissaire aux Comptes

26/05/2000

Acte sous seing privé

26/05/2000

Modification du Conseil d'Administration

26/05/2000

Acte modificatif

26/05/2000

Nomination/démission des organes de gestion

26/05/2000

PV du Conseil d'Administration

29/11/1999

Modification du Conseil d'Administration

29/11/1999

Nomination/démission des organes de gestion

29/11/1999

Acte sous seing privé

29/11/1999

Acte modificatif

29/11/1999

PV du Conseil d'Administration

15/09/1999

Changement de dénomination sociale

15/09/1999

Statuts mis à jour

15/09/1999

PV d'Assemblée

15/09/1999

Acte sous seing privé

07/09/1999

Acte modificatif

07/09/1999

Changement de Président (PDG, PCA)

07/09/1999

PV du Conseil d'Administration

07/09/1999

PV d'Assemblée

07/09/1999

Nomination/démission des organes de gestion

07/09/1999

Modification du Conseil d'Administration

07/09/1999

Acte sous seing privé

28/07/1999

Acte sous seing privé

28/07/1999

Nomination/démission des organes de gestion

13/03/1998

Nomination/démission des organes de gestion

13/03/1998

Acte sous seing privé

13/03/1998

Acte modificatif

13/03/1998

PV d'Assemblée

21/11/1997

Modification du Conseil d'Administration

21/11/1997

Acte modificatif

21/11/1997

PV du Conseil d'Administration

21/11/1997

Acte sous seing privé

26/09/1997

PV d'Assemblée

26/09/1997

Nomination/démission des organes de gestion

26/09/1997

Acte sous seing privé

26/09/1997

Changement de Commissaire aux Comptes

20/09/1996

Modification du Conseil d'Administration

20/09/1996

PV d'Assemblée

19/09/1996

Modification du Conseil d'Administration

19/09/1996

Nomination/démission des organes de gestion

19/09/1996

PV d'Assemblée

08/08/1996

Changement de Président (PDG, PCA)

08/08/1996

Modification du Conseil d'Administration

08/08/1996

Nomination/démission des organes de gestion

08/08/1996

PV d'Assemblée

08/08/1996

PV du Conseil d'Administration

08/08/1996

Acte modificatif

15/07/1996

Changement de Commissaire aux Comptes

15/07/1996

Acte modificatif

15/07/1996

Changement de Président (PDG, PCA)

15/07/1996

PV du Conseil d'Administration

15/07/1996

PV d'Assemblée

15/07/1996

Nomination/démission des organes de gestion

15/07/1996

Modification du Conseil d'Administration

27/10/1994

Modification du Conseil d'Administration

27/10/1994

Changement de Président (PDG, PCA)

27/10/1994

Acte modificatif

27/10/1994

PV du Conseil d'Administration

27/10/1994

Nomination/démission des organes de gestion

13/10/1994

Nomination/démission des organes de gestion

13/10/1994

Modification du Conseil d'Administration

13/10/1994

PV d'Assemblée

18/07/1994

Modification du Conseil d'Administration

18/07/1994

Acte modificatif

18/07/1994

PV du Conseil d'Administration

05/07/1994

Nomination/démission des organes de gestion

05/07/1994

PV du Conseil d'Administration

05/07/1994

Acte modificatif

05/07/1994

Changement de Président (PDG, PCA)

05/07/1994

Modification du Conseil d'Administration

22/01/1992

PV du Conseil d'Administration

22/01/1992

Modification du Conseil d'Administration

22/01/1992

Nomination/démission des organes de gestion

22/01/1992

Acte modificatif

 

 

 

Establishment events history

 

 

 

 

Date

Description

22/02/2014

Update of phone numbers

05/09/2013

Update of phone numbers

07/05/2013

Update Limit

07/05/2013

Update Rating

29/03/2013

Update Rating

24/01/2013

Update Rating

12/01/2013

Update of phone numbers

19/10/2011

Update Rating

26/08/2011

Update Rating

20/08/2011

Update Rating

01/06/2011

Update Rating

06/05/2011

Update Rating

12/04/2011

Update of Establishment Workforce

03/09/2010

Update Rating

13/07/2010

Update Rating

10/06/2010

Update Rating

26/01/2010

Update Rating

31/12/2009

Modification of Head office

29/12/2009

Update Rating

02/10/2009

Update Limit

05/09/2009

Update Rating

14/01/2009

Update Limit

14/01/2009

Update Rating

01/10/2008

Update Limit

03/09/2008

Update Rating

09/12/2007

Update Limit

27/09/2007

Update Rating

 

 

directors

Shareholder(s)

 

Name

REDCATS

 

Name of representative

 

Manager position

Administrator

Date of birth

 

Place of birth

 

Type

Moral person

Name at birth

 

 

 

Name

M. HUBER JEAN-JOEL

 

Manager position

Chairman of the Board, Managing director, Administrator

Date of birth

22/06/1963

 

Place of birth

STRASBOURG (67000)

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

 

Name

M. ERRIGO ROLLAND

 

Manager position

Administrator

Date of birth

09/12/1956

 

Place of birth

VICHY (03200)

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

Previous Directors

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

Administrator

MME CATHERINE DOUCET

- - -

Administrator

Mme PASCALE JAWORSKA

27/12/1961 - BAILLEUL (59043)

Administrator

Mme STÉPHANIE NAESSENS

01/03/1967 - MONTREUIL (93100)


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

        Rs.60.99

UK Pound

1

Rs.102.07

Euro

1

Rs.84.53

 

INFORMATION DETAILS

 

Report Prepared by :

MNL

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

 

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

 

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

 

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

 

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

 

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

 

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

 

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

Credit not recommended

 

--

NB

New Business

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.