MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

06.05.2014

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

FERROPEM

 

 

Registered Office :

517 Av De La Boisse, 73000 Chambery

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2012

 

 

Date of Incorporation :

January 1973

 

 

Com. Reg. No.:

RCS Chambery 7 642 005 177

 

 

Legal Form :

Simplified Joint Stock Company with Single Associate

 

 

Line of Business :

·         Engaged in Producing and selling Silicon Metal, CaSi FeSi HP and Microsilica and a full Range of nodularisers and inoculants for the casting sector.

·         Subject is specialized in casting products, and nodularisers specifically inoculants used in iron foundry.

 

 

No of Employees :

900 (31.12.2010)

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory

 

 

Payment Behaviour :

Slow But Correct 

 

 

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31, 2014

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2013)

Current Rating

(31.03.2014)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low Risk

 

A2

Moderate Low Risk

 

B1

Moderate Risk

 

B2

Moderate High Risk

 

C1

High Risk

C2

Very High Risk

 

D

 


 

France ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With at least 82 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that mitigate economic inequality. France's real GDP stagnated in 2012 and 2013. The unemployment rate (including overseas territories) increased from 7.8% in 2008 to 10.2% in 2013. Youth unemployment in metropolitan France decreased from a high of 25.4% in the fourth quarter of 2012 to 22.8% in the fourth quarter of 2013. Lower-than-expected growth and high spending have strained France's public finances. The budget deficit rose sharply from 3.3% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 4.1% of GDP in 2013, while France's public debt rose from 68% of GDP to nearly 94% over the same period. In accordance with its EU obligations, France is targeting a deficit of 3.6% of GDP in 2014 and 2.8% in 2015. The administration of President Francois HOLLANDE has implemented greater state support for employment, the separation of banks' traditional deposit taking and lending activities from more speculative businesses, increasing the top corporate and personal tax rates, including a temporary 75% tax on wages over one million euros, and hiring an additional 60,000 teachers during his five-year term. In January 2014 HOLLANDE proposed a “Responsibility Pact” aimed primarily at lowering labor costs in return for businesses’ commitment to create jobs. Despite stagnant growth and fiscal challenges, France's borrowing costs have declined in recent years because investors remain attracted to the liquidity of France’s bonds.

 

Source : CIA

 


company summary

 

Name

FERROPEM

SIRET

642 005 177 00406

 

 

 

 

 

EUR VAT Number

FR33642005177

 

Activity (APE)

·         Engaged in Producing and selling Silicon Metal, CaSi FeSi HP and Microsilica and a full Range of nodularisers and inoculants for the casting sector.

·         Subject is specialized in casting products, and nodularisers specifically inoculants used in iron foundry.

Legal form

Simplified Joint Stock Company with Single Associate

 

 

 

RCS Registration

RCS Chambery 7 642 005 177

 

 

 

Share capital

74,139,140 Euros

 

Address

FERROPEM
517 AV DE LA BOISSE
73000 CHAMBERY

Incorporated Date

01/1973

 

Nationality

France

Status

Economically active

 

 

Payment Information Summary - Trade Payment Data

Total number of Invoices available

32

Total number of Invoices paid within or up to 30 days after the due date

19

Total number of Invoices paid more than 30 days after the due date

13

Total number of Invoices currently outstanding where the due date has not yet been reached

0

Total number of Invoices currently outstanding beyond the due date

0

 

No social security and tax office preferential right to date

 

 

Ultimate Holding Company

 

Company Name

 

Company number

 

FERROATLANTICA SL

 

 

36322

 

 

Current Directors

4

 

Trading to Date

12/31/2012

12/31/2011

12/31/2010

Turnover

404,252,094 €

489,634,932 €

389,811,794 €

Gross Operating Surplus

8,04 % Turnover

21,04 % Turnover

15,92 % Turnover

Shareholders’ equity

147,697,358 €

155,629,870 €

131,377,466 €

Net result

12,964,047 €

51,807,811 €

27,638,471 €

Employees

900 (31.12.2010)

-

-


Trends    

 

Profitability

Liquidity

Net worth

 

 

Company details

 

 

 

 

Activity (APE)

·         Engaged in Producing and selling Silicon Metal, CaSi FeSi HP and Microsilica and a full Range of nodularisers and inoculants for the casting sector.

·         Subject is specialized in casting products, and nodularisers specifically inoculants used in iron foundry.

 

 

 

 

RCS Registration

RCS Chambery 7 642 005 177

Share capital

74,139,140 Euros

 

Registration Court

Chambery (73)

Legal form

Simplified Joint Stock Company with Single Associate

 

Court Registry Number

19 7 3B00018

EUR VAT Number

FR33642005177

 

Incorporation Date

01/1973

Formation Date

06/1983

 

Deregistration Date

Last account Date

31/12/2012

 

Nationality

France

 

 

Establishment details

 

 

 

 

Postal Address

FERROPEM 
517 AV DE LA BOISSE 
73000 CHAMBERY

Trading Address

517 AVENUE DE LA BOISSE 
73000 CHAMBERY

 

Activity (APE)

·         Engaged in Producing and selling Silicon Metal, CaSi FeSi HP and Microsilica and a full Range of nodularisers and inoculants for the casting sector.

·         Subject is specialized in casting products, and nodularisers specifically inoculants used in iron foundry.

 

 

 

 

Type

Head office

Status

Economically active

 

Formation Date

07/2003

Reason for formation

Other

 

Closure Date

Reason for closure

 

Reactivation Date

Production Role

 

Activity Nature

-

Activity Location

Other

 

Location surface

Seasonality

 

 

 

Department

Savoie (73)

Region

Rhône-Alpes

 

District

2

Area

99

 

City

CHAMBERY

Size of urban area

Urban unit with 100 000 to 199 999 inhabitants

 

 

 

Other establishments

 

 

 

Branches

9 branch entities in this company

 

Head office

 
> FERROPEM <<<  - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. (2013B)  in CHAMBERY  (73000) 
 

 

Secondary establishments

 FERROPEM  - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. (2013B)  in LE BOURGET DU LAC  (73370) 
 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE  - Sidérurgie (271Y)  in ANNECY  (74000) 
 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE  - Sidérurgie (271Y)  in SAINT BERON  (73520) 
 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE  - Sidérurgie (271Y)  in AIGUEBELLE  (73220) 
> ...

 

 

 

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas having at least 50% of workforce in same area

 

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which one activity grouping from 80 to 99% of workforce

 

 

Workforces

 

 

 

Workforce at address

50 to 99 employees

Company workforce

900 (31.12.2010)

 

 

accounts

 

Active Account |  Passive Account |  Account Results

 

 

Synthesized Accounts 

Display parameter

Currency

 Euro

 Kilo Euro

Comparison mode

 Average

 Median

 

Annual Accounts

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Account period (month)

12

12

12

Account Type

Normal

Normal

Normal

Date of capture

13/08/2013

22/07/2013

24/08/2011

Activity Code

2013B

2013B

2013B

Employees

0

0

900

 

 

Active account

Annual Accounts

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Sector Median2012

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

87 228 353

6,7%

81 773 256

16,6%

70 124 283

948 597

9095,5%

- Intangible assets

351 524

-7,1%

378 370

-5,0%

398 327

49 568,50

609,2%

- Tangible assets

78 899 841

7,3%

73 518 837

12,4%

65 407 202

671 106,50

11656,7%

- Financial assets

8 214 137

1,2%

8 113 198

78,0%

4 558 953

9 811,50

83619,5%

Net current assets

230 325 815

-5,1%

242 633 027

23,5%

196 520 707

2 342 750

9731,4%

- Stocks

147 100 383

-1,4%

149 145 106

29,9%

114 858 504

359 316

40839,0%

- Advanced payments

612 959

-5,1%

1 361 478

213,0%

434 913

0

0%

- Receivables

78 676 321

-10,3%

87 695 062

9,6%

79 992 548

1 264 885,50

6120,0%

- Securities and cash

3 936 152

-11,2%

4 431 381

258,9%

1 234 742

87 810,50

4382,6%

- Prepaid expenses

-

-

-

-

-

841

-

Accounts of regularization

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total Assets

317 554 164

-2,1%

324 406 285

21,7%

266 644 992

3 721 581

8432,8%



Passive Account

Annual Accounts

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Sector Median2012

Shareholders' equity

147 697 358

-5,1%

155 629 870

18,5%

131 377 466

1 021 643

14356,8%

Share capital

74 139 140

0%

74 139 140

0%

74 139 140

385 429,50

19135,5%

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

18 938 865

6,9%

17 717 593

15,2%

15 373 861

22 105,50

85574,9%

Liabilities

150 917 936

-0,1%

151 058 816

26,0%

119 893 665

2 083 443

7143,7%

- Financial liabilities

101 400 270

65,9%

61 123 025

40,7%

43 439 100

119 640,50

84654,1%

- Advanced payments received

0

0%

0

0%

0

0

0%

- Trade account payables

25 358 662

-39,1%

41 640 392

3,3%

40 315 366

507 266

4899,1%

- Tax and social liabilities

21 229 809

-49,6%

42 139 142

25,5%

33 582 504

516 470

4010,6%

- Other debts and fixed assets liabilities

2 929 195

-52,4%

6 156 257

140,8%

2 556 695

61 997

4624,7%

Account regularization

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total liabilities

317 554 164

-2,1%

324 406 284

21,7%

266 644 992

3 721 579,50

8432,8%



Results

Annual Accounts

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Sector Median2012

Sales of Goods

411 425 318

-20,0%

514 507 428

38,7%

370 989 169

5 299 082,50

7664,1%

Net turnover

404 252 094

-17,4%

489 634 932

25,6%

389 811 794

5 129 630

7780,7%

- of which net export turnover

0

0%

0

0%

0

53 894,50

0%

Operating charges

392 072 535

-8,2%

427 287 376

33,2%

320 864 168

4 921 425,50

7866,6%

Operating profit/loss

19 352 783

-77,8%

87 220 052

74,0%

50 125 001

72 275,50

26676,4%

Financial income

1 013 695

-11,5%

1 145 907

112,1%

540 245

4 108

24576,1%

Financial charges

4 011 465

64,2%

2 443 386

59,5%

1 532 327

27 965,50

14244,3%

Financial profit/loss

-2 997 770

-131,0%

-1 297 479

-30,8%

-992 082

-6 538

-45751,5%

Pretax net operating income

16 355 013

-81,0%

85 922 573

74,9%

49 132 919

47 827,50

34095,8%

Extraordinary income

1 204 163

46,0%

824 496

-62,2%

2 180 686

24 855

4744,8%

Extraordinary charges

3 082 816

-16,7%

3 703 052

-43,9%

6 602 348

42 152,50

7213,5%

Extraordinary profit/loss

-1 878 653

34,7%

-2 878 556

34,9%

-4 421 662

-376,50

-498878,2%

Net result

12 964 047

-75,0%

51 807 811

87,4%

27 638 471

34 388,50

37598,8%

 

Display parameter

Currency

 Euro

 Kilo Euro

 

Normal Account

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Months

12

12

12

 

 

Accounts - Active 
Current Assets |  Equalization accounts |  Reference 

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Grand Total (I to VI)

Net

317 554 164

-2,1%

324 406 285

21,7%

266 644 992

Gross

CO

497 616 019

0,5%

495 068 465

15,9%

427 200 195

Amortisation

1A

180 061 855

5,5%

170 662 180

6,3%

160 555 203

 

Non declared distributed capital (I)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

Gross

AA

0

0%

0

0%

0

 

Active fixed asset (II)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total Active fixed asset (II)

Net

87 228 353

6,7%

81 773 256

16,6%

70 124 283

Gross

BJ

264 131 510

6,7%

247 486 440

8,9%

227 196 116

Amortisation

BK

176 903 157

6,8%

165 713 184

5,5%

157 071 833

 

Intangible fixed assets

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Start-up cost

Net

32 961

0%

32 961

0%

32 961

Gross

AB

32 961

0%

32 961

0%

32 961

Amortisation

AC

28 203

0%

28 203

0%

28 203

R & D expenses

Net

8 916

-52,0%

18 561

-34,2%

28 207

Gross

CX

296 823

0%

296 823

0,0%

296 824

Amortisation

AE

287 907

3,5%

278 262

3,6%

268 617

Distributorships, patents

Net

85 456

-16,8%

102 656

-6,6%

109 918

Gross

AF

1 124 670

-1,1%

1 136 750

1,6%

1 119 082

Amortisation

AG

1 039 214

0,5%

1 034 094

2,5%

1 009 164

Goodwill

Net

224 191

0,0%

224 192

1370,6%

15 245

Gross

AH

224 191

0,0%

224 192

-1,3%

227 241

Amortisation

AI

208 946

0%

208 946

-1,4%

211 996

Other intangible fixed assets

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AJ

899

0%

899

-0,1%

900

Amortisation

AK

899

0%

899

-0,1%

900

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible Assets

Net

351 524

-7,1%

378 370

103,1%

186 331



Tangible fixed assets

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Lands

Net

2 783 937

-0,8%

2 805 082

-0,8%

2 826 550

Gross

AN

4 890 048

0,0%

4 890 049

0%

4 890 049

Amortisation

AO

2 106 111

1,0%

2 084 967

1,0%

2 063 499

Buildings

Net

19 129 586

26,3%

15 149 109

-15,7%

17 973 192

Gross

AP

53 038 923

15,5%

45 913 874

0,3%

45 783 657

Amortisation

AQ

33 909 337

10,2%

30 764 765

10,6%

27 810 465

Plant

Net

54 778 223

23,6%

44 312 546

7,3%

41 312 659

Gross

AR

187 427 927

10,9%

169 024 041

5,4%

160 372 252

Amortisation

AS

132 649 704

6,4%

124 711 495

4,7%

119 059 593

Other tangible fixed assets

Net

147 371

5,7%

139 422

3,6%

134 572

Gross

AT

2 294 972

1,1%

2 270 055

-3,2%

2 345 047

Amortisation

AU

2 147 601

0,8%

2 130 633

-3,6%

2 210 475

Fixed assets in construction

Net

1 972 777

-81,3%

10 535 224

284,9%

2 737 429

Gross

AV

1 972 777

-81,3%

10 535 224

284,9%

2 737 429

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

87 947

-84,8%

577 454

36,6%

422 800

Gross

AX

87 947

-84,8%

577 454

36,6%

422 800

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

Sub Total Tangible asset

Net

78 899 841

73 518 837

65 407 202

 

 

Financial assets

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

4 817 130

3,0%

4 678 750

277,1%

1 240 750

Gross

CU

8 561 330

2,3%

8 368 634

71,9%

4 868 635

Amortisation

CV

3 744 200

1,5%

3 689 884

1,7%

3 627 885

Inter-company receivables

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BC

0

0%

0

0%

0

Other investment securities

Net

1 220

0,1%

1 219

-0,1%

1 220

Gross

BD

16 667

0%

16 667

0,0%

16 668

Amortisation

BE

15 447

0,0%

15 448

0%

15 448

Loans

Net

3 200 090

-2,0%

3 263 753

2,9%

3 172 277

Gross

BF

3 965 678

0%

4 029 341

0%

3 937 865

Amortisation

BG

765 588

765 588

765 588

Other financial assets

Net

195 697

15,5%

169 476

17,1%

144 706

Gross

BH

195 697

15,5%

169 476

17,1%

144 706

Amortisation

BI

0

0%

0

0%

0

Sub Total Financial Assets

8 214 137

8 113 198

4 558 953

  

 

Current Assets (III)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total Assets

Net

230 325 815

-5,1%

242 633 027

23,5%

196 520 707

Gross

CJ

233 484 508

-5,7%

247 582 021

23,8%

200 004 079

Amortisation

CK

3 158 693

-36,2%

4 948 994

42,1%

3 483 372

 

Stocks

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Raw materials

Net

41 798 998

-11,1%

47 028 592

38,2%

34 017 632

Gross

BL

42 240 203

-12,1%

48 042 506

36,7%

35 136 808

Amortisation

BM

441 205

-56,5%

1 013 914

-9,4%

1 119 176

Work in progress (goods)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BN

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

104 802 534

4,4%

100 375 677

24,5%

80 654 184

Gross

BR

105 402 885

3,1%

102 247 970

25,4%

81 507 314

Amortisation

BS

600 351

-67,9%

1 872 293

119,5%

853 130

Goods for resale

Net

498 851

-71,3%

1 740 837

832,5%

186 688

Gross

BT

498 851

-71,3%

1 740 837

832,5%

186 688

Amortisation

BU

0

0%

0

0%

0

Sub Total Stocks

Net

147 100 383

-1,4%

149 145 106

29,9%

114 858 504

 

 

Advance payments to suppliers

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Advance payments to suppliers

Net

612 959

-55,0%

1 361 478

213,0%

434 913

Gross

BV

612 959

-55,0%

1 361 478

213,0%

434 913

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0

 

Debtors

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Trade accounts receivable

Net

49 000 155

-4,3%

51 213 830

20,9%

42 352 511

Gross

BX

51 117 292

-4,1%

53 276 617

21,5%

43 863 577

Amortisation

BY

2 117 137

2,6%

2 062 787

36,5%

1 511 066

Other debtors

Net

27 978 746

-20,8%

35 340 707

-3,3%

36 565 099

Gross

BZ

27 978 746

-20,8%

35 340 707

-3,3%

36 565 099

Amortisation

CA

0

0%

0

0%

0

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

Sub Total Debtors

Net

76 978 901

-11,1%

86 554 537

9,7%

78 917 610

 

 

Divers

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CD

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

3 936 152

-11,2%

4 431 381

258,9%

1 234 742

Gross

CF

3 936 152

-11,2%

4 431 381

258,9%

1 234 742

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

Sub Total Divers

Net

3 936 152

-11,2%

4 431 381

258,9%

1 234 742

 

Prepaid expenses

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Prepaid expenses

Net

1 697 420

48,8%

1 140 525

6,1%

1 074 938

Gross

CH

1 697 420

48,8%

1 140 525

6,1%

1 074 938

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts (IV to VI)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Multi-period charges

CW3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Currency differential gain

CN3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

 

References

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

 

 

Display parameter

Currency

 Euro

 Kilo Euro

 

Accounts - Passive 
Other capital resources | Provisions for risks and charges | Liabilities | Translation loss | Equalization accounts | References 

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Grand Total (I to V)

EE

317 554 164

-2,1%

324 406 284

21,7%

266 644 992

 

Shareholder Equity (I)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total shareholders' equity (Total I)

DL

147 697 358

-5,1%

155 629 870

18,5%

131 377 466

Equity and shareholders' equity

DA

74 139 140

0%

74 139 140

0%

74 139 140

Issue and merger premiums

DB

33 047

0%

33 047

0,0%

33 048

Revaluation differentials

DC

460 181

0%

460 181

0%

460 181

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

Legal reserve

DD

7 413 914

0%

7 413 914

0%

7 413 914

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

Other reserves

DG

9 904

0%

9 904

0%

9 904

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

0

0%

0

Profits or losses brought forward

DH

38 260 748

327,4%

8 952 937

-20,9%

11 314 466

Profit or loss for the period

DI

12 964 047

-75,0%

51 807 810

87,4%

27 638 472

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

Special tax-allowable reserves

DK

14 416 377

12,5%

12 812 937

23,6%

10 368 341

  


Other capital resources (II)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

  

 

Provisions for risks and charges (III)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

18 938 865

6,9%

17 717 593

15,2%

15 373 861

Risk provisions

DP

1 773 521

0,9%

1 757 833

15,1%

1 527 741

Reserves for charges

DQ

17 165 344

7,6%

15 959 760

15,3%

13 846 120

  


Liabilities (IV)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total Liabilities (Total IV)

EC

150 917 936

-0,1%

151 058 816

26,0%

119 893 665

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

Bank loans and liabilities

DU

55 881 212

-8,5%

61 086 314

40,7%

43 400 608

Sundry loans and financial liabilities

DV

45 519 058

123893,0%

36 711

-4,6%

38 492

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

Advance payments received for current orders

DW

0

0%

0

0%

0

Trade accounts payables

DX

25 358 662

-39,1%

41 640 392

3,3%

40 315 366

Tax and social security liabilities

DY

21 229 809

-49,6%

42 139 142

25,5%

33 582 504

Fixed asset liabilities

DZ

1 815 226

-65,2%

5 209 430

192,4%

1 781 431

Other debts

EA

1 113 969

17,7%

946 827

22,1%

775 264

  

 

Translation loss (V)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Translation loss (Total V)

ED

0

0%

0

0%

0

  


Equalization accounts

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Deferred income

EB

0

0%

0

0%

0

  


References

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

 Euro

 Kilo Euro


Result account 
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges | Financial income | Financial charges | Financial charges | Extraordinary charges |Employee profit sharing | Tax on profits | References 


1- Operating result (I-II)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Operating result (Total I-II)

GG

19 352 783

-77,8%

87 220 052

74,0%

50 125 001

 

2 - Financial result (V - VI)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Financial result (Total V-VI)

GV

-2 997 770

-131,0%

-1 297 479

-30,8%

-992 082

 

3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

16 355 013

-81,0%

85 922 573

74,9%

49 132 919

 

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

-1 878 653

34,7%

-2 878 556

34,9%

-4 421 662

 

Profit or loss

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Profit or loss

HN

12 964 047

-75,0%

51 807 811

87,4%

27 638 471

 

Total Income (I+III+V+VII)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total Income (I+III+V+VII)

HL

413 643 176

-19,9%

516 477 831

38,2%

373 710 100

 

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

400 679 127

-13,8%

464 670 020

34,3%

346 071 629

 

Operating income (I)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total operating income (Total I)

FR

411 425 318

-20,0%

514 507 428

38,7%

370 989 169

 

 

Operating income (details)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Sale of goods for resale

FC

5 898 134

90,4%

3 098 137

10041,9%

30 548

France

FA

5 898 134

90,4%

3 098 137

10041,9%

30 548

Export

FB

0

0%

0

0%

0

Sale of goods produced

FF

398 353 960

-18,1%

486 536 795

24,8%

389 781 246

France

FD

398 353 960

-18,1%

486 536 795

24,8%

389 781 246

Export

FE

0

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

0

0%

0

0%

0

France

FG

0

0%

0

0%

0

Export

FH

0

0%

0

0%

0

Net turnover

FL

404 252 094

-17,4%

489 634 932

25,6%

389 811 794

France

FJ

404 252 094

-17,4%

489 634 932

25,6%

389 811 794

Export

FK

0

0%

0

0%

0

Stocked production

FM

3 122 994

-85,0%

20 773 202

193,2%

-22 284 246

Self-constructed assets

FN

188 676

1078,9%

16 005

-59,9%

39 917

Operating grants

FO

10 906

990,6%

1 000

-99,5%

191 268

Release of reserves and provisions

FP

3 777 447

4,0%

3 632 741

16,2%

3 126 327

Other income

FQ

73 201

-83,7%

449 548

331,8%

104 109

 

Operating charges (II)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total operating charges (Total II)

GF

392 072 535

-8,2%

427 287 376

33,2%

320 864 168



Exploitation charges

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Purchase of goods for resale

FS

4 143 799

47,2%

2 814 578

1836,3%

145 355

Change in stocks of goods for resale

FT

182 295

111,7%

-1 554 150

-832,6%

-166 647

Purchase of raw materials

FU

167 241 779

-14,5%

195 698 219

33,1%

147 010 776

Change in stocks of raw materials

FV

6 828 197

153,1%

-12 871 080

-1159,1%

1 215 329

Other external purchases and charges

FW

121 676 420

-14,7%

142 629 326

52,5%

93 519 692

Tax, duty and similar payments

FX

6 055 943

-18,6%

7 440 425

112,0%

3 509 032

Payroll

FY

46 566 435

-8,3%

50 774 622

20,7%

42 051 002

Social security costs

FZ

22 380 271

-0,4%

22 460 799

22,0%

18 407 488

 

Depreciation

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Depreciation of fixed assets

GA

13 835 528

10,9%

12 478 042

2,5%

12 178 984

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

0

Depreciation/amortisation of current assets

GC

59 323

-97,6%

2 425 655

115,8%

1 124 269

Provisions for risks and charges

GD

2 944 181

-35,7%

4 580 366

151,0%

1 825 163

 

Other charges

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Other charges

GE

158 364

-61,4%

410 574

839,0%

43 725

  

Operating charges (III-IV)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

  

 

Financial income (V)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total financial income (Total V)

GP

1 013 695

-11,5%

1 145 907

112,1%

540 245

Share financial income

GJ

0

0%

0

0%

0

Other investment income & capitalised receivables

GK

05

-85,7%

35

-93,0%

499

Other interest and similar income

GL

286 972

-62,8%

771 985

482,9%

132 437

Released provisions and transferred charges

GM

0

0%

0

0%

0

Exchange gains

GN

726 718

94,4%

373 887

-8,2%

407 309

Net income from disposal of investment securities

GO

0

0%

0

0%

0

  
Financial Charge (VI)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total financial charge (Total VI)

GU

4 011 465

64,2%

2 443 386

59,5%

1 532 327

Financial reserves and provisions

GQ

54 316

-12,4%

62 000

0%

0

Interest and similar charges

GR

3 691 517

58,1%

2 334 724

52,2%

1 533 516

Exchange losses

GS

265 632

469,3%

46 662

4024,5%

-1 189

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

  

Extraordinary income (VII)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total extraordinary income (Total VII)

HD

1 204 163

46,0%

824 496

-62,2%

2 180 686

Extraordinary operating income

HA

0

0%

0

0%

56 177

Extraordinary income from capital transactions

HB

29 000

625,0%

4 000

-99,7%

1 164 710

Released provisions and transferred charges

HC

1 175 163

43,2%

820 496

-14,5%

959 799

  

Extraordinary charges (VIII)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

3 082 816

-16,7%

3 703 052

-43,9%

6 602 348

Extraordinary operating charges

HE

225 711

-22,7%

291 953

32,6%

220 128

Extraordinary charges from capital transactions

HF

0

0%

0

0%

1 158 468

Extraordinary reserves and provisions

HG

2 857 105

-16,2%

3 411 099

-34,7%

5 223 75

 

 

Employee profit sharing (IX)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

42 750

-99,2%

5 351 233

61,8%

3 308 120

  

Tax on profits (X)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Tax on profits (Total X)

HK

1 469 561

-94,3%

25 884 973

88,1%

13 764 666

  

References

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

Of which transferred charges

A1

0

0%

0

0%

0

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

 

 

Display parameter

Currency

 Euro

 Kilo Euro


Other incomes tax return forms 
Reserve for depreciation | Provisions included in balance sheet | State deadlines claims and debts at the end of period
Table allocation results and other information 

Fixed Assets
Grand Total Fixed Assets (I to IV)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

OK2

0

0%

0

0%

13 331 000

Gross value at the end of period

OL

0

0%

0

0%

227 196 000

 

Research and development Charge (Total I)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

330 000

Decreasess by budget item transfer

C01

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

C02

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

D0

0

0%

0

0%

330 000

 

Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Gross value at begin of period

KD

0

0%

0

0%

1 697 000

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

0

0%

0

0%

121 000

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

LV2

0

0%

0

0%

471 000

Gross value at the end of period

LW

0

0%

0

0%

1 347 000

 

Tangible fixed assets (Total III)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Gross value at begin of period

LN

0

0%

0

0%

211 847 000

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

0

0%

0

0%

17 466 000

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NG2

0

0%

0

0%

12 762 000

Gross value at the end of period

NH

0

0%

0

0%

216 551 000

 

 

Financial assets (Total IV)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Gross value at begin of period

LQ

0

0%

0

0%

8 419 000

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

0

0%

0

0%

647 000

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NJ2

0

0%

0

0%

98 000

Gross value at the end of period

NK

0

0%

0

0%

8 968 000

 

Reserves for depreciation

Situation and movement of reserve for depreciation

 

Grad total (I-II-III)

 

  


31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Reserve for depreciation value at begin of period

0N

0

0%

0

0%

0

Increases

0P

0

0%

0

0%

0

Decreasess

0Q

0

0%

0

0%

0

Reserve for depreciation value at the end of period

0R

0

0%

0

0%

0

 

Research and development charge (Total I)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0

 

Other intangible assets (Total II)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

0

0%

0

0%

1 547 000

Increases

PF

0

0%

0

0%

145 000

Decreasess

PG

0

0%

0

0%

470 000

Decreasess by budget item transfer

PH

0

0%

0

0%

1 222 000

 

Total fixed assets amotisation (Total III)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

0

0%

0

0%

142 718 000

Increases

QV

0

0%

0

0%

12 939 000

Decreases

QW

0

0%

0

0%

4 522 000

Decreasess by budget item transfer

QX

0

0%

0

0%

151 135 000


Movements during period affecting charge allocated over several period 

Charges à répartir ou frais d'émission d'emprunt

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0

 

Premium refund of obligations

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Net value at begining of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

330 000

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

  
Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)

 

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Value at begining of period

7C

0

0%

0

0%

29 174 000

Increases

UB

0

0%

0

0%

8 335 000

Decreases

UC

0

0%

0

0%

3 866 000

Value at the end of period

UD

0

0%

0

0%

33 643 000

 

Includes Total allocations

Operating

UE

0

0%

0

0%

3 111 000

Financial

UG

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UJ

0

0%

0

0%

5 224 000

 

Includes Total Withdrawal

Operating

UF

0

0%

0

0%

2 906 000

Financial

UH

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UK

0

0%

0

0%

960 000

 

 

Total regulated provisions (Total I)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Value at begining of period

3Z

0

0%

0

0%

5 829 000

Increases

TS

0

0%

0

0%

4 539 000

Decreases

TT

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

TU

0

0%

0

0%

10 368 000

 

Total risk and charge provisions (Total II)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Value at begining of period

5Z

0

0%

0

0%

15 610 000

Increases

TV

0

0%

0

0%

2 573 000

Decreases

TW

0

0%

0

0%

2 809 000

Value at the end of period

TX

0

0%

0

0%

15 374 000

 

Total Provision for depreciation (Total III)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Value at begining of period

7B

0

0%

0

0%

7 735 000

Increases

TY

0

0%

0

0%

1 223 000

Decreases

TZ

0

0%

0

0%

1 057 000

Value at the end of period

UA

0

0%

0

0%

7 901 000

 

State deadlines claims and debts at the end of period
State claims

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Gross value

VT

0

0%

0

0%

84 511 000

1 year at most

VU

0

0%

0

0%

80 761 000

More than one year

VV

0

0%

0

0%

3 750 000

 

State of loans

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Claims related to holdings (gross)

UL

0

0%

0

0%

0

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

0%

0

0%

0

Loans (gross)

UP

0

0%

0

0%

3 938 000

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

0

0%

333 000

Other financial assets (gross)

UT

0

0%

0

0%

145 000

Other financial assets (1 year at most)

UV

0

0%

0

0%

0

 

Receivables statement of assets

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Customers doubtful or disputed

VA

0

0%

0

0%

0

Other claims customer

UX

0

0%

0

0%

43 863 000

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts

UY

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

0

0%

0

Income taxes

VM

0

0%

0

0%

0

Value added tax

VB

0

0%

0

0%

0

Other taxes and payments assimilated

VN

0

0%

0

0%

0

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

0

0%

0

Group and Associates

VC

0

0%

0

0%

0

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

0

0%

0

0%

36 565 000

 

Prepaid

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Prepaid

VS

0

0%

0

0%

0

 

State Debt

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Total debt (gross)

VY

0

0%

0

0%

119 894 000

1 year at most

VZ2

0

0%

0

0%

119 894 000

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

VZ4

0

0%

0

0%

0

 

Details

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VG2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

0

0%

0

0%

43 401 000

1 year at most

VH2

0

0%

0

0%

43 401 000

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

0

0%

0

0%

39 000

1 year at most

8A2

0

0%

0

0%

39 000

More than 1 year and 5 years at most

8A3

0

0%

0

0%

0

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

0

0%

0

0%

40 315 000

1 year at most

8B2

0

0%

0

0%

40 315 000

More than 1 year and 5 years at most

8B3

0

0%

0

0%

40 315 000

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8C2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

0

0%

0

0%

33 583 000

1 year at most

8D2

0

0%

0

0%

33 583 000

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (gross)

VW1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VW2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VQ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

0

0%

0

0%

1 781 000

1 year at most

8J2

0

0%

0

0%

1 781 000

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VI2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More 5 years

VI4

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

0

0%

0

0%

775 000

1 year at most

8K2

0

0%

0

0%

775 000

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8L2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0

 

References

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Loans made during the period

VJ

0

0%

0

0%

6 000 000

Debt repaid during the period

VK

0

0%

0

0%

4 200 000

  

Table allocation results and other information 
Dividends distributed

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0

 

Commitments

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0

 

Other charges Externes

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0

 

Taxes and Fees

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0

 

VAT

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0

 

Average number of employees

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Average number of employees

YP

0

0%

0

0%

900

 

Groups and Shareholders

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Groups and Shareholders

ZR

0

-

0

-

-

 

 

 

Display parameter

Comparison mode

 Average

 Median

 

Ratios 
Structure and liquidity | Management or rotation | Profitability of the business | Return on capital 

Structure and Liquidity

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Sector Median2012

Fixed Asset Financing

1,68

3,7%

1,62

5,9%

1,53

1,17

43,6%

Global Debt

134 days

20,7%

111 days

0%

111 days

134 days

0%

Working Capital Fund overall net

161 days

43,8%

112 days

0,9%

111 days

61 days

163,9%

Financial independence

264,25%

3,7%

254,72%

-15,8%

302,63%

498,39%

-47,0%

Solvability

46,51%

-3,0%

47,97%

-2,6%

49,27%

45,48%

2,3%

Capacity debt futures

%

-

%

-

302,71%

720,76%

-

Coverage of current assets by net working capital overall

78,01%

25,9%

61,96%

2,7%

60,36%

41,55%

87,7%

General Liquidity

-

-

0,67

0,85

-

Restricted Liquidity

-

-

0,68

1,18

-


Management or rotation

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Sector Median2012

Need background in operating working capital

156 days

44,4%

108 days

-0,9%

109 days

36 days

333,3%

Treasury

4 days

33,3%

3 days

200%

1 days

4 days

0%

Inventory turnover of goods

42 days

-91,5%

497 days

115,7%

-3156 days

21 days

100%

Average length of credit granted to customers

46 days

17,9%

39 days

-4,9%

41 days

55 days

-16,4%

Average length of credit obtained suppliers

30 days

-34,8%

46 days

-23,3%

60 days

60 days

-50,0%

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

91 days

3,4%

88 days

2,3%

86 days

48 days

89,6%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

days

-

days

-

180 days

121 days

-

Rotation tangible assets

%

-

%

-

180,01%

174,72%

-



Profitability of the business

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Sector Median2012

Margin trading

0,39%

2,6%

0,38%

3700%

0,01

0,09%

333,3%

Profitability of the business

8,04

-61,8%

21,04

32,2%

15,92

5,67%

41,8%

Net profit

3,21%

-69,7%

10,58%

49,2%

7,09%

2,09%

53,6%

Growth rate of turnover (excluding VAT)

-17,44%

-168,1%

25,61%

-58,9%

62,31%

0%

0%

Rates integration

26,59%

-29,1%

37,52%

16,2%

32,28%

27,44%

-3,1%

Rate leasing furniture

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Work Factor

64,14%

60,9%

39,87%

-17,0%

48,04%

63,86%

0,4%

Weight interests

0,99

98,0%

0,50%

28,2%

0,39%

0,71%

39,4%


Return on capital

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Sector Median2012

Cash flow from the overall profitability

7,34%

-47,0%

13,84%

31,1%

10,56%

6,22%

18,0%

Rates of economic profitability

13%

-72,9%

48%

33,3%

36%

15,49%

-16,1%

Financial profitability

147697358%

-5,1%

155629870%

18,5%

131377466%

1021643%

14356,8%

Return on investment

6,81%

-72,8%

25,03%

50,0%

16,69%

6,60%

3,2%

 

 

Display parameter

Currency

 Euro

 Kilo Euro

Comparison mode

 Average

 Median

 

Soldes Intermédiaires de Gestion 

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Sector Median2012

Turnover

404 252 094

-17,4%

489 634 932

25,6%

389 811 794

5 129 630 € 

7780,7% 

 

Sales of goods

5 898 134

90,4%

3 098 137

10041,9%

30 548

 

 

- Purchase of goods

4 143 799

47,2%

2 814 578

1836,3%

145 355

 

 

+/- Stock of goods variation

182 295

111,7%

-1 554 150

-832,6%

-166 647

 

 

Trading margin

1 572 040 €

-14,5%

1 837 709 €

3445,0%

51 840 €

1 732 € 

90664,4% 

0,39 % CA

2,6%

0,38 % CA

3700%

0,01 % CA

0,46 % CA 

-15,2% 

 

Sale of goods produced

398 353 960

-18,1%

486 536 795

24,8%

389 781 246

 

 

+/- Stocked production

3 122 994

-85,0%

20 773 202

193,2%

-22 284 246

 

 

+ Self-constructed assets

188 676

1078,9%

16 005

-59,9%

39 917

 

 

Period production

401 665 630 €

-20,8%

507 326 002 €

38,0%

367 536 917 €

2 907 355,50 € 

13715,5% 

99,36 % CA

-4,1%

103,61 % CA

9,9%

94,29 % CA

99,22 % CA 

0,1% 

 

Trading margin

1 572 040

-14,5%

1 837 709

3445,0%

51 840

1 732 

90664,4% 

+ Period Production

401 665 630

-20,8%

507 326 002

38,0%

367 536 917

2 907 355,50 

13715,5% 

- Purchase of raw materials

167 241 779

-14,5%

195 698 219

33,1%

147 010 776

 

 

+/- Change in stocks of raw materiels

6 828 197

153,1%

-12 871 080

-1159,1%

1 215 329

 

 

- Other external purchases and charges

121 676 420

-14,7%

142 629 326

52,5%

93 519 692

 

 

Added value

107 491 274 €

-41,5%

183 707 246 €

46,0%

125 842 960 €

1 317 078,50 € 

8061,3% 

26,59 % CA

-29,1%

37,52 % CA

16,2%

32,28 % CA

27,44 % CA 

-3,1% 

 

Added value

107 491 274 €

-41,5%

183 707 246 €

46,0%

125 842 960 €

1 317 078,50 € 

8061,3% 

+ Operating grants

10 906

990,6%

1 000

-99,5%

191 268

 

 

- Tax, duty and similar payments

6 055 943

-18,6%

7 440 425

112,0%

3 509 032

 

 

- Personal charges

68 946 706

-5,9%

73 235 421

21,1%

60 458 490

 

 

Gross operating surplus

32 499 531 €

-68,5%

103 032 400 €

66,0%

62 066 706 €

213 142 € 

15147,8% 

8,04 % CA

-61,8%

21,04 % CA

32,2%

15,92 % CA

5,67 % CA 

41,8% 

 

Gross operating surplus

32 499 531 €

-68,5%

103 032 400 €

66,0%

62 066 706 €

213 142 € 

15147,8% 

+ Release of reserves and provisions

3 777 447

4,0%

3 632 741

16,2%

3 126 327

 

 

+ Other operating income

73 201

-83,7%

449 548

331,8%

104 109

 

 

- Depreciation/Amortisation

16 839 032

-13,6%

19 484 063

28,8%

15 128 416

 

 

- Other charges

158 364

-61,4%

410 574

839,0%

43 725

 

 

Operating result

19 352 783 €

-77,8%

87 220 052 €

74,0%

50 125 001 €

72 276 € 

26676,2% 

4,79 % CA

-73,1%

17,81 % CA

38,5%

12,86 % CA

4,01 % CA 

19,5% 

 

 

Operating result

19 352 783 €

-77,8%

87 220 052 €

74,0%

50 125 001 €

72 276 € 

26676,2% 

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

 

 

+ Financial income

1 013 695

-11,5%

1 145 907

112,1%

540 245

 

 

- Financial charges

4 011 465

64,2%

2 443 386

59,5%

1 532 327

 

 

Pre-tax result

16 355 013 €

-81,0%

85 922 573 €

74,9%

49 132 919 €

47 828 € 

34095,5% 

4,05 % CA

-76,9%

17,55 % CA

39,3%

12,60 % CA

2,56 % CA 

58,2% 

 

Extraordinary income

1 204 163

46,0%

824 496

-62,2%

2 180 686

24 855 

4744,8% 

- Extraordinary charges

3 082 816

-16,7%

3 703 052

-43,9%

6 602 348

 

 

Extraordinary result

-1 878 653 €

34,7%

-2 878 556 €

34,9%

-4 421 662 €

-376,50 € 

-498878,2% 

-0,46 % CA

22,0%

-0,59 % CA

47,8%

-1 % CA

-00,01 % CA 

-4500% 

 

Pre-tax result

16 355 013 €

-81,0%

85 922 573 €

74,9%

49 132 919 €

47 828 € 

34095,5% 

Extraordinary result

-1 878 653 €

34,7%

-2 878 556 €

34,9%

-4 421 662 €

-376,50 € 

-498878,2% 

- Employee profit sharing

42 750

-99,2%

5 351 233

61,8%

3 308 120

 

 

- Tax on profits

1 469 561

-94,3%

25 884 973

88,1%

13 764 666

 

 

Net result

12 964 049 €

-75,0%

51 807 811 €

87,4%

27 638 471 €

34 389 € 

37598,2% 

3,21 % CA

-69,7%

10,58 % CA

49,2%

7,09 % CA

2,09 % CA 

53,6% 

 

 

commentary

 

The comments are ordered according to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative for another or can change depending on its value. This is a purely statistical decision.

 

 

 

The shareholder's equity is 147,697,358 €

The creditor days are 22.90

The liabilities are 150,917,936 €

The net current assets are 230,325,815 €

The net turnover is 404,252,094 €

The pre-tax profit is 14,433,608 €

The risk provisions are 18,938,865 €

The total assets are 317,554,164 €

Low risk workforce size

The company has 6 directors

Industry code with low risk rating

Department code with low risk rating

The ratio total assets to total liabilities is 1,87

The return on total assets employed is 4,55

The sales to current assets ratio is 1,76

The stock to turnover ratio is 36.39

The increase in the gearing percentage over the last two accounting periods is 61 %

 

 


Payment Information Summary - Trade Payment Data

 

Payment Information Summary - Trade Payment Data

 

Total number of Invoices available

32

 

Total number of Invoices paid within or up to 30 days after the due date

19

 

Total number of Invoices paid more than 30 days after the due date

13

 

Total number of Invoices currently outstanding where the due date has not yet been reached

0

 

Total number of Invoices currently outstanding beyond the due date

0

 

 

judgements

 

Collective procedures

 

No judgment information for the company

 

   Social security, pension funds preferential rights | Tax office preferential rights

 

Preferential rights details and history

 

Summary of preferential rights

Company monitored since

14/04/2009

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

 

Social security, pension funds preferential rights

Number of preferential rights

0

Total amount

-

Due remaining amount

-

Date of last preferential right

-

 

Historical Data

Registration number

Registration date

Date of the planned end

Creditor

Amount of the debt

Due remaining amount

80315211

17/06/2008

10/01/2011

6 709 EUR

-

Reason for closure

Crossed Off

Court

Chambery

Debtor

FERROPEM 
517 AVENUE DE LA BOISSE 73000 CHAMBERY, CHAMBERY

 

Tax office preferential rights

Number of active preferential rights

0

Total amount

-

Due remaining amount

-

Date of last preferential right

-

 

Historical Data

Registration number

Registration date

Date of the planned end

Creditor

Amount of the debt

Due remaining amount

255143

26/05/2009

04/08/2009

TRESOR PUBLIC (COMPTABLE DIRECTION DES

238 557 EUR

-

Reason for closure

Crossed Off

Court

Chambery

Creditor

TRESOR PUBLIC (COMPTABLE DIRECTION DES 

Debtor

FERROPEM 
517 AVENUE DE LA BOISSE 73000 CHAMBERY, CHAMBERY

 

Pledges

Title of the act and date

BORDEREAU INSCRIPTION TRESOR en date du

 

 

Group data

Ultimate parent company

FERROATLANTICA SL

Direct parent

FERROATLANTICA SL - 100 %

Group – Number of companies

5

Linkages – Number of companies

1

Number of countries

1

 

Group Structure

 

Company Name

SIREN

Parts

Last account published

 FERROATLANTICA

 

36322

-

31/12/2012

 FERROPEM

 

642005177

100%

31/12/2012

 VAAL SILICON SMELTERS PTY LTD

 

-

100%

-

 PHOTOSIL INDUSTRIES

 

510803729

65%

31/12/2012

 FERROALPES

 

1467407

Majority

31/12/2009

 

 

Linkages

 

 

Ultimate parent company

FERROATLANTICA SL

Direct parent

FERROATLANTICA SL - 100 %

Group – Number of companies

5

Linkages – Number of companies

1

Number of countries

1

 

 

Company Name

SIREN

Last account

Turnover

FERROATLANTICA DEUTSCHLAND GMBH

 

HRB 20142

31/12/2012

-

 

 

event history

 

Status history

 

 

No Status History

 

 

Recent publications in Gazettes

 

 

Publication date

Gazette Name

Description

 

18/08/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

73 - SAVOIE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

5526 - 642005177 RCS. FERROPEM. Forme : Société par actions simplifiée à associé unique. Adresse : 517 avenue de la Boisse 73000 Chambéry.Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2012.

12/03/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

73 - SAVOIE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY

1452 - 642 005 177 RCS Chambery. FERROPEM. Forme : Société par actions simplifiée à associé unique. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 20 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS Président : BUCHER Jean Philippe Maxime en fonction le 27 Juillet 2011 Administrateur : LARREA PAGUAGA Pedro en fonction le 20 Juillet 2012 Président du conseil d'administration : BUCHER Jean Philippe Maxime en fonction le 20 Juillet 2012 Administrateur : BUCHER Jean Philippe Maxime en fonction le 20 Juillet 2012 Administrateur : SANCHEZ RECIO Juan Carlos en fonction le 20 Juillet 2012 Administrateur : GUERRERO AULLO Miguel en fonction le 20 Juillet 2012 Membre du conseil d'administration : OLLIVIER Benoît Emile Norbert en fonction le 04 Mars 2013. Activité : . 
Commentaires : Modification de représentant.

08/03/2013

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

Eco des Pays de Savoie (L )


Date de décision : 01/02/2013
La société 642005177 - FERROPEM, 517 AV DE LA BOISSE, 73000 CHAMBERY 
Fait l'objet du départ de Monsieur Santiago OLLER VELASCO

08/03/2013

JAL

Appointment of the social representative

 

Eco des Pays de Savoie (L )


Date de décision : 01/02/2013
Société faisant l'objet d'une nomination : 642005177 - FERROPEM, 517 AV DE LA BOISSE, 73000 CHAMBERY 
Nominé : Monsieur Benoît OLLIVIER, 01300 ARBIGNIEU
En la fonction de : Membre du Conseil d'Administration

03/09/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

73 - SAVOIE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY

5475 - 642005177 RCS. FERROPEM. Forme : Société par actions simplifiée à associé unique. Adresse : 517 avenue de la Boisse 73000 Chambéry.Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011.

20/07/2012

JAL

Appointment of the social representative

 

Eco des Pays de Savoie (L )


Date de décision : 29/06/2012
Société faisant l'objet d'une nomination : 642005177 - FERROPEM, 517 AV DE LA BOISSE, 73000 CHAMBERY 
Nominé : Monsieur Jean-Philippe BUCHER, 73460 MONTAILLEUR
En la fonction de : Président du Conseil d'Administration
Nominé : Monsieur Jean-Philippe BUCHER, 73460 MONTAILLEUR
En la fonction de : Président
Nominé : Monsieur Pedro LARREA PAGUAGA, 28046 MADRID
En la fonction de : Membre du Conseil d'Administration
Nominé : Monsieur Miguel GUERRERO AULLO, 28046 MADRID
En la fonction de : Membre du Conseil d'Administration
Nominé : Monsieur Santiago OLLER VELASCO, 28046 MADRID
En la fonction de : Membre du Conseil d'Administration
Nominé : Monsieur Juan Carlos SANCHEZ RECIO, 28046 MADRID
En la fonction de : Membre du Conseil d'Administration

20/07/2012

JAL

Appointment of the social representative

 

Eco des Pays de Savoie (L )


Date de décision : 29/06/2012
Société faisant l'objet d'une nomination : 642005177 - FERROPEM, 517 AV DE LA BOISSE, 73000 CHAMBERY 
Nominé : Monsieur Jean-Philippe BUCHER, 73460 MONTAILLEUR
En la fonction de : Président du Conseil d'Administration
Nominé : Monsieur Jean-Philippe BUCHER, 73460 MONTAILLEUR
En la fonction de : Président
Nominé : Monsieur Pedro LARREA PAGUAGA, 28046 MADRID
En la fonction de : Membre du Conseil d'Administration
Nominé : Monsieur Miguel GUERRERO AULLO, 28046 MADRID
En la fonction de : Membre du Conseil d'Administration
Nominé : Monsieur Santiago OLLER VELASCO, 28046 MADRID
En la fonction de : Membre du Conseil d'Administration
Nominé : Monsieur Juan Carlos SANCHEZ RECIO, 28046 MADRID
En la fonction de : Membre du Conseil d'Administration

28/07/2011

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

Journal du batiment et des travaux publics (Le)


Date de décision : 13/07/2011
La société 642005177 - FERROPEM, 517 AV DE LA BOISSE, 73000 CHAMBERY 
Fait l'objet du départ de Date d'effet : 13/07/2011

28/07/2011

JAL

Appointment of the social representative

 

Journal du batiment et des travaux publics (Le)


Société faisant l'objet d'une nomination : 642005177 - FERROPEM, 517 AV DE LA BOISSE, 73000 CHAMBERY 
Nominé : Monsieur Jean-Philippe BUCHER, 73460 MONTAILLEUR
En la fonction de : Président
Date d'effet : 13/07/2011

27/01/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

73 - SAVOIE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY

994 - 642 005 177 RCS Chambéry. FERROPEM. Forme : S.A.S. unipersonnelle. Administration : Président de la société : DE PENARANDA Y ALGAR Francisco Javier Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Capital : 74139140.41 EUR. Activité : Tant en France qu'à l'étranger : la fabrication, la transformation et la vente de tous produits chimiques, métallurgiques, électrochimiques, électrométallurgiques, de leurs dérivés, composés, sous-produits et matières premières. Adresse de l’établissement principal : 517 avenue de la Boisse, 73000 Chambéry. 
Adresse du siège social : 517 avenue de la Boisse, 73000 Chambéry. 
Commentaires : Changement de Président. Date de commencement de l’activité : 01/07/2003. Date d’effet : 22/12/2010.

13/01/2011

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

 

Eco des Pays de Savoie (L')


Date de décision : 22/12/2010
La société 642005177 - FERROPEM, 517 AV DE LA BOISSE, 73000 CHAMBERY 
Fait l'objet du départ de Date d'effet : 22/12/2010

09/09/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

73 - SAVOIE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY

9899 - 642005177 RCS. FERROPEM. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 517 avenue de la Boissé 73000 Chambéry. Commentaires :Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

01/06/2010

JAL

Proposed merger

 

ED. SAVOIE


Date de décision : 21/05/2010
Absorbant : 642005177 - FERROPEM, 517 AV DE LA BOISSE, 73000 CHAMBERY
Absorbé : 542078530 - SOCIETE DE PRODUITS INDUSTRIELS DU RHO, 517 AV DE LA BOISSE, 73000 CHAMBERY
Boni de fusion : 194 759 € 

07/09/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

73 - SAVOIE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

7086 - 642005177 RCS. FERROPEM. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 517 avenue de la Boissé 73000 Chambéry. Commentaires :Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

21/01/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

73 - SAVOIE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

949 - 642 005 177 RCS Chambéry. FERROPEM. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président de la société : MONTES PEREZ Eduardo. Directeur général : DE PENARANDA Y ALGAR Francisco Javier. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Capital : 74139140.41 EUR. Activité : Tant en France qu'à l'étranger : la fabrication, la transformation et la vente de tous produits chimiques, métallurgiques, électrochimiques, électrométallurgiques, de leurs dérivés, composés, sous-produits et matières premières. Adresse de l’établissement principal : 517 avenue de la Boissé, 73000 Chambéry. 
Adresse du siège social : 517 avenue de la Boissé, 73000 Chambéry. 
Commentaires : Réduction du capital. Date de commencement de l’activité : 01/07/2003.

02/11/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

73 - SAVOIE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

1059 - 642 005 177 RCS Chambéry. FERROPEM. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président de la société : MONTES PEREZ Eduardo. Directeur général : DE PENARANDA Y ALGAR Francisco Javier. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Capital : 114238170.29 EUR. Activité : Tant en France qu'à l'étranger : La fabrication, la transformation et la vente de tous produits chimiques, métallurgiques, électrochimiques, électrométallurgiques, de leurs dérivés, composés, sous-produits et matières premières. Adresse de l’établissement principal : 517 avenue de la Boissé, 73000 Chambéry. 
Adresse du siège social : 517 avenue de la Boissé, 73000 Chambéry. 
Commentaires : Changement de président. Date de commencement de l’activité : 01/07/2003. Date d’effet : 13/10/2008.

29/08/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

 

73 - SAVOIE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

10823 - 642005177 RCS. FERROPEM. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 517 avenue de la Boissé 73000 Chambéry. Commentaires :Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

08/01/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

 

73 - SAVOIE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

2069 - 642 005 177 RCS CHAMBERY. FERROPEM. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président de la société : VILLAR MIR Juan Miguel. Directeur général : DE PENARANDA Y ALGAR Francisco Javier. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Capital : 125695035.97 EUR. Activité : Tant en France qu'à l'étranger : La fabrication, la transformation et la vente de tous produits chimiques, métallurgiques, électrochimiques, électrométallurgiques, de leurs dérivés, composés, sous-produits et matières premières. Adresse de l’établissement principal : 517 avenue de la Boisse, 73000 Chambéry. 
Adresse du siège social : 517 avenue de la Boisse, 73000 Chambéry. 
Commentaires : Réduction du capital.

22/11/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

6917 - 642 005 177. RCS Chambéry FERROPEM. Forme: Société par actions simplifiée. Adresse du siège social: 517 avenue de la Boisse 73000 Chambéry. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

05/10/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

5130 - RCS Chambéry B 642 005 177. RC 73-B 18. FERROPEM. Forme: SAS . Adresse du siège social: 517, avenue de la Boisse,73000 Chambery. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

27/08/2006

Bodacc A

Vente et cession

 

0602 - RCS Saint-Gaudens B 491 205 860. THERMO MAGNESIUM FRANCE S.A.S. Forme : S.A.S. Capital : 37 000 euros. Adresse du siège social : usine de Marignac, Marignac, 31440 Saint-Béat. Etablissement principal - Activité : fonderie de magnésium et d'alliages de magnésium. Adresse : Marignac, 31440 Saint-Béat. Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 100 000 euros. Date de début d'activité : 31 juillet 2006. Précédent propriétaire : FERROPEM. RCS Saint-Gaudens 642 005 177. Publication légale : La Voix du Midi du 3 août 2006. Oppositions : S.C.P. Fargues Gely Fis, notaires associés, B.P. 18, 31110 Bagnères-de-Luchon.

22/06/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

0931 - Ancienne situation du siège social : RCS Chambéry B 642 005 177. RC 73-B 18. PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A.S. Capital : 165 243 255 euros. Adresse : 517 avenue de la Boisse, 73000 Nouvelle situation du siège social - Dénomination : FERROPEM. Etablissement principal - Activité : tant en France qu'à l'étranger, fabrication, transformation et vente de tous produits chimiques, métallurgiques, électrochimiques ou électrométallurgiques de leurs dérivés, de leurs composés, de sous-produits et de matières premières . Adresse : 517 avenue de la Boisse, 73000 Date d'effet : 25 avril 2006.

03/02/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

1436 - RCS Chambéry B 642 005 177. RC 73-B 18. PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A.S. Capital : 165 243 255 euros. Adresse du siège social : 517 avenue de la Boisse,, 73000 Administration : président : VILLAR MIR (Juan, Miguel). Directeur général : DE PENARANDA Y ALGAR (Francisco, Javier). Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES-BEAS S.A.R.L. Ancienne administration : ancien commissaire aux comptes titulaire : S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Ancien commissaire aux comptes suppléant : COLL (Pierre). Etablissement principal - Activité : tant en France qu'à l'étranger, fabrication, transformation et vente de tous produits chimiques, métallurgiques, électrochimiques ou électrométallurgiques de leurs dérivés, de leurs composés, de sous-produits et de matières premières . Adresse : 517 avenue de la Boisse, 73000 Date d'effet : 25 novembre 2005.

02/08/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

 

4362 - RCS Chambéry B 642 005 177. RC 73-B 18. PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme: SAS . Adresse du siège social: 517, avenue de la Boisse,73000 Chambéry. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

20/07/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

1103 - RCS Chambéry B 642 005 177. RC 73-B 18. PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A.S. Capital : 165 243 255 euros. Adresse du siège social : 517 avenue de la Boisse,, 73000 Administration : président : VILLAR MIR (Juan, Miguel). Nomination en qualité de directeur général : DE PENARANDA Y ALGAR (Francisco, Javier). Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : COLL (Pierre). Ancienne administration : ancien président : EPRON (Bernard, Louis, Gérard). Etablissement principal - Activité : tant en France qu'à l'étranger, fabrication, transformation et vente de tous produits chimiques métallurgiques, électrochimiques, électrométallurgiques, de leurs dérivés, composés, de sous-produits et de matières premières . Adresse : 517 avenue de la Boisse, 73000 Date d'effet : 31 mai 2005.

08/07/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

1305 - Ancienne situation du siège social : RCS Chambéry B 642 005 177. RC 73-B 18. PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A.S. Capital : 62 227,76 euros. Adresse : 517 avenue de la Boisse, 73000 Nouvelle situation du siège social - Capital : 165 243 255 euros. Etablissement principal - Activité : tant en France qu'à l'étranger, fabrication, transformation, vente de tous produits chimiques, métallurgiques, électrochimiques et électrométallurgiques de leurs dérivés composés, de sous-produits et de matières premières . Adresse : 517 avenue de la Boisse, 73000 Date d'effet : 30 mai 2005.

17/11/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Chambéry B 642005177 RC 73-B 18 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. S. Capital : 62 227 euros. Adresse du siège social : 517 avenue de la Boisse, 73000 Chambéry. Administration : président : EPRON (Bernard, Louis, Gérard). Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : COLL (Pierre). Ancienne administration : ancien commissaire aux comptes titulaire : S.A. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU-AUDIT. Ancien commissaire aux comptes suppléant : S.A. R.L. BEAS Etablissement principal: Activité : tant en France qu'à l' étranger, fabrication, transformation et vente de tous produits chimiques métallurgiques, électrochimiques, électrométallurgiques, de leurs dérivés, composés, sous-produits et matières premières. Adresse : 517 avenue de la Boisse, 73000 Chambéry. Date d'effet : 26 mai 2004.

24/08/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

Ancienne situation du siège social. RCS Chambéry B 642005177 RC 73-B 18 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. S. Capital : 62 227 euros. Adresse : 235 avenue Alsace-Lorraine, 73000 Chambéry Nouvelle situation du siège social. Adresse : 517 avenue de la Boisse, 73000 Chambéry Etablissement principal: Activité : tant en France qu'à l' étranger, fabrication, transformation, vente de tous produits chimiques, métallurgiques, électrochimiques et électrométallurgiques leurs dérivés, composés, sous-produits et matières premières. Adresse : 235 avenue Alsace- Lorraine, 73000 Chambéry ETABLISSEMENT PRINCIPAL nouvelle situation. Adresse : 517 avenue de la Boisse, 73000 Chambéry. Date d'effet : 1 e r juillet 2003.

07/02/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

Ancienne situation du siège social. RCS Chambéry B 642005177 RC 73-B 18 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. S. Capital : 62 227 euros. Adresse : La Défense 2, tour Manhattan, 5 place de l' Iris, 92400 Courbevoie Nouvelle situation du siège social. Adresse : 235 avenue Alsace-Lorraine, 73000 Chambéry Etablissement principal: Activité : tant en France qu'à l'étranger, fabrication, transformation et vente de tous produits chimiques, métallurgiques, électrochimiques et électrométallurgiques de leurs dérivés, composés, sous-produits et matières premières. Adresse : La Défense 2, tour Manhattan, 5 place de l'Iris, 92400 Courbevoie ETABLISSEMENT PRINCIPAL nouvelle situation. Adresse : 235 avenue Alsace-Lorraine, 73000 Chambéry. Date d'effet : 1 e r janvier 2003.

27/10/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Nanterre B 642005177 RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. S. Commentaires : modification survenue sur la forme juridique et l' administration. Administration : administrateurs partants : COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE S.A., représentée par ELFASSY (David) PECHINEY, représentée par VARIN (Philippe, Pierre) LEVY ( Gilles, Pierre, Joseph) RISS (Claude, Etienne, Aloys) PASQUIER (Alain, Jean) BIZEUL (Annick, Marie, Pierre) ( Nom d' usage : DELHON-BUGARD). Modification du président : EPRON (Bernard). Administrateur partant : RINALDI ( Michel). Administrateurs représentant les salariés partants : CROLET ( Emmanuel) ZANELLO (Tony). Administrateurs partants : SIBILLE ( Jean-Claude) VINET (Sébastien).

09/10/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Nanterre B 642005177 RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. Capital : 62 227,76 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital ( diminution) et l'administration. Administration : président du conseil d' administration partant : GANI (Jacques). Modification du P.-D.G. et administrateur : EPRON (Bernard). Nomination d'administrateurs représentant les salariés : CROLET ( Emmanuel) ZANELLO (Tony). Nomination d'administrateurs : SIBILLE (Jean- Claude) VINET (Sébastien).

23/07/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Nanterre B 642005177 RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateurs partants : CHAPUY (Jean- Paul) et RUFFIER (Gérard, Raymond).

04/06/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Nanterre B 642005177 RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateurs partants : MARTINON ( Jean, André) BOTTE (Robert, Jean, Michel). Nomination d'administrateurs : EPRON (Bernard) RINALDI (Michel).

31/01/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Nanterre B 642005177 RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : commissaire aux comptes titulaire partant : BEFEC-PRICE WATERHOUSE S.A. Commissaire aux comptes suppléant partant : DENIZEAU (Jacques).

31/01/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Nanterre B 642005177 RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : BAULON (Daniel, Maurice, Edmond, Henri). Nomination d' un administrateur : BIZEUL (Annick, Marie, Pierre) ( Nom d'usage : DELHON- BUGARD). Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU B.M.A. S.A. Nomination du commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDIT.

03/08/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

*. RCS Nanterre B 642 005 177 RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. Capital : 49 782 208 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

03/08/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

*. RCS Nanterre B 642 005 177 RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. Capital : 49 782 208 euros. Adresse du siège social : La Défense 2, tour Manhattan 92400 Courbevoie. Commentaires : rectificatif sur date d'effet de la fusion-absorption de la Société PEM TARENTAISE, au 1er janvier 1999, au lieu du 1er janvier 1999. A.G.M. du 12 mai 2000.

20/02/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Nanterre B 642005177 RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. Capital : 311 138 800 F. Adresse du siège social : tour Manhattan, La Défense 2, 92400 Courbevoie. Commentaires : modification survenue sur le capital ( augmentation). Fusion-absorption de la S.A. PEM TARENTAISE,. RCS Nanterre 672 033 065. Date d'effet : 1er novembre 1999.

16/01/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Nanterre B 642005177 RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification d'un administrateur : PECHINEY. Administrateur partant : LEFLON (Jacques, Paul, Benoit). Administrateur élu par les salariés partant : DEYMIER (Michel, Robert). Nomination d'un administrateur : PASQUIER (Alain, Jean). Commissaire aux comptes suppléant partant : MONTAGNE ( Bernard). Nomination du commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES- B.E.A.S. S.A.R.L.

08/08/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Nanterre B 642005177 RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. Capital : 308 919 600 F. Adresse du siège social : tour Manhattan, La Défense 2, 92400 Courbevoie. Commentaires : apport de la branche d'activité de silicium à la STE P.E.M. SILICIUM,. RCS Nanterre B 414 870 014, à compter du 3 mai 1999 avec effet rétroactif au 1er janvier 1999.

05/01/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Nanterre B 642 005 177 RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification d'un administrateur : PECHINEY.

05/01/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Nanterre B 642 005 177 RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateurs partants : LECOIN ( Michel) FARGE (Yves, Marie, Pierre). Nomination d'administrateurs : BAULON ( Daniel, Maurice, Edmond, Henri) RISS ( Claude, Etienne, Aloys). Modification du commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU B.M.A. S.A.

24/12/1997

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS Nanterre B 382 844 470 A dater du: 22 octobre 1997 P.E.M. ABRASIFS- REFRACTAIRES. Forme : S.A. Adresse du siège social : 5-6 place de l'Iris, Tour- Manhattan La Défense 2, 92400 Courbevoie Fonds secondaire acquis par apport, au montant évalué à 25 971 000 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Albertville 97-B 314. Activité : corindons blancs et autres , nitrures. Adresse : 73540 La Bathie Date de début d'activité: 1er janvier 1997 Précédente propriétaire-exploitante PECHINEY ELECTROMETALLURGIE S.A. RCS B 642 005 177 RC 73-B 7 Publication légale: La Gazette du Palais du 18 septembre 1997 déclaration de créances: au greffe du tribunal d'instance de Albertville.

16/12/1997

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS Nanterre B 382 844 470 PEM ABRASIFS- REFRACTAIRES. Forme : S.A. Adresse du siège social : 5-6 place de l'Iris, Tour Manhattan, La Défense 2, 92400 Courbevoie Divers biens et droits constituant une branche autonome d' activité dépendant du fonds secondaire acquis par apport au montant de l' apport net évalué à 99 750 000 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Bagnères-de- Bigorre 97-B 53. Activité : fabrication de corindons bruns et autres, bauxittes frittées. Adresse : avenue Gaston-Phoebus, usine de Beyrède, 65410 Sarrancolin. Date d'effet : 1er septembre 1997 (effet rétroactif au 1er janvier 1997) Précédente propriétaire- exploitante PECHINEY ELECTROMETALLURGIE S.A. RCS Bagnères-de-Bigorre B 642 005 177 RC 73-B 3 Publication légale: La Gazette du Palais du 18 septembre 1997 déclaration de créances: au greffe du tribunal de commerce de Bagnères-de- Bigorre.

12/10/1997

Bodacc A

Création d'établissement

 

RCS Nanterre B 382 844 470 RC 92-B 2167 PEM ABRASIFS-REFRACTAIRES. Forme : S.A. Capital : 100 000 000 de F. Activité : production et vente de corindons blancs, bruns, d'autres produits abrasifs et réfractaires industriels ainsi que les nitrures prise de participations dans toutes sociétés et tous groupements, français ou étrangers. Adresse du siège social : tour Manhattan, 5-6 place de l' Iris La Défense 2 92400 Courbevoie Apport de divers biens et droits constituant la branche autonome d' activité de fabrication de corindons blancs et bruns ainsi que les nitrures au montant évalué à 99 750 000 F. Date d'effet : 1er septembre 1997 avec effet rétroactif au 1er janvier 1997 Précédent Propriétaire SOCIETE PECHINEY ELECTROMETALLURGIE S.A. RCS Nanterre B 642 005 177 Publication légale: La Gazette du Palais du 18 septembre 1997 déclaration de créances: au tribunal de commerce de Nanterre.

12/10/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Nanterre B 642 005 177 RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. Capital : 308 919 600 F. Adresse du siège social : tour Manhattan, La Défense 2 92400 Courbevoie. Commentaires : apport de la branche autonome d'activité de fabrication de corindons blancs et bruns ainsi que de nitrures, à la STE PEM ABRASIFS REFRACTAIRES S.A., tour Manhattan, 5-6 place de l'Iris, La Défense 2, 92400 Courbevoie,. RCS Nanterre B 382 844 477, avec effet rétroactif au 1er janvier 1997. Date d'effet : 1er septembre 1997.

13/04/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Nanterre B 642 005 177 RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification d'un administrateur : COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE S.A.

08/12/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS *. RCS Nanterre B 642 005 177 RC RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. Administration : président du conseil d'administration : GANI ( Jacques) Administrateurs : COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE S.A. PECHINEY S.A. MARTINON (Jean, André) LECOIN ( Michel) BOTTE (Robert, Jean-Michel) LEVY (Gilles, Pierre, Joseph) LEFLON (Jacques, Paul, Benoit). Administrateurs représentant les salariés : RUFFIER (Gérard) BAT ( Pascal, Louis) BISOLI (Marc) CHAPUY (Jean-Paul). Commissaires aux comptes titulaires : BEFEC-PRICE WATERHOUSE S.A. CABINET BERNARD MONTAGNE ANDRE AMIC ET ASSOCIES. Commissaires aux comptes suppléants : MONTAGNE (Bernard) DENIZEAU (Jacques). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

06/08/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS Nanterre B 642 005 177 RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. Administration : président du conseil d' administration : GANI (Jacques). Administrateurs : COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE S.A. PECHINEY S.A. LOPPION (Jacques) MARTINON (Jean, André) LECOIN (Michel) BOTTE ( Robert, Jean, Michel) LEVY (Gilles, Pierre, Joseph). Administrateur représentant les salariés : RUFFIER ( Gérard) BAT (Pascal, Louis) BISOLI ( Marc) CHAPUY (Jean, Paul). Commissaires aux comptes titulaires : BEFEC PRICE WATERHOUSE S.A. CABINET BERNARD MONTAGNE ANDRE AMIC ET ASSOCIES. Commissaires aux comptes suppléants : MONTAGNE (Bernard) DENIZEAU (Jacques). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

01/06/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS *. RCS Nanterre B 642 005 177 RC RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. Administration : président du conseil d'administration : GANI ( Jacques) Administrateurs : COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE S.A. PECHINEY S.A. LOPPION (Jacques) MARTINON (Jean, André) LECOIN (Michel) BOTTE ( Robert, Jean-Michel) LEVY (Gilles, Pierre, Joseph). Administrateurs représentant les salariés : RUFFIER ( Gérard) BAT (Pascal, Louis) BISOLI (Marc) CHAPUY (Jean-Paul). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET PETITEAU SCACCHI S.A. CABINET BERNARD MONTAGNE ANDRE AMIC ET ASSOCIES. Commissaires aux comptes suppléants : MONTAGNE (Bernard) NARAIN (Pradeep). Commentaires : modification survenue sur l' administration.

07/04/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

 

RCS *. RCS Nanterre B 642 005 177 RC RC 84-B 623 PECHINEY ELECTROMETALLURGIE. Forme : S.A. Administration : président du conseil d'administration : GANI ( Jacques) Administrateurs : COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE S.A. PECHINEY S.A. LOPPION (Jacques) FEREC (Germain, Yves, Marie) MARTINON (Jean, André) LECOIN (Michel) BOTTE (Robert, Jean, Michel). Administrateurs representant les salariés : RUFFIER (Gérard) BAT (Pascal, Louis) BISOLI (Marc) CHAPUY (Jean-Paul). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET PETITEAU SCACCHI S.A. CABINET BERNARD MONTAGNE ANDRE AMIC ET ASSOCIES. Commissaires aux comptes suppléants : MONTAGNE (Bernard) NARAIN (Pradeep). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

 

 

Company events history

 

 

 

Date

Description

04/10/2013

Disengagement of the group

04/10/2013

New subsidiarie(s) detected

04/10/2013

New parent detected

27/08/2013

Update Rating

27/08/2013

Update Limit

27/08/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

18/08/2013

Bodacc C : Deposit accounts notice

31/07/2013

Update Rating

31/07/2013

Update Limit

31/07/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

12/03/2013

Bodacc B: Various editing or changing

08/03/2013

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

04/03/2013

Amendment

01/02/2013

Legal Gazette: Appointment of the social representative

31/12/2012

New accounts available

03/09/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

20/07/2012

Updated articles of association

20/07/2012

Changes to the Board of Directors

20/07/2012

Amendment

29/06/2012

Legal Gazette: Appointment of the social representative

31/12/2011

New accounts available

26/08/2011

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

28/07/2011

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

27/07/2011

Amendment

27/07/2011

New chairman (CEO, CoB)

13/07/2011

Legal Gazette: Appointment of the social representative

27/01/2011

Bodacc B: Various editing or changing

13/01/2011

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

10/01/2011

Preferential right lapsed

10/01/2011

Amendment

10/01/2011

Minutes of general meeting of shareholders

10/01/2011

New chairman (CEO, CoB)

31/12/2010

New accounts available

22/12/2010

Update of Company Legal Form

22/12/2010

Other modification of Establishment (error correction)

09/09/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

12/08/2010

Minutes of general meeting of shareholders

12/08/2010

Declaration of conformity

12/08/2010

Merger

12/08/2010

Amendment

03/06/2010

Legal Gazette: Proposed merger

21/05/2010

Merger

21/05/2010

Planned merger

31/12/2009

New accounts available

07/09/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

04/08/2009

Preferential right lapsed

26/05/2009

Unfiling of a Tax Office preferential right

26/05/2009

New Filling of Tax Office preferential right

14/04/2009

Collection of preferential rights activated for this company

21/01/2009

New Bodacc B ads detected

21/01/2009

Bodacc B: Various editing or changing

05/01/2009

Capital reduction

05/01/2009

Private document

05/01/2009

Statuts mis à jour

05/01/2009

Updated articles of association

05/01/2009

Acte modificatif

05/01/2009

Minutes of general meeting of shareholders

31/12/2008

Modification of Company Activity

31/12/2008

Update of Company Activity

31/12/2008

New accounts available

11/12/2008

Other modification of Establishment

20/11/2008

Réduction de Capital

20/11/2008

Acte modificatif

20/11/2008

Capital reduction

20/11/2008

Private document

20/11/2008

Amendment

20/11/2008

Minutes of general meeting of shareholders

02/11/2008

Bodacc B: Various editing or changing

02/11/2008

New Bodacc B ads detected

21/10/2008

Changement de Président (PDG, PCA)

21/10/2008

New manager

21/10/2008

Minutes of general meeting of shareholders

21/10/2008

Appointment/resignation of company officers

21/10/2008

Private document

21/10/2008

New chairman (CEO, CoB)

21/10/2008

PV d'Assemblée

29/08/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

17/06/2008

Unfiling of a Social Security preferential right

28/01/2008

Acte modificatif

28/01/2008

Updated articles of association

28/01/2008

Statuts mis à jour

28/01/2008

Minutes of general meeting of shareholders

28/01/2008

Private document

28/01/2008

Réduction de Capital

28/01/2008

Capital reduction

08/01/2008

Bodacc B: Various editing or changing

08/01/2008

New Bodacc B ads detected

31/12/2007

New accounts available

12/12/2007

Other modification of Establishment

07/12/2007

Réduction de Capital

07/12/2007

Minutes of general meeting of shareholders

07/12/2007

Statuts mis à jour

07/12/2007

Updated articles of association

07/12/2007

Capital reduction

07/12/2007

Acte modificatif

07/12/2007

Amendment

07/12/2007

Private document

14/11/2007

Amendment

14/11/2007

Acte modificatif

14/11/2007

Minutes of general meeting of shareholders

14/11/2007

Private document

14/11/2007

Réduction de Capital

14/11/2007

Capital reduction

09/11/2007

Other modification of Establishment

31/12/2006

New accounts available

24/11/2006

Merger

24/11/2006

Private document

24/11/2006

Déclaration de conformité

24/11/2006

Declaration of conformity

24/11/2006

Fusion

24/11/2006

Minutes of general meeting of shareholders

24/11/2006

Acte modificatif

24/11/2006

Updated articles of association

24/11/2006

Statuts mis à jour

08/11/2006

Audit or Management Report

08/11/2006

Rapport des Commissaires ou du Gérant

08/11/2006

Private document

04/10/2006

Private document

04/10/2006

Rapport des Commissaires ou du Gérant

04/10/2006

Audit or Management Report

31/08/2006

Private document

31/08/2006

Fusion

31/08/2006

Planned merger

31/08/2006

Projet de Fusion

30/05/2006

Acte modificatif

30/05/2006

Application and court order

30/05/2006

Requête et Ordonnance

24/05/2006

Private document

24/05/2006

New company name

24/05/2006

Changement de dénomination sociale

24/05/2006

Acte modificatif

24/05/2006

Updated articles of association

24/05/2006

Statuts mis à jour

24/05/2006

Minutes of general meeting of shareholders

09/01/2006

Minutes of general meeting of shareholders

09/01/2006

Nomination/démission des organes de gestion

09/01/2006

Private document

09/01/2006

Acte sous seing privé

09/01/2006

Acte modificatif

09/01/2006

New auditor

09/01/2006

Changement de Commissaire aux Comptes

09/01/2006

PV d'Assemblée

09/01/2006

Appointment/resignation of company officers

31/12/2005

New accounts available

28/06/2005

Minutes of general meeting of shareholders

28/06/2005

PV d'Assemblée

28/06/2005

Modification du Conseil d'Administration

28/06/2005

Appointment/resignation of company officers

28/06/2005

Private document

28/06/2005

Acte modificatif

28/06/2005

Acte sous seing privé

28/06/2005

Nomination/démission des organes de gestion

28/06/2005

Changement de Président (PDG, PCA)

16/06/2005

Capital increase

16/06/2005

Augmentation de Capital

16/06/2005

Minutes of general meeting of shareholders

16/06/2005

Rapport des Commissaires ou du Gérant

16/06/2005

PV d'Assemblée

16/06/2005

Capital reduction

16/06/2005

Acte sous seing privé

16/06/2005

Private document

16/06/2005

Statuts mis à jour

16/06/2005

Updated articles of association

16/06/2005

Reconstitution de l'Actif Net

16/06/2005

Réduction de Capital

31/12/2004

New accounts available

22/10/2004

Changement de Commissaire aux Comptes

22/10/2004

Acte modificatif

22/10/2004

Private document

22/10/2004

Appointment/resignation of company officers

22/10/2004

Nomination/démission des organes de gestion

22/10/2004

Minutes of general meeting of shareholders

22/10/2004

New auditor

22/10/2004

Acte sous seing privé

22/10/2004

PV d'Assemblée

05/04/2004

PV d'Assemblée

05/04/2004

Acte modificatif

05/04/2004

Continuation malgré perte supérieure à la moitié du capital

05/04/2004

Acte sous seing privé

31/12/2003

New accounts available

11/08/2003

Statuts mis à jour

11/08/2003

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

11/08/2003

Acte sous seing privé

11/08/2003

PV d'Assemblée

22/01/2003

Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce

22/01/2003

Immatriculation secondaire devient principale

22/01/2003

Statuts mis à jour

22/01/2003

Acte sous seing privé

22/01/2003

PV d'Assemblée

15/10/2002

Nomination/démission des organes de gestion

15/10/2002

Acte sous seing privé

15/10/2002

Changement de Forme Juridique sans changement de catégorie

15/10/2002

Changement de Forme Juridique avec changement de catégorie

15/10/2002

Rapport des Commissaires ou du Gérant

15/10/2002

Statuts mis à jour

15/10/2002

PV d'Assemblée

26/09/2002

Changement de Président (PDG, PCA)

26/09/2002

Statuts mis à jour

26/09/2002

Nomination/démission des organes de gestion

26/09/2002

PV d'Assemblée

26/09/2002

Acte sous seing privé

26/09/2002

Réduction de Capital

26/09/2002

Acte modificatif

26/09/2002

Reconstitution de l'Actif Net

26/09/2002

Modification du Conseil d'Administration

26/09/2002

Certificat de dépôt des fonds

26/09/2002

Augmentation de Capital

26/09/2002

PV du Conseil d'Administration

10/07/2002

Acte modificatif

10/07/2002

Nomination/démission des organes de gestion

10/07/2002

Acte sous seing privé

10/07/2002

Modification du Conseil d'Administration

16/05/2002

Acte modificatif

16/05/2002

Modification du Conseil d'Administration

16/05/2002

PV du Conseil d'Administration

16/05/2002

Nomination/démission des organes de gestion

16/05/2002

Acte sous seing privé

08/02/2002

Déclaration de conformité

08/02/2002

PV d'Assemblée

08/02/2002

Apport Partiel

07/02/2002

PV d'Assemblée

07/02/2002

Déclaration de conformité

07/02/2002

Acte sous seing privé

19/11/2001

Acte sous seing privé

19/11/2001

Projet de Fusion

19/11/2001

Apport Partiel

20/09/2001

Requête et Ordonnance

20/09/2001

Acte modificatif

16/01/2001

Nomination/démission des organes de gestion

16/01/2001

Changement de Commissaire aux Comptes

16/01/2001

PV du Conseil d'Administration

16/01/2001

Modification du Conseil d'Administration

16/01/2001

Acte sous seing privé

16/01/2001

PV d'Assemblée

16/01/2001

Acte modificatif

26/06/2000

PV du Conseil d'Administration

26/06/2000

Acte sous seing privé

26/06/2000

Statuts mis à jour

26/06/2000

Modification du Conseil d'Administration

26/06/2000

PV d'Assemblée

26/06/2000

Augmentation de Capital

26/06/2000

Rapport des Commissaires ou du Gérant

26/06/2000

Acte modificatif

26/06/2000

Nomination/démission des organes de gestion

26/06/2000

Conversion du Capital Social en Euros

27/01/2000

Déclaration de conformité

27/01/2000

Acte sous seing privé

27/01/2000

Augmentation de Capital

27/01/2000

Rapport des Commissaires ou du Gérant

27/01/2000

Statuts mis à jour

27/01/2000

PV d'Assemblée

27/01/2000

Fusion

06/12/1999

Acte sous seing privé

06/12/1999

Nomination/démission des organes de gestion

06/12/1999

Changement de Commissaire aux Comptes

06/12/1999

Acte modificatif

06/12/1999

Modification du Conseil d'Administration

06/12/1999

PV du Conseil d'Administration

29/11/1999

Projet de Fusion

29/11/1999

Acte sous seing privé

05/08/1999

Nomination/démission des organes de gestion

05/08/1999

Acte modificatif

05/08/1999

Requête et Ordonnance

15/06/1999

Déclaration de conformité

15/06/1999

PV du Conseil d'Administration

15/06/1999

Acte sous seing privé

15/06/1999

Augmentation de Capital

15/06/1999

Apport Partiel

15/06/1999

PV d'Assemblée

17/03/1999

Acte modificatif

17/03/1999

Apport Partiel

17/03/1999

Acte sous seing privé

18/12/1998

Nomination/démission des organes de gestion

18/12/1998

Modification du Conseil d'Administration

18/12/1998

Acte sous seing privé

18/12/1998

Acte modificatif

18/12/1998

PV du Conseil d'Administration

15/12/1998

PV du Conseil d'Administration

15/12/1998

Acte modificatif

15/12/1998

Acte sous seing privé

15/12/1998

Changement de Commissaire aux Comptes

18/09/1997

Apport Partiel

18/09/1997

PV d'Assemblée

18/09/1997

Déclaration de conformité

18/09/1997

Acte sous seing privé

16/07/1997

Projet de Fusion

16/07/1997

Apport Partiel

16/07/1997

Acte sous seing privé

26/03/1997

Nomination/démission des organes de gestion

26/03/1997

Modification du Conseil d'Administration

26/03/1997

Acte sous seing privé

26/04/1996

Acte modificatif

26/04/1996

PV du Conseil d'Administration

07/03/1996

Acte modificatif

07/03/1996

PV d'Assemblée

07/03/1996

Modification du Conseil d'Administration

07/03/1996

PV du Conseil d'Administration

07/03/1996

Statuts mis à jour

07/03/1996

Nomination/démission des organes de gestion

06/11/1995

Acte modificatif

06/11/1995

PV du Conseil d'Administration

06/11/1995

Modification du Conseil d'Administration

06/11/1995

Nomination/démission des organes de gestion

04/07/1995

PV d'Assemblée

04/07/1995

Acte modificatif

03/05/1995

PV du Conseil d'Administration

03/05/1995

Acte modificatif

03/05/1995

Modification du Conseil d'Administration

03/05/1995

Nomination/démission des organes de gestion

03/03/1995

Changement de Président (PDG, PCA)

03/03/1995

PV du Conseil d'Administration

03/03/1995

Modification du Conseil d'Administration

03/03/1995

Acte modificatif

03/03/1995

Acte sous seing privé

03/03/1995

Nomination/démission des organes de gestion

06/09/1994

PV du Conseil d'Administration

06/09/1994

Changement de Président (PDG, PCA)

06/09/1994

Modification du Conseil d'Administration

06/09/1994

Nomination/démission des organes de gestion

06/09/1994

Acte modificatif

06/09/1994

PV d'Assemblée

29/11/1993

Acte modificatif

29/11/1993

Acte sous seing privé

29/11/1993

PV du Conseil d'Administration

29/11/1993

Nomination/démission des organes de gestion

04/08/1993

Continuation malgré perte supérieure à la moitié du capital

04/08/1993

PV d'Assemblée

04/08/1993

Acte modificatif

04/08/1993

Augmentation de Capital

04/08/1993

Statuts mis à jour

04/08/1993

Déclaration de conformité

04/08/1993

Certificat de dépôt des fonds

10/06/1993

Nomination/démission des organes de gestion

10/06/1993

Acte modificatif

10/06/1993

Modification du Conseil d'Administration

10/06/1993

PV du Conseil d'Administration

08/03/1993

Acte modificatif

08/03/1993

PV du Conseil d'Administration

09/07/1992

Déclaration de conformité

09/07/1992

Statuts mis à jour

09/07/1992

PV d'Assemblée

09/07/1992

Acte modificatif

09/07/1992

PV du Conseil d'Administration

09/07/1992

Augmentation de Capital

16/12/1991

Nomination/démission des organes de gestion

16/12/1991

Modification du Conseil d'Administration

16/12/1991

PV du Conseil d'Administration

 


 

Establishment events history

 

 

Date

Description

31/07/2013

Update Limit

03/11/2012

Update Rating

06/10/2012

Update Limit

08/09/2012

Update Rating

28/06/2011

Update of phone numbers

22/12/2010

Modification of Head office

25/05/2010

Update of phone numbers

10/12/2009

Update Limit

10/12/2009

Update Rating

05/05/2009

Update Rating

05/05/2009

Update Limit

06/02/2009

Update Limit

05/02/2009

Update Rating

03/02/2009

Update Rating

03/02/2009

Update Limit

31/12/2008

Modification of Head office

01/08/2008

Update Rating

25/06/2008

Update Rating

07/02/2008

Update Rating

09/12/2007

Update Limit

11/09/2007

Update Rating

 

directors

 

Name

M. BUCHER JEAN PHILIPPE MAXIME

Manager position

Administrator, President, Chairman of the Board

Date of birth

15/04/1949

Place of birth

MALO LES BAINS

Type

Individual

Name at birth

 

 

Name

M. SANCHEZ RECIO JUAN CARLOS

Manager position

Administrator

Date of birth

31/03/1951

Place of birth

MADRID(ESPAGNE)

Type

Individual

Name at birth

 

 

Name

M. GUERRERO AULLO MIGUEL

Manager position

Administrator

Date of birth

09/04/1958

Place of birth

BARCELONE(ESPAGNE)

Type

Individual

Name at birth

 

Name

M. LARREA PAGUAGA PEDRO

Manager position

Administrator

Date of birth

03/01/1964

Place of birth

MADRID(ESPAGNE)

Type

Individual

Name at birth

 

 

Previous Directors

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

President

M EDUARDO MONTES PEREZ

- - -

Managing director

M FRANCISCO DE PENARANDA Y ALGAR

- - -

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.60.05

UK Pound

1

Rs.101.32

Euro

1

Rs.83.34

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

SUB

 

 

Report Prepared by :

MNL

 

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.