MIRA INFORM REPORT

 

 

Report Date :

15.09.2014              

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

LENZING AKTIENGESELLSCHAFT

 

 

Registered Office :

Werkstraße  2, A-4860 Lenzing

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

31.12.2013

 

 

Date of Incorporation :

07.07.1938

 

 

Legal Form :

joint stock company since 1938-05-31

 

 

Line of Business :

Manufacture of man-made fibres

Activities of holding companies

Manufacture of other inorganic basic chemicals

 

 

No. of Employees :

Not Available

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory

Payment Behaviour :

No complaints

Litigation :

Clear

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – June 01, 2014

 

Country Name

Previous Rating

(31.03.2014)

Current Rating

(01.06.2014)

Austria

A2

A2

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low Risk

 

A2

Moderate Low Risk

 

B1

Moderate Risk

 

B2

Moderate High Risk

 

C1

High Risk

 

C2

Very High Risk

 

D

 

 

AUSTRIA - ECONOMIC OVERVIEW

 

Austria, with its well-developed market economy, skilled labor force, and high standard of living, is closely tied to other EU economies, especially Germany's. Its economy features a large service sector, a sound industrial sector, and a small, but highly developed agricultural sector. Following several years of solid foreign demand for Austrian exports and record employment growth, the international financial crisis of 2008 and subsequent global economic downturn led to a sharp but brief recession. Austrian GDP contracted 3.8% in 2009 but saw positive growth of about 2% in 2010 and 2.7% in 2011. Growth fell to 0.6% in 2012. Unemployment did not rise as steeply in Austria as elsewhere in Europe, partly because the government subsidized reduced working hour schemes to allow companies to retain employees. The 2012 unemployment rate of 4.3% was the lowest within the EU. Stabilization measures, stimulus spending, and an income tax reform pushed the budget deficit to 4.5% in 2010 and 2.6% in 2011, from only about 0.9% in 2008. The international financial crisis of 2008 caused difficulties for Austria's largest banks whose extensive operations in central, eastern, and southeastern Europe faced large losses. The government provided bank support - including in some instances, nationalization - to support aggregate demand and stabilize the banking system. Austria's fiscal position compares favorably with other euro-zone countries, but it faces external risks, such as Austrian banks' continued exposure to Central and Eastern Europe as well as political and economic uncertainties caused by the European sovereign debt crisis. In 2011 the government attempted to pass a constitutional amendment limiting public debt to 60% of GDP by 2020, but it was unable to obtain sufficient support in parliament and instead passed the measure as a simple law. In March 2012, the Austrian parliament approved an austerity package consisting of a mix of expenditure cuts and new revenues that will bring public finances into balance by 2016. In 2012, the budget deficit rose to 3.1% of GDP

Source : CIA

 

 

 


Basic company information

 

Last up-date:

2014-09-11

Company name:

Lenzing Aktiengesellschaft

Status:

active company

Locations:

Werkstraße  2, A-4860 Lenzing

Phone:

0043 (7672) 701

Fax:

0043 (7672) 701 - 3880

E-mail:

office@lenzing.com

Internet:

http://www.lenzing.com

Activities:

Önace 20600 80% Manufacture of man-made fibres

 

Önace 64200 10% Activities of holding companies

 

Önace 20130 10% Manufacture of other inorganic basic chemicals

 

Additional company information

 

Year of incorporation:

1938

 

Activities:

 

 

Type of company:

Manufacturing

 

Legal form:

joint stock company since 1938-05-31

 

companies' house number:

FN 96499 k Wels 1938-07-07

 

Trade names:

Lenzing FR

 

Trade names:

Lenzing Modal

 

Trade names:

Lenzing Viscose

 

Trade names:

MicroModal

 

Trade names:

Tencel

 

VAT number:

ATU 23468003

 

ARA-number:

2294

 

number - Austrian National Bank:

6840

 

 

 

 

Export 

Country 

 

 

 

Export

world-wide

 

2014

 

 

Financial data

 

total turnover (total sales)

2013

EUR  746.356.750,57

(exact)

total turnover (total sales)

2012

EUR  766.128.273,46

(exact)

total turnover (total sales)

2011

EUR  839.523.861,46

(exact)

total turnover (total sales)

2010

EUR  698.717.928,78

(exact)

total turnover (total sales)

2009

EUR  650.772.925,24

(exact)

turnover (sales) - group

2013

EUR  1.908.869.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2012

EUR  2.090.403.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2011

EUR  2.140.032.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2010

EUR  1.766.323.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2009

EUR  1.254.734.000,00

(exact)

total employees

2014

2000

(approx.)

total stock

2014

EUR  56.000.000,00

(approx.)

total investments

2013

EUR  253.370.649,92

(exact)

 

 

Extraxt from the Companies' House

 

firm (style):

    1      Lenzing Aktiengesellschaft

legal form:

    1      Aktiengesellschaft

registered office:

    1      politischer Gemeinde Lenzing

business adress:

    1      Werkstraße 2
           4860 Lenzing (OÖ)

capital:

   72      EUR 27.574.071,43

reference date annual accounts:

    1      31. Dezember

annual accounts:

   82      zum 31.12.2013 eingereicht am 31.07.2014

consolidated accounts:

   82      zum 31.12.2013 eingereicht am 31.07.2014

power of representation:

    1      Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder
           bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder
           durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen
           vertreten.
           Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
           selbständige Vertretungsbefugnis erteilen.

other provisions:

   34      Der Vorstand besteht aus ein, zwei, drei oder vier Personen.

board of directors:

        BA   Mag.Dr. Peter Untersperger, geb. 27.02.1960
   62        Vorsitzende/r
             vertritt seit 01.01.1999 gemeinsam mit
             einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
        BE   Dipl.Ing. Friedrich Weninger, MBA, geb. 11.04.1957
   62        Mitglied
             vertritt seit 19.12.2008 gemeinsam mit
             einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
        CZ   Robert van de Kerkhof, geb. 25.02.1964
   81        Mitglied
             vertritt seit 01.05.2014 gemeinsam mit
             einem weiteren Vorstandsmitglied oder
             einer/einem Prokuristin/Prokuristen
        DD   Dr. Thomas Riegler, geb. 23.05.1969
   82        Mitglied
             vertritt seit 01.06.2014 gemeinsam mit
             einem weiteren Vorstandsmitglied oder
             einer/einem Prokuristin/Prokuristen

proxy:

         Q   Dipl.Ing. Herbert Grill, geb. 05.06.1956
    1        vertritt seit 09.04.1990 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren
             Gesamtprokuristen
        AW   Dipl.Ing. Josef Kroiß, geb. 18.01.1953
   15        vertritt seit 09.12.1997 gemeinsam mit
             einem  Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        BS   Dipl.Ing. Gottfried Paul Rosenauer, geb. 12.04.1962
   42        vertritt seit 14.07.2004 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        CB   Dipl.-Ing. Dr. Dieter Eichinger, geb. 11.06.1958
   60        vertritt seit 20.08.2008 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        CI   Dr. Klaus Geppert, geb. 21.05.1950
   64        vertritt seit 08.07.2009 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        CK   Wilhelm Feilmair, geb. 19.05.1962
   64        vertritt seit 08.07.2009 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        CL   Dipl.-Ing. Wolfgang Plasser, geb. 20.08.1966
   64        vertritt seit 08.07.2009 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        CM   Johann-Peter Viehböck, geb. 08.11.1966
   64        vertritt seit 08.07.2009 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        CP   Ingo Patric Thate, geb. 25.05.1973
   70        vertritt seit 01.01.2011 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        CQ   Johann Ruess, geb. 20.01.1964
   70        vertritt seit 01.01.2011 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        CS   Mag. Florian Wirth, geb. 03.03.1973
   74        vertritt seit 15.02.2012 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        CU   Dr. Otto Ramsenthaler, geb. 07.04.1959
   76        vertritt seit 01.10.2012 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        CV   Dipl.-Ing. Marco Schlimpert, geb. 30.03.1974
   77        vertritt seit 01.11.2012 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        CW   Stephanie Kniep, geb. 15.07.1966
   77        vertritt seit 01.11.2012 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
        CX   Mag. Christof Pöltner, geb. 17.02.1964
   78        vertritt seit 01.01.2013 gemeinsam mit
             einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen

supervisory board:

        AZ   Rudolf Baldinger, geb. 11.10.1954
   18        Mitglied
        BK   Johann Schernberger, geb. 06.01.1964
   31        Mitglied
        BR   Dr. Veit Sorger, geb. 10.06.1942
   71        Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
        CA   Mag. Andreas Schmidradner, geb. 18.04.1961
   59        Mitglied
        CE   Georg Liftinger, geb. 26.01.1961
   62        Mitglied
        CG   Dr. Josef Krenner, geb. 15.06.1952
   63        Mitglied
        CH   Mag. Helmut Bernkopf, geb. 10.05.1967
   63        Mitglied
        CO   Dr. Michael Junghans, geb. 06.07.1967
   71        Vorsitzende/r
        CR   Mag. Patrick Prügger, geb. 08.08.1975
   71        Mitglied
        CT   Dr. Astrid Skala-Kuhmann, geb. 07.09.1953
   75        Mitglied
        CY   Dr. Franz Gasselsberger, geb. 12.04.1959
   79        Mitglied
        DA   Dr. Hanno Bästlein, geb. 19.04.1963
   82        Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
        DB   Ing. Daniela Födinger, geb. 22.11.1964
   82        Mitglied
        DC   Franz Berlanda, geb. 01.03.1961
   82        Mitglied

general table:

 Landesgericht Wels
   1 Ersterfassung abgeschlossen am 12.05.1994  Geschäftsfall 913 Fr   166/94 p
       Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
  15 eingetragen am 23.01.1998                  Geschäftsfall  27 Fr  5685/97 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.12.1997
  18 eingetragen am 19.06.1998                  Geschäftsfall  29 Fr   475/98 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.06.1998
  22 eingetragen am 17.08.1999                  Geschäftsfall  29 Fr  2558/99 a
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.06.1999
  25 eingetragen am 30.10.1999                  Geschäftsfall  29 Fr  3429/99 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.09.1999
  29 eingetragen am 05.07.2000                  Geschäftsfall  29 Fr  1631/00 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.05.2000
  31 eingetragen am 12.09.2001                  Geschäftsfall  29 Fr  2752/01 x
       Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 05.09.2001
  34 eingetragen am 17.08.2002                  Geschäftsfall  29 Fr  2467/02 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.08.2002
  41 eingetragen am 15.07.2004                  Geschäftsfall  29 Fr  2687/04 b
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.07.2004
  42 eingetragen am 22.07.2004                  Geschäftsfall  29 Fr  2751/04 x
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 15.07.2004
  48 eingetragen am 07.10.2005                  Geschäftsfall  29 Fr  3969/05 x
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.09.2005
  49 eingetragen am 08.10.2005                  Geschäftsfall  29 Fr  3974/05 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.09.2005
  50 eingetragen am 25.01.2006                  Geschäftsfall  29 Fr   330/06 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.01.2006
  53 eingetragen am 01.12.2007                  Geschäftsfall  29 Fr  4703/07 v
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.09.2007
  56 eingetragen am 01.03.2008                  Geschäftsfall  29 Fr  1105/08 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.02.2008
  59 eingetragen am 07.08.2008                  Geschäftsfall  29 Fr  3382/08 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.07.2008
  60 eingetragen am 28.08.2008                  Geschäftsfall  29 Fr  3618/08 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.08.2008
  62 eingetragen am 17.04.2009                  Geschäftsfall  29 Fr  1342/09 v
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 31.03.2009
  63 eingetragen am 14.07.2009                  Geschäftsfall  29 Fr  2704/09 x
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.07.2009
  64 eingetragen am 21.07.2009                  Geschäftsfall  29 Fr  2745/09 g
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.07.2009
  65 eingetragen am 26.05.2010                  Geschäftsfall  29 Fr  2387/10 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.05.2010
  66 eingetragen am 28.07.2010                  Geschäftsfall  29 Fr  3031/10 k
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.07.2010
  67 eingetragen am 22.09.2010                  Geschäftsfall  29 Fr  3646/10 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.09.2010
  68 eingetragen am 15.10.2010                  Geschäftsfall  29 Fr  3904/10 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.09.2010
  69 eingetragen am 22.12.2010                  Geschäftsfall  29 Fr  4828/10 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.12.2010
  70 eingetragen am 08.03.2011                  Geschäftsfall  29 Fr   663/11 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.02.2011
  71 eingetragen am 25.05.2011                  Geschäftsfall  29 Fr  1940/11 s
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.05.2011
  72 eingetragen am 17.06.2011                  Geschäftsfall  29 Fr  2372/11 a
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.06.2011
  73 eingetragen am 12.08.2011                  Geschäftsfall  29 Fr  3024/11 i
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.08.2011
  74 eingetragen am 28.02.2012                  Geschäftsfall  29 Fr   453/12 m
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.02.2012
  75 eingetragen am 10.05.2012                  Geschäftsfall  29 Fr  1015/12 p
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.05.2012
  76 eingetragen am 02.10.2012                  Geschäftsfall  29 Fr  2898/12 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.09.2012
  77 eingetragen am 07.11.2012                  Geschäftsfall  29 Fr  3553/12 x
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 31.10.2012
  78 eingetragen am 15.01.2013                  Geschäftsfall  29 Fr    82/13 a
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.01.2013
  79 eingetragen am 26.07.2013                  Geschäftsfall  29 Fr  1292/13 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.06.2013
  81 eingetragen am 13.05.2014                  Geschäftsfall  29 Fr   962/14 d
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 06.05.2014
  82 eingetragen am 07.08.2014                  Geschäftsfall  29 Fr  1840/14 w
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 31.07.2014

Real estate

 

Registration number of real estate  167  Cadastral register  50313  Lenzing O  Number and date of entry  2965/2013  Status of  2014-03-24 

Part A - type of real estate  :

    GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
 KATASTRALGEMEINDE: 50313 Lenzing
    790       Landw(Feld/Wiese) *      909
    791/1     GST-Fläche        *     3440
              Landw(Feld/Wiese)        177
              Wald(Wälder)            3263
    801/1     GST-Fläche              5847
              Landw(Feld/Wiese)        998
              Sonst(Betriebsf.)       4849
   1026       Landw(Feld/Wiese) *      873
   1027       GST-Fläche              7444
              Landw(Feld/Wiese)       3573
              Sonst(Betriebsf.)       3871
   1028       GST-Fläche              3336
              Bauf.(Gebäude)           104
              Sonst(Betriebsf.)       3232  Pichlwanger Straße 8
   1048       Landw(Feld/Wiese) *      859
   1052       Landw(Feld/Wiese) *     3501
   1077       GST-Fläche        *     1320
              Bauf.(Gebäude)            11
              Landw(Feld/Wiese)       1309
   1082       GST-Fläche        *     1674
              Bauf.(Gebäude)           978
              Sonst(Betriebsf.)        696
   1083       GST-Fläche        *     4101
              Bauf.(Gebäude)          3038
              Sonst(Betriebsf.)       1063
   1084       GST-Fläche        *     2813
              Bauf.(Gebäude)           577
              Sonst(Betriebsf.)       2236
   1089       GST-Fläche             13932
              Bauf.(Gebäude)          3602
              Sonst(Betriebsf.)      10330  Bundesstraße 5a
   1093       Sonst(Betriebsf.)        168
   1094       GST-Fläche               168
              Bauf.(Gebäude)           118
              Sonst(Betriebsf.)         50
   1095       Bauf.(Gebäude)           168
   1096       Bauf.(Gebäude)           168
   1097       Bauf.(Gebäude)           167
   1098       Bauf.(Gebäude)           168  Bundesstraße 5a
   1099       GST-Fläche               194
              Bauf.(Gebäude)           109
              Sonst(Betriebsf.)         85
   1100       Sonst(Betriebsf.)        168
   1101       GST-Fläche              1207
              Bauf.(Gebäude)           473
              Sonst(Betriebsf.)        734  Bundesstraße 5a
   1102       Sonst(Betriebsf.)        168
   1103       Sonst(Betriebsf.)        193
   1104       Sonst(Betriebsf.)        194
   1105       Sonst(Betriebsf.)        194
   1106       Sonst(Betriebsf.)        168
   1107       Sonst(Betriebsf.)        168
   1108       Sonst(Betriebsf.)        168
   1109       Sonst(Betriebsf.)        194
   1113/1   G Sonst(Schienen)   *     1347
   1113/3   G Sonst(Straßen)    *     1412
   1115/1     GST-Fläche             36376
              Bauf.(Gebäude)          2116
              Sonst(Betriebsf.)      34260  Bundesstraße 9
                                            Bundesstraße 5a
   1116       GST-Fläche              6862
              Bauf.(Gebäude)            42
              Sonst(Betriebsf.)       6820
   1117       GST-Fläche              1933
              Bauf.(Gebäude)          1280
              Sonst(Betriebsf.)        653
   1118       Sonst(Betriebsf.)       5292
   1119       Sonst(Betriebsf.)      57217
   1120       GST-Fläche             38472
              Bauf.(Gebäude)           904
              Sonst(Betriebsf.)      37568
   1126/1     GST-Fläche              4651
              Bauf.(Gebäude)          1315
              Sonst(Betriebsf.)       3336
   1126/3     GST-Fläche              4309
              Bauf.(Gebäude)           136
              Sonst(Betriebsf.)       4173
   1127     G Sonst(Betriebsf.) *       88
   1142       Sonst(Betriebsf.)        402
   1146       Sonst(Betriebsf.) *       15
   1199       GST-Fläche              5427
              Sonst(Straßen)          5002
              Sonst(Betriebsf.)        425
   1200       Sonst(Betriebsf.)       2129
   1201/1     GST-Fläche            156063
              Bauf.(Gebäude)         46036
              Sonst(Straßen)          7468
              Sonst(Betriebsf.)     102559
   1201/3   G Sonst(Straßen)    *      300
   1202       Bauf.(Gebäude)          1767  Werkstraße 2
   1203       Bauf.(Gebäude)          1122
   1204       Sonst(Betriebsf.)        320
   1205       Bauf.(Gebäude)          3074  Werkstraße 4
   1206       Bauf.(Gebäude)    *      166
   1207       GST-Fläche               648
              Bauf.(Gebäude)           430
              Sonst(Betriebsf.)        218
   1208       GST-Fläche               767
              Bauf.(Gebäude)           340
              Sonst(Betriebsf.)        427
   1209       Bauf.(Gebäude)          3444
   1210       Bauf.(Gebäude)           215
   1211       Bauf.(Gebäude)           298
   1212       Bauf.(Gebäude)          1681
   1213       GST-Fläche              4348
              Bauf.(Gebäude)           973
              Sonst(Betriebsf.)       3375
   1214       GST-Fläche              6459
              Bauf.(Gebäude)          6066
              Sonst(Betriebsf.)        393
   1215       GST-Fläche             12763
              Bauf.(Gebäude)         12549
              Sonst(Betriebsf.)        214
   1216       Bauf.(Gebäude)           912
   1217       Bauf.(Gebäude)    *     1178
   1218       Bauf.(Gebäude)          6831
   1220       Bauf.(Gebäude)            69
   1221       Bauf.(Gebäude)          1084
   1222       Bauf.(Gebäude)          1820
   1224       Bauf.(Gebäude)          1592
   1225       GST-Fläche               528
              Bauf.(Gebäude)            26
              Sonst(Betriebsf.)        502
   1226       GST-Fläche               405
              Bauf.(Gebäude)           285
              Sonst(Betriebsf.)        120
   1227       Bauf.(Gebäude)           305
   1228       Bauf.(Gebäude)           121
   1229       GST-Fläche               311
              Bauf.(Gebäude)           309
              Sonst(Betriebsf.)          2
   1230       Bauf.(Gebäude)           326
   1231       Bauf.(Gebäude)           113
   1232       Bauf.(Gebäude)           535
   1233       Bauf.(Gebäude)            45
   1234       Sonst(Betriebsf.)         53
   1235       Bauf.(Gebäude)            61
   1239       Bauf.(Gebäude)          1612
   1242       Bauf.(Gebäude)           393
 KATASTRALGEMEINDE: 50316 Pichlwang
   1598       Landw(Feld/Wiese)       4774
   1606       Landw(Feld/Wiese)       1270
   1979/1   G Landw(Feld/Wiese) *     6305
    GESAMTFLAECHE                   444082
    5  a 341/1987 Zuschreibung Gst 1027 aus EZ 191 und 1026 aus EZ 34 je GB
           Pichlwang
   11  a 5211/1993 Tauschvertrag 1991-04-10 Zuschreibung Gst 1979/1 KG Pichlwang
           aus EZ 101 KG Pichlwang
   12  a 2075/1935 Grunddienstbarkeit des Geh- und Fahrtrechtes an Gst 1979/2 in
           EZ 264 für Gst 1979/1
       b 5211/1993 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 101 KG
           Pichlwang
   20  a 4402/1999 Tauschvertrag 1999-03-02 Zuschreibung Gst 801/1 aus EZ 86
   21  a 921/1972 Geh- und Fahrtrecht für Gst 801/1 an EZ 9
   26  c gelöscht
 

Part B - ownership details  :

    1 ANTEIL: 1/1
      Lenzing Aktiengesellschaft (FN 96499k)
      ADR: Werkstr. 2, Lenzing   4860
       a 1419/1938 Kaufvertrag 1938-06-29 Eigentumsrecht
       b 1011/1960 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 279 GB
           Pichlwang
       c 3604/1984 Namensänderung
       d gelöscht
 

Part C - registered charges  :

    1  a 430/1917
           DIENSTBARKEIT der Kraftleitung hins Gst 1606 GB Pichlwang
           für Elektrizitätswerke Stern & Hafferl Aktiengesellschaft
       b 1011/1960 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus
           EZ 279 GB Pichlwang
    3  a 1892/1949 6223/2011
           DIENSTBARKEIT des Gehens und Fahrens gem Par 3 Vertrag
           1949-12-01 hins Gst 1199 1201/1 1201/3 für EZ 194
       b 1011/1960 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus
           EZ 279 GB Pichlwang
    4  a 19/1880
           DIENSTBARKEIT des Fahrens hins Gst 1052 für Gst 1069 EZ 994
       b 1011/1960 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus
           EZ 41 GB Pichlwang
    5  a 2732/1956
           DIENSTBARKEIT der elektrischen Hochspannungsleitung gem Pkt
           1 2 Dienstbarkeitsvertrag 1953-03-27 hins Gst 1089 1115/1
           1120 1119 1126/1 1126/2 1126/3 für Oberösterreichische
           Kraftwerke Aktiengesellschaft
       b 1011/1960 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus
           EZ 41 GB Pichlwang
    6  a 3067/1956
           DIENSTBARKEIT der elektrischen Hochspannungsleitung gem Pkt
           1 2 Dienstbarkeitsvertrag 1956-10-10 hins Gst 1077 1052 für
           Oberösterreichische Kraftwerke Aktiengesellschaft
       b 1011/1960 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus
           EZ 41 GB Pichlwang
    9  a 4510/1963
           DIENSTBARKEIT der elektrischen Hochspannungsleitung gem Pkt
           II - IV Dienstbarkeitsvertrag 1963-11-19 hins Gst 1126/1
           1126/2 1126/3 1606 GB Pichlwang für Oberösterreichische
           Kraftwerke Aktiengesellschaft
   11  a 3168/1965
           DIENSTBARKEIT der elektrischen Hochspannungsleitung gem Pkt
           II - IV Dienstbarkeitsvertrag 1965-08-30 hins Gst 1077 1052
           für Oberösterreichische Kraftwerke Aktiengesellschaft
   13  a 2119/1984 Pfandurkunde 1984-05-08
           PFANDRECHT                                 Höchstbetrag 72.000.000,--
           für Creditanstalt-Bankverein
       b 1409/1986 Löschungsverpflichtung zugunsten LNr 14
       c 5768/1993 Löschungsverpflichtung zugunsten LNr 20
       d 5023/1996 Löschungsverpflichtung zugunsten LNr 21
   14  a 1409/1986 Pfandurkunde 1986-04-03
           PFANDRECHT                                 Höchstbetrag 16.800.000,--
           für Creditanstalt-Bankverein
       b 5023/1996 Löschungsverpflichtung zugunsten LNr 21
   15  a 70/1959 993/1960
           DIENSTBARKEIT der elektrischen Hochspannungsleitung gem Pkt
           1 2 Dienstbarkeitsvertrag 1955-10-24 hins Gst 1027 für
           Oberösterreichische Kraftwerke Aktiengesellschaft
       b 341/1987 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ
           191 GB Pichlwang
   16  a 338/1989
           DIENSTBARKEIT der Duldung der Versorgungseinrichtungen
           gem § 2 Dienstbarkeitsvertrag 1988-07-25 bzw. Nachtrag
           1989-01-03 auf Gst 1115/1 1118 1119 1201/1 1205 1215
           für Gst 1057 1058 1059 1069 1070 1071 1072 1073 EZ 994
           und Gst 1065/2 EZ 1120
   17  a 671/1990
           DIENSTBARKEIT der 30 kV-Kabelleitung über Gst 1077
           gem Pkt 1 2 Dienstbarkeitsvertrag 1989-12-22 samt Plan
           für Oberösterreichische Kraftwerke AG
   18  a 5211/1993
           DIENSTBARKEIT der elektrischen Hochspannungsleitung gem Pkt
           II - IV Dienstbarkeitsvertrag 1984-11-28 hins Gst 1979/1
           für Oberösterreichische Kraftwerke Aktiengesellschaft
       b 5211/1993 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ
           101 KG Pichlwang
   19  a 5768/1993 Pfandurkunde 1984-04-20
           PFANDRECHT                                 Höchstbetrag 90.000.000,--
           für Bank Austria Aktiengesellschaft
       b 5023/1996 Löschungsverpflichtung zugunsten LNr 21
   20  a 5768/1993 Pfandurkunde 1984-09-12
           PFANDRECHT                                 Höchstbetrag 78.000.000,--
           für Bank Austria Aktiengesellschaft im Range nach LNr 19
       b 5023/1996 Löschungsverpflichtung zugunsten LNr 21
   21  a 5023/1996 Pfandurkunde 1982-09-20
           PFANDRECHT                                 Höchstbetrag 60.000.000,--
           für Österreichische Investitionskredit Aktiengesellschaft
   22  a 4364/2008
           DIENSTBARKEIT der Erdgasleitung OGV 208 Lenzing gem Pkt II
           III Dienstbarkeitsvertrag 30.05.2008 hins Gst 1089 für
           Oberösterreichische Ferngas Aktiengesellschaft
   23  a 5107/2009
           DIENSTBARKEIT des Gehens und Fahrens gem Pkt IV
           Servitutsbestellungsvertrag 20.08.2009 über Gst 1089
           für Gst 1088
   24  a 2965/2013
           DIENSTBARKEIT des 110-kV Umspannwerkes, der 110-kV-
           Leitungsanlagen und des Betretens und Befahrens gem Pkt II
           Dienstbarkeitsvertrag 2012-06-29 hins Gst 1027 1028 für
           Energie AG Oberösterreich, FN 76532y
           Energie AG Oberösterreich Netz GmbH, FN 266534m
            Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS
 Grundbuch 24.03.2014 07:40:44
 

Private data

 

 

Surname

 

 

Date of birth

 

 

Address

 

 

Executive positions

 

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Dipl-Ing.Dr.  Dieter Eichinger

1958-06-11 

 

8280 Fürstenfeld Übersbach 208

joint signing clerk

 

1

 

Dipl-Ing.Dr.  Wilhelm Feilmair

1962-05-19 

 

4863 Seewalchen Attersee Lachwerwiese 30

joint signing clerk

 

1

 

Dr.  Klaus Geppert

 

1950-05-21 

 

4840 Vöcklabruck Am Pfarrerfeld 17

joint signing clerk

 

0

 

Dipl-Ing.  Herbert Grill

  

 

4802 Ebensee Offenseestraße 21a

joint signing clerk

 

0

 

Stephanie Kniep

1966-07-15 

4860 Lenzing Werkstraße 2

joint signing clerk

0

Dipl-Ing.  Josef Kroiß

 

1953-01-18 

 

4863 Seewalchen Attersee Carl Leißstraße 1

joint signing clerk

 

0

 

Dipl-Ing.  Wolfgang Plasser

1966-08-20 

 

4840 Vöcklabruck Oberstadtgries 5

joint signing clerk

 

0

 

Mag.  Christof Pöltner

 

1964-02-17 

 

4860 Lenzing (OÖ) p.A. Werkstraße 2

joint signing clerk

 

0

 

Dr.  Otto Ramsenthaler

1959-04-07 

4851 Gampern Nr. 148

joint signing clerk

0

Dipl-Ing.  Gottfried Paul Rosenauer

1962-04-12 

 

4865 Nußdorf Attersee Dorfstraße 53

joint signing clerk

 

2

 

Johann Ruess

1964-01-20 

9871 Seeboden Am Waldrand 21

joint signing clerk

0

Dipl-Ing.  Marco Schlimpert

1974-03-30 

 

4860 Lenzing Werkstraße 2

 

joint signing clerk

 

0

 

Ingo Patric Thate

1973-05-25 

4860 Lenzing Werkstraße 2

joint signing clerk

4

Johann Peter Viehböck

1966-11-08 

4864 Attersee Schloßberg 3

joint signing clerk

0

Mag.  Florian Wirth

1973-03-03 

4860 Lenzing Werkstraße 2

joint signing clerk

4

Mag.Dr.  Peter Untersperger

1960-02-27 

 

4860 Lenzing Werkstraße 2

 

chairman of the executive board

 

4

 

MBA.  Robert van de Kerkhof

1964-02-25 

 

4860 Lenzing (OÖ) Werkstraße 2

member of the executive board

 

0

 

Dr.  Thomas Riegler

1969-05-23 

4860 Lenzing (OÖ) Werkstraße 2

member of the executive board

0

MBA, Dipl-Ing.  Friedrich Weninger

1957-04-11 

 

5310 Mondsee Hochkreuz 13

 

member of the executive board

 

3

 

MMag.Dr.  Michael Junghans

1967-07-06 

 

1010 Wien Graben 19

 

chairman of the supervisory board

 

7

 

Dr.  Hanno Bästlein

1963-04-19 

1180 Wien Cottagegasse 8

deputy chairman of the supervisory board

8

Dr.  Veit Sorger

1942-06-10 

1130 Wien Wattmanngasse 16

deputy chairman of the supervisory board

15

Rudolf Baldinger

1954-10-11 

4860 Lenzing Hauptstraße 9

member of the supervisory board

1

Franz Berlanda

1961-03-01 

4860 Lenzing (OÖ) Werkstraße 2

member of the supervisory board

0

Mag.  Helmut Bernkopf

1967-05-10 

1010 Wien Schottengasse 6-8

member of the supervisory board

8

Ing.  Daniela Födinger

1964-11-22 

4860 Lenzing (OÖ) Werkstraße 2

member of the supervisory board

0

Konsul, KR, MBA, Dr. Gen.Dir.  Franz Gasselsberger

1959-04-12 

 

4111 Walding Überlendnerstraße 23

member of the supervisory board

 

6

 

Dr.  Josef Krenner

1952-06-15 

4021 Linz Klostergasse 7

member of the supervisory board

4

 

Landesbediensteter

Georg Liftinger

1961-01-26 

4852 Weyregg Attersee Bach 18

member of the supervisory board

0

Mag.  Patrick Prügger

1975-08-08 

1010 Wien Universitätsring 14

member of the supervisory board

21

Johann Schernberger

1964-01-06 

4844 Regau Dornet 5

member of the supervisory board

0

Mag.  Andreas Schmidradner

1961-04-18 

 

1010 Wien Universitätsring 14

 

member of the supervisory board

 

4

 

Dr.  Astrid Skala-Kuhmann

1953-09-07 

 

82057 Icking Deutschland Zellerweg 25b

member of the supervisory board

 

0

 

Andreas Dorner

  

4860 Lenzing Werkstraße 2(c/o)

head of marketing

0

Dipl-Ing.  Werner Arnitz

  

4860 Lenzing Werkstraße 2(c/o)

head of EDP

0

 

Balance Sheet  (absolute) all amounts in EUR 

 

 

2013-12-31 

 

 

 

 

Goodwill

392.855,09

 

 

 

 

Franchises, patents, licences, trademarks and similar rights and advantages

1.114.525,86

 

 

 

 

Sum intangible assets

1.507.380,95

 

 

 

 

 

Land and leasehold rights with buildings thereon including building on land owned by third parties

81.175.922,77

 

 

 

 

Other operating and business equipment

12.543.768,65

 

 

 

 

Technical plants and machines

252.247.511,23

 

 

 

 

Advanced payments and constructions in progress

161.684.226,57

 

 

 

 

Sum tangible assets

507.651.429,22

 

 

 

 

 

Shares on related firms

254.422.264,83

 

 

 

 

Other shareholdings

5.110.143,91

 

 

 

 

Loans to related firms

81.848.589,23

 

 

 

 

Other loans

2.207.403,85

 

 

 

 

Other financial assets, values and securities of fixed assets

17.812.449,94

 

 

 

 

Sum financial assets

361.400.851,76

 

 

 

 

 

Sum fixed assets

870.559.661,93

 

 

 

 

 

Raw-, auxiliary materials and supplies

29.295.015,47

 

 

 

 

Unfinished products

608.434,25

 

 

 

 

Finished products

26.187.165,77

 

 

 

 

Advanced payments

281.464,10

 

 

 

 

Sum stock

56.372.079,59

 

 

 

 

 

Claims from delivered goods and performed services

65.508.197,63

 

 

 

 

Claims against companies with shareholding relationship

3.075.710,26

 

 

 

 

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

150.188.482,84

 

 

 

 

Other claims and assets

28.508.940,19

 

 

 

 

Sum claims

247.281.330,92

 

 

 

 

 

Cash on hand, cheques and bank deposits

137.149.971,44

 

 

 

 

Sum cash and bank

137.149.971,44

 

 

 

 

 

Sum current assets

440.803.381,95

 

 

 

 

 

Deferred charges

1.285.641,70

 

 

 

 

Sum deferred charges

1.285.641,70

 

 

 

 

Assets

1.312.648.685,58

 

 

 

 

 

Subscribed/declared capital

27.574.071,43

 

 

 

 

Committed capital reserves

138.642.770,74

 

 

 

 

Free reserves

257.446.687,82

 

 

 

 

Balance sheet profit/balance sheet loss

151.216.955,03

 

 

 

 

Thereof profit/loss carried forward

94.011.280,58

 

 

 

 

Sum equity capital

574.880.485,02

 

 

 

 

 

Other reserves before taxes

16.391.950,54

 

 

 

 

Sum reserves before taxes

16.391.950,54

 

 

 

 

 

Subsidies and contributions

4.406.711,01

 

 

 

 

Sum floor capital

4.406.711,01

 

 

 

 

 

Reserves for severance pays

38.511.013,49

 

 

 

 

Reserves for pensions

27.196.794,00

 

 

 

 

Tax reserves

3.969.359,20

 

 

 

 

Other reserves

101.649.080,69

 

 

 

 

Sum reserves

171.326.247,38

 

 

 

 

 

Loans (including convertible loans)

120.000.000,00

 

 

 

 

Liabilities against credit institutes

90.158.333,33

 

 

 

 

Received advanced payments for orders

601.116,18

 

 

 

 

Liabilities from delivered goods and performed services

49.883.528,64

 

 

 

 

Liabilities against related firms

36.080.653,04

 

 

 

 

Liabilities against firm with shareholding relationship

946,69

 

 

 

 

Other liabilities

10.554.331,28

 

 

 

 

Other loans

213.500.000,00

 

 

 

 

Special account liabilities

24.741.352,77

 

 

 

 

Sum liabilities

545.520.261,93

 

 

 

 

 

Deferred income

123.029,70

 

 

 

 

Sum deferred income

123.029,70

 

 

 

 

Liabilities

1.312.648.685,58

 

 

 

 

 

Contingent liabilities

191.449.987,30

 

 

 

 

Balance sheet sum

1.312.648.685,58

 

 

 

 

 

P / L Account  (absolute) all amounts in EUR 

 

 

2013-12-31 

 

 

 

 

Gross sales 

746.356.750,57

 

 

 

 

Increase or decrease in finished and unfinished goods and in service claims 

872.518,02

 

 

 

 

Other manufacturing costs capitalized 

2.279.692,58

 

 

 

 

Total turnover or gross profit 

749.508.961,17

 

 

 

 

 

Profits from retirement of fixed assets, except financial assets 

111.649,41

 

 

 

 

Income from dissolution of reserves 

22.202.788,32

 

 

 

 

Other operating profits 

48.178.727,90

 

 

 

 

Other operating profits totally 

70.493.165,63

 

 

 

 

 

Costs for obtained services 

-58.996.140,25

 

 

 

 

Material costs 

-371.633.595,42

 

 

 

 

Costs for obtained services totally 

-430.629.735,67

 

 

 

 

 

Wages 

-62.473.704,37

 

 

 

 

Salaries 

-65.181.997,85

 

 

 

 

Costs for severance pays 

-17.485.672,39

 

 

 

 

Costs for old age pension 

-4.036.156,00

 

 

 

 

Legal fringe benefits and other payments depending on salaries 

-33.018.467,47

 

 

 

 

Other social fringe benefits 

-2.448.029,28

 

 

 

 

Personnel expenses totally 

-184.644.027,36

 

 

 

 

 

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation 

-57.099.295,28

 

 

 

 

Depreciation tangible assets / intangible assets totally 

-57.099.295,28

 

 

 

 

 

Other operating costs 

-121.864.595,76

 

 

 

 

Other taxes 

-147.683,74

 

 

 

 

Total costs 

-122.012.279,50

 

 

 

 

 

Operating result totally 

25.616.788,99

 

 

 

 

 

Profits from shareholdings 

61.872.484,20

 

 

 

 

Income from other securities and loans of financial assets 

2.728.843,34

 

 

 

 

Interest income, securties income and similar income 

4.019.235,05

 

 

 

 

Profits from the retirement of and investment in financial assets 

19.480,55

 

 

 

 

Interest and similar disbursements 

-13.009.132,41

 

 

 

 

Financial expenses 

-17.422.408,68

 

 

 

 

Financial profits totally 

38.208.502,05

 

 

 

 

 

Results from usual business activity totally 

63.825.291,04

 

 

 

 

 

Taxes on income and profits 

-6.950.606,09

 

 

 

 

Taxes on income and profits totally 

-6.950.606,09

 

 

 

 

Annual surplus/annual deficit totally 

56.874.684,95

 

 

 

 

 

Dissolution reserves before taxes 

330.989,50

 

 

 

 

Reserves movements totally 

330.989,50

 

 

 

 

Annual profit/annual loss totally 

57.205.674,45

 

 

 

 

 

Profit and loss carried forward from previous year 

94.011.280,58

 

 

 

 

Transfer of profits totally 

94.011.280,58

 

 

 

 

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account 

151.216.955,03

 

 

 

 

 

 

Key ratios

 

 

2013  

 

 

 

 

 

Cash flow II

  113.973.980,23

 

 

 

 

 

Debt amortisation period

  5,08

 

 

 

 

 

Bank indebtedness

  23,13

 

 

 

 

 

Equity capital share

  45,40

 

 

 

 

 

Social capital share

  5,00

 

 

 

 

 

Fixed assets coverage

  75,97

 

 

 

 

 

Net profit ratio

  8,51

 

 

 

 

 

Capital turnover

  0,57

 

 

 

 

 

Return on investment

  5,85

 

 

 

 

 

Cash flow in % of operating performance

  15,20

 

 

 

 

 

Cash flow I

  120.924.586,32

 

 

 

 

 

Gross productivity

  4,05

 

 

 

 

 

Net productivity

  1,72

 

 

 

 

 

Operating performance

  749.508.961,17

 

 

 

 

 

Inventories in % of operating performance

  7,52

 

 

 

 

 

Gross profit

  318.879.225,50

 

 

 

 

 

 

Locations

 

Type

Locations

Description

 

 

E-mail 

operational 

Werkstraße  2, A-4860 Lenzing

registered office 

 

 

 

operational 

Werkstraße  2, A-4860 Lenzing

registered headquarters, owned property 

 

 

office@lenzing.com

operational 

70, Race Course  1st Floor, Rajnarayan Towers, 641 018 Coimbatore, IND

office 

 

 

 

operational 

PO Box  462, DN31 2ZT Grimsby, CDN

office 

 

 

 

operational 

Kolingasse  1, A-1090 Wien

office, rented premises 

 

 

 

 


related companies

 

Company name

 

Postal code

 

Stake in %

 

 

Companies House

 

Shares in this company are held by:

B & C Lenzing Holding GmbH

 

Universitätsring  14, A-1010 Wien

50.59 %  

 

 

FN 256666 a

 

B & C Industrieholding GmbH

 

Universitätsring  14, A-1010 Wien

9.51 %  

 

 

FN 215332 s

 

B & C Iota GmbH & Co KG

 

Universitätsring  14, A-1010 Wien

7.6 %  

 

 

FN 353486 h

 

Oberbank AG

 

Untere Donaulände  28, A-4020 Linz

5 %  

 

 

FN 79063 w

 

 

This company holds 100% of the shares in:

Pulp Trading GmbH

 

Werkstraße  , A-4860 Lenzing

100 % 1988-07-28

 

 

FN 107873 m

 

Lenzing Fibers Holding GmbH

 

Werkstraße  2, A-4860 Lenzing

100 % 2005-09-08

 

 

FN 243282 v

 

 

This company holds 50% to 99% of the shares in:

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft m.b.H. für den Bezirk Vöcklabruck

Atterseestraße  21, A-4860 Lenzing

99.87 % 1994-05-04

 

 

FN 94451 z

 

BZL - Bildungszentrum Lenzing GmbH

Werkstraße  2, A-4860 Lenzing

75 % 1997-12-19

 

 

FN 165899 w

 

RVL Reststoffverwertung Lenzing GmbH

Lenzing AG - Werksgelände  , A-4860 Lenzing

50 % 1994-04-01

 

 

FN 84067 d

 

 

This company holds less than 50% of the shares in:

Lenzing Papier GmbH

 

Werkstraße  2, A-4860 Lenzing

40 % 2008-03-01

 

 

FN 306805 i

 

WWE Wohn- und Wirtschaftspark Entwicklungsgesellschaft m.b.H.

Julius Raab Promenade  27/30, A-3100 St. Pölten

25 % 1994-07-06

 

 

FN 84192 m

 

Lenzing Fibers GmbH

 

Industriegelände  1, A-7561 Heiligenkreuz Lafnitztal

0.02 % 1996-09-24

 

 

FN 129218 b

 

 

Affiliated companies and further participations:

Lenzing Technik GmbH

 

Werkstraße  2, A-4860 Lenzing

 

 

 

FN 185129 z

 

LENO Electronics GmbH

 

Photo Playstraße  1, A-4860 Lenzing

 

 

 

FN 196636 x

 

Lenzing Holding GmbH

 

Werkstraße  2, A-4860 Lenzing

 

 

 

FN 243281 t

 

Lenzing Beteiligungs GmbH

 

Werkstraße  2, A-4860 Lenzing

 

 

 

FN 253324 k

 

LP Automotive GmbH

 

Werkstraße  2, A-4860 Lenzing

 

 

 

FN 294350 v

 

AL International L P

 

777 West St  , 02048 Mansfield, USA

 

 

 

 

 

Bankers

 

 

 

Banker

Bank sort code

Type of banking connection

UniCredit Bank Austria AG, 1011 Wien

 

12000

 

main bank connection

 

Oberbank AG, 4860 Lenzing

 

15000

 

secondary banking connection

 

 

 

Historical development

 

Year of incorporation:

1938

Date of registration:

1938-07-07

 

Change in share capital:

From

To

Capital

   

  1999-08-18

ATS  367.500.000,00

  1999-08-18

  2011-06-17

EUR  26.717.250,00

  2011-06-17

   

EUR  27.574.071,43

 

Former executives:

From

To

Function

Name

   

  1997-02-19

joint signing clerk 

Dr. Christoph Boxan 

   

  1998-01-23

joint signing clerk 

Dr. Friedrich Gotschy 

  1999-02-25

  2009-04-17

member of the executive board 

Mag.Dr. Peter Untersperger 

  2011-03-08

  2011-08-12

member of the executive board 

Johann Ruess 

  2011-03-08

  2011-08-12

member of the executive board 

Ingo Patric Thate 

  2000-06-08

  2009-04-17

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Friedrich Weninger 

  1994-05-12

  1997-06-12

deputy chairman of the supervisory board 

Mag. Max Kothbauer 

  2010-09-22

  2011-05-25

deputy chairman of the supervisory board 

MMag.Dr. Michael Junghans 

  2002-08-17

  2006-08-19

member of the supervisory board 

Mag. Franz Zwickl 

  2010-07-28

  2010-09-22

member of the supervisory board 

MMag.Dr. Michael Junghans 

  2004-07-15

  2011-05-25

member of the supervisory board 

Dr. Veit Sorger 

  1986-06-18

  1998-01-23

joint signing clerk 

Dkfm. Rudolf Hauptmann 

   

  1998-01-23

joint signing clerk 

Franz Kogler 

   

  2003-04-23

joint signing clerk 

Ing. Helmuth Haab 

   

  1998-01-23

joint signing clerk 

Dipl-Ing.Dr. Dominik Mach 

   

  1998-01-23

joint signing clerk 

Dipl-Ing.Dr. Ingo Marini 

   

  1998-01-23

joint signing clerk 

Dipl-Ing.Dr. Johannes Serafin 

   

  1999-08-05

joint signing clerk 

Dr. Heinrich Ribnitz 

   

  2000-02-24

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Heinz tho Seeth 

   

  2000-02-24

joint signing clerk 

Mag.Dr. Hubert Scholl 

   

  2001-06-06

joint signing clerk 

Dr. Gerhard Danninger 

   

  2003-04-23

joint signing clerk 

Dipl-Ing.Dr. Wolfgang Künstner 

  2000-06-08

  2004-09-11

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Helmut Prokop 

   

  2005-05-13

joint signing clerk 

Otto Weitzl 

   

  1999-02-25

member of the executive board 

Dipl-Ing. Leopold Fermüller 

  1998-05-09

  1999-02-25

member of the executive board 

Mag. Martin Lenz 

   

  1999-02-25

member of the executive board 

Dipl-Ing. Ludwig Promberger 

  1997-06-12

  2002-06-19

member of the executive board 

Dkfm. Jochen Werz 

   

  1997-06-12

chairman of the supervisory board 

Dkfm. Gerhard Randa 

  2009-07-21

  2012-11-07

joint signing clerk 

Dipl-Betriebsw. Michael Hartig 

   

  1998-11-13

chairman of the executive board 

Dipl-Ing.Dr. Heinrich Stepniczka 

  1994-05-12

  1997-08-23

deputy chairman of the executive board 

Dr. Josef Zauner 

  2000-06-08

  2008-04-19

joint signing clerk 

Heinz Kmonicek 

  2003-02-04

  2008-04-19

joint signing clerk 

Mag. Sonja Probst 

  2000-06-08

  2008-05-01

joint signing clerk 

Edmund Gehmayr 

  2004-07-07

  2009-07-21

joint signing clerk 

Johann Huber 

  2000-06-08

  2010-09-22

joint signing clerk 

Ing. Manfred Schenner 

   

  2011-03-08

joint signing clerk 

DDr. Haio Harms 

   

  2011-08-12

joint signing clerk 

Ing. Rudolf Reifschneider 

  1997-06-12

  2001-09-12

chairman of the supervisory board 

Dkfm. Herbert Walter Liaunig 

  1997-06-12

  1998-06-19

deputy chairman of the supervisory board 

Herbert Lugmayr 

   

  1997-06-12

member of the supervisory board 

Dkfm. Roman Fojtl 

   

  1997-06-12

member of the supervisory board 

Herbert Rast 

   

  1998-05-09

member of the supervisory board 

Dr. Peter Weber 

   

  1998-06-19

member of the supervisory board 

Walter Baumgartinger 

   

  1998-06-19

member of the supervisory board 

Helmut Maderthaner 

   

  2001-09-12

member of the supervisory board 

Franz Huber 

   

  2002-08-17

member of the supervisory board 

Dipl-Ing. Othmar Pühringer 

  2002-08-17

  2010-09-22

deputy chairman of the supervisory board 

Dr. Walter Lederer 

  2010-09-22

  2012-05-10

member of the supervisory board 

Dr. Walter Lederer 

  2008-08-07

  2010-07-28

member of the supervisory board 

Dr. Winfried Braumann 

  2007-09-12

  2014-08-07

member of the supervisory board 

Mag. Martin Payer 

  2009-04-17

  2014-08-07

member of the supervisory board 

Ing. Gerhard Ratzesberger 

  2010-05-26

  2014-01-09

member of the executive board 

Mag. Thomas Winkler 

  2001-09-12

  2002-06-19

chairman of the supervisory board 

Mag. Ewald Nageler 

  1997-06-12

  1998-06-19

member of the supervisory board 

Mag. Ewald Nageler 

  1998-06-19

  2001-09-12

deputy chairman of the supervisory board 

Mag. Ewald Nageler 

  2000-06-20

  2009-04-17

member of the supervisory board 

Helmut Maderthaner 

  2000-06-20

  2009-07-14

member of the supervisory board 

Dr. Horst Bednar 

   

  1998-01-23

joint signing clerk 

Dipl-Ing.Dr. Thomas Markow 

   

  1999-02-25

joint signing clerk 

Dr. Franz Raninger 

  1999-02-25

  2002-06-19

deputy chairman of the executive board 

Dr. Franz Raninger 

  2002-06-19

  2004-07-22

member of the executive board 

Dr. Franz Raninger 

   

  1999-02-25

joint signing clerk 

Dipl-Ing.Dr. Christian Reisinger 

  1999-02-25

  2002-06-19

deputy chairman of the executive board 

Dipl-Ing.Dr. Christian Reisinger 

  2002-06-19

  2010-05-26

member of the executive board 

Dipl-Ing.Dr. Christian Reisinger 

  2001-10-06

  2002-11-23

joint signing clerk 

Mag. Dietmar Preslmayr 

  1998-01-23

  2005-08-30

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Werner Gschaider 

  2004-07-22

  2008-01-03

joint signing clerk 

Dr. David Andrew Hoyland 

  2004-07-22

  2012-10-02

joint signing clerk 

Michael John Proctor 

  2004-10-14

  2008-04-19

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Franz Gstettenhofer 

   

  1998-11-13

member of the executive board 

Dkfm.Dr. Uwe Franz Peter Skoupy 

  1999-02-25

  2012-10-02

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Ernst Lackerbauer 

  2008-11-11

  2014-08-07

joint signing clerk 

Dipl-Ing. Alois Kriechbaumer 

  2003-03-12

  2009-04-17

chairman of the executive board 

Dipl-Betriebsw. Thomas Michael Fahnemann 

  2008-01-03

  2009-07-21

joint signing clerk 

Dipl-Betriebsw. Robert Gregan 

  2009-04-17

  2011-03-08

joint signing clerk 

Andre Edward Beijers 

  2002-06-19

  2008-02-20

chairman of the supervisory board 

Karl Schmutzer 

  2001-09-12

  2002-06-19

deputy chairman of the supervisory board 

Karl Schmutzer 

  2008-08-07

  2011-05-25

chairman of the supervisory board 

Dkfm.Dr. Hermann Bell 

   

  2008-08-07

member of the supervisory board 

Dkfm.Dr. Hermann Bell 

   

  2000-06-20

member of the supervisory board 

Richard Lehner 

  1994-05-12

  2000-06-20

member of the supervisory board 

Dr. Gerhard Scharitzer 

  1997-06-12

  2002-06-19

member of the supervisory board 

Mag. Wolfgang Peter 

  2002-06-19

  2002-08-17

deputy chairman of the supervisory board 

Mag. Wolfgang Peter 

 

Former shareholders:

From

To

Function

Name

   

  2001-02-14

shareholder 

UniCredit Bank Austria AG 

   

  2001-02-14

shareholder 

Creditanstalt Auslandsbank AG 

 

Former shareholdings:

From

To

Name

   

 

LUSTRO-LENZING GmbH 

   

 

Oesterreichische Papierverkaufsgesellschaft m.b.H. 

  1995-06-30

  1997-12-05

SML Maschinengesellschaft mbH 

  1999-08-05

  2005-06-07

Lenzing Technik GmbH 

  1995-09-16

  2000-01-20

Papier & Recycling Logistik GmbH 

  2003-03-05

  2003-09-18

Energie- und Medienzentrale Heiligenkreuz GmbH 

  1996-01-11

  2005-06-10

Asia Fiber Engineering GmbH 

  1994-03-02

  2008-12-04

Energie- und Medienzentrale Heiligenkreuz GmbH 

  1993-01-22

  1998-07-22

Lustro-Lenzing GmbH & Co KG 

  2000-03-11

  2004-10-01

Lenzing Plastics GmbH & Co KG 

  2003-09-18

  2005-10-06

Energie- und Medienzentrale Heiligenkreuz GmbH & Co KG 

  2011-01-21

  2011-05-31

Beta LAG Holding GmbH 

  2000-02-22

  2005-06-07

Lenzing Plastics GmbH 

  1995-12-22

  2005-06-15

Cellulose Consulting GmbH 

  2004-06-05

  2013-09-26

ECRA Emission Certificate Registry Austria GmbH in Liqu. 

  1994-12-17

  2003-09-18

Lenzing Lyocell GmbH & Co KG 

  1999-09-04

  2004-10-01

Lenzing Technik GmbH & Co KG 

 

Mergers:

Date

Function

Name

  2005-10-07

merged with 

Energie- und Medienzentrale Heiligenkreuz GmbH & Co KG 

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.60.84

UK Pound

1

Rs.98.72

Euro

1

Rs.78.64

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

SUB

 

 

Report Prepared by :

PDT

 

               

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

 

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

 

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

 

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

 

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

 

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

 

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

 

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

Credit not recommended

 

--

NB

New Business

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                 Payment record (10%)

Credit history (10%)                    Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.