|
Active Account | Passive Account | Account Results
|
|
Synthesized Accounts
|
Annual
Accounts
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
|
Account
period (month)
|
12
|
|
12
|
|
12
|
|
|
|
Account Type
|
Normal
|
|
Normal
|
|
Normal
|
|
|
|
Date of
capture
|
13/08/2013
|
|
14/10/2011
|
|
11/11/2010
|
|
|
|
Activity
Code
|
4753Z
|
|
4753Z
|
|
4753Z
|
|
|
|
Employees
|
0
|
|
1601
|
|
1566
|
|
|
Active account
|
Annual Accounts
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
Sector Median2012
|
|
|
Capital not called
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0
|
0%
|
|
Total fixed assets
|
80,134,000
|
-12.4%
|
91,464,743
|
-8.5%
|
99,930,000
|
40,104.50
|
199713.0%
|
|
- Intangible assets
|
3,253,000
|
0.6%
|
3,233,227
|
6.8%
|
3,028,000
|
1,544.50
|
210518.3%
|
|
- Tangible assets
|
39,641,000
|
2.3%
|
38,760,203
|
0.1%
|
38,713,000
|
13,507.50
|
293374.0%
|
|
- Financial assets
|
37,240,000
|
-24.7%
|
49,471,313
|
-15.0%
|
58,189,000
|
2,032
|
1832577.2%
|
|
Net current assets
|
57,696,000
|
-3.7%
|
59,920,004
|
-14.6%
|
70,203,000
|
148,506.50
|
38750.8%
|
|
- Stocks
|
36,380,000
|
-2.8%
|
37,434,204
|
-8.9%
|
41,077,000
|
52,450.50
|
69260.6%
|
|
- Advanced payments
|
0
|
-3.7%
|
538,867
|
0%
|
0
|
0
|
0%
|
|
- Receivables
|
21,316,000
|
19.4%
|
17,851,139
|
-38.7%
|
29,126,000
|
33,117
|
64265.7%
|
|
- Securities and cash
|
0
|
0%
|
4,095,794
|
0%
|
0
|
24,263
|
0%
|
|
- Prepaid expenses
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
266
|
-
|
|
Accounts of regularization
|
0
|
0%
|
6,809
|
0%
|
0
|
0
|
0%
|
|
Total Assets
|
137,830,000
|
-9.0%
|
151,391,556
|
-11.0%
|
170,133,000
|
228,577.50
|
60199.0%
|
Passive Account
|
Annual Accounts
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
Sector Median2012
|
|
|
Shareholders' equity
|
33,628,000
|
-26.2%
|
45,587,822
|
-22.7%
|
58,997,000
|
55,051.50
|
60984.6%
|
|
Share capital
|
1,364,000
|
0.0%
|
1,363,786
|
0.0%
|
1,364,000
|
10,000
|
13540.0%
|
|
Other capital resources
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0
|
0%
|
|
Risk Provisions
|
7,307,000
|
16.0%
|
6,297,348
|
2.1%
|
6,166,000
|
0
|
0%
|
|
Liabilities
|
96,895,000
|
-2.0%
|
98,865,230
|
-5.8%
|
104,970,000
|
147,206.50
|
65722.5%
|
|
- Financial liabilities
|
63,675,000
|
6.3%
|
59,892,438
|
-13.7%
|
69,409,000
|
27,093
|
234923.8%
|
|
- Advanced payments received
|
0
|
0%
|
2,868,979
|
0%
|
0
|
0
|
0%
|
|
- Trade account payables
|
12,438,000
|
-14.8%
|
14,591,013
|
15.1%
|
12,672,000
|
44,068
|
28124.6%
|
|
- Tax and social liabilities
|
0
|
0%
|
18,140,441
|
0%
|
0
|
34,555.50
|
0%
|
|
- Other debts and fixed assets
liabilities
|
17,010,000
|
2091.5%
|
776,184
|
-96.6%
|
22,824,000
|
3,793.50
|
448298.6%
|
|
Account regularization
|
3,772,000
|
16.5%
|
3,237,332
|
4880.5%
|
65,000
|
0
|
0%
|
|
Total liabilities
|
137,830,000
|
-9.0%
|
151,391,556
|
-11.0%
|
170,133,000
|
228,578
|
60198.9%
|
Results
|
Annual Accounts
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
Sector Median2012
|
|
|
Sales of Goods
|
234,590,000
|
3.1%
|
227,591,613
|
-1.9%
|
231,925,000
|
340,304.50
|
68835.3%
|
|
Net turnover
|
231,063,000
|
2.8%
|
224,764,649
|
-2.3%
|
230,125,000
|
334,881.50
|
68898.4%
|
|
- of which net export turnover
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0
|
0%
|
|
Operating charges
|
237,428,000
|
3.8%
|
228,723,430
|
-1.4%
|
231,872,000
|
357,485.50
|
66316.1%
|
|
Operating profit/loss
|
-2,838,000
|
-150.7%
|
-1,131,817
|
-2235.5%
|
53,000
|
6,267.50
|
-45381.2%
|
|
Financial income
|
0
|
0%
|
3,051,900
|
229.2%
|
927,000
|
08
|
0%
|
|
Financial charges
|
17,264,000
|
-1.2%
|
17,472,519
|
0%
|
0
|
845.50
|
2041768.7%
|
|
Financial profit/loss
|
-17,264,000
|
-19.7%
|
-14,420,619
|
-1655.6%
|
927,000
|
-305
|
-5660227.9%
|
|
Pretax net operating income
|
-20,102,000
|
-29.3%
|
-15,552,436
|
-1687.0%
|
980,000
|
4,721
|
-425899.6%
|
|
Extraordinary income
|
11,740,000
|
45.6%
|
8,061,425
|
-92.8%
|
112,653,000
|
21.50
|
54604551.2%
|
|
Extraordinary charges
|
3,958,000
|
-33.2%
|
5,928,398
|
-94.5%
|
108,404,000
|
267
|
1482297.0%
|
|
Extraordinary profit/loss
|
7,782,000
|
264.8%
|
2,133,027
|
-49.8%
|
4,249,000
|
0
|
0%
|
|
Net result
|
-12,253,000
|
7.2%
|
-13,206,185
|
-349.4%
|
5,295,000
|
4,769
|
-257030.2%
|
|
|
|
|
Normal
Account
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Months
|
|
12
|
|
12
|
|
12
|
Accounts - Active
Current Assets | Equalization accounts | Reference
Grand Total -
Passive Accounts (I to IV)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Grand Total
(I to VI)
|
Net
|
137,830,000
|
-9.0%
|
151,391,556
|
-11.0%
|
170,133,000
|
|
|
Gross
|
CO
|
137,830,000
|
-49.4%
|
272,128,967
|
60.0%
|
170,133,000
|
|
|
Amortisation
|
1A
|
0
|
0%
|
120,737,411
|
0%
|
0
|
Non declared
distributed capital (I)
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Non declared
distributed capital (I)
|
AA3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
AA
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Active fixed
asset (II)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Total Active
fixed asset (II)
|
Net
|
80,134,000
|
-12.4%
|
91,464,743
|
-8.5%
|
99,930,000
|
|
|
Gross
|
BJ
|
80,134,000
|
-61.7%
|
208,964,714
|
109.1%
|
99,930,000
|
|
|
Amortisation
|
BK
|
0
|
0%
|
117,499,971
|
0%
|
0
|
Intangilble
fixed assets
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Start-up
cost
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
AB
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
AC
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
R & D
expenses
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
CX
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
AE
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Distributorships,
patents
|
Net
|
0
|
0%
|
183,723
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
AF
|
0
|
0%
|
818,362
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
AG
|
0
|
0%
|
634,639
|
0%
|
0
|
|
 
|
Goodwill
|
Net
|
0
|
0%
|
3,049,504
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
AH
|
0
|
0%
|
3,049,504
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
AI
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Other
intangible fixed assets
|
Net
|
3,253,000
|
0%
|
0
|
0%
|
3,028,000
|
|
|
Gross
|
AJ
|
3,253,000
|
0%
|
0
|
0%
|
3,028,000
|
|
|
Amortisation
|
AK
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Pre-payments
and downpayments
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
AL
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
AM
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Sub Total
Intangible Assets
|
Net
|
3,253,000
|
0.6%
|
3,233,227
|
6.8%
|
3,028,000
|
Tangilble
fixed assets
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Lands
|
Net
|
0
|
0%
|
8,075,626
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
AN
|
0
|
0%
|
8,190,276
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
AO
|
0
|
0%
|
114,650
|
0%
|
0
|
|
 
|
Buildings
|
Net
|
0
|
0%
|
25,399,655
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
AP
|
0
|
0%
|
97,082,651
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
AQ
|
0
|
0%
|
71,682,996
|
0%
|
0
|
|
 
|
Plant
|
Net
|
0
|
0%
|
168,550
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
AR
|
0
|
0%
|
1,875,160
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
AS
|
0
|
0%
|
1,706,610
|
0%
|
0
|
|
 
|
Other
tangible fixed assets
|
Net
|
39,641,000
|
753.2%
|
4,646,314
|
-88.0%
|
38,713,000
|
|
|
Gross
|
AT
|
39,641,000
|
31.9%
|
30,056,802
|
-22.4%
|
38,713,000
|
|
|
Amortisation
|
AU
|
0
|
0%
|
25,410,488
|
0%
|
0
|
|
 
|
Fixed assets
in construction
|
Net
|
0
|
0%
|
458,148
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
AV
|
0
|
0%
|
458,148
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
AW
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Advances and
payments on account
|
Net
|
0
|
0%
|
11,910
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
AX
|
0
|
0%
|
11,910
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
AY
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Sub Total
Tangible asset
|
Net
|
39,641,000
|
|
38,760,203
|
|
38,713,000
|
Financial
assets
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Associates
at equity
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
CS
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
CT
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Other
participations
|
Net
|
0
|
0%
|
33,320,286
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
CU
|
0
|
0%
|
49,153,562
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
CV
|
0
|
0%
|
15,833,276
|
0%
|
0
|
|
 
|
Inter-company
receivables
|
Net
|
0
|
0%
|
15,732,412
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
BB
|
0
|
0%
|
17,849,724
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
BC
|
0
|
0%
|
2,117,312
|
0%
|
0
|
|
 
|
Other investment
securities
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
BD
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
BE
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Loans
|
Net
|
0
|
0%
|
5,962
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
BF
|
0
|
0%
|
5,962
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
BG
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
 
|
Other
financial assets
|
Net
|
37,240,000
|
8924.5%
|
412,653
|
-99.3%
|
58,189,000
|
|
|
Gross
|
BH
|
37,240,000
|
8924.5%
|
412,653
|
-99.3%
|
58,189,000
|
|
|
Amortisation
|
BI
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Sub Total
Financial Assets
|
|
37,240,000
|
|
49,471,313
|
|
58,189,000
|
Current Assets (III)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Total Assets
|
Net
|
57,696,000
|
-3.7%
|
59,920,004
|
-14.6%
|
70,203,000
|
|
|
Gross
|
CJ
|
57,696,000
|
-8.6%
|
63,157,445
|
-10.0%
|
70,203,000
|
|
|
Amortisation
|
CK
|
0
|
0%
|
3,237,441
|
0%
|
0
|
Stocks
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Raw materials
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
BL
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
BM
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Work in progress (goods)
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
BN
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
BO
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Work in progress (services)
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
BP
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
BQ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Semi-finished and finished products
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
BR
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
BS
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Goods for resale
|
Net
|
36,380,000
|
-2.8%
|
37,434,204
|
-8.9%
|
41,077,000
|
|
|
Gross
|
BT
|
36,380,000
|
-8.1%
|
39,585,351
|
-3.6%
|
41,077,000
|
|
|
Amortisation
|
BU
|
0
|
0%
|
2,151,147
|
0%
|
0
|
|
|
Sub Total Stocks
|
Net
|
36,380,000
|
-2.8%
|
37,434,204
|
-8.9%
|
41,077,000
|
Advance payments to suppliers
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Advance payments to suppliers
|
Net
|
0
|
0%
|
538,867
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
BV
|
0
|
0%
|
538,867
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
BW
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Debtors
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Trade accounts receivable
|
Net
|
10,622,000
|
-4.6%
|
11,136,670
|
3.8%
|
10,730,000
|
|
|
Gross
|
BX
|
10,622,000
|
-7.9%
|
11,530,277
|
7.5%
|
10,730,000
|
|
|
Amortisation
|
BY
|
0
|
0%
|
393,607
|
0%
|
0
|
|
 
|
Other debtors
|
Net
|
8,507,000
|
59.1%
|
5,347,765
|
-69.4%
|
17,453,000
|
|
|
Gross
|
BZ
|
8,507,000
|
59.1%
|
5,347,765
|
-69.4%
|
17,453,000
|
|
|
Amortisation
|
CA
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Capital subscribed and called up
|
Net
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
CB
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
CC
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Sub Total Debtors
|
Net
|
19,129,000
|
16.0%
|
16,484,435
|
-41.5%
|
28,183,000
|
Divers
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Investment securities
|
Net
|
0
|
0%
|
1,538,232
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
CD
|
0
|
0%
|
2,230,919
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
CE
|
0
|
0%
|
692,687
|
0%
|
0
|
|
 
|
Cash and cash equivalents
|
Net
|
0
|
0%
|
2,557,562
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
CF
|
0
|
0%
|
2,557,562
|
0%
|
0
|
|
|
Amortisation
|
CG
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Sub Total Divers
|
Net
|
0
|
0%
|
4,095,794
|
0%
|
0
|
Prepaid expenses
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Prepaid expenses
|
Net
|
2,187,000
|
60.0%
|
1,366,704
|
44.9%
|
943,000
|
|
|
Gross
|
CH
|
2,187,000
|
60.0%
|
1,366,704
|
44.9%
|
943,000
|
|
|
Amortisation
|
CI
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Equalization accounts (IV to VI)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Multi-period charges
|
CW3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Premiums on redemption of bonds
|
CM3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Currency differential gain
|
CN3
|
0
|
0%
|
6,809
|
0%
|
0
|
|
|
Gross
|
|
0
|
0%
|
6,809
|
0%
|
0
|
References
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Due within one year
|
CP
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Due after one year
|
CR
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
|
|
Accounts - Passive
Other capital resources | Provisions for risks and charges | Liabilities |
Translation loss | Equalization accounts | References
Grand Total -
Passive Accounts (I to IV)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Grand Total
(I to V)
|
EE
|
137,830,000
|
-9.0%
|
151,391,556
|
-11.0%
|
170,133,000
|
Shareholder
Equity (I)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Total
shareholders' equity (Total I)
|
DL
|
33,628,000
|
-26.2%
|
45,587,822
|
-22.7%
|
58,997,000
|
|
|
Equity and
shareholders' equity
|
DA
|
1,364,000
|
0.0%
|
1,363,786
|
0.0%
|
1,364,000
|
|
|
Issue and
merger premiums
|
DB
|
0
|
0%
|
3,608,124
|
0%
|
0
|
|
|
Revaluation
differentials
|
DC
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Of which
equity differential
|
EK
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Legal
reserve
|
DD
|
0
|
0%
|
136,379
|
0%
|
0
|
|
|
Statutory or
contractual reserve
|
DE
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Special
regulated reserves
|
DF
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Of which
special reserve of provisions for current fluctuation
|
B1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Other
reserves
|
DG
|
44,517,000
|
-55.7%
|
100,378,563
|
91.8%
|
52,338,000
|
|
|
Of which
reserve for buying originals works from alive artists
|
EJ
|
0
|
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Profits or
losses brought forward
|
DH
|
0
|
0%
|
-49,444,498
|
0%
|
0
|
|
|
Profit or
loss for the period
|
DI
|
-12,253,000
|
7.2%
|
-13,206,185
|
-349.4%
|
5,295,000
|
|
|
Investment
grants
|
DJ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Special
tax-allowable reserves
|
DK
|
0
|
0%
|
2,751,653
|
0%
|
0
|
Other capital resources (II)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Total other capital resources (Total
II)
|
DO
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Income from participating securities
|
DM
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Conditional loans
|
DN
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Provisions for risks and charges (III)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Total provisions for risks and charges
(Total III)
|
DR
|
7,307,000
|
16.0%
|
6,297,348
|
2.1%
|
6,166,000
|
|
|
Risk provisions
|
DP
|
7,307,000
|
675.6%
|
942,065
|
-84.7%
|
6,166,000
|
|
|
Reserves for charges
|
DQ
|
0
|
0%
|
5,355,283
|
0%
|
0
|
Liabilities (IV)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Total Liabilities (Total IV)
|
EC
|
96,895,000
|
-2.0%
|
98,865,230
|
-5.8%
|
104,970,000
|
|
|
Convertible debentures
|
DS
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Other debentures
|
DT
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Bank loans and liabilities
|
DU
|
0
|
0%
|
54,238,280
|
0%
|
0
|
|
|
Sundry loans and financial liabilities
|
DV
|
63,675,000
|
1026.2%
|
5,654,158
|
-91.9%
|
69,409,000
|
|
|
Of which participating loans
|
EI
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Advance payments received for current orders
|
DW
|
0
|
0%
|
2,868,979
|
0%
|
0
|
|
|
Trade accounts payables
|
DX
|
12,438,000
|
-14.8%
|
14,591,013
|
15.1%
|
12,672,000
|
|
|
Tax and social security liabilities
|
DY
|
0
|
0%
|
18,140,441
|
0%
|
0
|
|
|
Fixed asset liabilities
|
DZ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Other debts
|
EA
|
17,010,000
|
12497.5%
|
135,027
|
-99.4%
|
22,824,000
|
Translation loss (V)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Translation loss (Total V)
|
ED
|
0
|
0%
|
641,157
|
0%
|
0
|
Equalization accounts
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Deferred income
|
EB
|
3,772,000
|
16.5%
|
3,237,332
|
4880.5%
|
65,000
|
References
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Of which tax-allowable reserve
|
EF
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Deferred income and liabilities
|
EG
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Of which current bank facilities
|
EH
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
|
|
Result account
Sales of Goods | Operating charges | Operating charges | Financial income |
Financial charges | Financial charges | Extraordinary charges | Employee
profit sharing | Tax on profits | References
1- Operating
result(I-II)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Operating
result (Total I-II)
|
GG
|
-2,838,000
|
-150.7%
|
-1,131,817
|
-2235.5%
|
53,000
|
2 -Financial
result(V - VI)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Financial
result (Total V-VI)
|
GV
|
-17,264,000
|
-19.7%
|
-14,420,619
|
-1655.6%
|
927,000
|
3 -Pre-tax net
operating income result(I - VI)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Pre-tax net
operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)
|
GW
|
-20,102,000
|
-29.3%
|
-15,552,436
|
-1687.0%
|
980,000
|
4
-Extraordinary result(VII-VIII)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Extraordinary
result (Total VII-VIII)
|
HI
|
7,782,000
|
264.8%
|
2,133,027
|
-49.8%
|
4,249,000
|
Profit or loss
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Profit or
loss
|
HN
|
-12,253,000
|
7.2%
|
-13,206,185
|
-349.4%
|
5,295,000
|
Total Income
(I+III+V+VII)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Total Income
(I+III+V+VII)
|
HL
|
246,330,000
|
3.2%
|
238,704,938
|
-30.9%
|
345,505,000
|
Total charges
(Total II+IV+VI+VIII+IX+X)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Total
charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)
|
HM
|
258,583,000
|
2.6%
|
251,911,122
|
-26.0%
|
340,210,000
|
Operating
income(I)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Total
operating income (Total I)
|
FR
|
234,590,000
|
3.1%
|
227,591,613
|
-1.9%
|
231,925,000
|
Operating
income (details)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Sale of
goods for resale
|
FC
|
0
|
0%
|
189,511,477
|
0%
|
0
|
|
|
France
|
FA
|
0
|
0%
|
189,511,477
|
0%
|
0
|
|
|
Export
|
FB
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Sale of
goods produced
|
FF
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
France
|
FD
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Export
|
FE
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Sale of
services
|
FI
|
231,063,000
|
555.4%
|
35,253,172
|
-84.7%
|
230,125,000
|
|
|
France
|
FG
|
231,063,000
|
555.4%
|
35,253,172
|
-84.7%
|
230,125,000
|
|
|
Export
|
FH
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Net turnover
|
FL
|
231,063,000
|
2.8%
|
224,764,649
|
-2.3%
|
230,125,000
|
|
|
France
|
FJ
|
231,063,000
|
2.8%
|
224,764,649
|
-2.3%
|
230,125,000
|
|
|
Export
|
FK
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Stocked
production
|
FM
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Self-constructed
assets
|
FN
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Operating
grants
|
FO
|
0
|
0%
|
17,654
|
0%
|
0
|
|
|
Release of
reserves and provisions
|
FP
|
0
|
0%
|
2,753,141
|
0%
|
0
|
|
|
Other income
|
FQ
|
3,527,000
|
6179.3%
|
56,169
|
-96.9%
|
1,800,000
|
Operating
charges(II)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Total
operating charges (Total II)
|
GF
|
237,428,000
|
3.8%
|
228,723,430
|
-1.4%
|
231,872,000
|
Exploitation
charges
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Purchase of
goods for resale
|
FS
|
0
|
0%
|
89,967,803
|
0%
|
0
|
|
|
Change in
stocks of goods for resale
|
FT
|
0
|
0%
|
2,304,816
|
0%
|
0
|
|
|
Purchase of
raw materials
|
FU
|
0
|
0%
|
779,725
|
0%
|
0
|
|
|
Change in
stocks of raw materials
|
FV
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Other
external purchases and charges
|
FW
|
154,968,000
|
167.2%
|
58,002,289
|
-62.3%
|
154,000,000
|
|
|
Tax, duty
and similar payments
|
FX
|
0
|
0%
|
10,980,648
|
0%
|
0
|
|
|
Payroll
|
FY
|
0
|
0%
|
43,073,663
|
0%
|
0
|
|
|
Social
security costs
|
FZ
|
76,420,000
|
334.5%
|
17,586,768
|
-75.3%
|
71,099,000
|
Depreciation
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Depreciation
of fixed assets
|
GA
|
6,040,000
|
16.9%
|
5,164,826
|
-23.7%
|
6,773,000
|
|
|
Amortisation
of fixed assets
|
GB
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Depreciation/amortisation
of current assets
|
GC
|
0
|
0%
|
76,522
|
0%
|
0
|
|
|
Provisions
for risks and charges
|
GD
|
0
|
0%
|
303,671
|
0%
|
0
|
Other charges
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Other
charges
|
GE
|
0
|
0%
|
482,699
|
0%
|
0
|
Operating
charges (III-IV)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Share of
joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)
|
GH
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Share of
joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)
|
GI
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Financial
income(V)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Total
financial income (Total V)
|
GP
|
0
|
0%
|
3,051,900
|
229.2%
|
927,000
|
|
|
Share
financial income
|
GJ
|
0
|
0%
|
407,004
|
0%
|
0
|
|
|
Other
investment income & capitalised receivables
|
GK
|
0
|
0%
|
827
|
0%
|
0
|
|
|
Other
interest and similar income
|
GL
|
0
|
0%
|
2,526,730
|
172.6%
|
927,000
|
|
|
Released
provisions and transferred charges
|
GM
|
0
|
0%
|
40,755
|
0%
|
0
|
|
|
Exchange
gains
|
GN
|
0
|
0%
|
74,651
|
0%
|
0
|
|
|
Net income
from disposal of investment securities
|
GO
|
0
|
0%
|
1,933
|
0%
|
0
|
Financial
Charge (VI)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Total
financial charge (Total VI)
|
GU
|
17,264,000
|
-1.2%
|
17,472,519
|
0%
|
0
|
|
|
Financial
reserves and provisions
|
GQ
|
0
|
0%
|
15,541,574
|
0%
|
0
|
|
|
Interest and
similar charges
|
GR
|
17,264,000
|
1166.0%
|
1,363,648
|
0%
|
0
|
|
|
Exchange
losses
|
GS
|
0
|
0%
|
567,297
|
0%
|
0
|
|
|
Net loss
from disposal of investment securities
|
GT
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Extraordinary
income(VII)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Total
extraordinary income (Total VII)
|
HD
|
11,740,000
|
45.6%
|
8,061,425
|
-92.8%
|
112,653,000
|
|
|
Extraordinary
operating income
|
HA
|
11,740,000
|
533.5%
|
1,853,228
|
-98.4%
|
112,653,000
|
|
|
Extraordinary
income from capital transactions
|
HB
|
0
|
0%
|
4,845,338
|
0%
|
0
|
|
|
Released
provisions and transferred charges
|
HC
|
0
|
0%
|
1,362,859
|
0%
|
0
|
Extraordinary
charges(VIII)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Total
extraordinary charges (Total VIII)
|
HH
|
3,958,000
|
-33.2%
|
5,928,398
|
-94.5%
|
108,404,000
|
|
|
Extraordinary
operating charges
|
HE
|
3,958,000
|
111.4%
|
1,872,019
|
-98.3%
|
108,404,000
|
|
|
Extraordinary
charges from capital transactions
|
HF
|
0
|
0%
|
888,534
|
0%
|
0
|
|
|
Extraordinary
reserves and provisions
|
HG
|
0
|
0%
|
3,167,845
|
0%
|
0
|
Employee
profit sharing(IX)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Employee
profit sharing (Total IX)
|
HJ
|
-67,000
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Tax on
profits(X)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Tax on
profits (Total X)
|
HK
|
0
|
0%
|
-213,225
|
-223.1%
|
-66,000
|
References
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Of which
equipment leases
|
HP
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Of which
property leases
|
HQ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Of which
transferred charges
|
A1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Of which
trader's own contributions
|
A2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Of which
royalties on licences and patents (income)
|
A3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Of which
royalties on licences and patents (charges)
|
A4
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
|
|
Other incomes tax return forms
Reserve for depreciation | Provisions included in balance sheet | State
deadlines claims and debts at the end of period
Table allocation results and other information
Fixed Assets
Grand Total Fixed Assets (I to IV)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Gross value
at begin of period
|
OG
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Increasess
due to revaluation
|
OH
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Decreasess,
acquisitions, creations, contributions
|
OJ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Decreasess
by budget item transfer
|
OK1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Decreasess
by transfers
|
OK2
|
0
|
0%
|
6,357,884
|
0%
|
0
|
|
|
Gross value
at the end of period
|
OL
|
0
|
0%
|
208,964,713
|
0%
|
0
|
Research and
development Charge (Total I)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Gross value
at begin of period
|
CZ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Increasess
due to revaluation
|
KB
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Increasess,
acquisitions, creations, contributions
|
KC
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Decreasess
by budget item transfer
|
C01
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Decreasess
by transfers
|
C02
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Gross value
at the end of period
|
D0
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Other budget
item from Intangible fixed assets(Total II)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Gross value
at begin of period
|
KD
|
0
|
0%
|
3,534,531
|
0%
|
0
|
|
|
Increasess
due to revaluation
|
KE
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Increasess,
acquisitions, creations, contributions
|
KF
|
0
|
0%
|
459,964
|
0%
|
0
|
|
|
Decreasess
by budget item transfer
|
LV1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Decreasess
by transfers
|
LV2
|
0
|
0%
|
126,630
|
0%
|
0
|
|
|
Gross value
at the end of period
|
LW
|
0
|
0%
|
3,867,865
|
0%
|
0
|
Tangible fixed
assets (Total III)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Gross value
at begin of period
|
LN
|
0
|
0%
|
136,703,432
|
0%
|
0
|
|
|
Increasess
due to revaluation
|
LO
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Increasess,
acquisitions, creations, contributions
|
LP
|
0
|
0%
|
6,239,431
|
0%
|
0
|
|
|
Decreasess
by budget item transfer
|
NG1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Decreasess
by transfers
|
NG2
|
0
|
0%
|
5,267,915
|
0%
|
0
|
|
|
Gross value
at the end of period
|
NH
|
0
|
0%
|
137,674,948
|
0%
|
0
|
Fiancial
assets (Total IV)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Gross value
at begin of period
|
LQ
|
0
|
0%
|
60,665,937
|
0%
|
0
|
|
|
Increasess
due to revaluation
|
LR
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Increasess,
acquisitions, creations, contributions
|
LS
|
0
|
0%
|
7,719,301
|
0%
|
0
|
|
|
Decreasess
by budget item transfer
|
NJ1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Decreasess
by transfers
|
NJ2
|
0
|
0%
|
963,338
|
0%
|
0
|
|
|
Gross value
at the end of period
|
NK
|
0
|
0%
|
67,421,900
|
0%
|
0
|
Reserve for depreciation
Situation and movement of reserve for depreciation
Grand total (I-II-III)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Reserve for depreciation value at
begin of period
|
0N
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Increases
|
0P
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Decreasess
|
0Q
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Reserve for depreciation value at the
end of period
|
0R
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Research and development charge (Total I)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Reserve for depreciation value at
begin of period
|
CY
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Increases
|
PB
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Decreasess
|
PC
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Decreasess by budget item transfer
|
PD
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Other intangible assets (Total II)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Reserve for depreciation value at
begin of period
|
PE
|
0
|
0%
|
506,337
|
0%
|
0
|
|
Increases
|
PF
|
0
|
0%
|
128,302
|
0%
|
0
|
|
Decreasess
|
PG
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Decreasess by budget item transfer
|
PH
|
0
|
0%
|
634,639
|
0%
|
0
|
Total fixed assets amotisation(Total III)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Reserve for depreciation value at
begin of period
|
QU
|
0
|
0%
|
97,990,252
|
0%
|
0
|
|
Increases
|
QV
|
0
|
0%
|
5,036,523
|
0%
|
0
|
|
Decreases
|
QW
|
0
|
0%
|
4,112,034
|
0%
|
0
|
|
|
Decreasess by budget item transfer
|
QX
|
0
|
0%
|
98,914,741
|
0%
|
0
|
Movements during period affecting charge allocated over several period
Charges à répartir ou frais d'émission
d'emprunt
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Gross value at begin of period
|
Z91
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Increases
|
Z92
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Depreciation of fixed assets during
period
|
Z9
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Decreasess by budget item transfer
|
B1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Premium refund of obligations
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Net value at begining of period
|
SP1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Increases
|
SP2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
Depreciation of fixed assets during
period
|
SP
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Net value at the end of period
|
SR
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Value at begining of period
|
7C
|
0
|
0%
|
13,513,620
|
0%
|
0
|
|
Increases
|
UB
|
0
|
0%
|
19,089,612
|
0%
|
0
|
|
Decreases
|
UC
|
0
|
0%
|
2,251,553
|
0%
|
0
|
|
|
Value at the end of period
|
UD
|
0
|
0%
|
30,351,679
|
0%
|
0
|
Includes Total allocations
|
|
Operating
|
UE
|
0
|
0%
|
380,193
|
0%
|
0
|
|
|
Financial
|
UG
|
0
|
0%
|
15,541,574
|
0%
|
0
|
|
|
Exceptional
|
UJ
|
0
|
0%
|
3,167,845
|
0%
|
0
|
Includes Total Withdrawal
|
|
Operating
|
UF
|
0
|
0%
|
930,811
|
0%
|
0
|
|
|
Financial
|
UH
|
0
|
0%
|
40,755
|
0%
|
0
|
|
|
Exceptional
|
UK
|
0
|
0%
|
1,279,987
|
0%
|
0
|
Total regulated provisions (Total I)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Value at begining of period
|
3Z
|
0
|
0%
|
2,954,605
|
0%
|
0
|
|
Increases
|
TS
|
0
|
0%
|
420,971
|
0%
|
0
|
|
Decreases
|
TT
|
0
|
0%
|
623,923
|
0%
|
0
|
|
|
Value at the end of period
|
TU
|
0
|
0%
|
2,751,653
|
0%
|
0
|
Total risk and charge provisions (Total II)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Value at begining of period
|
5Z
|
0
|
0%
|
6,165,752
|
0%
|
0
|
|
Increases
|
TV
|
0
|
0%
|
1,625,859
|
0%
|
0
|
|
Decreases
|
TW
|
0
|
0%
|
1,494,263
|
0%
|
0
|
|
|
Value at the end of period
|
TX
|
0
|
0%
|
6,297,348
|
0%
|
0
|
Total Provision for depreciation (Total III)
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Value at begining of period
|
7B
|
0
|
0%
|
4,393,264
|
0%
|
0
|
|
Increases
|
TY
|
0
|
0%
|
17,042,782
|
0%
|
0
|
|
Decreases
|
TZ
|
0
|
0%
|
133,366
|
0%
|
0
|
|
|
Value at the end of period
|
UA
|
0
|
0%
|
21,302,680
|
0%
|
0
|
State deadlines claims and debts at the end of
period
State claims
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Gross value
|
VT
|
0
|
0%
|
36,513,084
|
0%
|
0
|
|
|
1 year at most
|
VU
|
0
|
0%
|
18,250,707
|
0%
|
0
|
|
|
More than one year
|
VV
|
0
|
0%
|
18,262,377
|
0%
|
0
|
State of loans
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Claims related to holdings (gross)
|
UL
|
0
|
0%
|
17,849,724
|
0%
|
0
|
|
|
Claims related to shareholdings (1 year at
most)
|
UM
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Loans (gross)
|
UP
|
0
|
0%
|
5,962
|
0%
|
0
|
|
|
Loans (1 year at most)
|
UR
|
0
|
0%
|
5,962
|
0%
|
0
|
|
|
Other financial assets (gross)
|
UT
|
0
|
0%
|
412,653
|
0%
|
0
|
|
|
Other financial assets (1 year at most)
|
UV
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Receivables statement of assets
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Customers doubtful or disputed
|
VA
|
0
|
0%
|
705,168
|
0%
|
0
|
|
|
Other claims customer
|
UX
|
0
|
0%
|
10,825,109
|
0%
|
0
|
|
|
Receivables represent Loaned Securities
|
UU
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Provision for depreciation previously
established
|
UQ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Personnel and associated accounts
|
UY
|
0
|
0%
|
13,135
|
0%
|
0
|
|
|
Social Security and other social
organizations
|
UZ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Income taxes
|
VM
|
0
|
0%
|
212,072
|
0%
|
0
|
|
|
Value added tax
|
VB
|
0
|
0%
|
303,204
|
0%
|
0
|
|
|
Other taxes and payments assimilated
|
VN
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
State and other public - Miscellaneous
|
VP
|
0
|
0%
|
1,025,825
|
0%
|
0
|
|
|
Group and Associates
|
VC
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Accounts receivable (including claims
relating to the operation of pension titles)
|
VR
|
0
|
0%
|
3,793,530
|
0%
|
0
|
Prepaid
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Prepaid
|
VS
|
0
|
0%
|
1,366,704
|
0%
|
0
|
State Debt
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Total debt (gross)
|
VY
|
0
|
0%
|
95,996,250
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
VZ2
|
0
|
0%
|
62,061,270
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
VZ3
|
0
|
0%
|
33,934,980
|
0%
|
0
|
|
More than 5 years
|
VZ4
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Details
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
 
|
Convertible bonds (gross)
|
7Y1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
7Y2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
7Y3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Other bonds (gross)
|
7Z1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
7Z2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
7Z3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Borrowing & debts to 1 year
maximum at the origin (gross)
|
VG1
|
0
|
0%
|
13,533,375
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
VG2
|
0
|
0%
|
13,533,375
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
VG3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Borrowing & debts to more than 1
year at the origin (gross)
|
VH1
|
0
|
0%
|
40,704,905
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
VH2
|
0
|
0%
|
12,382,355
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
VH3
|
0
|
0%
|
28,322,550
|
0%
|
0
|
|
 
|
Loans and various financial
liabilities (gross)
|
8A1
|
0
|
0%
|
5,654,158
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
8A2
|
0
|
0%
|
41,728
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
8A3
|
0
|
0%
|
5,612,430
|
0%
|
0
|
|
 
|
Suppliers and associated accounts
(gross)
|
8B1
|
0
|
0%
|
14,591,013
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
8B2
|
0
|
0%
|
14,591,013
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
8B3
|
0
|
0%
|
14,591,013
|
0%
|
0
|
|
 
|
Personnel and associated accounts
(gross)
|
8C1
|
0
|
0%
|
8,704,856
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
8C2
|
0
|
0%
|
8,704,856
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
8C3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Social Security and other social
organizations (gross)
|
8D1
|
0
|
0%
|
5,854,402
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
8D2
|
0
|
0%
|
5,854,402
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
8D3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Taxes on profits (gross)
|
8E1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
8E2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
8E3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
VAT (gross)
|
VW1
|
0
|
0%
|
1,091,307
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
VW2
|
0
|
0%
|
1,091,307
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
VW3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Backed Obligations (gross)
|
VX1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
VX2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
VX3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Other taxes and assimilated (gross)
|
VQ1
|
0
|
0%
|
2,489,875
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
VQ2
|
0
|
0%
|
2,489,875
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
VQ3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Assets and liabilities associated
accounts (gross)
|
8J1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
8J2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
8J3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 5 years
|
8J4
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Groups and associates (gross)
|
VI1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
VI2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
VI3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More 5 years
|
VI4
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Other liabilities (gross)
|
8K1
|
0
|
0%
|
135,027
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
8K2
|
0
|
0%
|
135,027
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
8K3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Debt representative of borrowed
securities (gross)
|
SZ1
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
SZ2
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
SZ3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
 
|
Products in advance (gross)
|
8L1
|
0
|
0%
|
3,237,332
|
0%
|
0
|
|
1 year at most
|
8L2
|
0
|
0%
|
3,237,332
|
0%
|
0
|
|
More than 1 year and 5 years at most
|
8L3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
References
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Loans made during the period
|
VJ
|
0
|
0%
|
18,905,449
|
0%
|
0
|
|
|
Debt repaid during the period
|
VK
|
0
|
0%
|
18,971,500
|
0%
|
0
|
Table allocation results and other information
Dividends distributed
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Dividends
|
ZE
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Commitments
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Commitments leasing furniture
|
YQ
|
0
|
0%
|
12,010,931
|
0%
|
0
|
|
|
Commitments Real Estate Leasing
|
YR
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Effects brought to the discount and
unmatured
|
YS
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Other charges Externes
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Subcontracting
|
YT
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Rentals, rental charges and
condominiums
|
XQ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Staff outside the company
|
YU
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Remuneration intermediaries and fees
(excluding fees)
|
SS
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Fees, commissions and brokerage
|
YV
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Other accounts
|
ST
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Total Other purchases and external
|
ZJ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Taxes and Fees
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Business tax
|
YW
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Other taxes and payments assimilated
|
9Z
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Total taxes and fees
|
YX
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
VAT
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Amount VAT collected
|
YY
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
Total VAT on goods and services
|
YZ
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
Average number of employees
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Average number of employees
|
YP
|
0
|
0%
|
1,601
|
2.2%
|
1,566
|
Groups and Shareholders
|
|
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
|
|
Groups and Shareholders
|
ZR
|
0
|
-
|
0
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Ratios
Structure and liquidity | Management or rotation | Profitability of the
business | Return on capital
Structure and Liquidity
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
Sector Median2012
|
|
|
Fixed Asset Financing
|

|
1.31
|
19.1%
|
1.10
|
-18.5%
|
1.35
|
1.66
|
-21.1%
|
|
Global Debt
|

|
151days
|
-4.4%
|
158days
|
-3.7%
|
164days
|
124days
|
21.8%
|
|
Working Capital Fund overall net
|

|
38days
|
15.2%
|
33days
|
-38.9%
|
54days
|
47days
|
-19.1%
|
|
Financial independence
|

|
%
|
-
|
84.05%
|
-
|
%
|
275.62%
|
-
|
|
 More ratios
|
|
Solvability
|

|
24.40%
|
-19.0%
|
30.11%
|
-13.2%
|
34.68%
|
31.34%
|
-22.1%
|
|
Capacity debt futures
|

|
%
|
-
|
175.91%
|
-
|
%
|
795.50%
|
-
|
|
Coverage of current assets by net working
capital overall
|

|
44.09%
|
39.0%
|
31.73%
|
-36.6%
|
50.02%
|
36.02%
|
22.4%
|
|
General Liquidity
|

|
|
-
|
0.29
|
-
|
|
0.36
|
-
|
|
Restricted Liquidity
|

|
|
-
|
0.37
|
-
|
|
0.74
|
-
|
Management or rotation
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
Sector Median2012
|
|
|
Need background in operating working capital
|

|
41days
|
36.7%
|
30days
|
-43.4%
|
53days
|
11days
|
272.7%
|
|
Treasury
|

|
0days
|
0%
|
8days
|
0%
|
0days
|
10days
|
0%
|
|
Inventory turnover of goods
|

|
days
|
-
|
154days
|
-
|
days
|
115days
|
-
|
|
Average length of credit granted to customers
|

|
17days
|
-5.6%
|
18days
|
5.9%
|
17days
|
17days
|
0%
|
|
Average length of credit obtained suppliers
|

|
29days
|
-17.1%
|
35days
|
16.7%
|
30days
|
55.50days
|
-47.7%
|
|
 More ratios
|
|
Inventory turnover of raw materials in
industrial enterprises
|

|
days
|
-
|
0days
|
-
|
days
|
0days
|
-
|
|
Inventory turnover of intermediate and
finished products in the industrial enterprise
|

|
days
|
-
|
days
|
-
|
days
|
938days
|
-
|
|
Rotation tangible assets
|

|
%
|
-
|
163.26%
|
-
|
%
|
700.42%
|
-
|
Profitability of the business
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
Sector Median2012
|
|
|
Margin trading
|

|
0%
|
0%
|
43.26%
|
0%
|
0
|
38.30%
|
0%
|
|
Profitability of the business
|

|
-0.14
|
-115.1%
|
0.93
|
-57.3%
|
2.18
|
3.02%
|
-104.6%
|
|
Net profit
|

|
-5.30%
|
9.9%
|
-5.88%
|
-355.7%
|
2.30%
|
1.59%
|
-433.3%
|
|
 More ratios
|
|
Growth rate of turnover (excluding VAT)
|

|
2.80%
|
220.2%
|
-2.33%
|
75.6%
|
-9.53%
|
0%
|
0%
|
|
Rates integration
|

|
32.93%
|
0.4%
|
32.79%
|
-0.9%
|
33.08%
|
26.20%
|
25.7%
|
|
Rate leasing furniture
|

|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
Work Factor
|

|
100.43%
|
22.0%
|
82.30%
|
-11.9%
|
93.40%
|
77.63%
|
29.4%
|
|
Weight interests
|

|
7.47
|
-3.9%
|
7.77%
|
0%
|
0%
|
0.23%
|
3147.8%
|
Return on capital
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
Sector Median2012
|
|
|
Cash flow from the overall profitability
|

|
-2.69%
|
-235.9%
|
1.98%
|
-62.2%
|
5.24%
|
2.91%
|
-192.4%
|
|
Rates of economic profitability
|

|
0%
|
0%
|
2%
|
-50.0%
|
4%
|
10%
|
0%
|
|
Financial profitability
|

|
33628000%
|
-26.2%
|
45587822%
|
-22.7%
|
58997000%
|
28670%
|
117193.3%
|
|
Return on investment
|

|
5.15%
|
27.5%
|
4.04%
|
-1.9%
|
4.12%
|
6.87%
|
-25.0%
|
|
|
|
|
Soldes
Intermédiaires de Gestion
|
|
31/12/2012
|
|
31/12/2010
|
|
31/12/2009
|
Sector
Median2012
|
|
|
Turnover
|
231,063,000
|
2.8%
|
224,764,649
|
-2.3%
|
230,125,000
|
334,882 €
|
68898.4%
|
|
Sales of
goods
|
0
|
0%
|
189,511,477
|
0%
|
0
|
|
|
|
- Purchase
of goods
|
0
|
0%
|
89,967,803
|
0%
|
0
|
|
|
|
+/- Stock of
goods variation
|
0
|
0%
|
2,304,816
|
0%
|
0
|
|
|
|
Trading
margin
|
0 €
|
0%
|
97,238,858 €
|
0%
|
0 €
|
102,123.50 €
|
0%
|
|
|
0.00 % CA
|
0%
|
43.26 % CA
|
0%
|
0.00 % CA
|
38.78 % CA
|
0%
|
|
Sale of
goods produced
|
231,063,000
|
555.4%
|
35,253,172
|
-84.7%
|
230,125,000
|
|
|
|
+/- Stocked
production
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
|
+
Self-constructed assets
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
|
Period
production
|
231,063,000
€
|
555.4%
|
35,253,172 €
|
-84.7%
|
230,125,000
€
|
7,853 €
|
2942253.2%
|
|
|
100.00 % CA
|
537.8%
|
15.68 % CA
|
-84.3%
|
100.00 % CA
|
4.63 % CA
|
2059.8%
|
|
Trading
margin
|
0
|
0%
|
97,238,858
|
0%
|
0
|
102,123.50
|
0%
|
|
+ Period
Production
|
231,063,000
|
555.4%
|
35,253,172
|
-84.7%
|
230,125,000
|
7,853
|
2942253.2%
|
|
- Purchase
of raw materials
|
0
|
0%
|
779,725
|
0%
|
0
|
|
|
|
+/- Change
in stocks of raw materiels
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
|
- Other
external purchases and charges
|
154,968,000
|
167.2%
|
58,002,289
|
-62.3%
|
154,000,000
|
|
|
|
Added value
|
76,095,000 €
|
3.2%
|
73,710,016 €
|
-3.2%
|
76,125,000 €
|
87,723 €
|
86644.6%
|
|
|
32.93 % CA
|
0.4%
|
32.79 % CA
|
-0.9%
|
33.08 % CA
|
26.20 % CA
|
25.7%
|
|
Added value
|
76,095,000 €
|
3.2%
|
73,710,016 €
|
-3.2%
|
76,125,000 €
|
87,723 €
|
86644.6%
|
|
+ Operating
grants
|
0
|
0%
|
17,654
|
0%
|
0
|
|
|
|
- Tax, duty
and similar payments
|
0
|
0%
|
10,980,648
|
0%
|
0
|
|
|
|
- Personal
charges
|
76,420,000
|
26.0%
|
60,660,431
|
-14.7%
|
71,099,000
|
|
|
|
Gross
operating surplus
|
-325,000 €
|
-115.6%
|
2,086,591 €
|
-58.5%
|
5,026,000 €
|
11,012.50 €
|
-3051.2%
|
|
|
-0.14 % CA
|
-115.1%
|
0.93 % CA
|
-57.3%
|
2.18 % CA
|
3.02 % CA
|
-104.6%
|
|
Gross
operating surplus
|
-325,000 €
|
-115.6%
|
2,086,591 €
|
-58.5%
|
5,026,000 €
|
11,012.50 €
|
-3051.2%
|
|
+ Release of
reserves and provisions
|
0
|
0%
|
2,753,141
|
0%
|
0
|
|
|
|
+ Other
operating income
|
3,527,000
|
6179.3%
|
56,169
|
-96.9%
|
1,800,000
|
|
|
|
-
Depreciation/Amortisation
|
6,040,000
|
8.9%
|
5,545,019
|
-18.1%
|
6,773,000
|
|
|
|
- Other
charges
|
0
|
0%
|
482,699
|
0%
|
0
|
|
|
|
Operating
result
|
-2,838,000 €
|
-150.7%
|
-1,131,817 €
|
-2235.5%
|
53,000 €
|
6,267.50 €
|
-45381.2%
|
|
|
-1.23 % CA
|
-146.0%
|
-0.50 % CA
|
-2600%
|
0.02 % CA
|
2.07 % CA
|
-159.4%
|
|
Operating
result
|
-2,838,000 €
|
-150.7%
|
-1,131,817 €
|
-2235.5%
|
53,000 €
|
6,267.50 €
|
-45381.2%
|
|
+/- Result
of joint-venture transferred from/to other partners
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
|
+ Financial
income
|
0
|
0%
|
3,051,900
|
229.2%
|
927,000
|
|
|
|
- Financial
charges
|
17,264,000
|
-1.2%
|
17,472,519
|
0%
|
0
|
|
|
|
Pre-tax
result
|
-20,102,000
€
|
-29.3%
|
-15,552,436
€
|
-1687.0%
|
980,000 €
|
4,721 €
|
-425899.6%
|
|
|
-8.70 % CA
|
-25.7%
|
-6.92 % CA
|
-1709.3%
|
0.43 % CA
|
1.86 % CA
|
-567.7%
|
|
Extraordinary
income
|
11,740,000
|
45.6%
|
8,061,425
|
-92.8%
|
112,653,000
|
21.50
|
54604551.2%
|
|
-
Extraordinary charges
|
3,958,000
|
-33.2%
|
5,928,398
|
-94.5%
|
108,404,000
|
|
|
|
Extraordinary
result
|
7,782,000 €
|
264.8%
|
2,133,027 €
|
-49.8%
|
4,249,000 €
|
0 €
|
0%
|
|
|
3.37 % CA
|
254.7%
|
0.95 % CA
|
-48.6%
|
2 % CA
|
0 % CA
|
0%
|
|
Pre-tax
result
|
-20,102,000
€
|
-29.3%
|
-15,552,436
€
|
-1687.0%
|
980,000 €
|
4,721 €
|
-425899.6%
|
|
Extraordinary
result
|
7,782,000 €
|
264.8%
|
2,133,027 €
|
-49.8%
|
4,249,000 €
|
0 €
|
0%
|
|
- Employee
profit sharing
|
-67,000
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
|
|
|
- Tax on
profits
|
0
|
0%
|
-213,225
|
-223.1%
|
-66,000
|
|
|
|
Net result
|
-12,253,000
€
|
7.2%
|
-13,206,184
€
|
-349.4%
|
5,295,000 €
|
4,768 €
|
-257084.1%
|
|

|
-5.30 % CA
|
9.9%
|
-5.88 % CA
|
-355.7%
|
2.30 % CA
|
1.59 % CA
|
-433.3%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Publication date
|
Gazette Name
|
Description
|
|
|
26/09/2013
|
Bodacc A
|
Vente et cession : Acheteur
|
|
|
|
|
75 - PARIS
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
465 - 470 500 943 RCS Lille Métropole. TAPIS SAINT MACLOU. Forme
: Société anonyme. Adresse : 330 rue Carnot, 59150
Wattrelos.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de
78000,00 euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité
: Commerce de détail, revêtements sols et murs. Adresse : 144
boulevard de la Villette, 75019 Paris.
Précédent propriétaire : MONDIAL MOQUETTE. 328 412 440
RCS Paris.
A dater du : 10/03/1971. Date de commencement de l’activité :
01/07/2013. Publication légale : Le Parisien Libéré du
18/07/2013. Oppositions : Me Frédéric Fortier 11 rue de Meaux
75019 Paris pour la validité. Descriptif : . Commentaires : Achat
d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne
morale.
|
|
26/09/2013
|
Bodacc A
|
Vente et cession : Acheteur
|
|
|
|
|
75 - PARIS
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
469 - 470 500 943 RCS Lille Métropole. TAPIS SAINT MACLOU. Forme
: Société anonyme. Adresse : 330 rue Carnot, 59150
Wattrelos.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de
67000,00 euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité
: Commerce de détail, revêtements sols et murs. Adresse : 67
boulevard Ney, 75018 Paris.
Précédent propriétaire : MONDIAL MOQUETTE. 328 412 440
RCS Paris.
A dater du : 10/03/1971. Date de commencement de l’activité :
01/07/2013. Publication légale : Le Parisien Libéré du
18/07/2013. Oppositions : Me Antoine Corneloup 137 rue Marcadet
75018 Paris pour la validité. Descriptif : . Commentaires : Achat
d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne
morale.
|
|
26/09/2013
|
Bodacc A
|
Vente et cession : Acheteur
|
|
|
|
|
75 - PARIS
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
468 - 470 500 943 RCS Lille Métropole. TAPIS SAINT MACLOU. Forme
: Société anonyme. Adresse : 330 rue Carnot, 59150
Wattrelos.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de
192000,00 euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité
: Commerce de détail, revêtements sols et murs. Adresse : 88
à 94 boulevard Jourdan et 5 impasse St Alphonse, 75014 Paris.
Précédent propriétaire : MONDIAL MOQUETTE. 328 412 440
RCS Paris.
A dater du : 10/03/1971. Date de commencement de l’activité :
01/07/2013. Publication légale : Le Parisien Libéré du
18/07/2013. Oppositions : Me Jean-Luc Richard 94 boulevard du
Montparnasse 75014 Paris pour la validité. Descriptif : . Commentaires
: Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une
personne morale.
|
|
26/09/2013
|
Bodacc A
|
Vente et cession : Acheteur
|
|
|
|
|
75 - PARIS
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
467 - 470 500 943 RCS Lille Métropole. TAPIS SAINT MACLOU. Forme
: Société anonyme. Adresse : 330 rue Carnot, 59150
Wattrelos.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de
174000,00 euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité
: Commerce de détail, revêtements sols et murs. Adresse : 36/38
avenue Emile Zola, 6 place Alphonse Humbert et 35/37 rue de Javel,
75015 Paris.
Précédent propriétaire : MONDIAL MOQUETTE. 328 412 440
RCS Paris.
A dater du : 10/03/1971. Date de commencement de l’activité :
01/07/2013. Publication légale : Le Parisien Libéré du
18/07/2013. Oppositions : Me Jérôme Graux 45 rue de Lourmel
75015 Paris pour la validité. Descriptif : . Commentaires : Achat
d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne
morale.
|
|
19/09/2013
|
Bodacc A
|
Vente et cession : Acheteur
|
|
|
|
|
45 - LOIRET
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
215 - 470 500 943 RCS Lille métropole. TAPIS SAINT MACLOU. Forme
: Société anonyme. Sigle : TSM. Administration : Personne
ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : MULLIEZ
Gonzague. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 409000
Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité
: Commerce de détail revêtements sols et murs. Adresse : rue
Anthelme Brillat Savarin, 45100 Orléans.
Précédent propriétaire : MONDIAL MOQUETTE. 328 412 440
RCS Lille métropole.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2013. Publication légale
: La République du Centre du 19/07/2013. Oppositions : Etude
de Me Jean-Paul BLACHIER, notaire, 2 avenue de Paris 45000 Orléans et
étude de Me DELATTRE, notaire, 56 rue du Maréchal Foch à Roubaix (59). Descriptif
: . Commentaires : Autre achat, apport, attribution.
|
|
17/09/2013
|
Bodacc A
|
Vente et cession : Acheteur
|
|
|
|
|
72 - SARTHE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
521 - 470 500 943 RCS Lille métropole. TAPIS SAINT MACLOU
S.S. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle
: TSM. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 146000
Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité
: Commerce de détail revêtements sols et murs. Adresse : Zone
d'Activités Commerciales du Moulin aux Moines, 72650 La Chapelle
Saint-Aubin.
Précédent propriétaire : MONDIAL MOQUETTE. 328 412 440
RCS Lille métropole.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2013. Publication
légale : Ouest France du 18/07/2013. Oppositions : Etude
de Me Ribot 14, avenue Pierre Mendes France 72000 Le Mans. Descriptif
: . Commentaires : Autre achat, apport, attribution.
|
|
13/09/2013
|
Bodacc A
|
Vente et cession : Acheteur
|
|
|
|
|
92 - HAUTS-DE-SEINE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
478 - 470 500 943 RCS Nanterre. TAPIS SAINT MACLOU - T. S. M.
Forme : Société anonyme. Adresse : 330 rue Carnot,
59391 Wattrelos.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé
de 197000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité
: commerce de détail revêtements sols et murs. Adresse : 109-111
boulevard de Verdun, 92400 Courbevoie.
Précédent propriétaire : MONDIAL MOQUETTE. 328 412 440
RCS Lille metropole.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2013. Publication
légale : Le Parisien du 18/07/2013. Oppositions : Au
Mandataire Maître Hervé SEYEWETZ Notaire 13bis rue de l'Abreuvoir 92400
Courbevoie pour la validité et pour la correspondance Etude de Me
delattre Notaire 56 rue du Maréchal Foch 59100 ROUBAIX. Descriptif :
. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.
|
|
11/09/2013
|
Bodacc A
|
Vente et cession : Acheteur
|
|
|
|
|
78 - YVELINES
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
VERSAILLES
1032 - 470 500 943 RCS Versailles. TAPIS SAINT MACLOU. Forme
: Société anonyme. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé
de 135000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité
: commerce de détail, revêtements sols et murs. Adresse : 265
267 avenue Gabriel Péri, 78360 Montesson.
Précédent propriétaire : MONDIAL MOQUETTE. 328 412 440
RCS Lille metropole.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2013. Publication
légale : Le Parisien du 18/07/2013. Oppositions : Au
Mandataire Me GUEGAN Catherine, Notaire à Montesson, 54 Av Paul Doumer
pour la validité et pour la correspondance Chez Me Delattre, 56 rue Du
Marechal Foch 59100 ROUBAIX. Descriptif : . Commentaires : Autre
achat, apport, attribution.
|
|
11/09/2013
|
Bodacc A
|
Vente et cession : Acheteur
|
|
|
|
|
33 - GIRONDE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
308 - 470 500 943 RCS Bordeaux. TAPIS SAINT MACLOU. Forme
: Société anonyme. Adresse : 330 rue Carnot, 59000
Xattrelos.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé
de 94000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité
: commerce de détail revêtements sols et murs. Adresse : Centre
Commercial Auchan, Zone Artisanale Alienor, d'Aquitaine 33300 Bordeaux.
Précédent propriétaire : MONDIAL MOQUETTE. 328 412 440
RCS Lille metropole.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2013. Publication
légale : Le Républicain du 18/07/2013. Oppositions : Au
Mandataire Maître GAUTHIER Fabrice 23 ave du Jeu de Paume 33200
BORDEAUX - Maître DELATTRE 56 rue du Mal Foch 59100 ROUBAIX pour la
validité et pour la correspondance. Descriptif : . Commentaires
: Autre achat, apport, attribution.
|
|
26/08/2013
|
Bodacc C
|
Comptes annuels et rapports
|
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
MÉTROPOLE
2426 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société
anonyme. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires
: Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2012.
|
|
02/08/2013
|
Bodacc B
|
Modification et mutation diverse
|
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
METROPOLE
578 - 470 500 943 RCS Lille Métropole. TAPIS SAINT MACLOU. Forme
: Société anonyme. Sigle : T S M. Capital : 1785526
EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : modification survenue sur le capital
(augmentation).
|
|
18/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Parisien (Le)/Edition nationale
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 192000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
18/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Parisien (Le)/Edition nationale
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 174000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
18/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Parisien (Le)/Edition nationale
Date de décision : 10/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 67000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
18/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Parisien (Le)/Edition nationale
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 78000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
18/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Parisien (Le)/Edition des Yvelines
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 135000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
18/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Parisien (Le) /Edition de Paris
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 185000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES
DENAIN
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 197000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES
DENAIN
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 409000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES
DENAIN
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 135000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES
DENAIN
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 146000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES
DENAIN
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 185000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES
DENAIN
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 192000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES
DENAIN
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 174000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES
DENAIN
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 67000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES
DENAIN
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 78000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES
DENAIN
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 94000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition LILLE
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 94000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition LILLE
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 197000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition LILLE
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 409000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition LILLE
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 135000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition LILLE
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 146000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition LILLE
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 185000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition LILLE
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 192000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition LILLE
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 174000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition LILLE
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 67000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
17/07/2013
|
JAL
|
Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
|
|
|
Voix du Nord (La)/édition LILLE
Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 78000 €
Date d’effet : 01/07/2013
|
|
29/06/2013
|
JAL
|
Modification of the share capital
|
|
|
|
|
Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord
Date de décision : 28/06/2013
La société : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, TSM, 330 RUE
CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS a subi une augmentation de
son capital social désormais de 1 785 526 €
Date d'effet : 28/06/2013
|
|
10/12/2012
|
Bodacc C
|
Comptes annuels et rapports
|
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
ROUBAIX-TOURCOING
6975 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société
anonyme. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires
: Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011.
|
|
28/09/2012
|
Bodacc B
|
Modification et mutation diverse
|
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
ROUBAIX-TOURCOING
647 - 470 500 943 RCS Roubaix / Tourcoing. TAPIS SAINT
MACLOU. Forme : Société anonyme. Sigle : T S M. Administration
: Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET
BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Société d'Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes, nomination du Commissaire aux comptes
titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant
partant : Darrousez, Jean-François, nomination du Commissaire aux
comptes suppléant : BEAS. Capital : 1588416 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.
|
|
15/02/2012
|
Bodacc B
|
Modification et mutation diverse
|
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
ROUBAIX-TOURCOING
2469 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU.
Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle
: T S M. Administration : Président du conseil
d'administration : RIBAULT Christophe Vice-président : JOLIVET Yvon
Directeur général : BLANC Philippe Administrateur : THOMAS Guy
Administrateur : RIBAULT Christophe Administrateur : T.S.2.M.,
représenté par MME MULLIEZ Sybille Administrateur : TAPIMA, représenté
par M LECLERCQ Bertrand Administrateur : DELOZANNE Marc Administrateur
: JOLIVET Yvon Commissaire aux comptes titulaire : CABINET
BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : BMD
Associés Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit Commissaire
aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1588416
EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous textiles et
plus particulièrement de tapis. L'organisation de formation en qualité
de prestataire de la formation professionnelle continue. Adresse de
l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Augmentation de capital. Date de commencement
de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 24/01/2012.
|
|
04/02/2012
|
JAL
|
Modification of the share capital
|
|
|
|
|
Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord
Date de décision : 24/01/2012
La société : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, TSM, 330 RUE
CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS a subi une augmentation de
son capital social désormais de 1 588 416 €
Date d'effet : 24/01/2012
|
|
25/10/2011
|
Bodacc C
|
Comptes annuels et rapports
|
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
ROUBAIX-TOURCOING
9329 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société
anonyme à conseil d'administration. Adresse : 330 rue Carnot
59150 Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et rapports de
l'exercice clos le : 31/12/2010.
|
|
20/09/2011
|
Bodacc B
|
Modification et mutation diverse
|
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
ROUBAIX-TOURCOING
1168 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU.
Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle
: T S M. Administration : Président du conseil
d'administration : RIBAULT Christophe Vice-président : JOLIVET Yvon
Directeur général : BLANC Philippe Administrateur : THOMAS Guy
Administrateur : RIBAULT Christophe Administrateur : T.S.2.M.,
représenté par MME MULLIEZ Sybille Administrateur : TAPIMA, représenté
par M LECLERCQ Bertrand Administrateur : DELOZANNE Marc Administrateur
: JOLIVET Yvon Commissaire aux comptes titulaire : CABINET
BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : BMD
Associés Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit Commissaire
aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1363786
EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous textiles et
plus particulièrement de tapis. L'organisation de formation en qualité
de prestataire de la formation professionnelle continue. Adresse de
l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Départ d'un administrateur. Date de
commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 04/03/2011.
|
|
10/09/2011
|
JAL
|
Resignation / Revocation of the social representative
|
|
|
|
|
Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord
Date de décision : 15/04/2011
La société 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, TSM, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Fait l'objet du départ de Non renseignée SAS SOCIETE MOUVALLOISE
DE CONSE
Date d'effet : 04/03/2011
|
|
09/03/2011
|
Bodacc B
|
Modification et mutation diverse
|
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
ROUBAIX-TOURCOING
1457 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU.
Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle
: T S M. Administration : Président du conseil
d'administration : RIBAULT Christophe Vice-président : JOLIVET Yvon
Directeur général : BLANC Philippe Administrateur : THOMAS Guy
Administrateur : SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL, représenté par M
GASPARD Georges Administrateur : RIBAULT Christophe Administrateur :
T.S.2.M., représenté par MME MULLIEZ Sybille Administrateur : TAPIMA,
représenté par M LECLERCQ Bertrand Administrateur : DELOZANNE Marc
Administrateur : JOLIVET Yvon Commissaire aux comptes titulaire :
CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire
: BMD Associés Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit
Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital
: 1363786 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous
textiles et plus particulièrement de tapis. L'organisation de formation
en qualité de prestataire de la formation professionnelle continue. Adresse
de l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Changement d'administrateur Changement de
directeur général. Date de commencement de l’activité : 01/10/1969.
Date d’effet : 01/01/2011.
|
|
19/02/2011
|
JAL
|
Appointment of the social representative
|
|
|
|
|
Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord
Société faisant l'objet d'une nomination : 470500943 - TAPIS
SAINT MACLOU, TSM, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Nominé : Monsieur Yvon JOLIVET, 22 Rue du Quai, LILLE
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Monsieur Philippe BLANC, 49 Rue Auguste Lançon, PARIS
En la fonction de : Directeur général
Date d'effet : 21/01/2011
|
|
19/02/2011
|
JAL
|
Resignation / Revocation of the social representative
|
|
|
|
|
Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord
Date de décision : 21/01/2011
La société 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, TSM, 330 RUE CARNOT,
BP 149, 59150 WATTRELOS
Fait l'objet du départ de Date d'effet : 21/01/2011
|
|
26/01/2011
|
Bodacc B
|
Modification et mutation diverse
|
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
ROUBAIX-TOURCOING
2290 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU.
Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle
: T S M. Administration : Président du conseil
d'administration : RIBAULT Christophe Directeur général : FAUVET
Vincent Administrateur : THOMAS Guy Administrateur : SOCIETE
MOUVALLOISE DE CONSEIL, représenté par M GASPARD Georges Administrateur
: RIBAULT Christophe Administrateur : T.S.2.M., représenté par MME
MULLIEZ Sybille Administrateur : TAPIMA, représenté par MME MULLIEZ
Muriel Administrateur : MULLIEZ Fanny Administrateur : DELOZANNE Marc
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET
ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés Commissaire
aux comptes suppléant : DE REU Benoit Commissaire aux comptes suppléant
: DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1363786 EUR. Activité : L'industrie
et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis.
L'organisation de formation en qualité de prestataire de la formation
professionnelle continue. Adresse de l’établissement principal : 330
rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Changement d'administrateur. Date de
commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 24/06/2010.
|
|
17/12/2010
|
Bodacc B
|
Modification et mutation diverse
|
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
ROUBAIX-TOURCOING
754 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU. Forme
: Société anonyme à conseil d'administration. Sigle : T S M.
Administration : Président du conseil d'administration : RIBAULT
Christophe Directeur général : FAUVET Vincent Administrateur : THOMAS
Guy Administrateur : SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL, représenté par M
GASPARD Georges Administrateur : RIBAULT Christophe Administrateur :
CIMOFLU, représenté par M MULLIEZ Thierry Administrateur : T.S.2.M.,
représenté par MME MULLIEZ Sybille Administrateur : TAPIMA, représenté
par MME MULLIEZ Muriel Administrateur : MULLIEZ Fanny Commissaire aux
comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Commissaire
aux comptes titulaire : BMD Associés Commissaire aux comptes suppléant
: DE REU Benoit Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ
Jean-François. Capital : 1363786 EUR. Activité : L'industrie
et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis.
L'organisation de formation en qualité de prestataire de la formation
professionnelle continue. Adresse de l’établissement principal : 330
rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Changement de l'objet et de l'activité. Date
de commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 01/12/2010.
|
|
12/10/2010
|
Bodacc C
|
Comptes annuels et rapports
|
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
ROUBAIX-TOURCOING
7407 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société
anonyme à conseil d'administration. Adresse : 330 rue Carnot
59150 Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et rapports de
l'exercice clos le : 31/12/2009.
|
|
30/12/2009
|
Bodacc C
|
Comptes annuels et rapports
|
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
ROUBAIX-TOURCOING
7741 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société
anonyme à conseil d'administration. Adresse : 330 rue Carnot 59150
Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et rapports de
l'exercice clos le : 31/12/2008.
|
|
25/06/2009
|
Bodacc B
|
Modification et mutation diverse
|
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
ROUBAIX-TOURCOING
1461 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU.
Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle
: T S M. Administration : Président du conseil
d'administration : RIBAULT Christophe. Directeur général : FAUVET
Vincent. Administrateur : THOMAS Guy. Administrateur : SOCIETE MOUVALLOISE
DE CONSEIL, représenté par M GASPARD Georges. Administrateur : RIBAULT
Christophe. Administrateur : CIMOFLU, représenté par M MULLIEZ Thierry.
Administrateur : T.S.2.M., représenté par MME MULLIEZ Sybille.
Administrateur : TAPIMA, représenté par MME MULLIEZ Muriel.
Administrateur : MULLIEZ Fanny. Commissaire aux comptes titulaire :
CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes
titulaire : BMD Associés. Commissaire aux comptes suppléant : DE REU
Benoit. Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital
: 1363786 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous
textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse de
l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Transformation en société anonyme à conseil
d'administration. Date de commencement de l’activité : 01/10/1969.
Date d’effet : 12/05/2009.
|
|
24/04/2009
|
Bodacc C
|
Comptes annuels et rapports
|
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
ROUBAIX-TOURCOING
7259 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société
anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse : 330
rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et
rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.
|
|
12/08/2008
|
Bodacc B
|
Modification et mutation diverse
|
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
ROUBAIX-TOURCOING
1423 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU.
Forme : Société anonyme à directoire. Sigle : T S M. Administration
: Président du directoire : FAUVET VincentMembre du directoire :
FAUVET Vincent. Membre du directoire : CAPELIEZ Laurent. Président du
conseil de surveillance : RIBAULT Christophe. Membre du conseil de
surveillance : THOMAS Guy. Membre du conseil de surveillance :
T.S.2.M., représenté par MME MULLIEZ Sybille. Membre du conseil de
surveillance : TAPIMA, représenté par M MULLIEZ Yann Guy. Membre du
conseil de surveillance : SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL, représenté
par M GASPARD Georges. Membre du conseil de surveillance : RIBAULT
Christophe. Membre du conseil de surveillance : CIMOFLU, représenté par
M MULLIEZ Thierry. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET
BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes titulaire : BMD
Associés. Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit.
Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital
: 1363786 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous
textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse de
l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Changement de membres du directoire. Date de
commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 13/06/2008.
|
|
15/06/2008
|
Bodacc B
|
Modification et mutation diverse
|
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
ROUBAIX-TOURCOING
1046 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU.
Forme : Société anonyme à directoire. Sigle : T S M. Administration
: Président du directoire : FAUVET VincentMembre du directoire :
BASEDEN Eric. Membre du directoire : FAUVET Vincent. Membre du
directoire : CAPELIEZ Laurent. Président du conseil de surveillance :
RIBAULT Christophe. Membre du conseil de surveillance : THOMAS Guy.
Membre du conseil de surveillance : T.S.2.M.. Membre du conseil de
surveillance : TAPIMA. Membre du conseil de surveillance : SOCIETE
MOUVALLOISE DE CONSEIL. Membre du conseil de surveillance : RIBAULT
Christophe. Membre du conseil de surveillance : CIMOFLU. Commissaire
aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES.
Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés. Commissaire aux
comptes suppléant : DE REU Benoit. Commissaire aux comptes suppléant :
DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1363786 EUR. Activité : L'industrie
et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse
de l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Changement membres conseil surveillance Changement
de président du conseil de surveillance. Date de commencement de
l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 22/04/2008.
|
|
11/06/2008
|
Bodacc A
|
Immatriculation
|
|
|
|
|
86 - VIENNE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
2090 - 502 082 324 RCS Poitiers. FUTUROSOL. Forme : S.A.R.L.
à associé unique. Administration : Gérant : RICHET Olivier
François Hervé. Capital : 1000 EUR. Adresse : 10 rue du
Commerce, 86360 Chasseneuil-du-Poitou.
Etablissement : Siège social et établissement principal. Activité
: Vente et pose de revêtements de sols en tant que mandataire de la
société Tapis Saint Maclou. Adresse : 10 rue du Commerce, 86360
Chasseneuil-du-Poitou.
Précédent exploitant : TAPIS SAINT MACLOU. 470 500 943
RCS Poitiers.
A dater du : 29/01/2008. Date de commencement de l’activité :
23/01/2008. Descriptif : Fonds principal reçu en gérance
mandat de la société TAPIS SAINT MACLOU. Commentaires : Autre
immatriculation personne morale. Date d’effet : 23/01/2008.
|
|
08/06/2008
|
Bodacc C
|
Comptes annuels et rapports
|
|
|
|
|
59 - NORD
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
ROUBAIX-TOURCOING
3971 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société
anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse : 330
rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et
rapports de l'exercice clos le : 31/12/2006.
|
|
24/08/2007
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
659 - Ancienne situation du siège social : RCS Roubaix-Tourcoing
B 470 500 943. RC 70-B 94. TAPIS SAINT MACLOU. Sigle : TSM. Forme :
S.A. à directoire. Capital : 1 358 286 euros. Adresse : 330 rue Carnot,
59150 Nouvelle situation du siège social - Capital : 1 363 786 euros.
Etablissement principal - Activité : industrie, commerce de tout
textile et plus particulièrement, de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150
Date d'effet : 30 juin 2007.
|
|
05/05/2007
|
Bodacc C
|
Avis de dépôt des comptes
|
|
|
|
|
7396 - RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943. RC 70-B 94. TAPIS
SAINT MACLOU. Sigle: T S M Forme: S.A. à directoire. . Adresse du siège
social: 330, rue Carnot,59150 Wattrelos. Comptes annuels et rapports de
l'exercice clos le: 31 décembre 2005.
|
|
20/10/2006
|
Bodacc A
|
Vente et cession
|
|
|
|
|
0223 - RCS B 470 500 943. RC AP-B 40019. TAPIS SAINT MACLOU.
Forme : S.A. à directoire. Adresse du siège social : 330 rue Carnot,
59150 Wattrelos. Etablissement secondaire - Activité : achat, vente de
tapis, de revêtements de sols et muraux. Adresse : 8 boulevard
Voltaire, 19100 Brive. Etablissement secondaire acquis par achat au
prix stipulé de 324 000 euros. Date d'effet : 1er septembre 2006.
Précédent propriétaire : S.A.R.L. GRAU. RCS 340 898 444. Publication
légale : La Montagne du 15 septembre 2006. Oppositions : Me Masmonteil,
28 boulevard Jules-Ferry, 19100 Brive, pour la validité et la
correspondance.
|
|
27/09/2006
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
0985 - RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943. RC 70-B 94. TAPIS
SAINT MACLOU. Sigle : TSM. Forme : S.A. à directoire. Capital : 1 358
286 euros. Adresse du siège social : 330 rue Carnot,, 59150
Administration : président du directoire : FAUVET (Vincent). Président
du conseil de surveillance : MULLIEZ (Gonzague). Vice-président du
conseil de surveillance : LECLERCQ (Olivier). Membres du conseil de
surveillance : THOMAS (Guy) T.S.2.M. TAPIMA SOCIETE MOUVALLOISE DE
CONSEIL CIMOFLU LECLERCQ (Olivier). Commissaires aux comptes titulaires
: CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES BMD ASSOCIES. Commissaires aux comptes
suppléants : DE REU (Benoît) DARROUSEZ (Jean-François). Ancienne
administration : ancien gérant : STE T.S.2.M. Anciens associés en
commandite : STE T.S.2.M. MULLIEZ (Gonzague). Ancien gérant : MULLIEZ
(Gonzague). Anciens membres du conseil de surveillance : S.C. GOMA GRAS
(Emmanuel). Ancien président du conseil de surveillance : GRAS
(Emmanuel). Anciens membres du conseil de surveillance : STE TAPIMA STE
SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL. Etablissement principal - Activité :
industrie, commerce de tout textile et plus particulièrement, de tapis.
Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Commentaires : modification survenue
sur la forme juridique. Ancienne : S.C.A. Date d'effet : 13 juin 2006.
|
|
16/11/2005
|
Bodacc A
|
Vente et cession
|
|
|
|
|
199 - RCS B 470 500 943. RC 05-B 258. TAPIS SAINT MACLOU. Sigle
: TSM. Forme : société en commandite par action. Adresse du siège
social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Etablissement secondaire -
Activité : vente, pose de moquettes, de tapis, de revêtements
plastiques, de tissu et d'articles d'ameublement. Adresse : 44 rue de
la Grassinais, 35400 Saint-Malo. Etablissement secondaire acquis par
achat au prix stipulé de 175 001 euros. Date de début d'activité : 19
septembre 2005. Précédent propriétaire : SOCIETE CHRISTIAN FOUGERAY
& Cie S.A. RCS B 896 780 079. Publication légale : Le Paysan breton
du 30 septembre 2005. Oppositions : Me Lebranchu, notaire, 61 rue
Georges-Clemenceau, B.P. 33, 35403 Saint-Malo Cedex.
|
|
16/11/2005
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
684 - RCS Saint-Malo B 483 917 027. RC 05-B 287. DYKE. Forme :
S.A.R.L. à associé unique. Capital : 1 500 euros. Adresse du siège
social : 44 rue de la Grassinais, 35400 Saint-Malo. Commentaires : le
fonds fait l'objet d'une gérance par mandat et non d'une création comme
précédemment déclaré. Modification de la date de début d'activité.
Ancienne : 15 septembre 2005. Fonds reçu en location-gérance. Date de
début d'activité : 19 septembre 2005. Propriétaire : SOCIETE TAPIS
SAINT MACLOU. RCS B 470 500 943.
|
|
05/01/2005
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
980 - Ancienne situation du siège social : RCS Roubaix-Tourcoing
B 470 500 943. RC 70-B 94. TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : TSM. Forme :
S.C.A. Capital : 1 035 346,83 euros. Adresse : 330 rue Carnot, 59150
Nouvelle situation du siège social - Capital : 1 358 286 euros.
Etablissement principal - Activité : industrie, commerce de tous
textiles et plus particulièrement, de tapis. Adresse : 330 rue Carnot,
59150 Date d'effet : 7 décembre 2004.
|
|
07/08/2003
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
RCS Roubaix-Tourcoing B 470500943 RC 70- B 94 TAPIS
SAINT-MACLOU. Sigle : TSM. Forme : S.C.A. Capital : 1 035 346 euros.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Administration : président du conseil de surveillance : GRAS
(Emmanuel). Membres du conseil de surveillance : STE CIVILE GOMA GRAS (
Emmanuel) TAPIMA STE MOUVALLOISE DE CONSEIL. Gérants : T.S. 2M MULLIEZ
( Gonzague). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET BRACQ ET
ASSOCIES STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
MOLARD (Jean- Paul). Commissaires aux comptes suppléants : DESURMONT
(Jean, Marie) BMD ASSOCIES. Associés en commandite : T.S. 2M MULLIEZ
(Gonzague). Ancien président du conseil de surveillance : BASEDEN
(Eric). Anciens membres du conseil de surveillance : BASEDEN (Eric)
LECLERCQ (Bertrand) THOMAS (Guy) Etablissement principal: Activité :
industrie et commerce de tous textiles et plus particulièrement de
tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Date d'effet : 11
juin 2003.
|
|
17/12/2002
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
RCS Roubaix-Tourcoing B 470500943 RC 70- B 94 TAPIS
SAINT-MACLOU. Sigle : TSM. Forme : S.C.A. Capital : 1 035 346 euros.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Administration : président du conseil de surveillance : BASEDEN (Eric).
Membres du conseil de surveillance : LECLERCQ (Bertrand) THOMAS (Guy)
BASEDEN (Eric). Gérants : MULLIEZ (Gonzague) TS 2M. Commissaires aux
comptes titulaires : CABINET BRACQ ET ASSOCIES STE D' EXPERTISE
COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MOLARD (Jean-Paul).
Commissaires aux comptes suppléants : DESURMONT (Jean, Marie) B.M.D.
ASSOCIES. Associés en commandite : MULLIEZ (Gonzague) TS 2M. Ancien
président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann, Guy)
Etablissement principal: Activité : industrie et commerce de tous
textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse : 330 rue Carnot,
59150 Wattrelos. Date d'effet : 17 juin 2002.
|
|
26/12/2001
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
RCS Roubaix-Tourcoing B 470500943 RC 70- B 94 TAPIS SAINT-MACLOU.
Sigle : T.S.M. Forme : S.C.A. Capital : 6 791 430 F. Adresse du siège
social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Administration : président du
conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann, Guy). Membres du conseil de
surveillance : LECLERCQ (Bertrand) THOMAS (Guy). Gérants : MULLIEZ (
Gonzague) TS 2M. Commissaires aux comptes titulaires : CABINET BRACQ ET
ASSOCIES STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
MOLARD ( Jean-Paul). Commissaires aux comptes suppléants : DESURMONT
(Jean, Marie) B.M.D. ASSOCIES. Associés en commandite MULLIEZ
(Gonzague) TS 2M. Ancien commissaire aux comptes titulaire :
VANDENBURIE (Pierre). Ancien commissaire aux comptes suppléant : MOLARD
(Jean-Paul) Etablissement principal: Activité : industrie, vente d'
articles de tout textile et plus particulièrement de tapis. Adresse :
330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Date d'effet : 29 juin 2001.
|
|
21/01/2001
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
RCS Roubaix-Tourcoing B 470500943 RC 70- B 94 TAPIS
SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.C.A. Capital : 6 791 430 F.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Administration : président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann,
Guy). Membres du conseil de surveillance : LECLERCQ (Bertrand) THOMAS
(Guy). Gérants : MULLIEZ ( Gonzague) T.S. 2M. Commissaires aux comptes
titulaires : VANDENBURIE ( Pierre) CABINET BRACQ ET ASSOCIES STE
D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES. Commissaires aux
comptes suppléants : DESURMONT ( Jean, Marie) MOLARD (Jean-Paul).
Ancien commissaire aux comptes suppléant : BRACQ (Léon). Ancien gérant
et associé en commandite : S.A.R.L. T.S. 2M Etablissement principal:
Activité : industrie et commerce de tout textile plus particulièrement,
de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Date d'effet : 30
juin 2000.
|
|
24/12/2000
|
Bodacc A
|
Création d'établissement
|
|
|
|
|
RCS B 470500943 RC AP-B 573 SAINT- MACLOU. Forme : société en
commandité par actions. Capital : 6 696 030 F. Adresse du siège social
: 330 rue Carnot, 59391 Wattrelos Etablissement principal: Activité :
vente au détail de fournitures, de mobilier et de matériel de bureau de
dessin. Adresse : 131 avenue Aristide-Briand, 92120 Montrouge
Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 385 000 F.
Date d'effet : 27 octobre 2000. Précédent propriétaire : SOCIETE
MULTIGRAPHIC. RCS B 632041596 Publication légale: Les Petites affiches
du 5 décembre 2000. Oppositions : M e Riffier, 205 avenue
Georges-Clemenceau, 92000 Nanterre.
|
|
30/09/1999
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
o. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC 70-B 94 TAPIS
SAINT-MACLOU. Sigle : T. S.M. Forme : S.A.S. Capital : 6 791 430 F.
Adresse du siège social : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos.
Administration : président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann,
Guy) Membres du conseil de surveillance : LECLERCQ (Bertrand) THOMAS
(Guy). Ancien membre du conseil de surveillance : DE BUCK (Jacques).
Gérant : MULLIEZ (Gonzague) Etablissement principal: Activité :
industrie et commerce de tous textiles et plus particulièrement de
tapis. Adresse : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos. Date d'effet : 30
juin 1999 Date de début d'activité: 1er octobre 1969.
|
|
30/09/1999
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
o. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC 70-B 94 TAPIS
SAINT-MACLOU. Sigle : T. S.M. Forme : Société en commandite par
actions. Capital : 6 791 430 F. Adresse du siège social : 330, rue
Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : ancien capital : 6 743 580 F
Etablissement principal: Activité : industrie et commerce de tous
textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse : 330, rue Carnot
59150 Wattrelos. Date d'effet : 2 septembre 1999 Date de début
d'activité: 1er octobre 1969.
|
|
29/09/1999
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
RCS Roubaix-Tourcoing B 470500943 RC 70- B 94 TAPIS
SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.-M. Forme : S.C.A. Capital : 6 743 580 F.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Administration : président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann,
Guy). Membres du conseil de surveillance : DE BUCK (Jacques) LECLERCQ
(Bertrand). Gérant : MULLIEZ ( Gonzague) Etablissement principal:
Activité : industrie, commerce de tous textiles et plus
particulièrement de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : apport partiel d'actif à SAINT-MACLOU PRODUCTION S.A.R.
L. Date d'effet : 30 juin 1999.
|
|
12/06/1999
|
Bodacc A
|
Création d'établissement
|
|
|
|
|
RCS Roubaix-Tourcoing 470500943 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle :
T.S.M. Forme : S.C.A. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59391
Wattrelos Cedex ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Montauban 99-B 140. A dater
du : 20 mai 1999. Activité : vente de revetements de sols, de
moquettes, de tapis et de tissus collés. Adresse : 700 avenue de Paris,
82000 Montauban Etablissement secondaire acquis par achat au prix
stipulé de 150 000 F Date de début d'activité: 1er avril 1999.
Précédent propriétaire : indivision VESSIO Germaine. RCS 780142824 RC
73-A 219. Précédent exploitant : S.A.R.L. VESSIO. RCS 349086272 RC 89-B
7 Publication légale: Le Journal du Palais de Tarn-et-Garonne du 29
avril 1999. Oppositions : Alizé Conseil, avocat, 42 avenue Gambetta,
B.P. 443, 82004 Montauban Cedex.
|
|
27/10/1998
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
Propriétaire. RCS Dunkerque A 309 666 709 RC 64-A 33 KRABANSKY
Raphael, Noel Français. Activité : vente à titre ambulant de
boulangerie, de patisserie, de pain et de confiserie. Adresse : centre
commercial 2 59760 Grande-Synthe Fonds donné en location-gérance.
Commentaires : fin de la location- gérance consentie à la S.A.
BOULANGERIE PATISSERIE KRABANSKY, à compter du 31 juillet 1998. Date
d'effet : 1er aout 1998 Bénéficiaire: E.U.R.L. SAINT- JACQUES.
|
|
03/07/1998
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
RCS o. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC RC 70-B 94 TAPIS
SAINT MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : Société en commandite par actions.
Capital : 6 743 580 F. Adresse du siège social : 330, rue Carnot 59150
Wattrelos. Commentaires : ancien capital : 6 696 030 F Etablissement principal:
Activité : industrie et commerce de tous textiles plus particulièrement
de tapis. Adresse : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos Date de début
d'activité: 1er octobre 1969. Date d'effet : 20 janvier 1998.
|
|
30/01/1998
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
RCS o. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC RC 70-B 94 TAPIS
SAINT MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : Société en commandite par actions.
Capital : 6 696 030 F. Adresse du siège social : 330, rue Carnot 59150
Wattrelos. Administration : président du conseil de surveillance :
MULLIEZ (Yann, Guy) Membres du conseil de surveillance : DE BUCK
(Jacques) LECLERCQ (Bertrand). Gérant : MULLIEZ ( Gonzague). Ancien
membre du conseil de surveillance : LECONTE (Sandrine) Etablissement
principal: Activité : industrie et commerce de tous textiles plus
particulièrement de tapis. Adresse : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos
Date de début d'activité: 1er octobre 1969. Date d'effet : 31 mai 1997.
|
|
01/06/1997
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 470
500 943 RC 70-B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.A. à
conseil d'administration. Capital : 6 691 680 F. Adresse : 330 rue
Carnot 59150 Wattrelos. Administration : P.-D.G. : MULLIEZ (Gonzague).
Administrateurs : MULLIEZ (Yann, Guy) DE BUCK (Jacques) LECLERCQ
(Bertrand) GUERMONPREZ (Marc) Mme LECONTE, née DERVILLE (Sandrine).
Commissaires aux comptes titulaires : VANDENBURIE ( Pierre) CABINET
BRACQ ET ASSOCIES-STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX
COMPTES. Commissaires aux comptes suppléants : BRACQ (Léon) DESURMONT
(Jean, Marie). Anciens administrateurs : PLANCKE (Michel) SACCHI
(Emmanuel) Nouvelle situation du siège social. Capital : 6 749 200 F
Etablissement principal: Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Date
d'effet : 30 octobre 1995.
|
|
01/06/1997
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 470
500 943 RC 70-B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.A. à
conseil d'administration. Capital : 6 696 030 F. Adresse : 330 rue
Carnot 59150 Wattrelos. Administration : président du conseil de
surveillance : MULLIEZ (Yann, Guy). Membres du conseil de surveillance
: DE BUCK (Jacques) LECLERCQ (Bertrand) LECONTE, née DERVILLE
(Sandrine). Gérant : MULLIEZ ( Gonzague) Nouvelle situation du siège
social. Forme : société en commandite par actions Etablissement
principal: Activité : industrie et commerce de tous textiles, plus
particulièrement de tapis. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos.
Date d'effet : 1er janvier 1997.
|
|
01/06/1997
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 470
500 943 RC 70-B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.A. à
conseil d'administration. Capital : 6 749 200 F. Adresse : 330 rue
Carnot 59150 Wattrelos Nouvelle situation du siège social. Capital : 6
696 030 F Etablissement principal: Adresse : 330 rue Carnot 59150
Wattrelos. Date d'effet : 18 décembre 1995.
|
|
28/01/1996
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 470
500 943 RC 70-B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.A.
Capital : 6 727 000 F. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos.
Administration : P.-D.G. : MULLIEZ ( Gonzague). Administrateurs :
MULLIEZ ( Yann, Guy) DE BUCK (Jacques) PLANCKE (Michel) LECLERCQ
(Bertrand) GUERMONPREZ (Marc) Mme LECONTE, née DERVILLE (Sandrine)
SACCHI (Emmanuel). Commissaires aux comptes titulaires : VANDENBURIE
(Pierre) CABINET BRACQ ET ASSOCIES-STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES. Commissaires aux comptes suppléants : BRACQ
(Léon) DESURMONT (Jean, Marie). Anciens administrateurs : MULLIEZ (
Olivier) DUPREZ (Philippe) MULLIEZ ( Damien) TAPIS INVESTISSEMENT
Nouvelle situation du siège social. Capital : 6 691 680 F Etablissement
principal: Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Date d'effet : 16
novembre 1994.
|
|
18/01/1996
|
Bodacc B
|
Modifications et mutations diverses
|
|
|
|
|
RCS o. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC RC 70-B 94 TAPIS
SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.A. à conseil d' administration.
Capital : 6 727 000 F. Adresse du siège social : 330, rue Carnot 59150
Wattrelos. Administration : président-directeur général : MULLIEZ ( Gonzague)
Administrateurs : MULLIEZ ( Damien) TAPIS INVESTISSEMENT DUPREZ
(Philippe) MULLIEZ (Yann, Guy). Nouveaux administrateurs : DE BUCK (
Jacques) GUERMONPREZ (Marc) MULLIEZ (Olivier). Commissaires aux comptes
titulaires : VANDENBURIE (Pierre) CABINET BRACQ ET ASSOCIES SOCIETE D'
EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES. Commissaires aux
comptes suppléants : BRACQ (Léon) DESURMONT ( Jean-Marie) Etablissement
principal: Adresse : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos Date de début
d'activité: 1er octobre 1969. Date d'effet : 17 juin 1994.
|
|
|
|
|
|
Date
|
Description
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26/09/2013
|
Bodacc A : Sale and transfer
|
|
19/09/2013
|
Bodacc A : Sale and transfer
|
|
17/09/2013
|
Bodacc A : Sale and transfer
|
|
13/09/2013
|
Bodacc A : Sale and transfer
|
|
11/09/2013
|
Bodacc A : Sale and transfer
|
|
27/08/2013
|
Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment
of this company's creditworthiness
|
|
26/08/2013
|
Bodacc C : Deposit accounts notice
|
|
02/08/2013
|
Bodacc B: Various editing or changing
|
|
16/07/2013
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
16/07/2013
|
Capital increase
|
|
16/07/2013
|
Updated articles of association
|
|
16/07/2013
|
Amendment
|
|
10/07/2013
|
Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
03/07/2013
|
Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer
|
|
03/07/2013
|
Modification to Establishment Address or Identifier
|
|
28/06/2013
|
Other modification of Establishment
|
|
28/06/2013
|
Legal Gazette: Modification of the share capital
|
|
17/01/2013
|
Collection of preferential rights activated for this company
|
|
31/12/2012
|
New accounts available
|
|
10/12/2012
|
Bodacc C : Deposit accounts notice
|
|
28/09/2012
|
Bodacc B: Various editing or changing
|
|
13/09/2012
|
New auditor
|
|
13/09/2012
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
13/09/2012
|
Amendment
|
|
15/02/2012
|
Bodacc B: Various editing or changing
|
|
03/02/2012
|
Amendment
|
|
03/02/2012
|
Minutes of Board meeting
|
|
03/02/2012
|
Updated articles of association
|
|
03/02/2012
|
Capital increase
|
|
24/01/2012
|
Legal Gazette: Modification of the share capital
|
|
24/01/2012
|
Other modification of Establishment
|
|
25/10/2011
|
Bodacc C : Deposit accounts notice
|
|
19/10/2011
|
Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment
of this company's creditworthiness
|
|
20/09/2011
|
Bodacc B: Various editing or changing
|
|
10/09/2011
|
Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social
representative
|
|
09/09/2011
|
Amendment
|
|
09/09/2011
|
Changes to the Board of Directors
|
|
09/09/2011
|
Minutes of Board meeting
|
|
09/03/2011
|
Bodacc B: Various editing or changing
|
|
04/03/2011
|
New ultimate parent
|
|
28/02/2011
|
Amendment
|
|
28/02/2011
|
Acte modificatif
|
|
28/02/2011
|
Minutes of Board meeting
|
|
28/02/2011
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
28/02/2011
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
28/02/2011
|
Appointment/resignation of company officers
|
|
28/02/2011
|
Changes to the Board of Directors
|
|
28/02/2011
|
Modification du Conseil d'Administration
|
|
19/02/2011
|
Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social
representative
|
|
26/01/2011
|
Bodacc B: Various editing or changing
|
|
21/01/2011
|
Legal Gazette: Appointment of the social representative
|
|
13/01/2011
|
PV d'Assemblée
|
|
13/01/2011
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
13/01/2011
|
Modification du Conseil d'Administration
|
|
13/01/2011
|
Changes to the Board of Directors
|
|
31/12/2010
|
New accounts available
|
|
17/12/2010
|
Bodacc B: Various editing or changing
|
|
06/12/2010
|
PV d'Assemblée
|
|
06/12/2010
|
Statuts mis à jour
|
|
06/12/2010
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
06/12/2010
|
Modification de l'objet social
|
|
06/12/2010
|
Change to corporate purpose
|
|
06/12/2010
|
Updated articles of association
|
|
30/11/2010
|
Update of Company Activity
|
|
30/11/2010
|
Modification of Company Activity
|
|
12/10/2010
|
Bodacc C : Deposit accounts notice
|
|
13/08/2010
|
New subsidiarie(s) detected
|
|
13/08/2010
|
New ultimate parent
|
|
13/08/2010
|
New parent detected
|
|
30/03/2010
|
Payment incident closed
|
|
26/01/2010
|
Payment incident detected
|
|
31/12/2009
|
New accounts available
|
|
30/12/2009
|
Bodacc C : Deposit accounts notice
|
|
25/06/2009
|
Bodacc B: Various editing or changing
|
|
16/06/2009
|
Statuts mis à jour
|
|
16/06/2009
|
Updated articles of association
|
|
16/06/2009
|
Acte modificatif
|
|
16/06/2009
|
Minutes of Board meeting
|
|
16/06/2009
|
PV du Conseil d'Administration
|
|
16/06/2009
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
16/06/2009
|
PV d'Assemblée
|
|
16/06/2009
|
Appointment/resignation of company officers
|
|
16/06/2009
|
Private document
|
|
16/06/2009
|
Modification du Conseil d'Administration
|
|
16/06/2009
|
Changes to the Board of Directors
|
|
16/06/2009
|
Changement de Président (PDG, PCA)
|
|
16/06/2009
|
New chairman (CEO, CoB)
|
|
15/05/2009
|
Payment incident closed
|
|
12/05/2009
|
Other modification of Establishment (error correction)
|
|
12/05/2009
|
Modification to Establishment Address or Identifier
|
|
12/05/2009
|
Update of Company Legal Form
|
|
24/04/2009
|
Bodacc C : Deposit accounts notice
|
|
25/02/2009
|
Payment incident detected
|
|
31/12/2008
|
New accounts available
|
|
01/12/2008
|
Formation of Establishment
|
|
12/08/2008
|
Bodacc B: Various editing or changing
|
|
12/08/2008
|
New Bodacc B ads detected
|
|
01/08/2008
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
01/08/2008
|
Acte modificatif
|
|
01/08/2008
|
PV d'Assemblée
|
|
01/08/2008
|
Appointment/resignation of company officers
|
|
01/08/2008
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
01/08/2008
|
Private document
|
|
15/06/2008
|
New Bodacc B ads detected
|
|
15/06/2008
|
Bodacc B: Various editing or changing
|
|
11/06/2008
|
Bodacc A : Registration
|
|
11/06/2008
|
New Bodacc A ads detected
|
|
08/06/2008
|
Bodacc C : Deposit accounts notice
|
|
02/06/2008
|
New chairman (CEO, CoB)
|
|
02/06/2008
|
Private document
|
|
02/06/2008
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
02/06/2008
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
02/06/2008
|
Capital increase
|
|
02/06/2008
|
PV d'Assemblée
|
|
02/06/2008
|
Changement de Président (PDG, PCA)
|
|
02/06/2008
|
Appointment/resignation of company officers
|
|
02/06/2008
|
Acte modificatif
|
|
18/04/2008
|
Collection of preferential rights activated for this company
|
|
31/12/2007
|
New accounts available
|
|
20/07/2007
|
Acte modificatif
|
|
20/07/2007
|
Capital increase
|
|
20/07/2007
|
Statuts mis à jour
|
|
20/07/2007
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
20/07/2007
|
Updated articles of association
|
|
20/07/2007
|
Augmentation de Capital
|
|
20/07/2007
|
Private document
|
|
20/07/2007
|
PV d'Assemblée
|
|
30/06/2007
|
Other modification of Establishment
|
|
31/12/2006
|
New accounts available
|
|
12/09/2006
|
Audit or Management Report
|
|
12/09/2006
|
Acte modificatif
|
|
12/09/2006
|
New legal form – no new category
|
|
12/09/2006
|
Updated articles of association
|
|
12/09/2006
|
Appointment/resignation of company officers
|
|
12/09/2006
|
PV d'Assemblée
|
|
12/09/2006
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
12/09/2006
|
Statuts mis à jour
|
|
12/09/2006
|
Rapport des Commissaires ou du Gérant
|
|
12/09/2006
|
Private document
|
|
31/12/2005
|
New accounts available
|
|
20/12/2004
|
Statuts mis à jour
|
|
20/12/2004
|
Acte sous seing privé
|
|
20/12/2004
|
Capital increase
|
|
20/12/2004
|
PV d'Assemblée
|
|
20/12/2004
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
20/12/2004
|
Private document
|
|
20/12/2004
|
Updated articles of association
|
|
20/12/2004
|
Augmentation de Capital
|
|
21/06/2004
|
Updated articles of association
|
|
21/06/2004
|
Statuts mis à jour
|
|
21/06/2004
|
PV d'Assemblée
|
|
21/06/2004
|
Private document
|
|
21/06/2004
|
Acte sous seing privé
|
|
21/06/2004
|
Minutes of general meeting of shareholders
|
|
28/07/2003
|
Acte modificatif
|
|
28/07/2003
|
Changement de Président (PDG, PCA)
|
|
28/07/2003
|
PV d'Assemblée
|
|
28/07/2003
|
Acte sous seing privé
|
|
28/07/2003
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
28/07/2003
|
Modification du Conseil d'Administration
|
|
04/12/2002
|
Acte modificatif
|
|
04/12/2002
|
Changement de Président (PDG, PCA)
|
|
04/12/2002
|
PV d'Assemblée
|
|
04/12/2002
|
Acte sous seing privé
|
|
04/12/2002
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
04/12/2002
|
Modification du Conseil d'Administration
|
|
23/09/2002
|
Acte sous seing privé
|
|
23/09/2002
|
PV d'Assemblée
|
|
23/09/2002
|
Statuts mis à jour
|
|
12/12/2001
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
12/12/2001
|
PV d'Assemblée
|
|
12/12/2001
|
Changement de Commissaire aux Comptes
|
|
12/12/2001
|
Acte sous seing privé
|
|
05/01/2001
|
Statuts mis à jour
|
|
05/01/2001
|
PV d'Assemblée
|
|
05/01/2001
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
05/01/2001
|
Changement de Commissaire aux Comptes
|
|
05/01/2001
|
Acte sous seing privé
|
|
05/01/2001
|
Changement de Gérant
|
|
16/09/1999
|
PV d'Assemblée
|
|
16/09/1999
|
Acte modificatif
|
|
16/09/1999
|
Augmentation de Capital
|
|
16/09/1999
|
Acte sous seing privé
|
|
16/09/1999
|
Statuts mis à jour
|
|
15/09/1999
|
Acte sous seing privé
|
|
15/09/1999
|
PV d'Assemblée
|
|
15/09/1999
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
02/06/1999
|
Acte modificatif
|
|
02/06/1999
|
Acte sous seing privé
|
|
18/06/1998
|
Augmentation de Capital
|
|
18/06/1998
|
Acte sous seing privé
|
|
18/06/1998
|
PV d'Assemblée
|
|
18/06/1998
|
Statuts mis à jour
|
|
18/06/1998
|
Acte modificatif
|
|
13/01/1998
|
Acte sous seing privé
|
|
13/01/1998
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
13/01/1998
|
PV d'Assemblée
|
|
16/05/1997
|
PV du Conseil d'Administration
|
|
16/05/1997
|
PV d'Assemblée
|
|
16/05/1997
|
Acte modificatif
|
|
16/05/1997
|
Changement de Forme Juridique sans changement de catégorie
|
|
16/05/1997
|
Réduction de Capital
|
|
16/05/1997
|
Changement de Président (PDG, PCA)
|
|
16/05/1997
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
16/05/1997
|
Statuts mis à jour
|
|
16/05/1997
|
Modification du Conseil d'Administration
|
|
16/05/1997
|
Acte sous seing privé
|
|
16/05/1997
|
Augmentation de Capital
|
|
12/01/1996
|
Modification du Conseil d'Administration
|
|
12/01/1996
|
Réduction de Capital
|
|
12/01/1996
|
Acte modificatif
|
|
12/01/1996
|
Statuts mis à jour
|
|
12/01/1996
|
PV du Conseil d'Administration
|
|
12/01/1996
|
PV d'Assemblée
|
|
12/01/1996
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
29/12/1995
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
29/12/1995
|
Modification du Conseil d'Administration
|
|
29/12/1995
|
PV d'Assemblée
|
|
23/12/1993
|
Déclaration de conformité
|
|
23/12/1993
|
Statuts mis à jour
|
|
23/12/1993
|
Acte modificatif
|
|
23/12/1993
|
Réduction de Capital
|
|
23/12/1993
|
PV du Conseil d'Administration
|
|
22/12/1993
|
PV du Conseil d'Administration
|
|
22/12/1993
|
Déclaration de conformité
|
|
22/12/1993
|
Statuts mis à jour
|
|
22/12/1993
|
Augmentation de Capital
|
|
22/12/1993
|
Acte modificatif
|
|
03/12/1993
|
Déclaration de conformité
|
|
03/12/1993
|
Augmentation de Capital
|
|
03/12/1993
|
PV du Conseil d'Administration
|
|
03/12/1993
|
Acte modificatif
|
|
03/12/1993
|
Statuts mis à jour
|
|
09/09/1993
|
PV d'Assemblée
|
|
09/09/1993
|
Augmentation de Capital
|
|
03/05/1993
|
Modification du Conseil d'Administration
|
|
03/05/1993
|
PV d'Assemblée
|
|
03/05/1993
|
Nomination/démission des organes de gestion
|
|
03/05/1993
|
PV du Conseil d'Administration
|
|
03/05/1993
|
Acte modificatif
|
|
11/12/1991
|
Déclaration de conformité
|
|
11/12/1991
|
PV d'Assemblée
|
|
11/12/1991
|
Augmentation de Capital
|
|
11/12/1991
|
Fusion
|
|
11/12/1991
|
Statuts mis à jour
|
|
|
|