MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

319104

Report Date :

29.04.2015

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

RHI AG

 

 

Registered Office :

Wienerbergstraße 9 A-1100 Wien

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

31.12.2014

 

 

Date of Incorporation :

1976

 

 

Legal Form :

Joint Stock Company

 

 

Line of Business :

Manufacture of refractory products.

 

 

No. of Employee :

700 (Approx.)

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory

 

 

Payment Behaviour :

No complaints

 

 

Litigation :

Clear

 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – December 31, 2014

 

Country Name

Previous Rating

(30.09.2014)

Current Rating

(31.12.2014)

Austria

A2

A2

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 

AUSTRIA ECONOMIC OVERVIEW

 

Austria, with its well-developed market economy, skilled labor force, and high standard of living, is closely tied to other EU economies, especially Germany's. Its economy features a large service sector, a sound industrial sector, and a small, but highly developed agricultural sector. Following several years of solid foreign demand for Austrian exports and record employment growth, the international financial crisis of 2008 and subsequent global economic downturn led to a sharp but brief recession. Austrian GDP contracted 3.8% in 2009 but saw positive growth of in 2010-12. Growth fell below 1% in 2013-14. Unemployment did not rise as steeply in Austria as elsewhere in Europe, partly because the government subsidized reduced working hour schemes to allow companies to retain employees. Stabilization measures, stimulus spending, and an income tax reform pushed the budget deficit to 4.5% in 2010. In March 2012, the Austrian parliament approved an austerity package consisting of a mix of expenditure cuts and new revenues that will bring public finances into balance by 2016. The deficit was steadily reduced to 1.5% of GDP in 2014 as a result of the measures. The international financial crisis of 2008 caused difficulties for Austria's largest banks whose extensive operations in central, eastern, and southeastern Europe faced large losses. The government provided bank support - including in some instances, nationalization - to support aggregate demand and stabilize the banking system. Austria's fiscal position compares favorably with other euro-zone countries, but it faces external risks, such as Austrian banks' continued exposure to Central and Eastern Europe as well as political and economic uncertainties caused by the European sovereign debt crisis. In 2011, the government attempted to pass a constitutional amendment limiting public debt to 60% of GDP by 2020, but it was unable to obtain sufficient support in parliament and instead passed the measure as a simple law.

 

Source : CIA

 

 

 

Company name and address

 

 

RHI AG

 

Wienerbergstraße 9

A-1100 Wien

 

 

Phone:

(0043) 5 0213

Fax:

(0043) 5 0213 - 6213

E-mail:

info@rhi-ag.com

Internet:

http://www.rhi-ag.com

 

 

Activities

 

ÖNACE 23200 90% Manufacture of refractory products

ÖNACE 82990 5% Other business support service activities n.e.c.

ÖNACE 64200 5% Activities of holding companies

 

 

Financial data

 

Financial details can also be entered during the period, irrespective of the balance sheet date.

 

total turnover (total sales)

2014

EUR

1.212.786.797,18

(exact)

total turnover (total sales)

2013

EUR

1.241.955.052,87

(exact)

total turnover (total sales)

2012

EUR

1.256.323.063,49

(exact)

total turnover (total sales)

2011

EUR

1.217.291.767,95

(exact)

total turnover (total sales)

2010

EUR

1.102.033.564,70

(exact)

 

turnover (sales) - group

2014

EUR

1.721.200.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2013

EUR

1.754.700.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2012

EUR

1.835.700.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2011

EUR

1.758.600.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2010

EUR

1.522.900.000,00

(exact)

 

total investments

2014

EUR

77.400.000,00

(exact)

 

total employees

2015

 

700

(approx.)

white collar workers

2015

 

700

(approx.)

 

 

General company information

 

Company name

RHI AG

Year of incorporation

1976

Type of company

Manufacturing

Legal form

joint stock company since 1979-11-16

Companies House number

FN 103123 b Wien  since 1979-12-18

Import

world-wide

2015

Export

world-wide

2015

VAT number

ATU 14187609

number - Austrian National Bank

62871

Last balance sheet:

2014

Banking connection

The Royal Bank of Scotland N.V.

BLZ 19985

main bank connection

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

BLZ 20111

main bank connection

UniCredit Bank Austria AG

BLZ 20151

main bank connection

BKS Bank AG

BLZ 17000

secondary banking connection

Raiffeisen Bank International AG

BLZ 31000

secondary banking connection

 

 

Locations

 

operational

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9

registered headquarters, rented premises

 

0043 5 0213

info@rhi-ag.com

operational

A-1011 Wien, P.O. Box 143

postbox

operational

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9

registered office, rented premises

operational

A-8700 Leoben, Prettachstraße 8

branch office

operational

A-8784 Trieben, Schoberpassbundesstraße 57, Werk Veitsch Radex

branch office

operational

A-8700 Leoben, Gösserplatz 1

branch office

operational

A-8700 Leoben, Magnesitstrasse 2, 4, 6 und 8, Technologiezentrum

branch office, rented premises

former

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 11

registered headquarters

former

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 11

registered office

former

A-1040 Wien, Mommsengasse 35

registered office

former

A-1010 Wien, Opernring 1

office

former

A-9545 Radenthein, Millstätterstraße 25

office

Private data

 

Surname

Date of birth

Address

Executive positions

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Dipl-Ing. Hubert Buchsteiner

1966-04-27

A-8740 Möbersdorf

Am Teichgrund 10

joint signing clerk

0

Bernhard Goliasch

1964-05-19

A-1100 Wien

Palisagasse 20

joint signing clerk

3

Dipl-Ing. Erik Hagander

1956-06-29

A-1040 Wien

Graf Starhemberggasse 1A

joint signing clerk

0

Dipl-Ing. Gernot Harm

1976-07-08

A-2500 Baden

Augustinergasse 22

joint signing clerk

1

Dipl-Ing. Thomas Jakowiak

1972-04-08

A-1100 Wien

Wienerbergstraße 11(c/o)

joint signing clerk

0

Mag. Gabriele Pichler

1975-05-24

A-3240 Mank

Plainachergasse 7

joint signing clerk

1

Mag. Robert Ranftler

1971-11-25

A-1100 Wien

Alxingergasse 57-59

joint signing clerk

5

Dipl-Ing. Stefan Schriebl

1971-02-26

A-9363 Metnitz

Marktstraße 27

joint signing clerk

1

Mag. Felix Warmuth

1981-03-30

A-2483 Ebreichsdorf

Gutshofzeile 1

joint signing clerk

0

Dipl-Ing. Holger Woltron

1964-12-19

A-2630 Ternitz

Döpplingerstraße 24

joint signing clerk

1

Dkfm. Franz Struzl

1942-07-03

A-8650 Kindberg

Kreutzerstraße 65

chairman of the executive board

3

Dipl-Ing. Franz Buxbaum

1956-02-22

A-2540 Bad Vöslau

Anzengruberstraße 10

member of the executive board

1

Mag. Barbara Potisk-Eibensteiner

1968-09-09

A-1030 Wien

Modecenterstraße 14

member of the executive board

1

Dipl-Ing. Reinhold Steiner

1964-10-06

A-8793 Trofaiach

Edling 24d

member of the executive board

2

Dr. Herbert Cordt

1947-01-12

A-1010 Wien

Am Parkring 12

chairman of the supervisory board

9

Dipl-Ing.Dr. Helmut Draxler

1950-04-25

A-1010 Wien

Singerstraße 8

deputy chairman of the supervisory board

3

 

Vorsitzender des Vorstandes

Mag.Dr. Wolfgang Ruttenstorfer

1950-10-15

A-2340 Mödling

Parkstraße 19

deputy chairman of the supervisory board

8

Ing. Walter Geier

1957-04-19

A-8700 Leoben

Magnesitgasse 6

member of the supervisory board

0

Hubert Gorbach

1956-07-27

A-6820 Frastanz

Obere Lände 1

member of the supervisory board

2

Dr. Alfred Gusenbauer

1960-02-08

A-1070 Wien

Sankt Ulrichsplatz 4

member of the supervisory board

11

Ing. Christian Hütter

1957-02-24

A-1050 Wien

Högelmüllerstraße 3

member of the supervisory board

0

Dipl-Betriebsw. Gerd Peskes

1944-12-26

D-40479 Düsseldorf

Inselstraße 20

member of the supervisory board

1

Roland Rabensteiner

1971-01-27

A-8663 St. Barbara Mürztal

Köhlersiedlung 3

member of the supervisory board

0

Franz Reiter

1962-01-25

A-6020 Innsbruck

Universitätsstraße 15(c/o)

member of the supervisory board

0

Prinz Stanislaus Sayn-Wittgenstein Berleburg

1965-09-15

D-81672 München

Rosenheimerstraße 146 b(c/o)

member of the supervisory board

0

David Schlaff

1978-10-08

A-1100 Wien

Wienerbergstraße 11(c/o)

member of the supervisory board

0

Dipl-Betriebsw. Peter Luef

 

A-1100 Wien

Wienerbergstraße 9(c/o)

head of accounting

0

Ing. Karl Astecker

 

A-1100 Wien

Wienerbergstraße 11(c/o)

head of EDP

0

Dkfm. Michael Merzbach

 

A-1100 Wien

Wienerbergstraße 9(c/o)

head of personnel

0

 

 

related companies

 

Company name

Address

Shareholdings in %

Since

Commercial register no.

Shares in this company are held by:

Chestnut Beteiligungsgesell- schaft mbH

D-82064 Straßlach Dingharting

Am Holzmaierfeld 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Silver Beteiligungsgesell- schaft mbH

D-82064 Straßlach Dingharting

Am Holzmaierfeld 1

 

 

 

 

 

 

 

 

MS Privatstiftung

A-1010 Wien

An der Hülben 4

 

 

FN 194908 f

 

 

 

 

 

FEWI Beteiligungsgesellschaft mbH

D-82064 Straßlach-Dingharting

Am Holzmaierfeld 1

 

 

 

 

 

 

 

 

This company holds 100% of the shares in:

Veitscher Vertriebsgesellschaft m.b.H.

A-1100 Wien

Wienerbergstraße 9

100 %

2002-05-01

FN 127094 d

 

 

 

 

 

Refractory Intellectual Property GmbH

A-1100 Wien

Wienerbergstraße 9

100 %

2002-01-31

FN 218190 v

 

 

 

 

 

Veitsch-Radex GmbH

A-1100 Wien

Wienerbergstraße 9

100 %

2002-03-13

FN 219532 t

 

 

 

 

 

"VEITSCH-RADEX" Vertriebsgesellschaft m.b.H.

A-1100 Wien

Wienerbergstraße 9

100 %

2002-05-09

FN 168287 g

 

 

 

 

 

This company holds 50% to 99% of the shares in:

RHI Refractories Raw Material GmbH

A-1100 Wien

Wienerbergstraße 9

99,8 %

1999-04-10

FN 138973 y

 

 

 

 

 

This company holds less than 50% of the shares in:

Kompetenz- und Informationszentrum für Humanvermögen und interdisziplinäre Arbeits- und Unternehmensforschung GmbH in Liqu.

A-3400 Klosterneuburg

Kierlingerstraße 87

8,89 %

2003-10-10

FN 240485 f

 

 

 

 

 

Affiliated companies and further participations:

Veitsch-Radex GmbH & Co OG

A-1100 Wien

Wienerbergstraße 9

 

2002-05-08

FN 221994 m

 

 

 

 

 

Refractory Intellectual Property GmbH & Co KG

A-1100 Wien

Wienerbergstraße 11

 

2002-03-15

FN 219265 z

 

 

 

 

 

Lokalbahn Mixnitz-St. Erhard Aktien-Gesellschaft

A-1100 Wien

Wienerbergstraße 9

 

 

FN 129255 g

 

 

 

 

 

Radex Vertriebsgesellschaft m.b.H.

A-8700 Leoben

Magnesitstraße 2

 

 

FN 168288 h

 

 

 

 

 

MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH

A-8614 Breitenau Hochlantsch

Magnesitstraße 40

 

 

FN 228996 i

 

 

 

 

 

MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH & Co KG

A-8614 Breitenau Hochlantsch

Magnesitstraße 40

 

 

FN 229831 m

 

 

 

 

 

 

 

Balance Sheet

 

(absolute) all amounts in EUR

 

 

2014-12-31

Franchises, patents, licences, trademarks and similar rights and advantages

4.484.205,96

Sum intangible assets

4.484.205,96

Other operating and business equipment

3.604.939,40

Technical plants and machines

6.345.732,00

Advanced payments and constructions in progress

2.769.829,14

Sum tangible assets

12.720.500,54

Shares on related firms

1.122.862.580,90

Other financial assets, values and securities of fixed assets

4.127.421,02

Special account financial assets

10.979.677,48

Sum financial assets

1.137.969.679,40

Sum fixed assets

1.155.174.385,90

Raw-, auxiliary materials and supplies

3.264.844,61

Finished products

43.120.246,03

Outstanding service claims

595.282,12

Sum stock

46.980.372,76

Claims from delivered goods and performed services

114.190.062,36

Claims against companies with shareholding relationship

27.896,40

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

497.165.813,18

Other claims and assets

26.243.349,33

Sum claims

637.627.121,27

Cash on hand, cheques and bank deposits

92.022.973,34

Sum cash and bank

92.022.973,34

Sum current assets

776.630.467,37

Deferred charges

6.339,14

Sum deferred charges

6.339,14

Assets

1.931.811.192,41

 

Subscribed/declared capital

289.376.212,84

Committed capital reserves

39.142.056,75

Balance sheet profit/balance sheet loss

602.860.844,82

Thereof profit/loss carried forward

560.485.807,64

Sum equity capital

931.379.114,41

Reserves for severance pays

22.679.232,43

Reserves for pensions

27.320.545,00

Tax reserves

3.397.938,00

Other reserves

75.657.234,12

Sum reserves

129.054.949,55

Liabilities against credit institutes

553.813.020,08

Received advanced payments for orders

6.783.911,60

Liabilities from delivered goods and performed services

16.042.559,01

Liabilities against related firms

273.288.325,30

Other liabilities

21.449.312,46

Sum liabilities

871.377.128,45

 

Liabilities

1.931.811.192,41

Contingent liabilities

63.388.889,90

Balance sheet sum

1.931.811.192,41

 

 

 

P / L Account

 

(absolute) all amounts in EUR

 

 

2014-12-31

Gross sales

1.212.786.797,18

Increase or decrease in finished and unfinished goods and in service claims

-126.431,13

Other manufacturing costs capitalized

56.632,73

Total turnover or gross profit

1.212.716.998,78

 

Profits from retirement of fixed assets, except financial assets

3.746,92

Income from dissolution of reserves

2.976.235,01

Other operating profits

33.330.610,97

Other operating profits totally

36.310.592,90

 

Costs for obtained services

-13.929,14

Material costs

-943.761.921,87

Costs for obtained services totally

-943.775.851,01

 

Salaries

-60.952.757,30

Costs for severance pays

-6.479.594,36

Costs for old age pension

-4.585.258,09

Legal fringe benefits and other payments depending on salaries

-13.738.800,58

Other social fringe benefits

-1.078.232,69

Personnel expenses totally

-86.834.643,02

 

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation

-4.364.537,06

Depreciation tangible assets / intangible assets totally

-4.364.537,06

 

Other operating costs

-221.069.920,06

Other taxes

-70.397,72

Total costs

-221.140.317,78

 

Operating result totally

-7.087.757,19

 

Profits from shareholdings

77.739.420,47

Income from other securities and loans of financial assets

165.062,40

Interest income, securties income and similar income

11.929.955,34

Interest and similar disbursements

-15.299.116,80

Financial expenses

-23.999.734,88

Financial profits totally

50.535.586,53

 

Results from usual business activity totally

43.447.829,34

 

Taxes on income and profits

-1.072.792,16

Taxes on income and profits totally

-1.072.792,16

 

Annual surplus/annual deficit totally

42.375.037,18

 

Annual profit/annual loss totally

42.375.037,18

 

Profit and loss carried forward from previous year

560.485.807,64

Transfer of profits totally

560.485.807,64

 

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account

602.860.844,82

 

 

 

Key ratios

 

 

2014

Cashflow II

46.739.574,24

Debt amortisation period in years

19,29

Bank indebtedness

28,66

Equity capital share in %

48,38

Social capital share

2,58

Fixed assets coverage

84,95

Net profit ratio

3,58

Capital turnover

0,62

Return on investment in %

3,04

Cashflow in % of operating performance

3,85

Cashflow I

47.812.366,40

Gross productivity

13,96

Net productivity

3,09

Operating performance

1.212.716.998,78

Inventories in % of operating performance

3,87

Gross profit

268.941.147,77

Land Register

 

Note

 

No real estate property registered

 

 

Commercial register

 

firm (style)

22      RHI AG

legal form

1      Aktiengesellschaft

registered office

1      politischer Gemeinde Wien

business adress

137      Wienerbergstraße 9
1100 Wien

capital

129      EUR 289.376.212,84

reference date annual accounts

1      31. Dezember

annual accounts

158      zum 31.12.2013 eingereicht am 06.06.2014

consolidated accounts

158      zum 31.12.2013 eingereicht am 06.06.2014

power of representation

1      Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder
durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten.
Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
selbständige Vertretungsbefugnis erteilen.

other provisions

3      Der Vorstand besteht aus 2, 3, 4 oder 5 Personen.

 

Board Of Directors

CN   Mag. Barbara Potisk-Eibensteiner, geb. 09.09.1968
147        Mitglied
vertritt seit 01.04.2012 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
DC   DI Franz Buxbaum, geb. 22.02.1956
154        vertritt seit 01.07.2013 gemeinsam mit
einer Vorständin/einem Vorstand oder einer Prokuristin/einem
Prokuristen
DE   Dkfm. Franz Struzl, geb. 03.07.1942
144        Vorsitzende/r
vertritt seit 08.09.2011 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
DM   DI Reinhold Steiner, geb. 06.10.1964
154        vertritt seit 01.07.2013 gemeinsam mit
einer Vorständin/einem Vorstand oder einer Prokuristin/einem
Prokuristen

 

Proxy

BZ   Bernhard Goliasch, geb. 19.05.1964
91        vertritt seit 01.01.2006 gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen
CO   Mag. Gabriele Becker-Pichler, geb. 24.05.1975
115        vertritt seit 19.12.2007 gemeinsam mit
einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
CY   Dipl.Ing. Thomas Jakowiak, geb. 08.04.1972
126        vertritt seit 25.05.2009 gemeinsam mit
einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
DA   Dipl.Ing. Holger Woltron, geb. 19.12.1964
126        vertritt seit 25.05.2009 gemeinsam mit
einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
DF   Mag. Felix Warmuth, geb. 30.03.1981
147        vertritt seit 03.05.2012 gemeinsam mit
einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
DJ   DI Erik Hagander, geb. 29.06.1956
151        vertritt seit 04.02.2013 gemeinsam mit
einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
DK   Mag. Robert Ranftler, geb. 25.11.1971
152        vertritt seit 22.04.2013 gemeinsam mit
einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
DN   DI Gernot Harm, geb. 08.07.1976
156        vertritt seit 16.09.2013 gemeinsam mit
einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
DO   DI Hubert Buchsteiner, geb. 27.04.1966
161        vertritt seit 22.09.2014 gemeinsam mit
einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied
DP   DI Stefan Schriebl, geb. 26.02.1971
162        vertritt seit 27.02.2015 gemeinsam mit
einem weiteren Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied

 

Supervisory Board

AX   Dipl.Bw. Gerd Peskes, geb. 26.12.1944
111        Mitglied
BJ   Stanislaus Prinz zu Sayn-Wittgenstein
-Berleburg, geb. 15.09.1965
47        Mitglied
CI   Dipl.-Ing.Dr. Helmut Draxler, geb. 25.04.1950
111        Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
CJ   Dr. Herbert Cordt, geb. 12.01.1947
133        Vorsitzende/r
CL   Hubert Gorbach, geb. 27.07.1956
109        Mitglied
CQ   Franz Reiter, geb. 25.01.1962
116        Mitglied
CV   Roland Rabensteiner, geb. 27.01.1971
124        Mitglied
DD   David Schlaff, geb. 08.10.1978
133        Mitglied
DG   Dr. Wolfgang Ruttenstorfer, geb. 15.10.1950
153        Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
DH   Ing. Christian Hütter, geb. 24.02.1957
150        Mitglied
DI   Ing. Walter Geier, geb. 19.04.1957
150        Mitglied
DL   Dr. Alfred Gusenbauer, geb. 08.02.1960
153        Mitglied

 

General Table

Handelsgericht Wien
1 datenersterfasst am 17.06.1994             Geschäftsfall 920 Fr  1462/94 s
Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
3 eingetragen am 01.07.1994                  Geschäftsfall 703 Fr  6865/94 s
Berichtigung - Antrag  eingelangt am 29.06.1994
12 eingetragen am 12.12.1995                  Geschäftsfall 702 Fr 12830/95 p
Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.12.1995
13 eingetragen am 13.12.1995                  Geschäftsfall 702 Fr 12831/95 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.12.1995
22 eingetragen am 08.01.1998                  Geschäftsfall  72 Fr 12900/97 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.12.1997
33 eingetragen am 22.07.1999                  Geschäftsfall  72 Fr  8698/99 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.07.1999
34 eingetragen am 06.08.1999                  Geschäftsfall  72 Fr  8701/99 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.07.1999
35 eingetragen am 07.09.1999                  Geschäftsfall  72 Fr  9670/99 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.07.1999
36 eingetragen am 15.10.1999                  Geschäftsfall  73 Fr  1989/99 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.10.1999
42 eingetragen am 19.05.2001                  Geschäftsfall  73 Fr  5484/01 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.04.2001
47 eingetragen am 06.07.2001                  Geschäftsfall  73 Fr  8859/01 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.07.2001
69 eingetragen am 05.08.2003                  Geschäftsfall  73 Fr  8065/03 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 15.07.2003
70 eingetragen am 25.09.2003                  Geschäftsfall  73 Fr 10680/03 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.09.2003
72 eingetragen am 24.12.2003                  Geschäftsfall  73 Fr 14627/03 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.12.2003
74 eingetragen am 24.03.2004                  Geschäftsfall  73 Fr  3326/04 i
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.03.2004
75 eingetragen am 24.06.2004                  Geschäftsfall  73 Fr  6931/04 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.06.2004
78 eingetragen am 28.09.2004                  Geschäftsfall  73 Fr 11101/04 v
Berichtigung - Antrag  eingelangt am 27.09.2004
80 eingetragen am 18.12.2004                  Geschäftsfall  73 Fr 15541/04 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.12.2004
83 eingetragen am 19.03.2005                  Geschäftsfall  73 Fr  3641/05 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.03.2005
84 eingetragen am 28.06.2005                  Geschäftsfall  73 Fr  7870/05 a
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.06.2005
87 eingetragen am 09.09.2005                  Geschäftsfall  73 Fr  9194/05 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.07.2005
88 eingetragen am 24.09.2005                  Geschäftsfall  73 Fr 11472/05 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.09.2005
90 eingetragen am 21.12.2005                  Geschäftsfall  73 Fr 15872/05 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.12.2005
91 eingetragen am 27.01.2006                  Geschäftsfall  73 Fr   816/06 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.01.2006
93 eingetragen am 25.03.2006                  Geschäftsfall  71 Fr  2706/06 a
Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.03.2006
94 eingetragen am 30.06.2006                  Geschäftsfall  71 Fr  6101/06 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.06.2006
97 eingetragen am 14.07.2006                  Geschäftsfall  71 Fr  6725/06 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.07.2006
98 eingetragen am 22.09.2006                  Geschäftsfall  71 Fr  9393/06 i
Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.09.2006
99 eingetragen am 21.12.2006                  Geschäftsfall  71 Fr 13417/06 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.12.2006
102 eingetragen am 07.02.2007                  Geschäftsfall  71 Fr  1466/07 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 01.02.2007
103 eingetragen am 28.03.2007                  Geschäftsfall  71 Fr  3756/07 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.03.2007
104 eingetragen am 30.03.2007                  Geschäftsfall  71 Fr  3911/07 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.03.2007
106 eingetragen am 26.06.2007                  Geschäftsfall  71 Fr  7189/07 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.06.2007
107 eingetragen am 27.06.2007                  Geschäftsfall  71 Fr  7379/07 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.06.2007
109 eingetragen am 31.07.2007                  Geschäftsfall  71 Fr  7486/07 p
Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.06.2007
110 eingetragen am 15.09.2007                  Geschäftsfall  71 Fr 10678/07 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.09.2007
111 eingetragen am 03.10.2007                  Geschäftsfall  71 Fr 11666/07 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.09.2007
114 eingetragen am 22.12.2007                  Geschäftsfall  71 Fr 15179/07 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.12.2007
115 eingetragen am 17.01.2008                  Geschäftsfall  71 Fr   555/08 f
Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.01.2008
116 eingetragen am 06.02.2008                  Geschäftsfall  71 Fr  1394/08 p
Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.01.2008
118 eingetragen am 17.05.2008                  Geschäftsfall  75 Fr  4804/08 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.05.2008
119 eingetragen am 11.09.2008                  Geschäftsfall  75 Fr  9111/08 t
Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.08.2008
120 eingetragen am 24.09.2008                  Geschäftsfall  75 Fr 10547/08 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.09.2008
121 eingetragen am 09.01.2009                  Geschäftsfall  75 Fr 15828/08 w
Urkundenvorlage  eingelangt am 23.12.2008
124 eingetragen am 16.05.2009                  Geschäftsfall  71 Fr  6076/09 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.05.2009
126 eingetragen am 03.07.2009                  Geschäftsfall  71 Fr  8155/09 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.06.2009
127 eingetragen am 11.07.2009                  Geschäftsfall  71 Fr  8561/09 m
Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.07.2009
128 eingetragen am 22.09.2009                  Geschäftsfall  71 Fr 11849/09 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.09.2009
129 eingetragen am 23.12.2009                  Geschäftsfall  71 Fr 16770/09 i
Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.12.2009
130 eingetragen am 30.01.2010                  Geschäftsfall  71 Fr   930/10 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.01.2010
133 eingetragen am 03.06.2010                  Geschäftsfall  71 Fr  5509/10 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.05.2010
137 eingetragen am 11.11.2010                  Geschäftsfall  71 Fr 11954/10 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.11.2010
140 eingetragen am 23.06.2011                  Geschäftsfall  75 Fr 10438/11 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 10.06.2011
144 eingetragen am 10.11.2011                  Geschäftsfall  75 Fr 21319/11 x
Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.11.2011
145 eingetragen am 16.12.2011                  Geschäftsfall  75 Fr 22832/11 x
Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.12.2011
146 eingetragen am 27.06.2012                  Geschäftsfall  75 Fr  8069/12 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.06.2012
147 eingetragen am 06.07.2012                  Geschäftsfall  75 Fr  8285/12 m
Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.06.2012
148 eingetragen am 20.07.2012                  Geschäftsfall  75 Fr  9452/12 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 27.06.2012
150 eingetragen am 19.01.2013                  Geschäftsfall  75 Fr   461/13 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.01.2013
151 eingetragen am 20.02.2013                  Geschäftsfall  75 Fr  1624/13 a
Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.02.2013
152 eingetragen am 07.05.2013                  Geschäftsfall  75 Fr  4623/13 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.05.2013
153 eingetragen am 11.06.2013                  Geschäftsfall  75 Fr  5756/13 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.06.2013
154 eingetragen am 05.07.2013                  Geschäftsfall  75 Fr  7742/13 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.07.2013
155 eingetragen am 03.09.2013                  Geschäftsfall  75 Fr 10466/13 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.08.2013
156 eingetragen am 04.10.2013                  Geschäftsfall  75 Fr 15818/13 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 01.10.2013
158 eingetragen am 12.06.2014                  Geschäftsfall  75 Fr  5693/14 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 06.06.2014
161 eingetragen am 12.11.2014                  Geschäftsfall  75 Fr 16375/14 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.10.2014
162 eingetragen am 18.03.2015                  Geschäftsfall  75 Fr  2183/15 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.03.2015

 

 

Historical development

 

Year of incorporation

1976

Date of registration

1979-12-18

 

 

Change in share capital

 

from

to

asset

 

2004-03-24

2004-06-24

EUR

145.803.790,62

2004-06-24

2004-09-24

EUR

146.523.251,68

 

1999-08-09

ATS

1.392.003.900,00

1999-08-09

1999-10-18

EUR

101.160.868,59

1999-10-18

2003-09-25

EUR

144.764.569,09

2003-09-25

2003-12-24

EUR

145.364.119,97

2003-12-24

2004-03-24

EUR

145.723.850,50

2004-09-24

2004-12-18

EUR

158.873.999,85

2004-12-18

2005-03-19

EUR

159.753.341,14

2005-03-19

2005-06-28

EUR

166.947.951,72

2005-06-28

2005-09-24

EUR

167.387.622,16

2005-09-24

2005-12-21

EUR

188.491.803,28

2005-12-21

2006-03-25

EUR

189.531.024,32

2006-03-25

2006-06-30

EUR

193.328.178,12

2006-06-30

2006-09-22

EUR

195.646.440,44

2006-09-22

2006-12-21

EUR

196.805.571,60

2006-12-21

2007-03-28

EUR

212.074.126,88

2007-03-28

2007-03-30

EUR

235.976.219,65

2007-03-30

2007-06-26

EUR

237.295.231,46

2007-06-26

2007-06-27

EUR

271.909.298,91

2007-06-27

2007-09-15

EUR

271.989.239,02

2007-09-15

2007-12-20

EUR

272.109.149,18

2007-12-20

2007-12-22

EUR

272.189.089,29

2007-12-22

2008-05-19

EUR

272.348.969,51

2008-05-19

2008-09-24

EUR

272.548.819,78

2008-09-24

2009-01-09

EUR

274.827.112,90

2009-01-09

2009-09-22

EUR

275.626.514,00

2009-09-22

2009-12-23

EUR

276.665.735,42

2009-12-23

 

EUR

289.376.212,84

 

 

Former executives

 

from

to

position

name

2002-01-18

2007-01-20

deputy chairman of the executive board

Dipl-Ing.Dr. Andreas Meier

2007-01-20

2007-07-04

deputy chairman of the executive board

Dr. Eduard Zehetner

1999-02-09

2002-01-16

member of the executive board

Dipl-Ing.Dr. Andreas Meier

2002-01-18

2002-04-08

member of the executive board

Dipl-Ing.Dr. Andreas Meier

2002-01-16

2007-01-20

member of the executive board

Dr. Eduard Zehetner

2002-06-06

2007-10-03

deputy chairman of the supervisory board

Dipl-Betriebsw. Gerd Peskes

2007-11-03

2008-09-11

deputy chairman of the supervisory board

Dr. Herbert Cordt

2007-10-03

2010-06-03

deputy chairman of the supervisory board

Dr. Herbert Cordt

2002-03-01

2002-06-06

chairman of the supervisory board

Dipl-Betriebsw. Gerd Peskes

1999-07-22

2002-03-01

member of the supervisory board

Dipl-Betriebsw. Gerd Peskes

2007-07-31

2008-05-19

member of the supervisory board

Dr. Herbert Cordt

2007-07-31

2008-05-19

member of the supervisory board

Dipl-Ing.Dr. Helmut Draxler

 

2013-06-11

member of the supervisory board

Mag.Dr. Wolfgang Ruttenstorfer

2007-10-03

2012-07-06

joint signing clerk

Mag. Barbara Potisk Eibensteiner

2010-01-30

2013-07-05

joint signing clerk

Dipl-Ing. Franz Buxbaum

2002-01-14

2007-01-20

chairman of the executive board

Dipl-Ing.Dr. Helmut Draxler

2007-01-20

2009-01-17

chairman of the executive board

Dipl-Ing.Dr. Andreas Meier

2007-07-04

2009-06-17

deputy chairman of the executive board

Dr. Stefano Colombo

 

1999-02-09

member of the executive board

Dipl-Ing.Dr. Günther Mörtl

1999-02-09

2001-05-31

member of the executive board

Dipl-Ing. Jakob Aurel Mosser

 

1997-07-04

chairman of the supervisory board

Dipl-Ing. Hellmut Friedrich Longin

1999-07-22

2002-03-01

chairman of the supervisory board

Dr. Walter Ressler

2002-03-01

2004-07-03

member of the supervisory board

Dr. Walter Ressler

 

1999-07-22

chairman of the executive board

Dr. Walter Ressler

2001-10-19

2001-11-27

deputy chairman of the supervisory board

DDr. Erhard Schaschl

1999-07-22

2001-10-19

member of the supervisory board

DDr. Erhard Schaschl

2001-11-27

2007-07-31

member of the supervisory board

DDr. Erhard Schaschl

 

1999-05-06

member of the supervisory board

Dkfm. Gerhard Randa

1995-08-22

2005-09-03

member of the supervisory board

Dipl-Ing. Maximilian Ardelt

 

2001-09-12

employee's representative on the supervisory board

Karl Prettner

1999-02-09

2001-06-22

joint signing clerk

Mag. Gabriel Faimann

2001-06-22

2005-01-25

joint signing clerk

Dipl-Ing. Stefan Wallner

2008-01-17

2009-12-23

joint signing clerk

Mag. Johann Diwald

2001-06-22

2009-07-03

joint signing clerk

Dipl-Ing. Klaus Dösinger

2009-07-03

2010-09-08

joint signing clerk

Dipl-Betriebsw. Robert Gregan

2009-07-03

2010-09-08

joint signing clerk

Dipl-Betriebsw. Ernst Stoelzel

2009-07-03

2013-01-19

joint signing clerk

Ulf Andersson

 

1998-01-30

member of the executive board

Mag. Hans Jörg Kaltenbrunner

2009-01-17

2010-10-23

chairman of the executive board

Dipl-Betriebsw. Thomas Michael Fahnemann

1999-07-22

2001-09-12

member of the supervisory board

Dr. Erich Hampel

1999-07-22

2002-01-16

chairman of the executive board

Dr. Georg Obermeier

 

2000-01-21

member of the executive board

Rudolf Kanzi

1999-02-16

2003-05-06

member of the executive board

Mag. Roland Platzer

 

1999-02-09

joint signing clerk

Mag. Roland Platzer

2007-07-04

2010-04-01

member of the executive board

Mag. Rudolf Payer

1999-02-09

2007-07-04

joint signing clerk

Mag. Rudolf Payer

1999-02-09

2000-01-28

joint signing clerk

DDipl-Ing. Gerd Ingo Janitschek

1999-02-09

2001-06-22

joint signing clerk

Dr. Günter Karhut

1999-02-09

2001-10-18

joint signing clerk

Mag. Norbert Wittmann

2002-07-30

2002-11-12

joint signing clerk

Mag. Norbert Wittmann

1999-02-09

2002-07-26

joint signing clerk

Mag. Ronald Elgert

1998-01-30

2008-05-16

joint signing clerk

Mag. Andreas Bier

2010-01-30

2011-03-31

member of the executive board

Henning Jensen

2011-03-31

2011-11-10

chairman of the executive board

Henning Jensen

2011-03-31

2012-07-06

member of the executive board

Mark Eckhout

2007-07-31

2008-09-11

member of the supervisory board

Mark Eckhout

2007-01-04

2013-07-05

member of the executive board

Dr. Giorgio Cappelli

2001-05-24

2007-02-07

joint signing clerk

Dr. Giorgio Cappelli

2007-01-04

2013-07-05

member of the executive board

Dr. Manfred Hödl

2001-05-24

2007-02-07

joint signing clerk

Dr. Manfred Hödl

1995-08-22

1999-07-22

chairman of the supervisory board

Dipl-Ing.Dr. Friedrich Nemec

 

1997-07-04

deputy chairman of the supervisory board

Dipl-Ing.Dr. Friedrich Nemec

1999-07-22

2002-03-01

deputy chairman of the supervisory board

Dipl-Ing.Dr. Friedrich Nemec

2002-03-01

2002-10-03

member of the supervisory board

Dipl-Ing.Dr. Friedrich Nemec

2001-09-12

2009-05-16

member of the supervisory board

Karl Wetzelhütter

1994-12-02

2003-02-08

joint signing clerk

Dr. Georg Gerhardt

2002-06-06

2010-06-03

chairman of the supervisory board

Dkfm. Michael Gröller

2002-03-01

2002-06-06

deputy chairman of the supervisory board

Dkfm. Michael Gröller

2010-06-03

2013-06-11

deputy chairman of the supervisory board

Dkfm. Michael Gröller

1998-01-30

1999-07-22

deputy chairman of the supervisory board

Dr. Andreas Foglar Deinhardstein

 

1998-01-30

member of the supervisory board

Dr. Andreas Foglar Deinhardstein

1997-07-04

1997-11-05

member of the supervisory board

Ferdinand Lacina

 

1999-07-22

member of the supervisory board

Andreas Huiskamp

 

2001-07-06

member of the supervisory board

Max Deitcher

 

1999-07-22

member of the supervisory board

Hellmuth Wandschneider

1998-06-25

2001-10-26

member of the supervisory board

Mag. Andreas Treichl

2004-07-03

2005-08-23

member of the supervisory board

August Francois von Finck

2004-12-07

2005-10-04

member of the supervisory board

Ing. Günther Lippitsch

2006-07-14

2007-07-31

member of the supervisory board

Dr. Kurt Waniek

2002-10-03

2007-10-03

member of the supervisory board

Dr.jur. Cornelius Alexander Grupp

2002-03-01

2007-11-03

member of the supervisory board

Ing. Gerd Klaus Gregor

2008-09-11

2010-06-03

member of the supervisory board

Dr. Ulrich Glaunach

2006-07-13

2013-01-19

member of the supervisory board

Mag. Martin Kowatsch

1999-03-17

2013-01-19

member of the supervisory board

Dipl-Ing. Leopold Miedl

 

1999-03-17

employee's representative on the supervisory board

Helga Klement

1993-07-03

2004-12-07

employee's representative on the supervisory board

Georg Eder

1993-12-01

2008-02-06

employee's representative on the supervisory board

Josef Horn

 

1997-04-25

joint signing clerk

Dr. Franz Aust

 

1998-08-07

joint signing clerk

Günther Pacher

 

1998-11-24

joint signing clerk

Ing.Mag. Johannes Elsner

 

1999-05-06

joint signing clerk

Rosa Maria Lesacher

1998-01-30

2000-12-29

joint signing clerk

Mag. Peter Hofmann

1999-02-09

2000-12-29

joint signing clerk

Dr. Peter Podesser

2001-05-24

2001-08-01

joint signing clerk

Dipl-Ing. Edmar Allitsch

2001-05-24

2001-08-01

joint signing clerk

Dipl-Ing. Viktor Fischer

2001-05-24

2009-07-03

joint signing clerk

Juan Alvarez

1999-02-09

2002-07-26

joint signing clerk

Fritz Friedrich

1999-02-09

2003-11-08

joint signing clerk

Dr. Gerhard Kantusch

2006-07-08

2009-07-03

joint signing clerk

Dr. Dieter Siegel

2005-01-21

2006-01-27

joint signing clerk

Dipl-Ing. Björn Karlsson

2005-01-21

2009-07-03

joint signing clerk

Dipl-Ing. Max Taferner

2004-01-21

2010-04-27

joint signing clerk

Mag. Andreas Berger

2000-12-29

2007-06-16

joint signing clerk

Dkfm. Markus Richter

2006-07-08

2009-04-07

joint signing clerk

Dipl-Ing. Claus Braunhuber

2006-07-08

2011-07-20

joint signing clerk

Mag. Rainhard Mayer

2001-06-22

2009-04-07

joint signing clerk

Dipl-Ing.Dr. Stefan Pirker

2000-05-17

2009-04-07

joint signing clerk

Dr. Robin Schmidt Whitley

2008-05-16

2009-07-03

joint signing clerk

Mag. Martin Bartmann

2001-05-24

2009-07-03

joint signing clerk

Mag. Josef Leitgeb

2006-07-08

2011-07-20

joint signing clerk

Dr. Gerald Klenner

2002-07-26

2011-11-12

joint signing clerk

Gottfried Hofreither

2003-01-21

2013-05-07

joint signing clerk

Mag. Gerlinde Celia Konrad

2002-06-06

2014-03-21

joint signing clerk

Dipl-Ing. Ingo Gruber

2009-04-07

2014-08-07

joint signing clerk

Mag. Bernd Dieter Buchberger

2003-05-09

2014-10-01

joint signing clerk

Mag. Michael Csebits

Former shareholdings

 

from

to

company name

1998-04-22

1999-02-26

Knauf Insulation GmbH

1995-12-22

2001-03-27

VIAG Telecom Connect zweite Beteiligungs-GmbH

1999-10-15

2003-02-06

Knauf Insulation GmbH

2002-05-03

2005-07-30

Radex Vertriebsgesellschaft m.b.H.

2002-11-23

2010-09-18

MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH

2002-12-20

2010-10-19

MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH & Co KG

 

1999-04-10

RHI Refractories Raw Material GmbH

1999-03-05

2001-05-19

VRD Asia Pacific Feuerfestbeteiligungen GmbH

2002-04-30

2003-12-11

Radex Vertriebsgesellschaft m.b.H.

 

1999-09-07

Heraklith AG

 

1997-01-14

Refractories Consulting & Engineering Gesellschaft m.b.H. in Liqu.

2002-04-10

2002-05-08

Veitsch-Radex Betriebs GmbH

2002-02-28

2002-12-20

MAGNIFIN Magnesiaprodukte Gesellschaft m.b.H.

 

1996-10-26

Österreichische Magnesit Aktiengesellschaft in Liquidation

 

 

Mergers

 

On

position

name

2013-07-10

merged with

Heraklith Holding Aktiengesellschaft

2005-03-22

merged with

Veitsch-Radex Aktiengesellschaft für feuerfeste Erzeugnisse

2001-05-28

merged with

VRD Asia Pacific Feuerfestbeteiligungen GmbH

2000-12-01

merged with

Heraklith AG

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.63.33

UK Pound

1

Rs.96.52

Euro

1

Rs.68.93

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

SUB

 

 

Report Prepared by :

ANK

 


 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.