MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

334725

Report Date :

01.08.2015

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

SANDOZ GMBH

 

 

Registered Office :

Biochemiestraße 10, A-6250 Kundl

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

31.12.2013

 

 

Year of Establishment :

1965

 

 

Com. Reg. No.:

3630

 

 

Legal Form :

Limited Liability Company

 

 

Line of Business :

Subject is manufacture of pharmaceutical preparations

 

 

No. of Employee :

3630

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory

 

 

Payment Behaviour :

No complaints

 

 

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31, 2015

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2014)

Current Rating

(31.03.2015)

Austria

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 

AUSTRIA - ECONOMIC OVERVIEW

 

Austria, with its well-developed market economy, skilled labor force, and high standard of living, is closely tied to other EU economies, especially Germany's. Its economy features a large service sector, a relatively sound industrial sector, and a small, but highly developed agricultural sector. Economic growth was anemic at less than 0.5% in 2013 and 2014, and growth in 2015 is not expected to exceed 0.5%. Austria’s 5.6% unemployment rate, while low by European standards, is at an historic high for Austria. Without extensive vocational training programs and generous early retirement, the unemployment rate would be even higher. Public finances have not stabilized even after a 2012 austerity package of expenditure cuts and new revenues. On the contrary, in 2014, the government created a “bad bank” for the troubled nationalized “Hypo Alpe Adria” bank, pushing the budget deficit up by 0.9% of GDP to 2.4% and public debt to 84.5% of the GDP. Although Austria's fiscal position compares favorably with other euro-zone countries, it faces several external risks, such as Austrian banks' continued exposure to Central and Eastern Europe, repercussions from the Hypo Alpe Adria bank collapse, political and economic uncertainties caused by the European sovereign debt crisis, the current crisis in Russia/Ukraine, the recent appreciation of the Swiss Franc, and political developments in Hungary.

 

Source : CIA

 

 

Company name and address

 

SANDOZ GMBH

 

Biochemiestraße 10, A-6250 Kundl

 

Phone:

(0043) 5338 200

Fax:

(0043) 5338 200 - 415

E-mail:

kundl.austria@sandoz.com

Internet:

http://www.sandoz.com

Internet:

http://www.sandoz.at

 

 

Activities

 

ÖNACE 21200 100% Manufacture of pharmaceutical preparations

 

 

Collections

 

Submitted for collection on

Submitted amount

Amount paid so far

Outstanding amount

Last status of debt collection

Status as of

2014-12-19

EUR

508,21

EUR

508,21

EUR

0,00

Payment of balance (outstanding)

2015-01-20

2013-05-16

EUR

578,31

EUR

578,31

EUR

0,00

Payment after KSV1870 debt collection

2013-06-17

2012-11-08

EUR

348,96

EUR

348,96

EUR

0,00

Payment after KSV1870 debt collection

2012-12-04

Summen

EUR

1.435,48

EUR

1.435,48

EUR

0,00

 

 

 

 

Financial data

 

Financial details can also be entered during the period, irrespective of the balance sheet date.

 

total turnover (total sales)

2014

EUR

1.520.000.000,00

(estimated)

total turnover (total sales)

2013

EUR

1.496.118.876,88

(exact)

total turnover (total sales)

2012

EUR

1.449.492.227,45

(exact)

total turnover (total sales)

2011

EUR

1.480.566.195,12

(exact)

total turnover (total sales)

2010

EUR

1.428.954.760,56

(exact)

total investments

2013

EUR

159.715.369,74

(exact)

total employees

2015

 

3630

(approx.)

 

 

General company information

 

Company name

SANDOZ GMBH

Year of incorporation

1965

Type of company

Manufacturing

Legal form

limited liability company since 1965-11-18

Companies house number

FN 50587 v Innsbruck  since 1965-11-26

Export

world-wide

world-wide

2015

2014

ARA-number

3462

VAT number

ATU 32425809

number - Austrian National Bank

4812

Last balance sheet:

2013

Banking connection

UniCredit Bank Austria AG

BLZ 12000

main bank connection

 

 

Locations

 

operational

A-6250 Kundl, Biochemiestraße 10

registered office

operational

A-6250 Kundl, Biochemiestraße 10

registered headquarters, owned property

 

0043 5338 200

kundl.austria@sandoz.com

operational

A-1230 Wien, Brunnerstraße 59

branch office, rented premises

 

0043 1 866590

 

operational

A-6330 Kufstein, Schaftenau Biochemiestraße 10

factory, owned property

 

0043 5372 6996

 

operational

A-6250 Kundl, Dr. Hans Bachmannstraße 7, (umben.auf Biochemiestraße 10)

registered headquarters

former

A-1220 Wien, Wagramerstraße 19

branch office

 

 

 

 

Private data

 

Surname

Date of birth

Address

Executive positions

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Mag. Hubert Hirzinger

1957-05-10

A-6250 Kundl

Biochemiestraße 10 (p/A Sandoz GmbH)

manager

4

Dkfm. Klaus Neumayer

1964-07-17

A-6250 Kundl

Biochemiestraße 10

manager

0

Dr. Thomas Nothegger

1967-07-11

A-6250 Kundl

c/o Sandoz GmbH Biochemiestraß 10

manager

0

Dr. Konrad Schaefer

1960-10-08

A-6250 Kundl

Schieferrollstraße 13

manager

0

Dr. Jens Scheibner

1968-11-15

A-6250 Kundl

c/o Sandoz GmbH Biochemiestraß 10

manager

0

Mag. Hans Peter Amon

1975-01-19

A-1020 Wien

Stella Klein Löwweg 17

joint signing clerk head of accounting

4

Dkfm. Michael Friedhofen

1967-08-27

A-1020 Wien

Stella Klein Löwweg 17

joint signing clerk

1

Sibylla Härtel

1962-10-21

A-6250 Kundl

Biochemiestraße 10(c/o)

joint signing clerk

0

Dip.-Chem. Michael Kocher

1967-04-12

A-6250 Kundl

c/o Sandoz GmbH Biochemiestraß 10

joint signing clerk

0

Dr. Nikolaus Kofler

1968-12-05

A-6250 Kundl

c/o Sandoz GmbH Biochemiestraß 10

joint signing clerk

0

Dr. Christopher Manuel Mader

1973-04-10

A-6250 Kundl

c/o Sandoz GmbH Biochemiestraß 10

joint signing clerk

0

Rodrigo Goarmon Pedroso Santos-Ferreira

1978-11-10

A-1020 Wien

Stella Klein Löwweg 17

joint signing clerk

2

 

Ferreira

Mag. Ingrid Schwarzenberger

1958-03-20

A-6250 Kundl

Biochemiestraße 10(c/o)

joint signing clerk

0

Dr. Josef Egerbacher

1958-11-20

A-6250 Kundl

Biochemiestraße 10(c/o)

chairman of the supervisory board member of the supervisory board

0

Dr. Andreas Brutsche

1962-09-17

D-83607 Holzkirchen

Industriestraße 25

deputy chairman of the supervisory board

0

Barbara Nerad

1962-12-30

A-6250 Kundl

Biochemiestraße 10

member of the supervisory board

0

Helmut Pancheri

1961-07-05

A-6250 Kundl

Biochemiestraße 10(c/o)

member of the supervisory board

0

Sandrine Charlotte Philippe Piret-Gerard

1975-10-17

D-83607 Holzkirchen

c/o HEXAL AG Industriestraße 25

member of the supervisory board

0

Felix Senn

1959-05-26

CH-4056 Basel

Novartis Campus Forum 1

member of the supervisory board

0

Mag. Max Leitinger

 

A-6250 Kundl

Biochemiestraße 10(c/o)

head of EDP

0

Josef Postl

 

A-6250 Kundl

Biochemiestraße 10(c/o)

technical director

0

 

 

related companies

 

Company name

Address

Shareholdings in %

Since

Commercial register no.

Shares in this company are held by:

Novartis Austria GmbH

A-1020 Wien

Stella Klein Löwweg 17

99,99 %

2006-07-27

FN 274620 d

Novartis Holding AG

CH-4056 Basel

Lichtstraße 35

0,01 %

1997-02-22

 

 

This company holds 100% of the shares in:

HEXAL PHARMA GmbH

A-1020 Wien

Stella Klein Löwweg 17

100 %

2005-12-17

FN 44896 z

Novartis Institutes for Biomedical Research GmbH

A-6250 Kundl

Biochemiestraße 10

100 %

1993-08-13

FN 43251 f

 

 

This company holds less than 50% of the shares in:

Nabriva Therapeutics AG

A-1112 Wien

Leberstraße 20

3,35 %

 

FN 269261 y

 

Affiliated companies and further participations:

Novartis Institutes for BioMedical Research GmbH & Co KG

A-1235 Wien

Brunnerstraße 59

 

2004-10-23

FN 253505 b

Austrian Center of Biopharmaceutical Technology

A-1190 Wien

Muthgasse 18

 

 

 

HBHG Pharma Ges.m.b.H.

A-4866 Unterach Attersee

Mondseestraße 11

 

 

FN 215663 b

Novartis Pharma GmbH

A-1020 Wien

Stella Klein Löwweg 17

 

 

FN 41622 i

EBEWE Spezial-Pharma Holding GmbH

A-1020 Wien

Stella Klein Löwweg 17

 

 

FN 331193 z

 

 

Balance Sheet

 

(absolute) all amounts in EUR

 

2013-12-31

Franchises, patents, licences, trademarks and similar rights and advantages

10.517.586,87

Sum intangible assets

10.517.586,87

Land and leasehold rights with buildings thereon including building on land owned by third parties

272.157.348,76

Other operating and business equipment

19.349.235,85

Technical plants and machines

147.003.610,97

Advanced payments and constructions in progress

85.077.459,40

Sum tangible assets

523.587.654,98

Shares on related firms

56.831.602,18

Other shareholdings

1.751.901,77

Other financial assets, values and securities of fixed assets

18.051.774,04

Sum financial assets

76.635.277,99

Sum fixed assets

610.740.519,84

Raw-, auxiliary materials and supplies

80.531.973,71

Unfinished products

154.198.842,07

Finished products

37.655.853,59

Sum stock

272.386.669,37

Claims from delivered goods and performed services

130.329.080,94

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

141.547.017,72

Other claims and assets

54.046.409,90

Sum claims

325.922.508,56

Cash on hand, cheques and bank deposits

4.781.773,95

Sum cash and bank

4.781.773,95

Sum current assets

603.090.951,88

Deferred charges

949.397,27

Sum deferred charges

949.397,27

Assets

1.214.780.868,99

 

Subscribed/declared capital

32.703.000,00

Legal reserves

3.270.300,00

Free reserves

99.991.891,44

Balance sheet profit/balance sheet loss

0,00

Sum equity capital

135.965.191,44

Other reserves before taxes

24.061.760,15

Sum reserves before taxes

24.061.760,15

Investment contributions

557.404,46

Sum floor capital

557.404,46

Reserves for severance pays

47.244.982,00

Reserves for pensions

62.223.887,00

Other reserves

75.068.795,26

Sum reserves

184.537.664,26

Liabilities against credit institutes

4.416.356,48

Received advanced payments for orders

6.711.020,99

Liabilities from delivered goods and performed services

121.144.856,15

Liabilities against related firms

718.491.287,70

Liabilities against firm with shareholding relationship

2.476.066,96

Other liabilities

7.970.213,28

Other loans

1.474.413,00

Sum liabilities

862.684.214,56

 

Deferred income

6.974.634,12

Sum deferred income

6.974.634,12

Liabilities

1.214.780.868,99

Contingent liabilities

1.700.000,00

Balance sheet sum

1.214.780.868,99

 

 

P / L Account

 

(absolute) all amounts in EUR

 

2013-12-31

Gross sales

1.496.118.876,88

Increase or decrease in finished and unfinished goods and in service claims

-3.688.594,78

Other manufacturing costs capitalized

4.943.709,32

Total turnover or gross profit

1.497.373.991,42

 

Profits from retirement of fixed assets, except financial assets

52.284,01

Other operating profits

25.610.882,10

Other operating profits totally

25.663.166,11

 

Costs for obtained services

-35.905.614,21

Material costs

-812.029.603,51

Costs for obtained services totally

-847.935.217,72

 

Wages

-27.252.938,16

Salaries

-159.084.034,37

Costs for severance pays

-3.639.921,46

Costs for old age pension

-6.652.421,94

Legal fringe benefits and other payments depending on salaries

-48.815.704,62

Other social fringe benefits

-6.969.046,50

Personnel expenses totally

-252.414.067,05

 

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation

-67.475.792,73

Depreciation tangible assets / intangible assets totally

-67.475.792,73

 

Other operating costs

-314.828.351,82

Other taxes

-582.752,31

Total costs

-315.411.104,13

 

Operating result totally

39.800.975,90

 

Profits from shareholdings

11.027.987,22

Income from other securities and loans of financial assets

551.302,92

Interest income, securties income and similar income

99,97

Interest and similar disbursements

-11.860.973,78

Financial profits totally

-281.583,67

 

Results from usual business activity totally

39.519.392,23

 

Taxes on income and profits

-8.044,52

Taxes on income and profits totally

-8.044,52

 

Annual surplus/annual deficit totally

39.511.347,71

 

Dissolution reserves before taxes

824.117,96

Transfer to profit reserves

-40.335.465,67

Reserves movements totally

-39.511.347,71

 

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account

0,00

 

 

Key ratios

 

 

2013

Cashflow II

106.987.140,44

Debt amortisation period in years

9,68

Bank indebtedness

0,48

Equity capital share in %

13,29

Social capital share

9,01

Fixed assets coverage

44,21

Net profit ratio

2,63

Capital turnover

1,23

Return on investment in %

4,22

Cashflow in % of operating performance

7,14

Cashflow I

106.995.184,96

Gross productivity

5,93

Net productivity

2,57

Operating performance

1.497.373.991,42

Inventories in % of operating performance

18,19

Gross profit

649.438.773,70

 

 

Land Register

 

Last check

2015-07-29

 

Entry number

Cadastral community

Journal number

100

Kundl                                T 83108

2567/2013

 

Section A – type of property:

GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
32/1     GST-Fläche               877
Bauf.(10)                240
Gärten(10)               637  Biochemiestraße 4
43/2     GST-Fläche              3405
Bauf.(10)               1513
Sonst(50)               1892  Biochemiestraße 5
Biochemiestraße 9
Biochemiestraße 11
478/2   G GST-Fläche        *     5848
Bauf.(10)                  6
Landw(10)               5160
Sonst(40)                682
478/3   G GST-Fläche        *      152
Landw(10)                138
Sonst(10)                 14
481/1     Landw(30)                344
484     G GST-Fläche        *   108797
Bauf.(10)              49467
Sonst(50)              59330  Biochemiestraße 10
Biochemiestraße 6
GESAMTFLÄCHE                    119423
Legende:
G: Grundstück im Grenzkataster
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude)
Gärten(10): Gärten (Gärten)
Landw(10): landwirtschaftlich genutzte Grundflächen (Äcker, Wiesen oder Weiden)
Landw(30): landwirtschaftlich genutzte Grundflächen (Verbuschte Flächen)
Sonst(10): Sonstige (Straßenverkehrsanlagen)
Sonst(40): Sonstige (Parkplätze)
Sonst(50): Sonstige (Betriebsflächen)
1  a Stand 1923 Miteigentumsrecht zu 1/3 Anteil an EZ 57
2  a 354/1951 Miteigentumsrecht zu 1/2 Anteil an EZ 56
11  a 2346/1989 2463/2009 Recht der Führung, Benützung und Erhaltung von
Leitungen auf gst 478/1 478/4 29 in EZ 90030
16  a 3065/1990 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von 2
Leitungen auf Gst 1449 in EZ 90040
17  a 3117/1990 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von 2
Leitungen auf Gst 1428/1 in EZ 186
18  a 3122/1990 2862/2000 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und
Erhaltung von 2 Leitungen auf Gst 1448 in EZ 333
19  a 676/1991 2567/2013 RECHT der Führung, Verlegung, Benützung und
Erhaltung von Leitungen und Bauwerken auf
GST-NR 1459/1 in EZ 979
GST-NR 1459/2 in EZ 996
20  a 790/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
Leitungen und Bauwerken auf Gst 462 in EZ 710
21  a 791/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
Leitungen und Bauwerken auf Gst 1430 in EZ 90023
22  a 792/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
Leitungen und Bauwerken auf Gst 1425 in EZ 90011
23  a 793/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
Leitungen und Bauwerken auf Gst 1431 in EZ 25
24  a 794/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
Leitungen und Bauwerken auf Gst 466/2 1424 in EZ 90025
25  a 795/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
Leitungen und Bauwerken auf Gst 1426 in EZ 90027
26  a 796/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
Leitungen und Bauwerken auf Gst 1423 in EZ 90033
27  a 797/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
Leitungen und Bauwerken auf Gst 1428/1 in EZ 186
28  a 798/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
Leitungen und Bauwerken auf Gst 452/2 in EZ 90031
29  a 799/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
Leitungen und Bauwerken auf Gst 1433 in EZ 90003
30  a 800/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
Leitungen und Bauwerken auf Gst 463 in EZ 90028
31  a 801/1991 2307/2003 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und
Erhaltung von Leitungen und Bauwerken auf Gst 1427 in EZ 90066
32  a 802/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
Leitungen und Bauwerken auf Gst 1429 in EZ 982
33  a 803/1991 2460/2011 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und
Erhaltung von Leitungen und Bauwerken auf
Gst 1458/1 in EZ 166
Gst 1458/2 in EZ 996
34  a 1088/1991 Recht der Führung, Verlegung, Benützung und Erhaltung von
Leitungen und Bauwerken auf Gst 1432 in EZ 204
36  a 2325/1996 Wasserschutzgebiet auf Gst 489 gem § 34 Abs 5 WRG
40  a 528/2004 Kaufvertrag 2003-11-25 Zuschreibung Gst 481/1 aus EZ 90043
42  a 2463/2009 Kaufvertrag und Urkunde 2009-10-29 Zuschreibung Gst 478/2
478/3 aus EZ 90030
43  a 2463/2009 RECHT des Gehens und Fahrens auf Gst 478/4 in EZ 90030
für Gst 478/2 478/3 484
44  a 2463/2009 RECHT der Unterlassung der Errichtung eines Mistlagers, einer
Bioabfall-Anlage oder einer Fäulnisanlage sowie der Ausbringung von
Gülle, Mist oder anderen geruchsintensiven Düngemitteln auf Gst 477/1
478/1 1293 in EZ 90030 für Gst 478/2
45  a 2463/2009 Kaufvertrag und Urkunde 2009-10-29 Zuschreibung Teilfläche(n)
Gst 1294/1 aus EZ 56, Einbeziehung in Gst 478/2 484
46  a 1053/2011 RECHT der unterirdischen Führung, Verlegung, Benützung und
Erhaltung von Leitungen in Gst 1428/1 in EZ 186 für Gst 484
47  a 1053/2011 RECHT der unterirdischen Führung, Verlegung, Benützung und
Erhaltung von Leitungen in Gst 1428/1 in EZ 186 für Gst 484
48  a gelöscht

Section B – ownership structure:

1 ANTEIL: 1/1
Sandoz GmbH
ADR: Biochemiestraße 10, Kundl   6250
a 561/1956 Urkunde und Übergabsvertrag 1956-08-13 Eigentumsrecht
b 1660/2003 Namensänderung

Section C – encumbrances:

3  a 1589/1993
DIENSTBARKEIT der Verlegung, des Betriebes, der Erhaltund
und Erneuerung einer Leitung auf Gst 481/1 gem
Dienstbarkeitsvertrag 1993-04-30 für
Tiroler Ferngas Gesellschaft mbH
b 528/2004 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ
90043
4  a 2463/2009
DIENSTBARKEIT des Gehens und Fahrens auf Gst 478/2 478/3
484 gemäß Punkt VI. Ziffer 1. Kauf- und
Dienstbarkeitsvertrag 2009-10-29
für Gst 477/1 478/1 478/4 1293 in EZ 90030
5  a 672/2011
DIENSTBARKEIT zur Führung, Benützung und Erhaltung von
sechs unterirdischen Niederspannungsleitungen nach Maßgabe
des Punktes II. des Dienstbarkeitsvertrages vom 15.03.2011
in Gst 484 für Gst 59/1 in EZ 275
Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.
Grundbuch 29.07.2015 10:30:15

 

 

Commercial register

 

firm (style)

63      Sandoz GmbH

legal form

1      Gesellschaft mit beschränkter Haftung

registered office

1      politischer Gemeinde Kundl

business adress

15      Biochemiestraße 10
6250 Kundl

capital

52      EUR 32.703.000

reference date annual accounts

1      31. Dezember

annual accounts

139      zum 31.12.2013 eingereicht am 11.09.2014

power of representation

1      Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten.

other provisions

8      Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.
1   Gesellschaftsvertrag  vom 18.11.1965                                001
1   Der Gesellschaftsvertrag wurde mehrfach geändert, zuletzt           002
mit Beschluss der Generalversammlung  vom 23.05.1986
1   Verschmelzungsvertrag  vom 30.05.1972                               003
1   Generalversammlungsbeschluss  vom 19.06.1972                        004
Die Biochemie Kundl Gesellschaft m.b.H., Kundl wurde mit
dieser Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen.
8   Generalversammlungsbeschluss vom 27.06.1994 bzw.                    005
vom 19.07.1994
Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
22   Generalversammlungsbeschluss  vom 30.04.1997                        006
Änderung des Gesellschaftsvertrages im Artikel 1.
32   Verschmelzungsvertrag  vom 01.09.1998                               007
32   Generalversammlungsbeschluss  vom 01.09.1998                        008
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Novartis Handelsgesellschaft m.b.H.
(FN 143149 p)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Wien.
52   Gesellschaftsvertrag mit Generalversammlungsbeschluss               009
vom 25.09.2001
gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 224,62.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Artikeln 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 und 19.
63   Generalversammlungsbeschluss  vom 24.04.2003                        010
Änderung des Gesellschaftsvertrages im Artikel 1.
79   Verschmelzungsvertrag  vom 28.09.2005                               011
79   Generalversammlungsbeschluss  vom 28.09.2005                        012
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Grandis Handel mit pharmazeutischen
Produkten Gesellschaft mbH
(FN 158417 t)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Kundl.
80   Verschmelzungsvertrag  vom 22.12.2005                               013
80   Generalversammlungsbeschluss  vom 22.12.2005                        014
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Sandoz GmbH
(FN 233373 x)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Wien.
87   Einbringungsvertrag  vom 30.01.2006                                 015
Einbringung eines Teilbetriebes in die
Nabriva Therapeutics Forschungs GmbH
(FN 269261 y)
Teilbetrieb: Antibiotic Research Institute
98   Generalversammlungsbeschluss  vom 15.12.2008                        016
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Artikeln 6, 8, 9,
11, 12, 15 und 19.
102   Einbringungsvertrag  vom 21.09.2009                                 017
Einbringung eines Teilbetriebes der
Novartis Institutes for BioMedical
Research GmbH & Co KG
(FN 253505 b)
Teilbetrieb: "TopDerm"
103   Generalversammlungsbeschluss  vom 21.09.2009                        018
Spaltung
103   zur Aufnahme in die                                                 019
Novartis Pharma GmbH
(FN 41622 i)
durch Übertragung
des Teilbetriebes "TopDerm"
gemäß Spaltungs- und Übernahmsvertrag vom 21.09.2009
141   Verschmelzungsvertrag  vom 12.09.2014                               020
141   Generalversammlungsbeschluss  vom 12.09.2014  der                   021
Novartis Animal Health GmbH
(FN 152616 k)
als übertragender Gesellschaft. Verschmelzung mit dieser
Gesellschaft als übernehmender Gesellschaft.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Kundl.

 

 

Proxy

 

CT   Sibylla Härtel, geb. 21.10.1962
26        vertritt seit 01.01.1998 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
CW   Mag. Ingrid Schwarzenberger, geb. 20.03.1958
26        vertritt seit 01.01.1998 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
EC   Mag. Hans-Peter Amon, geb. 19.01.1975
100        vertritt seit 01.02.2009 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
EK   Dipl.-Chem. Michael Kocher, geb. 12.04.1967
122        vertritt seit 23.02.2012 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
EL   Dr. Nikolaus Kofler, geb. 05.12.1968
124        vertritt seit 10.04.2012 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
EM   Dkfm. Michael Friedhofen, geb. 27.08.1967
125        vertritt seit 12.06.2012 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
ES   Dr. Christopher Manuel Mader, geb. 10.04.1973
134        vertritt seit 19.02.2014 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in oder
einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen
EU   Rodrigo Goarmon Pedroso Santos
Ferreira, geb. 10.11.1978
137        vertritt seit 01.06.2014 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in oder
einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

 

supervisory board

 

CX   Helmut Pancheri, geb. 05.07.1961
25        Mitglied
DF   Dr. Josef Egerbacher, geb. 20.11.1958
138        Vorsitzende/r
EA   Barbara Nerad, geb. 30.12.1962
96        Mitglied
EP   Felix Senn, geb. 26.05.1959
132        Mitglied
EQ   Dr. Andreas Brutsche, geb. 17.09.1962
138        Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
EV   Sandrine Charlotte Philippe Piret-
Gerard, geb. 17.10.1975
138        Mitglied

 

managing director

 

BD   Mag. Hubert Hirzinger, geb. 10.05.1957
90        vertritt seit 01.06.2007 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
ER   Dipl.Kfm. Klaus Neumayer, geb. 17.07.1964
133        vertritt seit 01.12.2013 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
ET   Dr. Jens Scheibner, geb. 15.11.1968
136        vertritt seit 01.04.2014 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
EW   Dr. Thomas Nothegger, geb. 11.07.1967
140        vertritt seit 10.09.2014 gemeinsam mit
einem/einer weiteren Geschäftsführer/in oder
einer/einem Prokuristin/Prokuristen
EX   Dr. Konrad Schaefer, geb. 08.10.1960
143        vertritt seit 01.02.2015 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen

 

Shareholder

 

CM   Novartis Holding AG
85        ........................  EUR 3.000
85        ...................................................  EUR 3.000
DW   Novartis Austria GmbH
85        ...................  EUR 32.700.000
85        ..............................................  EUR 32.700.000
-------------------------------------------------------
Summen:          EUR 32.703.000             EUR 32.703.000

 

general table

 

Landesgericht Innsbruck
1 datenersterfasst am 23.09.1993             Geschäftsfall 915 Fr  3046/93 i
Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
8 eingetragen am 04.08.1994                  Geschäftsfall  19 Fr  3050/94 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.07.1994
15 eingetragen am 31.07.1996                  Geschäftsfall  50 Fr  3421/96 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 10.07.1996
18 eingetragen am 22.02.1997                  Geschäftsfall  50 Fr   480/97 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.01.1997
22 eingetragen am 14.06.1997                  Geschäftsfall  50 Fr  3183/97 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.06.1997
25 eingetragen am 24.01.1998                  Geschäftsfall  50 Fr   503/98 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.01.1998
26 eingetragen am 27.01.1998                  Geschäftsfall  50 Fr   356/98 m
Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.01.1998
32 eingetragen am 24.11.1998                  Geschäftsfall  50 Fr  7458/98 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.09.1998
40 eingetragen am 12.01.2000                  Geschäftsfall  50 Fr 15588/99 x
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.12.1999
52 eingetragen am 05.10.2001                  Geschäftsfall  62 Fr  1934/01 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.09.2001
63 eingetragen am 01.05.2003                  Geschäftsfall  62 Fr   914/03 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.04.2003
66 eingetragen am 01.10.2003                  Geschäftsfall  62 Fr  1753/03 t
Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.09.2003
79 eingetragen am 06.10.2005                  Geschäftsfall  62 Fr  1652/05 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.09.2005
80 eingetragen am 11.02.2006                  Geschäftsfall  62 Fr  2534/05 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.12.2005
85 eingetragen am 27.07.2006                  Geschäftsfall  62 Fr  1055/06 t
Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.07.2006
87 eingetragen am 10.10.2006                  Geschäftsfall  62 Fr  1543/06 i
Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.09.2006
90 eingetragen am 06.06.2007                  Geschäftsfall  62 Fr   777/07 t
Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.05.2007
96 eingetragen am 01.08.2008                  Geschäftsfall  62 Fr  1428/08 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.07.2008
98 eingetragen am 19.12.2008                  Geschäftsfall  62 Fr  3130/08 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.12.2008
100 eingetragen am 19.02.2009                  Geschäftsfall  62 Fr   265/09 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.02.2009
102 eingetragen am 29.10.2009                  Geschäftsfall  62 Fr  2202/09 f
Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.09.2009
103 eingetragen am 30.10.2009                  Geschäftsfall  62 Fr  2201/09 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.09.2009
114 eingetragen am 12.10.2010                  Geschäftsfall  62 Fr  2478/10 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.10.2010
122 eingetragen am 16.03.2012                  Geschäftsfall  60 Fr   618/12 m
Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.03.2012
123 eingetragen am 26.04.2012                  Geschäftsfall  60 Fr   963/12 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.04.2012
124 eingetragen am 01.05.2012                  Geschäftsfall  60 Fr  1009/12 m
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.04.2012
125 eingetragen am 11.07.2012                  Geschäftsfall  60 Fr  1826/12 p
Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.07.2012
132 eingetragen am 05.10.2013                  Geschäftsfall  60 Fr  3714/13 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.09.2013
133 eingetragen am 22.01.2014                  Geschäftsfall  60 Fr  5161/13 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.11.2013
134 eingetragen am 05.03.2014                  Geschäftsfall  60 Fr   705/14 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.02.2014
136 eingetragen am 15.05.2014                  Geschäftsfall  60 Fr  1195/14 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.04.2014
137 eingetragen am 11.07.2014                  Geschäftsfall  60 Fr  2187/14 m
Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.07.2014
138 eingetragen am 16.07.2014                  Geschäftsfall  60 Fr  2246/14 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.07.2014
139 eingetragen am 13.09.2014                  Geschäftsfall  60 Fr  3500/14 v
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 11.09.2014
140 eingetragen am 03.10.2014                  Geschäftsfall  60 Fr  3933/14 f
Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.09.2014
141 eingetragen am 08.10.2014                  Geschäftsfall  60 Fr  3725/14 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.09.2014
143 eingetragen am 26.02.2015                  Geschäftsfall  64 Fr   383/15 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.02.2015
144 eingetragen am 28.02.2015                  Geschäftsfall  64 Fr   421/15 d
amtswegige Berichtigung

 

Historical development

 

Year of incorporation

1965

Date of registration

1965-11-26

 

 

Change of company name

 

from

to

company name

 

2003-05-02

Biochemie GmbH

2003-05-02

 

Sandoz GmbH

 

 

Change in share capital

 

from

to

asset

 

 

2001-10-05

ATS

450.000.000,00

2001-10-05

 

EUR

32.703.000,00

 

 

Former executives

 

from

to

position

name

2009-02-19

2010-07-29

chairman of the supervisory board

Dr. Horst Uwe Groh

2010-07-29

2013-10-05

chairman of the supervisory board

Mag. Christian Seiwald

 

2014-07-16

chairman of the supervisory board

Hans Helmut Michael Fabry

1995-06-21

1997-05-16

deputy chairman of the supervisory board

Dr. Daniel Vasella

1999-10-12

2000-11-30

deputy chairman of the supervisory board

Dr. Argeric Karabelas

1997-05-16

2002-03-12

deputy chairman of the supervisory board

Dr. Jörg Reinhardt

2000-11-30

2002-05-30

deputy chairman of the supervisory board

Thomas Ebeling

2002-05-30

2005-04-19

deputy chairman of the supervisory board

Paul Choffat

2005-04-19

2010-07-29

deputy chairman of the supervisory board

Mag. Christian Seiwald

2010-07-29

2012-09-26

deputy chairman of the supervisory board

Christina Ackermann Swistara

 

2013-10-05

deputy chairman of the supervisory board

Peter Goldschmidt

 

2014-07-16

deputy chairman of the supervisory board

Dr. Josef Egerbacher

 

1997-05-16

member of the supervisory board

Dr. Raymund Breu

 

1998-04-18

member of the supervisory board

Daniel Wagniere

1998-04-18

1999-08-06

member of the supervisory board

Dr. Hans Kindler

1997-05-16

1999-08-06

member of the supervisory board

Dr. Erwin Schillinger

1999-08-06

1999-10-12

member of the supervisory board

Dipl-Ing.Dr. Oswald Sellemond

1999-08-06

2001-10-02

member of the supervisory board

Mag. Christian Seiwald

2001-10-02

2002-05-30

member of the supervisory board

Dipl-Ing.Dr. Oswald Sellemond

2002-03-12

2005-07-14

member of the supervisory board

Dr. Urs Bärlocher

2005-07-14

2007-03-16

member of the supervisory board

Kevin Plummer

2002-05-30

2007-06-28

member of the supervisory board

Dr. Erwin Schillinger

1999-08-06

2008-08-01

member of the supervisory board

Hermann Egger

2007-06-28

2008-08-01

member of the supervisory board

Dr. Peter Jager

2008-08-01

2009-03-11

member of the supervisory board

Knut Mager

2009-03-11

2010-04-20

member of the supervisory board

Dr. Andreas Rummelt

2010-04-20

2010-07-29

member of the supervisory board

Christina Ackermann Swistara

2010-07-29

2010-09-22

member of the supervisory board

Dr. Horst Uwe Groh

2007-03-16

2011-06-30

member of the supervisory board

Dipl-Ing.Dr. Heinrich Scherfler

2010-09-22

2012-03-09

member of the supervisory board

Dr. Gerhard Schaefer

 

2013-10-05

member of the supervisory board

Dr. Josef Egerbacher

2011-06-30

2013-10-05

member of the supervisory board

Hans Helmut Michael Fabry

 

2014-07-16

member of the supervisory board

Dr. Andreas Brutsche

 

1998-01-24

employee's representative on the supervisory board

Johann Auer

 

1999-08-06

employee's representative on the supervisory board

Helmuth Stubenvoll

1997-11-07

2002-10-01

joint signing clerk

Dr. Helmut Deimel

1999-04-15

2003-03-19

joint signing clerk

Mag. Gerhard Hörl

1993-09-23

2003-04-29

joint signing clerk

Mag. Bernhard Sigl

1999-08-17

2003-04-29

joint signing clerk

Mag.Dr. Franz Stumpf

2001-10-02

2003-12-18

joint signing clerk

MMag.Dr. Johannes Gerstenbauer

1998-01-27

2003-12-18

joint signing clerk

Mag. Gottfried Rieser

2003-05-06

2004-11-03

joint signing clerk

Mag. Siegfried Johann Leitner

1998-02-02

2005-03-08

joint signing clerk

Peter Haselböck

1993-09-23

2005-03-08

joint signing clerk

Dr. Ernst Leitner

1998-01-27

2006-05-16

joint signing clerk

Dr. Santiago Alonso Ciriza

2004-08-10

2006-05-16

joint signing clerk

Knut Ulrich Mager

2000-03-14

2006-05-16

joint signing clerk

Hans Schaller

1993-09-23

2007-02-09

joint signing clerk

Mag. Rupert Labner

2006-06-23

2007-06-15

joint signing clerk

Lorraine Lynne Christina Perry

2003-10-01

2007-06-15

joint signing clerk

Mag.Dr. Otto Scheidl

2002-07-17

2007-06-15

joint signing clerk

Dr. Elisabeth Schneider Scherzer

1998-04-02

2007-06-15

joint signing clerk

Dr. Bruno Wallnöfer

2000-01-12

2007-06-15

joint signing clerk

Mag. Barbara Weigl Aman

2004-10-06

2008-05-29

joint signing clerk

MBA. Elgar Schnegg

2000-05-31

2009-02-19

joint signing clerk

Kurt Unterkircher

2000-01-12

2010-01-09

joint signing clerk

Dr. Josef Egerbacher

1993-09-23

2010-03-19

joint signing clerk

Mag. Friedrich Fuchs

2008-05-29

2010-06-18

joint signing clerk

Dipl-Betriebsw. Björn Komischke

2006-06-23

2011-02-10

joint signing clerk

Mag. Helmuth Hofer

2001-12-19

2012-05-01

joint signing clerk

Dr. Maria Schmalzl

2010-06-18

2012-09-21

joint signing clerk

Dr. Gerhard van der Meij

1998-01-27

2012-10-17

joint signing clerk

Dr. Elmar Dolejsi

 

2014-03-18

joint signing clerk

Dr. Friedrich Sernetz

1993-05-10

1997-05-16

chairman of the supervisory board

Dr. Urs Bärlocher

1997-05-16

1998-04-18

chairman of the supervisory board

Pierre Douaze

1998-04-18

1999-10-12

chairman of the supervisory board

Dr. Argeric Karabelas

1999-10-12

2001-10-02

chairman of the supervisory board

Dipl-Ing.Dr. Oswald Sellemond

2001-10-02

2002-05-30

chairman of the supervisory board

Mag. Christian Seiwald

2002-05-30

2005-04-19

chairman of the supervisory board

Mag. Christian Seiwald

2005-04-19

2009-02-19

chairman of the supervisory board

Dr. Andreas Rummelt

 

1999-04-13

manager

Dipl-Ing.Dr. Oswald Sellemond

 

2003-04-29

manager

Werner Meßner

2003-04-29

2004-09-01

manager

Mag.Dr. Franz Stumpf

2003-04-29

2005-07-28

manager

Mag. Hubert Hirzinger

2003-04-29

2005-07-28

manager

Dr. Patrick Vink

 

2006-06-03

manager

Dipl-Ing.Dr. Heinrich Scherfler

2004-09-01

2007-06-06

manager

Mag. Johannes Schwertner

2003-04-29

2008-02-21

manager

Mag. Bernhard Sigl

2008-02-21

2010-02-20

manager

Dipl-Ing. Bianca Stöhr

2010-01-09

2012-02-03

manager

Mag. Hannes Teißl

2010-11-13

2012-12-18

manager

Mag. Richard Kronbichler

2010-02-20

2014-01-22

manager

Dr. Peter Gasteiger

2010-01-09

2014-05-15

manager

Dr. Günter Stempfer

2006-06-03

2015-02-24

manager

Dipl-Ing. Ernst Meijinders

1993-09-23

1999-02-16

joint signing clerk

Dr. Paul Inama Sternegg

1998-10-20

1999-04-15

joint signing clerk

Eric Gorka

1993-09-23

2000-09-13

joint signing clerk

Dr. Otto Streichsbier

1993-09-23

2000-10-11

joint signing clerk

Mag. Hubert Hirzinger

1993-09-23

2001-03-13

joint signing clerk

Dr. Eberhard Pirich

1993-09-23

2001-10-02

joint signing clerk

Dr. Walter Killiches

1998-01-27

2002-04-25

joint signing clerk

Mag. Vinzenz Plörer

 

 

Former shareholders

 

from

to

position

name

 

1997-02-22

partner

Sandoz Holding AG

1997-02-22

2000-08-26

partner

Novartis AG

 

Former shareholdings

 

from

to

company name

1996-05-08

1998-11-24

Novartis Handelsgesellschaft m.b.H.

2004-09-16

2004-10-23

Novartis Forschungsinstitut GmbH

2005-01-27

2005-10-06

Grandis Handel mit pharmazeutischen Produkten Gesellschaft mbH

2006-01-24

2007-11-10

Nabriva Therapeutics AG

1993-12-17

2014-05-09

Biozym GmbH in Liqu.

1996-12-03

2014-10-08

Novartis Animal Health GmbH

 

 

Mergers

 

On

position

name

2014-10-08

merged with

Novartis Animal Health GmbH

2006-12-14

merged with

Sandoz GmbH

2005-10-06

merged with

Grandis Handel mit pharmazeutischen Produkten Gesellschaft mbH

2000-11-24

merged with

Novartis Handelsgesellschaft m.b.H.

 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.64.01

UK Pound

1

Rs.99.84

Euro

1

Rs.70.16

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

RAS

 

 

Report Prepared by :

ASH

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.