MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

353069

Report Date :

12.12.2015

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

BOREALIS AGROLINZ MELAMINE GMBH

 

 

Registered Office :

St. Peterstraße 25, A-4021 LINZ

 

 

Financials (as on) :

31.12.2014

 

 

Country :

Austria

 

 

Year of Establishment :

1939

 

 

Legal Form :

Limited Liability Company

 

 

Line of Business :

  • Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds
  • Wholesale of chemical products

 

 

No. of Employee :

706 (2015)

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Good 

 

 

Payment Behaviour :

Regular

 

 

Litigation :

Clear

 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31, 2015

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2014)

Current Rating

(31.03.2015)

Austria

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 

AUSTRIA - ECONOMIC OVERVIEW

 

Austria, with its well-developed market economy, skilled labor force, and high standard of living, is closely tied to other EU economies, especially Germany's. Its economy features a large service sector, a relatively sound industrial sector, and a small, but highly developed agricultural sector. Economic growth was anemic at less than 0.5% in 2013 and 2014, and growth in 2015 is not expected to exceed 0.5%. Austria's 5.6% unemployment rate, while low by European standards, is at an historic high for Austria. Without extensive vocational training programs and generous early retirement, the unemployment rate would be even higher. Public finances have not stabilized even after a 2012 austerity package of expenditure cuts and new revenues. On the contrary, in 2014, the government created a "bad bank" for the troubled nationalized "Hypo Alpe Adria" bank, pushing the budget deficit up by 0.9% of GDP to 2.4% and public debt to 84.5% of the GDP. Although Austria's fiscal position compares favorably with other euro-zone countries, it faces several external risks, such as Austrian banks' continued exposure to Central and Eastern Europe, repercussions from the Hypo Alpe Adria bank collapse, political and economic uncertainties caused by the European sovereign debt crisis, the current crisis in Russia/Ukraine, the recent appreciation of the Swiss Franc, and political developments in Hungary.

 

Source : CIA

 

Company name and address

 

BOREALIS AGROLINZ MELAMINE GMBH

 

St. Peterstraße 25, A-4021 Linz

 

Phone:

(0043) 732 6914

Fax:

(0043) 732 6914 - 3581

Internet:

http://www.borealisgroup.com

 

 

Activities

 

ÖNACE 20150 70% Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds

ÖNACE 46750 30% Wholesale of chemical products

 

 

Financial data

 

Financial details can also be entered during the period, irrespective of the balance sheet date.

 

total turnover (total sales)

2014

EUR

405.809.291,40

(exact)

total turnover (total sales)

2013

EUR

398.042.412,48

(exact)

total turnover (total sales)

2012

EUR

480.882.549,63

(exact)

total turnover (total sales)

2011

EUR

481.640.194,51

(exact)

total turnover (total sales)

2010

EUR

392.767.524,57

(exact)

 

total investments

2014

EUR

12.121.494,89

(exact)

 

total employees

2015

 

706

(exact)

 

 

General company information

 

Company name

Borealis Agrolinz Melamine GmbH

Year of incorporation

1939

Type of company

Manufacturing

Legal form

limited liability company since 1991-09-02

Companies house number

FN 78587 w Linz  since 1991-09-26

Import

Morocco

European Union

Morocco

European Union

2015

2015

2014

2014

Export

world-wide

world-wide

2015

2014

VAT number

ATU 23057607

number - Austrian National Bank

1676423

Last balance sheet:

2014

Banking connection

The Royal Bank of Scotland N.V.

BLZ 19985

main bank connection

Raiffeisen Bank International AG

BLZ 31000

main bank connection

UniCredit Bank Austria AG

BLZ 20151

secondary banking connection

 

 

Locations

 

operational

A-4020 Linz, St. Peter-Str. 25

registered office

operational

A-4021 Linz, St. Peterstraße 25

registered headquarters

 

0043 732 6914

 

operational

A-4021 Linz, PF 21

postbox

 

 

Private data

 

Surname

Date of birth

Address

Executive positions

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Dr. Roland Franzi

1954-01-01

A-4040 Linz

Donaufeldstraße 3

manager

0

Markku Korvenranta

1966-01-26

A-1220 Wien

Wagramerstraße 17-19

manager

2

Hubert Puchner

1954-02-22

A-4040 Linz

Blindwiesen 7

manager

0

Ing.Mag. Ernst Buchner

1959-02-13

A-4210 Gallneukirchen

Loschkeweg 12b

joint signing clerk

2

Herwig Ertel

1962-03-26

A-4064 Oftering

Oberndorf 3

joint signing clerk

0

Thomas Fuschl

1974-08-18

A-4020 Linz

St. Peter-Str. 25(c/o)

joint signing clerk

0

Mag.Dr. Norbert Kehrer

1966-07-19

A-4020 Linz

St. Peterstraße 25(c/o)

joint signing clerk

1

MBA Dipl-Ing.Dr. Gerald Papst

1964-10-29

A-1140 Wien

Lebereckstraße 36

joint signing clerk

1

Mag. Dietmar Remplbauer

1962-09-13

A-4020 Linz

St. Peterstraße 25(c/o)

joint signing clerk

1

Ingo Rendel

1969-10-27

A-4020 Linz

St. Peterstraße 25(c/o)

joint signing clerk

0

Mag. Christian Wiesmeier

1968-11-09

A-4064 Oftering

Kaplanstraße 40

joint signing clerk

1

Martijn Arjen van Koten

1970-02-25

A-1220 Wien

Wagramerstraße 17-19

chairman of the supervisory board

2

Claus Dieter Haar

1956-07-27

A-1020 Wien

Glockengasse 1

deputy chairman of the supervisory board

2

Dipl-Ing.Dr. Johann Berger

1957-08-29

A-2500 Baden

Schimmergasse 15

member of the supervisory board

0

Mario Feyrer

1957-07-03

A-4020 Linz

St. Peterstraße 30(c/o)

member of the supervisory board

0

Christian Kempinger

1961-06-04

A-4020 Linz

St. Peterstraße 25 (c/o)

member of the supervisory board

1

Katja Tautscher

1972-01-02

A-1220 Wien

Wagramerstraße 17-19

member of the supervisory board

2

Dr. Norbert Kehrer

 

A-4021 Linz

St. Peterstraße 25(c/o)

head of accounting

0

 

 

related companies

 

Company name

Address

Shareholdings in %

Since

Commercial register no.

Shares in this company are held by:

Borealis AG

A-1220 Wien

Wagramerstraße 17-19

100 %

2007-09-25

FN 269858 a

 

 

 

This company holds less than 50% of the shares in:

Chemiepark Linz Betriebsfeuerwehr GmbH

A-4021 Linz

St.Peterstraße 25

47,5 %

1999-02-03

FN 178148 h

 

Affiliated companies and further participations:

Borealis Polyolefine GmbH

A-2320 Schwechat

Danubiastraße 21-25

 

 

FN 125430 g

Borealis L.A.T GmbH

A-4020 Linz

St. Peterstraße 25

 

 

FN 257746 p

 

 

Balance Sheet (absolute) all amounts in EUR

 

 

2014-12-31

Intangible assets

914.107,66

Sum intangible assets

914.107,66

 

Tangible assets

249.532.075,00

Sum tangible assets

249.532.075,00

 

Financial assets

62.151.519,63

Sum financial assets

62.151.519,63

 

Sum fixed assets

312.597.702,29

 

Special account stock

34.074,00

Raw-, auxiliary materials and supplies

22.510.832,19

Unfinished products

2.873.266,99

Finished products

22.973.960,67

Sum stock

48.392.133,85

 

Claims from delivered goods and performed services

8.633.662,33

Claims against companies with shareholding relationship

83.358,00

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

35.910.895,99

Other claims and assets

11.380.319,07

Sum claims

56.008.235,39

 

Cash on hand, cheques and bank deposits

1.234.228,81

Sum cash and bank

1.234.228,81

 

Sonstige Aktiva

11.566.315,33

Sum current assets

105.634.598,05

 

Deferred charges

634.210,46

Sum deferred charges

634.210,46

Assets

430.432.826,13

 

Subscribed/declared capital

70.000.000,00

Not committed capital reserves

7.006.209,06

Other reserves

5.866.702,72

Balance sheet profit/balance sheet loss

52.443.131,53

Thereof profit/loss carried forward

8.130.755,06

Sum equity capital

135.316.043,31

 

Other reserves before taxes

11.679.284,13

Sum reserves before taxes

11.679.284,13

 

Reserves for severance pays

23.320.891,00

Reserves for pensions

20.494.890,00

Other reserves

28.765.942,93

Sum reserves

72.581.723,93

 

Liabilities against credit institutes

1.210,68

Liabilities from delivered goods and performed services

45.436.934,72

Liabilities against related firms

152.773.650,82

Liabilities against firm with shareholding relationship

88.807,40

Other liabilities

11.497.059,76

Sum liabilities

209.797.663,38

 

Deferred income

1.058.111,38

Sum deferred income

1.058.111,38

 

Liabilities and shareholders'equity

430.432.826,13

Balance sheet sum

430.432.826,13

 

 

P / L Account (absolute) all amounts in EUR

 

 

2014-12-31

Gross sales

405.809.291,40

Increase or decrease in finished and unfinished goods and in service claims

-2.604.512,18

Other manufacturing costs capitalized

845.852,61

Total turnover or gross profit

404.050.631,83

 

Other operating profits

12.446.642,97

Other operating profits totally

12.446.642,97

 

Special account material costs

-249.893.108,64

Costs for obtained services totally

-249.893.108,64

 

Personnel expenses

-64.053.884,76

Personnel expenses totally

-64.053.884,76

 

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation

-19.752.462,93

Depreciation tangible assets / intangible assets totally

-19.752.462,93

 

Other operating costs

-59.273.516,87

Total costs

-59.273.516,87

 

Operating result totally

23.524.301,60

 

Income from other securities and loans of financial assets

164.044,81

Profits from the retirement of and investment in financial assets  and securities of current assets

27.703.048,00

Interest income, securties income and similar income

4.788,00

Interest and similar disbursements

-2.932.682,81

Financial profits totally

24.939.198,00

 

Results from usual business activity totally

48.463.499,60

 

Taxes on income and profits

-5.286.326,71

Taxes on income and profits totally

-5.286.326,71

 

Annual surplus/annual deficit totally

43.177.172,89

 

Dissolution reserves before taxes

1.135.203,58

Reserves movements totally

1.135.203,58

 

Annual profit/annual loss totally

44.312.376,47

 

Profit and loss carried forward from previous year

8.130.755,06

Transfer of profits totally

8.130.755,06

 

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account

52.443.131,53

 

 

Key ratios

 

 

2014

Cashflow II

62.929.635,82

Debt amortisation period in years

4,46

Bank indebtedness

0,00

Equity capital share in %

34,15

Social capital share

10,17

Fixed assets coverage

61,04

Net profit ratio

11,99

Capital turnover

0,93

Return on investment in %

11,94

Cashflow in % of operating performance

15,57

Cashflow I

68.215.962,53

Gross productivity

6,30

Net productivity

2,40

Operating performance

404.050.631,83

Inventories in % of operating performance

11,97

Gross profit

154.157.523,19

 

 

Commercial register

 

firm (style)

71      Borealis Agrolinz Melamine GmbH

legal form

1      Gesellschaft mit beschränkter Haftung

registered office

1      politischer Gemeinde Linz

business adress

1      St. Peter-Str. 25
4020 Linz

capital

26      EUR 70.000.000

reference date annual accounts

1      31. Dezember

annual accounts

93      zum 31.12.2014 eingereicht am 10.07.2015

consolidated accounts

59      zum 31.12.2006 eingereicht am 18.06.2007

power of representation

1      Bei Geschäftsführermehrheit wird die Gesellschaft durch je
zwei Geschäftsführer oder einem Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten, soferne nicht durch Be-
schluß der Gesellschafter eine andere Vertretungsbefugnis
bestimmt wird.
1   Gesellschaftsvertrag  vom 02.09.1991                                001
1   Die Gesellschaft ist durch Umwandlung der "CHEMIE HOLDING           002
AKTIENGESELLSCHAFT" entstanden.
1   Verschmelzungsvertrag  vom 26.09.1991                               003
1   Generalversammlungsbeschluss  vom 26.09.1991                        004
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Chemie Linz Gesellschaft m.b.H.
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Linz.
1   Generalversammlungsbeschluss  vom 26.09.1991                        005
Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
1   Verschmelzungsvertrag  vom 07.05.1992                               006
1   Generalversammlungsbeschluss  vom 07.05.1992                        007
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
META-Chemie Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Enns.
1   Verschmelzungsvertrag  vom 27.09.1993                               008
1   Generalversammlungsbeschluss  vom 27.09.1993                        009
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Chemserv Industrie Service
Gesellschaft m.b.H.
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Linz.
1   Verschmelzungsvertrag  vom 28.09.1993                               010
1   Generalversammlungsbeschluss  vom 28.09.1993                        011
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Agrolinz Agrarchemikalien
Gesellschaft m.b.H.
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Linz.
3   Sacheinlagevertrag vom 14.03.1994                                   012
Einbringung des Teilbetriebes "Feinchemie" als Sacheinlage
in die Chemie Linz Chemikalien Gesellschaft m.b.H., Linz
(FN 69745 t, LG Linz), künftig: Chemie Linz GmbH
3   Generalversammlungsbeschluss  vom 14.03.1994                        013
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (1).
3   Generalversammlungsbeschluss  vom 14.03.1994                        014
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (1).
4   Sacheinlagevertrag vom 01.04.1994                                   015
Einbringung des Teilbetriebes "Technik" in die
Chemserv Industrie Service Gesellschaft m.b.H., Linz
(FN 68550 i LG Linz)
10   Einbringung des Teilbetriebes "Pflanzenschutz" in die               016
NUFARM Pflanzenschutz GmbH & Co.KG, FN 134778 d.
13   Verschmelzungsvertrag  vom 25.09.1996                               017
13   Generalversammlungsbeschluss  vom 25.09.1996                        018
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Agrarchemikalien Gesellschaft m.b.H.
(FN 56139 h)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Linz.
13   Verschmelzungsvertrag  vom 25.09.1996                               019
13   Generalversammlungsbeschluss  vom 25.09.1996                        020
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Hermann Oder Geschäftsführungs-
gesellschaft m.b.H.
(FN 79788 k)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Linz.
26   Gesellschaftsvertrag mit Generalversammlungsbeschluss               021
vom 07.09.2000
gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.
26   Generalversammlungsbeschluss  vom 07.09.2000                        022
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 597.443,37.
Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
44   Generalversammlungsbeschluss  vom 08.09.2003                        023
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (1).
50   Generalversammlungsbeschluss  vom 04.08.2005                        024
Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
67   Gesellschafterbeschluss  vom 08.08.2008                             025
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Punkten 2., 7.,
10., 11., 13., 14., 17. und 18.
71   Generalversammlungsbeschluss  vom 19.06.2009                        026
Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt 1.
83   Generalversammlungsbeschluss  vom 27.03.2013                        027
Spaltung
83   zur Aufnahme in die                                                 028
LINZER AGRO TRADE GmbH
(FN 257746 p)
durch Übertragung
des Teilbetriebes "Produktionsplanung, -auftragsvergabe und
Vertrieb von Mineraldüngern und technischen Stickstoffpro-
dukten" (Standort St. Peter-Straße 25, 4020 Linz) sowie
der Beteiligung der Borealis Agrolinz Melamine GmbH an der
LINZER AGRO TRADE GmbH im Nominale von EUR 35.000,--
gemäß Spaltungs- und Übernahmsvertrag vom 25.02.2013

 

proxy

AR   Mag. Dietmar Remplbauer, geb. 13.09.1962
33        vertritt seit 01.02.2002 gemeinsam mit
einem kollektivvertretungsbefugten Geschäftsführer oder
einem weiteren Gesamtprokuristen
AW   DI Dr. Gerald Papst, MBA, geb. 29.10.1964
45        vertritt seit 01.01.2004 gemeinsam mit
einem kollektivvertretungsbefugten Geschäftsführer oder
einem weiteren Gesamtprokuristen
BM   Herwig Ertel, geb. 26.03.1962
65        vertritt seit 14.02.2008 gemeinsam mit
einem weiteren Gesamtprokuristen
BQ   Mag. Dr. Norbert Kehrer, geb. 19.07.1966
72        vertritt seit 01.10.2009 gemeinsam mit
einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer oder
einem weiteren Gesamtprokuristen
BY   Thomas Fuschl, geb. 18.08.1974
81        vertritt seit 01.08.2012 gemeinsam mit
einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer oder
einem weiteren Gesamtprokuristen
BZ   Christian Wiesmeier, geb. 09.11.1968
81        vertritt seit 01.08.2012 gemeinsam mit
einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer oder
einem weiteren Gesamtprokuristen
CA   Ingo Rendel, geb. 27.10.1969
84        vertritt seit 18.05.2013 gemeinsam mit
einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer oder
einem weiteren Gesamtprokuristen
CD   Ing. Mag. Ernst Buchner, geb. 13.02.1959
88        vertritt seit 01.04.2014 gemeinsam mit
einem/einer kollektivvertretungsbefugten Geschäfts-
führer/in oder einer/einem weiteren Gesamtprokuristin/
Gesamtprokuristen

 

supervisory board

AG   Christian Kempinger, geb. 04.06.1961
56        Mitglied
BT   Katja Tautscher, geb. 02.01.1972
75        Mitglied
BV   Claus Dieter Haar, geb. 27.07.1956
92        Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
CC   Martijn Arjel Van Koten, geb. 25.02.1970
92        Vorsitzende/r
CE   Mario Feyrer, geb. 03.07.1957
89        Mitglied
CF   Johann Berger, geb. 29.08.1957
92        Mitglied

 

managing director

BD   Hubert Puchner, geb. 22.02.1954
78        vertritt seit 01.09.2011 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
BU   Markku Korvenranta, geb. 26.01.1966
91        vertritt seit 06.08.2014 gemeinsam mit
einem/einer weiteren Geschäftsführer/in oder
einer/einem Prokuristin/Prokuristen
CB   Dr. Roland Franzi, geb. 01.01.1954
86        vertritt seit 01.10.2013 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen

 

shareholder

BE   Borealis AG
60        ...................  EUR 70.000.000
60        ..............................................  EUR 70.000.000
-------------------------------------------------------
Summen:          EUR 70.000.000             EUR 70.000.000

 

general table

Landesgericht Linz
1 Ersterfassung abgeschlossen am 10.02.1994  Geschäftsfall 913 Fr   187/94 s
Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
3 eingetragen am 19.03.1994                  Geschäftsfall  17 Fr   406/94 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.03.1994
4 eingetragen am 01.06.1994                  Geschäftsfall  17 Fr  1430/94 f
Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.05.1994
eingetragen am 01.06.1994                  Geschäftsfall  17 Fr  1595/94 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.05.1994
7 eingetragen am 20.12.1994                  Geschäftsfall  17 Fr  5670/94 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.12.1994
10 eingetragen am 11.07.1995                  Geschäftsfall  12 Fr  2886/95 v
amtswegige Nachbearbeitung
eingetragen am 11.07.1995                  Geschäftsfall  12 Fr  2896/95 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.07.1995
13 eingetragen am 09.11.1996                  Geschäftsfall  12 Fr  5189/96 p
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.09.1996
eingetragen am 09.11.1996                  Geschäftsfall  12 Fr  5190/96 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.09.1996
26 eingetragen am 19.10.2000                  Geschäftsfall  13 Fr  3466/00 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.09.2000
33 eingetragen am 24.05.2002                  Geschäftsfall  13 Fr  2178/02 p
Antrag auf Änderung  eingelangt am 15.05.2002
44 eingetragen am 02.10.2003                  Geschäftsfall  13 Fr  3517/03 t
Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.09.2003
45 eingetragen am 04.02.2004                  Geschäftsfall  13 Fr   327/04 i
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.01.2004
50 eingetragen am 23.08.2005                  Geschäftsfall  13 Fr  4201/05 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.08.2005
55 eingetragen am 19.01.2007                  Geschäftsfall  13 Fr   212/07 t
Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.01.2007
56 eingetragen am 08.02.2007                  Geschäftsfall  13 Fr   115/07 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.01.2007
59 eingetragen am 07.07.2007                  Geschäftsfall  13 Fr  2537/07 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.06.2007
60 eingetragen am 25.09.2007                  Geschäftsfall  13 Fr  3593/07 p
Antrag auf Änderung  eingelangt am 27.08.2007
65 eingetragen am 05.04.2008                  Geschäftsfall  13 Fr  1553/08 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.04.2008
67 eingetragen am 26.09.2008                  Geschäftsfall  13 Fr  3580/08 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.08.2008
71 eingetragen am 07.07.2009                  Geschäftsfall  13 Fr  2634/09 x
Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.06.2009
72 eingetragen am 14.11.2009                  Geschäftsfall  13 Fr  6312/09 f
Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.11.2009
75 eingetragen am 19.11.2010                  Geschäftsfall  13 Fr  6585/10 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.11.2010
76 eingetragen am 08.06.2011                  Geschäftsfall  13 Fr  3916/11 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 31.05.2011
78 eingetragen am 16.12.2011                  Geschäftsfall  29 Fr   469/11 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.10.2011
81 eingetragen am 14.09.2012                  Geschäftsfall  29 Fr  2444/12 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 06.09.2012
83 eingetragen am 01.05.2013                  Geschäftsfall  13 Fr  1005/13 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.03.2013
84 eingetragen am 05.07.2013                  Geschäftsfall  13 Fr  2677/13 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.07.2013
86 eingetragen am 15.11.2013                  Geschäftsfall  13 Fr  6693/13 a
Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.11.2013
87 eingetragen am 21.02.2014                  Geschäftsfall  13 Fr   274/14 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.01.2014
88 eingetragen am 17.04.2014                  Geschäftsfall  13 Fr  1389/14 i
Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.04.2014
89 eingetragen am 24.04.2014                  Geschäftsfall  13 Fr  1522/14 f
Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.04.2014
91 eingetragen am 04.09.2014                  Geschäftsfall  13 Fr  3923/14 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.08.2014
92 eingetragen am 16.04.2015                  Geschäftsfall  13 Fr  1398/15 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.04.2015
93 eingetragen am 14.07.2015
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 10.07.2015

 

 

Historical development

 

Year of incorporation

1939

Date of registration

1991-09-26

 

 

Change of company name

 

from

to

company name

 

2003-10-02

Agrolinz Melamin GmbH

2003-10-02

2009-07-07

AMI Agrolinz Melamine International GmbH

2009-07-07

 

Borealis Agrolinz Melamine GmbH

 

 

Change in share capital

 

from

to

asset

 

 

2000-10-19

ATS

955.000.000,00

2000-10-19

 

EUR

70.000.000,00

 

 

 

Former executives

 

from

to

position

name

 

1998-10-14

manager

Mag.Dr. Franz Wurm

 

2001-02-07

manager

Dipl-Vw Günther Schwarz

2007-01-19

2007-12-07

manager

Hubert Puchner

 

2015-04-16

deputy chairman of the supervisory board

Martijn Arjen van Koten

 

2000-05-27

member of the supervisory board

Christian Kempinger

2011-06-08

2015-04-16

member of the supervisory board

Claus Dieter Haar

2007-12-28

2009-03-27

joint signing clerk

Hubert Puchner

2000-05-27

2002-11-08

manager

Dr. Walter Hatak

 

2000-05-27

member of the supervisory board

Dr. Walter Hatak

 

2005-02-11

manager

Dipl-Ing. Gerhard Ketscher

 

1999-08-12

joint signing clerk

Helmut Ilk

2002-05-08

2007-02-08

chairman of the supervisory board

Mag.Dr. Wolfgang Ruttenstorfer

2000-05-27

2002-05-08

deputy chairman of the supervisory board

Mag.Dr. Wolfgang Ruttenstorfer

 

1997-10-16

chairman of the supervisory board

Mag.Dr. Wolfgang Ruttenstorfer

2007-02-08

2008-03-07

chairman of the supervisory board

Dr. Gerhard Roiss

2002-05-08

2005-09-30

deputy chairman of the supervisory board

Dr. Gerhard Roiss

2000-06-14

2002-05-08

member of the supervisory board

Dr. Gerhard Roiss

1997-10-15

2000-06-14

chairman of the supervisory board

Dr. Gerhard Roiss

2009-01-03

2012-09-14

joint signing clerk

Ing. Wolfgang Haider

2009-03-27

2010-02-06

deputy chairman of the supervisory board

Dr. Alfred Stern

2010-02-06

2010-11-19

member of the supervisory board

Dr. Alfred Stern

2007-12-28

2011-12-16

joint signing clerk

Dipl-Ing. Rainer Höfling

2007-12-28

2009-11-14

joint signing clerk

Rainer Van Haver

2009-11-14

2012-09-14

joint signing clerk

Dr. Christian Schatz

2001-02-07

2007-06-22

manager

Dr. Joachim Grill

2000-04-29

2001-02-07

joint signing clerk

Dr. Joachim Grill

2004-02-18

2007-10-27

manager

Dr. Günther Tappeiner

2007-12-28

2009-03-27

joint signing clerk

Dr. Günther Tappeiner

2007-12-07

2009-03-27

manager

Dr. Martin Kuzaj

 

2013-11-15

manager

Ing. Louis Desal

 

2013-08-09

joint signing clerk

John Webster

2008-03-07

2009-03-27

chairman of the supervisory board

Mark Garrett

2007-10-12

2008-03-07

member of the supervisory board

Mohamed Al Mehairi

2008-03-07

2009-03-27

member of the supervisory board

Daniel James Shook

2009-03-27

2015-04-16

chairman of the supervisory board

Herbert Willerth

2008-03-07

2009-03-27

deputy chairman of the supervisory board

Herbert Willerth

 

1997-10-16

deputy chairman of the supervisory board

Dipl-Ing.Dr. Richard Schenz

2000-05-27

2000-06-14

member of the supervisory board

Dipl-Ing.Dr. Richard Schenz

2000-06-14

2002-05-08

chairman of the supervisory board

Dipl-Ing.Dr. Richard Schenz

2005-09-30

2007-10-12

deputy chairman of the supervisory board

Mohamed Nasser Al Khaily

2007-10-12

2008-03-07

deputy chairman of the supervisory board

Khadem Al Qubaisi

2005-09-30

2007-10-12

member of the supervisory board

Khadem Al Qubaisi

2010-02-06

2011-06-08

deputy chairman of the supervisory board

Gerd Löbbert

2011-06-08

2014-02-21

deputy chairman of the supervisory board

Markuu Korvenranta

2010-11-19

2011-06-08

member of the supervisory board

Markuu Korvenranta

 

2000-05-27

member of the supervisory board

Dr. Johann Risak

 

2002-10-12

member of the supervisory board

Dipl-Ing. Rudolf Strasser

1997-04-10

2000-05-27

member of the supervisory board

Dr. Heinrich Georg Stahl

2002-05-08

2005-09-30

member of the supervisory board

Dipl-Ing.Mag. Helmut Langanger

2007-02-08

2008-03-07

member of the supervisory board

Mohamed Abdulla Al Azdi

2002-10-12

2008-03-07

member of the supervisory board

David Charles Davies

1994-06-01

2008-03-07

member of the supervisory board

Hugo Pleckinger

2007-02-08

2008-03-07

member of the supervisory board

John Jeffrey Taylor

2009-03-27

2010-11-19

member of the supervisory board

Philippe Roodhooft

1994-06-01

2014-04-24

member of the supervisory board

Karl Leonhartsberger

 

1999-08-12

joint signing clerk

Dipl-Ing. Herbert Schäffer

 

2000-06-01

joint signing clerk

Ing. Karl Nitsche

2000-04-29

2000-12-06

joint signing clerk

MMag.Dr. Peter Roman Zheden

 

2001-03-29

joint signing clerk

Edmund Wiesmayr

 

2001-08-02

joint signing clerk

Dr. Roland Gahler

 

2003-01-08

joint signing clerk

Dipl-Ing. Johann Grausam

 

2002-06-07

joint signing clerk

Dipl-Ing.Dr. Werner Czysch

2002-05-24

2002-08-27

joint signing clerk

Dipl-Ing.Dr. Werner Auer

 

2003-08-07

joint signing clerk

Dr. Dietfried Geissler

 

2004-02-04

joint signing clerk

Dipl-Ing. Friedrich Wimmer

2003-09-18

2006-06-21

joint signing clerk

Armin Stein

2003-08-07

2007-06-27

joint signing clerk

Dipl-Betriebsw. Stefan Sommer

2002-05-24

2007-07-07

joint signing clerk

Dr. Horst König

1999-08-12

2007-12-28

joint signing clerk

Mag. Gerald Kappes

 

2009-11-14

joint signing clerk

Erich Obereder

 

 

Former shareholders

 

from

to

position

name

birth date

1991-09-26

2000-04-29

partner

Mag. Burkhard Guth

1943-08-07

2000-04-29

2002-10-12

partner

Dr. Jürg Cabjolsky

1941-12-05

2002-10-12

2005-09-06

partner

Mag.Dr. Wolfgang Baumann

1958-03-02

1994-02-10

2007-09-25

partner

OMV Aktiengesellschaft

 

2005-08-23

2007-09-25

partner

International Petroleum Investment Company

 

 

 

Former shareholdings

 

from

to

company name

 

1996-10-17

"Terrakult" Grundverwertung und Liegenschafts Gesellschaft m.b.H.

 

1996-11-09

Agrarchemikalien Gesellschaft m.b.H.

 

1996-11-09

Hermann Oder Geschäftsführungsgesellschaft m.b.H.

2005-01-25

2013-05-01

Borealis L.A.T GmbH

 

1994-12-24

Bauprodukte Gesellschaft m.b.H. in Liquidation

1995-06-22

1999-08-11

NUFARM GmbH

1994-03-08

2004-04-27

Venture Finanzierungs- gesellschaft m.b.H. in Liqu.

1994-01-29

2007-01-13

GWCL Wohnungsgesellschaft mbH

 

1996-12-21

Hermann Oder Gesellschaft m.b.H. & Co. Kommanditgesellschaft

1995-07-26

1999-10-13

NUFARM GmbH & Co.KG

 

1991-10-17

Chemie Linz Gesellschaft m.b.H.

 

1994-01-01

btF biotechnologische Forschungsgesellschaft m.b.H. in Liquidation

 

 

Mergers

 

On

position

name

1993-10-12

merged with

Agrolinz Agrarchemikalien Gesellschaft m.b.H.

2006-04-11

merged with

Hermann Oder Gesellschaft m.b.H. & Co. Kommanditgesellschaft

2005-09-23

merged with

Agrarchemikalien Gesellschaft m.b.H.

 

 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.66.79

UK Pound

1

Rs.101.10

Euro

1

Rs.73.10

EUR

1

Rs. 73.81

Note : Above are approximate rates obtained from sources believed to be correct

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

HEE

 

 

Report Prepared by :

ASH

 


 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.