MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

354503

Report Date :

19.12.2015

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

DOKA GMBH

 

 

Registered Office :

Josef Umdaschplatz 1, A-3300 Amstetten

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

31.12.2014

 

 

Year of Establishment :

28.04.1958

 

 

Legal Form :

Limited Liability Company

 

 

Line of Business :

  • Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment
  • Wholesale of construction materials and sanitary equipment

 

 

No. of Employee :

1629 (2015)

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

A

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

Fairly Large

 

Status :

Good 

 

 

Payment Behaviour :

Regular

 

 

Litigation :

Clear

 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31, 2015

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2014)

Current Rating

(31.03.2015)

Austria

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 

AUSTRIA - ECONOMIC OVERVIEW

 

Austria, with its well-developed market economy, skilled labor force, and high standard of living, is closely tied to other EU economies, especially Germany's. Its economy features a large service sector, a relatively sound industrial sector, and a small, but highly developed agricultural sector. Economic growth was anemic at less than 0.5% in 2013 and 2014, and growth in 2015 is not expected to exceed 0.5%. Austria's 5.6% unemployment rate, while low by European standards, is at an historic high for Austria. Without extensive vocational training programs and generous early retirement, the unemployment rate would be even higher. Public finances have not stabilized even after a 2012 austerity package of expenditure cuts and new revenues. On the contrary, in 2014, the government created a "bad bank" for the troubled nationalized "Hypo Alpe Adria" bank, pushing the budget deficit up by 0.9% of GDP to 2.4% and public debt to 84.5% of the GDP. Although Austria's fiscal position compares favorably with other euro-zone countries, it faces several external risks, such as Austrian banks' continued exposure to Central and Eastern Europe, repercussions from the Hypo Alpe Adria bank collapse, political and economic uncertainties caused by the European sovereign debt crisis, the current crisis in Russia/Ukraine, the recent appreciation of the Swiss Franc, and political developments in Hungary.

 

Source : CIA

 

Company name and address

 

DOKA GMBH

 

Josef Umdaschplatz 1, A-3300 Amstetten

 

Phone:

(0043) 7472 605

Fax:

(0043) 7472 64430

E-mail:

oest.doka@doka.com

Internet:

http://www.doka.com

 

 

Activities

 

ÖNACE 46732 80% Wholesale of construction materials and sanitary equipment

ÖNACE 77320 20% Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment

 

 

Financial data

 

Financial details can also be entered during the period, irrespective of the balance sheet date.

 

total turnover (total sales)

2014

EUR

359.422.031,55

(exact)

total turnover (total sales)

2013

EUR

50.486.703,31

(exact)

total turnover (total sales)

2012

EUR

173.843.602,15

(exact)

total turnover (total sales)

2011

EUR

188.671.732,30

(exact)

total turnover (total sales)

2010

EUR

170.031.005,59

(exact)

 

total investments

2014

EUR

27.295.084,80

(exact)

 

total employees

2015

 

1629

(approx.)

 

 

General company information

 

Company name

DOKA GMBH

Year of incorporation

1958

Type of company

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles

Legal form

limited liability company since 1958-04-28

Companies house number

FN 105743 f St. Pölten  since 1958-05-06

Export

world-wide

world-wide

2015

2014

VAT number

ATU 36871104

number - Austrian National Bank

30660

Last balance sheet:

2014

Banking connection

UniCredit Bank Austria AG

BLZ 12000

main bank connection

Oberbank AG

BLZ 15000

main bank connection

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

BLZ 20111

secondary banking connection

Raiffeisen Bank International AG

BLZ 31000

secondary banking connection

 

 

Locations

 

operational

A-3300 Amstetten, Josef-Umdasch-Platz 1

registered office, rented premises

operational

A-3300 Amstetten, Josef Umdaschplatz 1, umbenannt v. Reichstr. 23

registered headquarters, rented premises

 

0043 7472 605

oest.doka@doka.com

former

A-3300 Amstetten, Reichsstraße 23

registered office

former

A-3300 Amstetten, Reichsstraße 23

registered headquarters

former

A-9020 Klagenfurt, Primoschgasse 18

branch office

former

A-5303 Thalgau, Plainfelderstraße 17

branch office

former

A-6401 Inzing, Schießstand 7

branch office

former

A-1140 Wien, Zimbagasse 3

branch office

former

A-8055 Graz Puntigam, Mühlfelderweg 24

branch office

former

A-4614 Marchtrenk, Ritzstraße 10

branch office

former

A-9541 Äussere Einöde, Primoschgasse 18

branch office

former

A-5303 Thalgau, Enzersberg 159

branch office

former

A-3372 Blindenmarkt, Ennsbach 110

factory

 

 

Private data

 

Surname

Date of birth

Address

Executive positions

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Dipl.-Ing.(FH) Helmut Jürgen Obiegli

1954-10-07

A-3300 Amstetten (NÖ)

Josef-Umdasch-Platz 1

manager

2

Dkfm. Gerd Pechura

1958-10-13

D-88085 Langenargen

Wiesenweg 14

manager head of accounting

10

Dipl-Ing. Ludwig Pekarek

1970-05-13

A-4020 Linz

Pillweinstraße 43

manager

0

Dipl-Ing. Martin Bruderhofer

1975-10-02

A-3300 Amstetten (NÖ)

Südhangsiedlung 4

joint signing clerk

0

Dr. Christoph Haring

1974-03-06

A-4020 Linz

Andreas Hoferplatz 11

joint signing clerk

0

Dipl-Ing. Werner Hillinger

1960-11-19

A-3300 Amstetten

Austraße 32

joint signing clerk

0

Ing. Franz Hochholzer

1967-07-07

A-3363 Neufurth

Krokeschwalddtraße 12

joint signing clerk

1

Mag. Josef Hochstöger

1955-06-02

A-3300 Amstetten (NÖ)

Grünlandstraße 2

joint signing clerk

0

Mag. Kurt König

1961-08-25

A-3300 Amstetten

Johann Blaschkestraße 22

joint signing clerk

1

Ing. Christian Mayr

1970-11-17

A-3300 Amstetten

Austraße 38

joint signing clerk

0

Ing.M.Sc. Alois Oberleitner

1965-03-01

A-3325 Ferschnitz

Freidegg 111

joint signing clerk

0

Ing. Johann Peneder

1966-02-13

A-3325 Ferschnitz

Truckenstetten 7

joint signing clerk

0

Mag. Werner Pfleger

1969-04-26

A-3311 Zeillern

Friedhofstraße 445

joint signing clerk

0

Mag. Christian Pum

1961-08-12

A-4210 Gallneukirchen

Franz Nowotnystraße 3

joint signing clerk

1

Dr. Werner Reicher

1957-04-19

A-4050 Traun

Traunerstraße 35B

joint signing clerk

1

Dipl-Ing. Peter Reisinger

1963-09-14

A-3300 Amstetten

Elsa Brandströmstraße 20

joint signing clerk

0

Ing. Herbert Ritt

1955-12-23

A-3353 Biberbach

Nr. 204

joint signing clerk

0

Dipl-Ing. Kurt Steindl

1971-12-01

A-4391 Waldhausen im Strudengau

Schlossberg 84

joint signing clerk

0

Dr. Hartmut Weller

1953-01-25

A-3300 Amstetten

Leopoldine Pelzlstraße 3

joint signing clerk

0

Dipl-Ing. Alfred Wolfschwenger

1969-12-27

A-4491 Niederneukirchen

Mitterberg 6

joint signing clerk

1

Dr. Paolo Zumaglini

1957-10-10

A-3300 Amstetten

Josef Umdaschplatz 1

joint signing clerk

0

Hilde Umdasch

1943-01-02

A-3300 Amstetten

Südhangstraße 92

chairman of the supervisory board

7

Alfred Umdasch

1937-08-21

A-3300 Amstetten

Nepomukplatz 1

deputy chairman of the supervisory board

8

Dr. Jörg Jakobljevich

1958-05-05

A-1010 Wien

Seilerstätte 16

member of the supervisory board

31

Andreas Schauer

1964-04-26

A-3680 Persenbeug

Hagsdorf 31

member of the supervisory board

0

Josef Steinböck

1961-03-16

A-3251 Purgstall Erlauf

Kirchenstraße 26

member of the supervisory board

0

Mag.Dr. Reinhold Süßenbacher

1949-05-02

A-4651 Stadl Paura

Maximilian Paglstraße 44

member of the supervisory board

9

Elfriede Roseneder

 

A-3300 Amstetten

Josef Umdaschplatz 1(c/o)

head of marketing

0

Mag. Josef Hochstöger

 

A-3300 Amstetten

Josef Umdaschplatz 1 (c/o)(c/o)

head of EDP

0

Mag. Kurt König

 

A-3300 Amstetten

Reichsstraße 23 (c/o)

head of personnel

0

 

 

related companies

 

Company name

Address

Shareholdings in %

Since

Commercial register no.

Shares in this company are held by:

Umdasch Group AG

A-3300 Amstetten

Josef Umdaschplatz 1

100 %

1994-06-30

FN 101743 y

 

This company holds 100% of the shares in:

DOKA Beteiligungs-GmbH

A-3300 Amstetten

Josef Umdaschplatz 1

100 %

2011-05-26

FN 363552 k

FORM-ON GmbH

A-3300 Amstetten

Josef Umdaschplatz 1

100 %

2012-07-24

FN 383219 h

Doka Österreich GmbH

A-3300 Amstetten

Josef Umdaschplatz 1

100 %

2008-07-02

FN 312874 i

 

 

 

Affiliated companies and further participations:

Mitropex GmbH

A-3300 Amstetten

Josef Umdasch Platz 1

 

 

FN 163847 b

Alpex Beteiligungs GmbH

A-3300 Amstetten

Josef Umdaschplatz 1

 

 

FN 178759 g

MMiT Retail GmbH

A-4040 Linz

Blütenstraße 21/67

 

 

FN 436090 i

Umdasch Shopfitting Group GmbH

A-3300 Amstetten

Josef Umdaschplatz 1

 

 

FN 99376 t

Umdasch Metallfertigung GmbH

A-8430 Leibnitz

Ottokar Kernstockgasse 16

 

 

FN 35797 v

Umdasch Immobilien GmbH

A-3300 Amstetten

Josef Umdaschplatz 1

 

 

FN 377288 k

 

 

Financials

 

Balance Sheet (absolute) all amounts in EUR

 

 

2014-12-31

Other tangible assets

176.308,00

Other operating and business equipment

66.391,00

Sum tangible assets

242.699,00

 

Shares on related firms

278.871.392,00

Sum financial assets

278.871.392,00

 

Sum fixed assets

279.114.091,00

 

Special account stock

14.950.794,45

Finished products

11.090.058,36

Sum stock

26.040.852,81

 

Claims from delivered goods and performed services

4.939.423,58

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

40.000.874,71

Other claims and assets

18.680.693,90

Sum claims

63.620.992,19

 

Cash on hand, cheques and bank deposits

1.658.400,74

Sum cash and bank

1.658.400,74

 

Sum current assets

91.320.245,74

 

Deferred charges

703.104,27

Sum deferred charges

703.104,27

Assets

371.137.441,01

 

Subscribed/declared capital

1.000.000,00

Not committed capital reserves

55.406.668,94

Legal reserves

100.000,00

Free reserves

30.000.000,00

Balance sheet profit/balance sheet loss

13.921.871,69

Thereof profit/loss carried forward

137.984,75

Sum equity capital

100.428.540,63

 

Other reserves before taxes

384.876,13

Sum reserves before taxes

384.876,13

 

Reserves for severance pays

7.957.000,00

Tax reserves

74.000,00

Other reserves

10.833.000,00

Sum reserves

18.864.000,00

 

Liabilities against credit institutes

117.090.829,33

Received advanced payments for orders

1.041.384,82

Liabilities from delivered goods and performed services

2.562.303,40

Liabilities against related firms

126.756.196,39

Other liabilities

4.009.310,31

Sum liabilities

251.460.024,25

 

Liabilities and shareholders'equity

371.137.441,01

Contingent liabilities

6.835.804,32

Balance sheet sum

371.137.441,01

 

 

P / L Account (absolute) all amounts in EUR

 

 

2014-12-31

Gross sales

359.422.031,55

Total turnover or gross profit

359.422.031,55

 

Profits from retirement of fixed assets, except financial assets

1.929,44

Income from dissolution of reserves

12.000,00

Other operating profits

9.022.371,30

Other operating profits totally

9.036.300,74

 

Costs for obtained services

-15.708.341,45

Material costs

-280.377.081,93

Costs for obtained services totally

-296.085.423,38

 

Wages

-728.968,04

Salaries

-32.558.102,93

Costs for severance pays

-1.400.113,40

Costs for old age pension

-120.829,24

Legal fringe benefits and other payments depending on salaries

-8.472.541,62

Other social fringe benefits

-46.101,56

Personnel expenses totally

-43.326.656,79

 

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation

-46.773,95

Depreciation tangible assets / intangible assets totally

-46.773,95

 

Other operating costs

-32.349.442,98

Total costs

-32.349.442,98

 

Operating result totally

-3.349.964,81

 

Income from other securities and loans of financial assets

36.465.942,38

Interest income, securties income and similar income

1.349.614,36

Profits from the retirement of and investment in financial assets

8.566.646,00

Disbursements from other financial assets and from securities of current assets (e.g. depreciations)

-26.073.605,85

Interest and similar disbursements

-2.074.258,38

Financial profits totally

18.234.338,51

 

Results from usual business activity totally

14.884.373,70

 

Taxes on income and profits

-1.051.357,74

Taxes on income and profits totally

-1.051.357,74

 

Annual surplus/annual deficit totally

13.833.015,96

 

Transfer to profit reserves

-49.129,02

Reserves movements totally

-49.129,02

 

Annual profit/annual loss totally

13.783.886,94

 

Profit and loss carried forward from previous year

137.984,75

Transfer of profits totally

137.984,75

 

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account

13.921.871,69

 

 

Key ratios

 

 

2014

Cashflow II

13.879.789,91

Debt amortisation period in years

19,28

Bank indebtedness

31,54

Equity capital share in %

27,23

Social capital share

2,14

Fixed assets coverage

38,96

Net profit ratio

4,14

Capital turnover

0,96

Return on investment in %

4,56

Cashflow in % of operating performance

3,86

Cashflow I

14.931.147,65

Gross productivity

8,29

Net productivity

1,46

Operating performance

359.422.031,55

Inventories in % of operating performance

7,24

Gross profit

63.336.608,17

 

Land Register

 

Note

No real estate property registered

 

 

Commercial register

 

firm (style)

28      Doka GmbH

legal form

1      Gesellschaft mit beschränkter Haftung

registered office

1      politischer Gemeinde Amstetten

business adress

27      Josef-Umdasch-Platz 1
3300 Amstetten (NÖ)

capital

55      EUR 1.000.000

reference date annual accounts

1      31. Dezember

annual accounts

63      zum 31.12.2014 eingereicht am 26.08.2015

power of representation

59      Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen
bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam
oder durch eine/n von ihnen gemeinsam mit einer/einem
Prokuristin/Prokuristen vertreten.
1   Gesellschaftsvertrag  vom 28.04.1958                                001
1   Generalversammlungsbeschluss  vom 07.12.1970                        002
Kapitalerhöhung um ATS 6.000.000,--.
Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt 3.
und Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
1   Der Gesellschaftsvertrag wurde mehrfach geändert, zuletzt           003
mit Beschluss der Generalversammlung  vom 27.12.1989
28   Generalversammlungsbeschluss  vom 20.06.2008                        004
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Punkten 1. und 2.
47   Einbringungsvertrag  vom 19.06.2013                                 005
Einbringung eines Teilbetriebes in die
Doka Österreich GmbH
(FN 312874 i)
Teilbetrieb: Vertrieb Österreich
55   Gesellschaftsvertrag mit Generalversammlungsbeschluss               006
vom 09.09.2014
gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.
55   Generalversammlungsbeschluss  vom 09.09.2014                        007
Kapitalerhöhung um EUR 491.290,16.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Punkten 1., 4.,
5., 6. und 7.
56   Verschmelzungsvertrag  vom 09.09.2014                               008
56   Generalversammlungsbeschluss  vom 09.09.2014                        009
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Doka Industrie GmbH
(FN 104172 w)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Amstetten.
58   Erwerb des vertraglich definierten Geschäftsbereiches               010
Produktion und Vertrieb von Schalungsplatten der
WIEHAG GmbH mit dem Sitz in Altheim (FN 115499 b)
mit Kaufvertrag vom 16.04.2015
58   Haftungsausschluss gemäß § 38 UGB                                   011
für die Verbindlichkeiten sowie die gemäß Punkt 2. und
Punkt 3. des Kaufvertrages vom 16.04.2015 nicht
übernommenen Rechtsverhältnisse
59   Generalversammlungsbeschluss  vom 25.06.2015                        012
Spaltung zur Aufnahme eines Vermögensteiles der
UMDASCH AG
(FN 101743 y)
und zwar
des Teilbetriebes des operativen Produktionsbetriebes sowie
der zentralen Supportfunktionen
gemäß Spaltungs- und Übernahmsvertrag
vom 25.06.2015
59   Generalversammlungsbeschluss  vom 25.06.2015                        013
Neufassung des Gesellschaftsvertrages

 

proxy

L   Ing. Franz Hochholzer, geb. 07.07.1967
13        vertritt seit 01.01.2002 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
M   Dipl.Ing. Peter Reisinger, geb. 14.09.1963
14        vertritt seit 01.10.2002 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
S   Dipl.-Ing. Alfred Wolfschwenger, geb. 27.12.1969
29        vertritt seit 01.07.2008 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
T   Dr. Hartmut Weller, geb. 25.01.1953
44        vertritt seit 16.04.2012 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
W   Mag. Werner Pfleger, geb. 26.04.1969
39        vertritt seit 01.01.2012 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
X   Dipl.-Ing. Kurt Steindl, geb. 01.12.1971
42        vertritt seit 01.02.2012 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
Y   Dr. Christoph Haring, geb. 06.03.1974
46        vertritt seit 02.04.2013 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
AA   Mag. Christian Pum, geb. 12.08.1961
64        vertritt seit 01.10.2015 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in oder
einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen
AE   Ing. Johann Peneder, geb. 13.02.1966
56        vertritt seit 09.09.2014 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in oder
einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen
AF   Dipl.-Ing. Werner Hillinger, geb. 19.11.1960
56        vertritt seit 09.09.2014 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in oder
einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen
AG   Ing. Christian Mayr, geb. 17.11.1970
56        vertritt seit 09.09.2014 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in oder
einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen
AH   Dipl.-Ing. Martin Bruderhofer, geb. 02.10.1975
56        vertritt seit 09.09.2014 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in oder
einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen
AN   Ing. Herbert Ritt, geb. 23.12.1955
60        vertritt seit 01.07.2015 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in oder
einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen
AO   Mag. Kurt König, geb. 25.08.1961
60        vertritt seit 01.07.2015 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in oder
einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen
AP   Ing. M.Sc. Alois Oberleitner, geb. 01.03.1965
60        vertritt seit 01.07.2015 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in oder
einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen
AQ   Mag. Josef Hochstöger, geb. 02.06.1955
60        vertritt seit 01.07.2015 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in oder
einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen
AR   Dr. Werner Reicher, geb. 19.04.1957
60        vertritt seit 01.07.2015 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in oder
einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen
AS   Dr. Paolo Zumaglini, geb. 10.10.1957
64        vertritt seit 01.10.2015 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in oder
einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

 

supervisory board

H   Alfred Umdasch, geb. 21.08.1937
59        Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
AI   Hilde Umdasch, geb. 02.01.1943
59        Vorsitzende/r
AJ   Mag.Dr. Reinhold Süßenbacher, geb. 02.05.1949
59        Mitglied
AK   Dr. Jörg Jakobljevich, geb. 05.05.1958
59        Mitglied
AL   Andreas Schauer, geb. 26.04.1964
59        Mitglied
AM   Josef Steinböck, geb. 16.03.1961
59        Mitglied

 

managing director

U   Dipl.-Kfm. Gerd Pechura, geb. 13.10.1958
64        vertritt seit 01.10.2015 gemeinsam mit
einem/einer weiteren Geschäftsführer/in oder
einer/einem Prokuristin/Prokuristen
AB   Dipl.-Ing.(FH) Helmut Jürgen Obiegli, geb. 07.10.1954
52        vertritt seit 01.05.2014 gemeinsam mit
einem/einer weiteren Geschäftsführer/in oder
einer/einem Prokuristin/Prokuristen
AC   Dipl.-Ing. Ludwig Pekarek, geb. 13.05.1970
56        vertritt seit 09.09.2014 gemeinsam mit
einem/einer weiteren Geschäftsführer/in oder
einer/einem Prokuristin/Prokuristen

 

shareholder

E   Umdasch Group AG
55        ....................  EUR 1.000.000
55        ...............................................  EUR 1.000.000
-------------------------------------------------------
Summen:           EUR 1.000.000              EUR 1.000.000

 

general table

Landesgericht St. Pölten
1 datenersterfasst am 30.06.1994             Geschäftsfall 916 Fr  1409/94 y
Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
3 eingetragen am 14.09.1994                  Geschäftsfall  10 Fr  1105/94 p
Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.07.1994
13 eingetragen am 17.01.2002                  Geschäftsfall  28 Fr    94/02 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.12.2001
14 eingetragen am 29.10.2002                  Geschäftsfall  28 Fr  5832/02 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.10.2002
27 eingetragen am 05.01.2008                  Geschäftsfall  18 Fr  3872/07 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.12.2007
28 eingetragen am 27.06.2008                  Geschäftsfall  18 Fr  2012/08 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.06.2008
29 eingetragen am 09.07.2008                  Geschäftsfall  28 Fr  1779/08 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.06.2008
36 eingetragen am 04.05.2011                  Geschäftsfall  28 Fr  1933/11 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.04.2011
39 eingetragen am 04.01.2012                  Geschäftsfall  28 Fr  8577/11 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.12.2011
41 eingetragen am 24.01.2012                  Geschäftsfall  28 Fr   167/12 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.01.2012
42 eingetragen am 11.02.2012                  Geschäftsfall  28 Fr   292/12 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.02.2012
43 eingetragen am 24.02.2012                  Geschäftsfall  28 Fr   343/12 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.02.2012
44 eingetragen am 21.04.2012                  Geschäftsfall  28 Fr  1095/12 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.04.2012
46 eingetragen am 13.04.2013                  Geschäftsfall  28 Fr  1261/13 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.04.2013
47 eingetragen am 06.07.2013                  Geschäftsfall  28 Fr  2019/13 a
Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.06.2013
51 eingetragen am 03.01.2014                  Geschäftsfall  28 Fr  5434/13 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.12.2013
52 eingetragen am 01.05.2014                  Geschäftsfall  28 Fr  1153/14 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.04.2014
55 eingetragen am 02.10.2014                  Geschäftsfall  28 Fr  3674/14 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.09.2014
56 eingetragen am 04.10.2014                  Geschäftsfall  28 Fr  3686/14 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.09.2014
58 eingetragen am 29.04.2015                  Geschäftsfall  28 Fr  1141/15 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.04.2015
59 eingetragen am 01.07.2015                  Geschäftsfall  28 Fr  1852/15 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.06.2015
60 eingetragen am 25.07.2015                  Geschäftsfall  28 Fr  2035/15 t
Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.07.2015
61 eingetragen am 30.07.2015                  Geschäftsfall  28 Fr  2253/15 m
amtswegige Berichtigung zu Eintragung 60
62 eingetragen am 28.08.2015                  Geschäftsfall  28 Fr  2612/15 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.08.2015
63 eingetragen am 05.09.2015                  Geschäftsfall  28 Fr  2635/15 z
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 26.08.2015
64 eingetragen am 08.10.2015                  Geschäftsfall  28 Fr  4408/15 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.10.2015

 

 

Historical development

 

Year of incorporation

1958

Date of registration

1958-05-06

 

 

Change of company name

 

from

to

company name

2008-06-27

 

Doka GmbH

 

2008-06-27

Österreichische DOKA Schalungstechnik Gesellschaft m.b.H.

 

 

Change in share capital

 

from

to

asset

 

 

2014-10-02

ATS

7.000.000,00

2014-10-02

 

EUR

1.000.000,00

 

 

Former executives

 

from

to

position

name

2001-04-05

2012-01-04

joint signing clerk

Ing. Gerhard Maderthaner

2008-07-09

2012-01-14

joint signing clerk

Dr. Hartmut Weller

 

2014-05-17

joint signing clerk

Dr. Barbara Priesching

2001-04-05

2014-10-04

joint signing clerk

Ing. Leopold Hochpöchler

2007-02-20

2015-08-28

joint signing clerk

Ing. Gerold Heinrich

2011-05-04

2015-10-08

joint signing clerk

Dkfm. Gerd Pechura

 

2015-10-08

manager

Mag. Christian Pum

 

2002-01-17

manager

Werner Haring

 

2007-02-20

manager

Dipl-Ing. Ernst Pürrer

2012-01-04

2013-07-18

manager

Dipl.-Ing.(FH) Gregor Gaisböck

2008-07-09

2014-05-01

manager

Ing. Josef Kurzmann

2008-07-09

2015-10-08

manager

Ing.Mag. Johann Strunz

2007-02-20

2008-07-09

joint signing clerk

Ing.Mag. Johann Strunz

1988-05-30

2011-05-04

joint signing clerk

Mag. Alois Wischenbart

2007-02-20

2015-10-08

manager

Dipl-Ing. Rainer Spitzer

2006-01-03

2007-02-20

joint signing clerk

Dipl-Ing. Rainer Spitzer

 

2015-10-08

manager

Dr. Andreas Johannes Ludwig

2003-07-09

2010-07-16

joint signing clerk

Mag. Alois Ströbitzer

1999-01-19

2001-04-05

joint signing clerk

Mag. Alois Ströbitzer

1998-01-17

2009-12-03

manager

Franz Prinz

 

1998-01-17

joint signing clerk

Franz Prinz

 

 

Mergers

 

On

position

name

2014-10-04

merged with

Doka Industrie GmbH

 

 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.66.42

UK Pound

1

Rs.99.17

Euro

1

Rs.72.14

 

1

Rs.72.06

Note : Above are approximate rates obtained from sources believed to be correct

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

DIV

 

 

Report Prepared by :

ASH

 


 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.