MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

356575

Report Date :

26.12.2015

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

TAPIS SAINT MACLOU

 

 

Registered Office :

330 Rue Carnot Bp 149 59391 Wattrelos Cedex

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2014

 

 

Date of Incorporation :

January 1970

 

 

Legal Form :

Public limited company with board of directors

 

 

Line of Business :

Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialized stores.

 

 

No. of Employee :

1488 employees

           

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

B

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

Small

 

Status :

Moderate

 

 

Payment Behaviour :

Slow but correct

 

 

Litigation :

Clear

 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31, 2015

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2014)

Current Rating

(31.03.2015)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 

FRANCE ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With more than 84 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that mitigate economic inequality. France's real GDP increased by 0.4% in 2014. The unemployment rate (including overseas territories) increased from 7.8% in 2008 to 10.4% in the fourth quarter of 2014. Youth unemployment in metropolitan France decreased from a high of 25.4% in the fourth quarter of 2012 to 24.3% in the fourth quarter of 2014. Lower-than-expected growth and high spending have strained France's public finances. The budget deficit rose sharply from 3.3% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 4% of GDP in 2014, while France's public debt rose from 68% of GDP to more than 95% in 2014, and may hit 100% by 2016. Elected on a conventionally leftist platform, President Francois HOLLANDE surprised and angered many supporters with a January 2014 speech announcing a sharp change in his economic policy, recasting himself as a liberalizing reformer. The government's budget for 2014 shifted the balance of fiscal consolidation from taxes to a total of $24 billion in spending cuts. In December 2014, HOLLANDE announced additional reforms, including a plan to extend commercial business hours, liberalize professional services, and sell off $6.2-12.4 billion in state owned assets. France’s tax burden remains well above the EU average and income tax cuts over the past decade are being partly reversed, particularly for higher earners. The top rate of income tax is 41%. The government is allowing a 75% payroll tax on salaries over $1.24 million to lapse.

 

Source : CIA

 

Company name and summary

 

Name

TAPIS SAINT MACLOU

Acronym

TSM

Trade name

-

Status

Economically active

Postal Address

TAPIS SAINT MACLOU
TSM
330 RUE CARNOT
BP 149
59391 WATTRELOS CEDEX

Share Capital

1,785,526 Euros

Telephone

03 20 81 56 30

Activity (APE)

Retail sale of carpets , rugs, wall and floor coverings in specialized stores (4753Z)

RCS Registration

RCS Lille Metropole B 470 500 943

Formation Date

01/1970

EUR VAT Number

FR66470500943

Deregistration Date

-

Last account Date

31/12/2014

Court Registry Number

19 7 1B00052

Incorporiation Date

10/1970

Registration Court

Lille Metropole (59)

Fax

03 20 81 03 28

Nationality

France

Legal form

Public limited company with board of directors

Currency

Euros

 

 

Key Financials

 

Year to date

Turnover

Gross operating surplus

Shareholder's equity

Net result

Employees

31/12/2014

232,668,069 €

-0.68% Turnover

55,354,801 €

-3,815,408 €

1488 employees

31/12/2013

228,744,000 €

0.26% Turnover

53,132,000 €

-5,749,000 €

1 000 to 1 999 employees

31/12/2012

231,063,000 €

-0.14% Turnover

33,628,000 €

-12,253,000 €

1 000 to 1 999 employees

 

 

Trends

 

Profitability

Liquidity

Net Worth

 

 

Directors

 

Current Directors

11

 

 

Ultimate Holding Company

 

Name

Country

Company Number

S.C.A VALMA

351813233

Affiliation links.

14 companies in the international Group Structure from 2 countries.

 

 

Judgment and Preferential

 

Judgment

No judgement

Preferential Right

No social security and tax office preferential right to date

 

 

Establishment Details

 

Type of Establishment

Head Office

Production Role

-

APE/NAF Code

4753Z

Activity

Retail sale of carpets , rugs, wall and floor coverings in specialized stores

Formation Date

-

Reason for Formation

-

Closure Date

-

Reason for Closure

-

Reactivation Date

-

Seasonality

-

Activity Nature

Retail trade

Activity Location

Store

Trading Address

330 RUE CARNOT
59150 WATTRELOS

Department

Nord (59)

Location Surface

-

District

5

City

WATTRELOS

Status

Economically active

Business Pages FT®

VENTE, POSE DE MOQUETTES, DE REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS

Region

Nord-Pas-de-Calais

Area

99

Size of Urban Area

Urban unit with 200 000 to 1 999 999 inhabitants

 

 

Ultimate Parent(s)

 

1 ultimate parent company/companies for this company

Company Name

Activity (APE)

APE/NAF Code

City

Post Code

SCA VALMA

Investment funds and similar financial entities

6430Z

ROUBAIX

59100

 

 

Other Establishment(s)

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas but no one grouping more than 50% of workforce

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which one activity grouping from 80 to 99% of workforce

Branches

202 branch entities in this company

 

 

Company Name

Company Type

APE/NAF Code

Activity

City

Post Code

TAPIS SAINT MACLOU

Head Office

4753Z

Retail sale of carpets , rugs, wall and floor coverings in specialized stores

WATTRELOS

59150

TAPIS SAINT MACLOU

Branch

4753Z

Retail sale of carpets , rugs, wall and floor coverings in specialized stores

MONTLUCON

03100

TAPIS SAINT MACLOU

Branch

4753Z

Retail sale of carpets , rugs, wall and floor coverings in specialized stores

MONTLUCON

03100

TAPIS SAINT MACLOU

Branch

4753Z

Retail sale of carpets , rugs, wall and floor coverings in specialized stores

BELLERIVE SUR ALLIER

03700

TAPIS SAINT MACLOU

Branch

4753Z

Retail sale of carpets , rugs, wall and floor coverings in specialized stores

NICE

06300

 

 

Workforces

 

Workforce at address

100 to 199 employees

Company workforce

1 000 to 1 999 employees

 

 

Commentary

 

The comments are ordered according to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative for another or can change depending on its value. This is a purely statistical decision.

The return on total assets employed is -3

The stock to turnover ratio is 14.69

The pre-tax profit is -3,895,331 €

The ratio total assets to total liabilities is 1.80

The sales to current assets ratio is 3.61

Department code with medium risk rating

Industry code with low risk rating

The company has 13 directors

Low risk workforce size

The total assets are 124,462,749 €

The risk provisions are 11,182,034 €

The net turnover is 232,668,069 €

The net current assets are 64,515,210 €

The liabilities are 57,925,542 €

The decrease in the gearing percentage over the last two accounting periods is 14 %

The creditor days are 16.07

The shareholder's equity is 55,354,801 €

 

 

Industry comparison

 

Activity (APE)

Retail sale of carpets , rugs, wall and floor coverings in specialized stores (4753Z)

Industry average credit rating

46

Industry average credit limit

10,776

 

 

Collective procedures

 

No judgment information for the company

 

 

Preferential rights details and history

 

Summary of preferential rights

 

Company monitored since

18/04/2008

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

 

 

Group Data

 

Ultimate parent company

S.C.A VALMA

Direct parent

TAPIMA - 81 %

Group – Number of companies

206

Linkages – Number of companies

14

Number of countries

2

 

 

 

Name

SIREN

Parts

Last account published

1

SCA VALMA

351813233

-

31/12/2013

2

SURAUMARCHE

519087837

100 %

31/12/2014

3

AUMARCHE

439529512

100 %

31/12/2014

4

SAMAUCHAN

453628372

12.58 %

31/12/2013

SOPACCORD

487947863

65.87 %

-

SOPARATAC

429389687

34.97 %

-

CLEPACHAN

512902131

99.90 %

-

2

SURBOLEM

519087928

Majority

31/12/2014

3

BOLEM

439529140

66 %

31/12/2014

4

HIGH TECH MULTICANAL GROUP

478613169

94 %

31/12/2009

5

BOULANGER

347384570

100 %

31/12/2009

6

SYNEDIS

485191407

10 %

31/12/2014

6

CLIXITY

482339645

100 %

31/12/2008

7

WEBDISTRIB

443041926

100 %

31/12/2007

STOCK MENAGER SERVICE

451220677

100 %

31/12/2008

ECO-SYSTEMES

483450433

4 %

31/12/2014

5

CAP BOULANGER HOLDING

349210237

100 %

31/12/2010

6

CAP BOULANGER

392327607

100 %

31/12/2010

LOKEO

509637161

100 %

-

VENDIDO

494707482

Majority

31/12/2009

5

HTM PRO

519172472

100 %

-

6

PRO BY PRO

334656121

100 %

31/03/2010

7

IMENAGER

442807582

100 %

31/03/2010

ELECTRODOMESTIC TRADING & DEVELOPMENT

529363327

100 %

-

5

ELECTRO DEPOT GROUP

480056712

Majority

-

6

ELECTRO DEPOT FRANCE

433744539

100 %

31/12/2004

SOLVAREA

751145178

100 %

-

SOPAR-HTM

422194811

Majority

31/12/2011

2

SURHOLYMPIADES

519088231

Majority

31/12/2014

3

DECATHLON

306138900

43 %

31/12/2013

COROT

488981531

Majority

31/12/2013

DEVELOP MOBILIER INDUSTRIEL

442112371

Min blocking

-

SOC CIVILE DE LA PORTE DE LYON

783881907

Min blocking

-

2

SURFIPAR

519088124

Majority

31/12/2014

3

SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION

313455610

100 %

31/12/2014

4

ARGOSYN

477180467

44 %

31/12/2014

5

JM. BRUNEAU

343958138

99.99 %

31/12/2014

6

MAXIBURO

404451494

100 %

31/12/2014

JM BRUNEAU ESPAÑA

444320

100 %

31/12/2014

ALLIANSYS

377594601

3 %

31/12/2014

COFIDIS PARTICIPATIONS

378176291

5 %

31/12/2003

BEAUTE CREATEURS PARTICIPATIONS

393258298

91.63 %

31/12/2014

DIREXI

351746094

99.99 %

31/12/2014

5

3SI COMMERCE

408536928

99.99 %

31/12/2013

6

CIDAL

552019697

0.20 %

31/12/2014

6

3 SUISSES FRANCE

475581591

100 %

31/12/2014

7

3S ASSURANCES

349807388

90 %

31/12/2014

COGEMAG

475580437

100 %

31/12/2014

CIDAL

552019697

99.80 %

31/12/2014

3 SUISSES VOYAGES

389655978

99.80 %

31/12/2014

DISPEO

529192304

100 %

31/12/2014

EQUIPAR

378176473

99.99 %

31/12/2014

5

COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LA VENTE A DISTANCE

321008013

100 %

31/12/2014

6

ZABOR SARL

-

100 %

-

3S ASSURANCES

349807388

10 %

31/12/2014

BECQUET

466500683

100 %

31/12/2014

CONTENTIA FRANCE

348967332

100 %

31/12/2014

5

MARTINTER

487602740

100 %

31/12/2014

6

COFIDIS PARTICIPATIONS

378176291

44 %

31/12/2003

5

3SI SERVICES

529033995

100 %

31/12/2014

6

MONDIAL RELAY

385218631

100 %

31/12/2014

7

MONDIAL RELAY

-

100 %

-

MONDIAL RELAY

-

100 %

-

CITE NUMERIQUE

377559646

100 %

31/12/2014

6

MEZZO

487600686

100 %

31/12/2014

7

MEZZO SARL

-

100 %

-

MOBILIS BANQUE

339019275

99.99 %

31/12/2014

SODEREC

344364666

100 %

-

SODISTRI

344124177

100 %

31/12/2014

GARGANO

494308356

Min blocking

-

2

SURLEBRICO

519088348

63.14 %

31/12/2014

3

LEBRICO

439528696

100 %

31/12/2014

4

GROUPE ADEO

358200913

66 %

31/12/2014

5

BRICOMAN

420809923

100 %

31/12/2013

5

LEROY MERLIN FRANCE

384560942

100 %

31/12/2014

6

SEINE INVESTISSEMENTS SAS

489422758

100 %

31/12/2014

SCI LE ROCHER

414302976

100 %

-

6

FRANKREICHBASTEL 1 GMBH

HRB 52063

100 %

31/12/2012

7

LEROY MERLIN GSB

408957363

99.90 %

31/12/2013

FRANKREICHBASTEL 1

481552578

100 %

-

5

LEROY MERLIN ESPAÑA

2177432

75 %

31/12/2013

6

IMMOBILIÈRE LEROY MERLIN S.L.U

-

100 %

-

LEROY MERLIN SA

-

100 %

-

AKI BRICOLAJE

-

100 %

-

BRICOMAN ESPAGNE

-

100 %

-

6

BRICOGAL

-

100 %

-

7

BRICOLAGE SA LM PORTUGAL

-

100 %

-

BRICODIS

-

100 %

-

7

BRIMOGAL

-

100 %

-

8

BRIMOILHAS

-

100 %

-

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PORTUGAL LEROY MERLIN

-

100 %

-

5

WELDOM

390922490

70 %

31/12/2013

6

IRONSIDE INTERNATIONAL SCRL

442188257

9.09 %

31/12/2014

INVESTISSEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRENARIAT EN

494774516

30 %

31/12/2014

BRICOFIT SAS

448777045

100 %

31/12/2014

SCI BRICO LUC

507850550

99 %

-

5

ADEO SERVICES

421206079

100 %

31/12/2014

6

ADEO SERVICES CONSULTING

-

100 %

-

MSB OBI

444609986

100 %

31/12/2014

5

L IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE

421227224

100 %

31/12/2014

6

LES PORTES DE RONCHIN

444668776

100 %

-

7

SCI LE JARDIN DU ROI

499737690

100 %

-

LUTECE INVEST IMMO

484985296

100 %

31/12/2012

LIONHEART SAS

489507491

100 %

31/12/2014

L'IROISE D'INVESTISSEMENTS

530037886

100 %

31/12/2014

EURL PUGET INVESTISSEMENTS

343960860

100 %

31/12/2014

CONSTRUCT INDUS PASSEREL ELEVAT AQUITA

472200013

100 %

31/12/2014

OBJETS ET CIE

451363493

95.56 %

31/12/2014

DOMPRO

448829697

100 %

31/12/2014

KBANE

501633267

99.54 %

31/12/2013

NATURAL SECURITY

507967933

19.67 %

31/12/2014

5

HEXAGONE

780097093

100 %

31/12/2014

6

KAMPEN

-

100 %

-

7

YOLE GECALUX

-

100 %

-

5

ACHADIS

451363451

100 %

31/12/2014

6

ELBEE

480442292

90.85 %

-

7

DECOCLICO

442898193

100 %

-

IDILINK

509633715

100 %

31/12/2014

SOLTEK GROUP

-

99.99 %

-

5

LEROY MERLIN UKRAINE

-

100 %

-

6

SOLTEK GROUP

-

0.01 %

-

BRICOLAGE UKRAINE

-

100 %

-

IMMOBILIERE BRICOMAN FRANCE

421206046

100 %

31/12/2013

5

BRICO 8

488279555

100 %

31/12/2014

6

SCI DU MOULIN DE CAGE

501066369

100 %

-

5

OBI 1

444610034

100 %

31/12/2014

6

IMMO LOIRE

444470207

99 %

-

SCI IMMO BRICO 04

444056246

97.50 %

-

BRICO XIV

519021398

100 %

31/12/2011

BRICO XIII

493504336

100 %

31/12/2014

BRICO XV

519022594

100 %

31/12/2011

5

BRICO XI

493504278

100 %

31/12/2014

6

QUOTATIS GROUPE

424057495

100 %

31/12/2007

7

QUOTATIS TECHNIQUE INTERNATIONAL

512285032

100 %

-

QUOTATIS FRANCE SAS

511755555

100 %

-

ILEXIA I

518968854

100 %

-

ILEXIA II

519021281

100 %

-

MOLVEAUX DEPIGNY

085780716

100 %

31/12/2014

E.P.S.I

533881470

100 %

31/12/2014

ADEO MAYA YAP? MARKETLERI

-

90 %

-

SCB DIY COMPANY

-

71.71 %

-

5

DELBOIS TRADING

-

100 %

-

6

DELBOIS HOME DECORATION

-

100 %

-

5

BRICOLAGE INVESTISSEMENT FRANCE

539055475

100 %

31/12/2014

6

LEROY MERLIN ESPAGNE S.L.U.

-

25 %

-

7

IMMOBILIÈRE LEROY MERLIN S.L.U

-

100 %

-

LEROY MERLIN SA

-

100 %

-

AKI BRICOLAJE

-

100 %

-

BRICOMAN ESPAGNE

-

100 %

-

7

BRICOGAL

-

100 %

-

8

BRICOLAGE SA LM PORTUGAL

-

100 %

-

BRICODIS

-

100 %

-

8

BRIMOGAL

-

100 %

-

9

BRIMOILHAS

-

100 %

-

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PORTUGAL LEROY MERLIN

-

100 %

-

6

LEROY MERLIN POLSKA

-

100 %

-

7

BRICOMAN POLOGNE

-

100 %

-

LIBURNIA CENTRUM LTD

-

100 %

-

LIBURNIA PLUS SP Z.O.

-

100 %

-

SOCIÉTÉ ITALIENNE DE BRICOLAGE

-

50 %

-

6

LEROY MERLIN INWESTYCZJE

-

100 %

-

7

CONFORAMA POLSKA

-

100 %

-

LEROY MERLIN BRÉSIL

-

90 %

-

LEROY MERLIN BUILDINGS & MATERIALS CHINA

-

95.63 %

-

LEROY MERLIN CONSULTING

-

100 %

-

6

LEROY MERLIN VOSTOK

-

100 %

-

7

START INVEST RUSSIE

-

100 %

-

FIAL

-

100 %

-

SOTIS

-

100 %

-

INVESTKOM

-

100 %

-

7

SANGLIYE

-

100 %

-

8

DRAYCOTTE

-

100 %

-

LAZERTA

-

100 %

-

7

ALICAN

-

100 %

-

8

ELENA

-

100 %

-

INTELLEK I PRAVO

-

100 %

-

ZELENLY MAGASIN

-

100 %

-

SARL LMR

-

100 %

-

LMT

-

100 %

-

6

BRICO FINANCES

420379117

100 %

31/12/2014

7

SOCIÉTÉ ITALIENNE DE BRICOLAGE

-

50 %

-

VAASTU MULTICHANNELS SERVICES LTD

-

99 %

-

GROUPE ADEO & CIE VALADEO

-

50.64 %

-

6

LEROY MERLIN ROUMANIE

-

100 %

-

7

INPROX BUCURESTI SRL

-

100 %

-

INPROX BRAILA SRL

-

100 %

-

INPROX ORADEA SRL

-

100 %

-

INPROX GALATI SRL

-

100 %

-

INPROX CRAIOVA SRL

-

100 %

-

IMMOROM SIGMA SRL

-

100 %

-

BAUMAX ROUMANIA SRL

-

100 %

-

LEROY MERLIN INWESTYCZJE 2

-

100 %

-

SOCIÉTÉ GRECQUE DE BRICOLAGE

-

71.71 %

-

VAASTU MULTICHANNELS SERVICES LTD

-

1 %

-

LEROY MERLIN BRICOLAJE S.R.L

-

100 %

-

SCI LINGOSTIERE INVESTISSEMENT

508060993

100 %

-

111

483743985

100 %

31/12/2013

CAMPUS DE L'HABITAT

800553216

100 %

31/12/2014

LUZITANIA

-

90 %

-

IMMOBILIARE BRICOMAN SLU

-

100 %

-

ZODIO ITALIA SRL

-

100 %

-

PORTA DELLA CITTA

-

100 %

-

GACIV

-

24.91 %

-

ELYSSE

-

100 %

-

NI 6

-

100 %

-

EDEN ATRIUM

-

100 %

-

SIMPLY GREEN

-

100 %

-

ZOLOTOY VEK

-

100 %

-

LERU

-

100 %

-

PERSPEKTIVA

-

100 %

-

KIP

-

100 %

-

CLEPADEO

513004945

99.90 %

-

CLEPATHLON

512971193

99.90 %

-

SOPARLIN B

351814546

53.77 %

31/12/2008

2

SURHOLKIA

519088199

Majority

31/12/2014

3

HOLKIA

508941739

Min blocking

31/12/2014

SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION LOUIS MULLIEZ LESTIENNE

-

Majority

-

SURMUFIL

519088512

48.66 %

31/12/2014

SURESTAG

519088033

Min blocking

31/12/2014

PIMINVEST

353526551

Min blocking

-

SOPARTHLON B

351819248

Min blocking

31/12/2011

2

SURTAPIMA

519088611

Majority

31/12/2014

3

TAPIMA

439528910

Majority

31/12/2014

4

TAPIS SAINT MACLOU

470500943

81 %

31/12/2014

5

MONDIAL MOQUETTE

328412440

100 %

31/12/2014

6

MONDIAL SERVICES

383929783

100 %

31/12/2014

SAINT MACLOU

-

100 %

-

TAPIS INVESTISSEMENT

326464997

57.85 %

-

FILUNOR SA

-

Min blocking

-

HAPED BV

-

Min blocking

-

 

 

Linkages

 

Company Name

Siren

Last Account Published

Turnover

I.D.C.B. NV

447275809

31/12/2014

-

INTERIORS FOR EUROPE NV

472232226

31/12/2012

-

DECATHLON UK LIMITED

03140144

31/12/2014

104,878,000 £

SPORTSTOCK LIMITED

03883733

31/12/2014

2,018,000 £

JAVEN LIMITED

07357128

31/12/2014

0 £

EBUILDERS HOLDINGS LIMITED

05720968

31/12/2014

-

QUOTATIS LIMITED

05643725

31/12/2014

-

EBUILDERS LIMITED

03404409

31/12/2014

-

CONSERVATORIESONLINE LIMITED

03003008

31/03/2015

-

DIAL A CONSERVATORY LIMITED

03230022

31/03/2015

-

CONSERVATORIESTODAY LIMITED

03404743

31/03/2015

-

ONLINECONSERVATORIES LIMITED

03991368

31/03/2015

-

WINDOWSTODAY LIMITED

03991405

31/03/2015

-

CONSERVATORIES LIMITED

04351118

31/03/2015

-

 

 

Shareholder(s)

 

Name

T.S.2.M.

Name of representative

Manager position

Administrator

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

Name

TAPIMA

Name of representative

Manager position

Administrator

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

 

Director(s)

 

Name

M. RIBAULT CHRISTOPHE

Manager position

Chairman of the Board, Administrator

Date of birth

26/12/1958

Place of birth

TOURCOING (59200)

Type

Individual

Name at birth

Name

M. JOLIVET YVON

Manager position

Vice-president, Administrator

Date of birth

17/02/1951

Place of birth

PETOSSE (85570)

Type

Individual

Name at birth

 

Name

M. BLANC PHILIPPE

 

Manager position

Managing director

Date of birth

15/10/1958

 

Place of birth

LYON (69006)

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

Name

M. THOMAS GUY

Manager position

Administrator

Date of birth

09/01/1952

Place of birth

LAMBERSART (59130)

Type

Individual

Name at birth

 

Name

M. DELOZANNE MARC

Manager position

Administrator

Date of birth

16/11/1962

Place of birth

PARIS (75013)

Type

Individual

Name at birth

 

 

Statutory Auditor

 

Name

BMD ASSOCIES

Name of representative

Manager position

Statutory auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

Name

DELOITTE & ASSOCIES

Name of representative

Manager position

Statutory auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

Name

M. DE REU BENOIT

Manager position

Deputy auditor

Date of birth

17/05/1959

Place of birth

ROUBAIX (59051)

Type

Individual

Name at birth

Name

BEAS

Name of representative

Manager position

Deputy auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

 

Previous Directors

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

Administrator

CIMOFLU

-

Administrator

MME. MULLIEZ FANNY

-

Administrator

SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL

-

Administrator

SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL

-

Administrator

TAPIMA

-

Statutory auditor

BMD ASSOCIÉS

-

Deputy auditor

BEAS

-

 

 

Status history

 

No Status History

 

 

Recent publications in Gazettes

 

Publication date

Gazette Name

Description

31/08/2015

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

6432 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2014.

02/12/2014

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

6816 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2013.

26/09/2013

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

465 - 470 500 943 RCS Lille Métropole. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 78000,00 euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Commerce de détail, revêtements sols et murs. Adresse : 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris.
Précédent propriétaire : MONDIAL MOQUETTE. 328 412 440 RCS Paris.
A dater du : 10/03/1971. Date de commencement de l’activité : 01/07/2013. Publication légale : Le Parisien Libéré du 18/07/2013. Oppositions : Me Frédéric Fortier 11 rue de Meaux 75019 Paris pour la validité. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

26/09/2013

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

469 - 470 500 943 RCS Lille Métropole. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 67000,00 euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Commerce de détail, revêtements sols et murs. Adresse : 67 boulevard Ney, 75018 Paris.
Précédent propriétaire : MONDIAL MOQUETTE. 328 412 440 RCS Paris.
A dater du : 10/03/1971. Date de commencement de l’activité : 01/07/2013. Publication légale : Le Parisien Libéré du 18/07/2013. Oppositions : Me Antoine Corneloup 137 rue Marcadet 75018 Paris pour la validité. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

26/09/2013

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

468 - 470 500 943 RCS Lille Métropole. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 192000,00 euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Commerce de détail, revêtements sols et murs. Adresse : 88 à 94 boulevard Jourdan et 5 impasse St Alphonse, 75014 Paris.
Précédent propriétaire : MONDIAL MOQUETTE. 328 412 440 RCS Paris.
A dater du : 10/03/1971. Date de commencement de l’activité : 01/07/2013. Publication légale : Le Parisien Libéré du 18/07/2013. Oppositions : Me Jean-Luc Richard 94 boulevard du Montparnasse 75014 Paris pour la validité. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

26/09/2013

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

467 - 470 500 943 RCS Lille Métropole. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 174000,00 euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Commerce de détail, revêtements sols et murs. Adresse : 36/38 avenue Emile Zola, 6 place Alphonse Humbert et 35/37 rue de Javel, 75015 Paris.
Précédent propriétaire : MONDIAL MOQUETTE. 328 412 440 RCS Paris.
A dater du : 10/03/1971. Date de commencement de l’activité : 01/07/2013. Publication légale : Le Parisien Libéré du 18/07/2013. Oppositions : Me Jérôme Graux 45 rue de Lourmel 75015 Paris pour la validité. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

19/09/2013

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

45 - LOIRET

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

215 - 470 500 943 RCS Lille métropole. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme. Sigle : TSM. Administration : Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : MULLIEZ Gonzague. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 409000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Commerce de détail revêtements sols et murs. Adresse : rue Anthelme Brillat Savarin, 45100 Orléans.
Précédent propriétaire : MONDIAL MOQUETTE. 328 412 440 RCS Lille métropole.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2013. Publication légale : La République du Centre du 19/07/2013. Oppositions : Etude de Me Jean-Paul BLACHIER, notaire, 2 avenue de Paris 45000 Orléans et étude de Me DELATTRE, notaire, 56 rue du Maréchal Foch à Roubaix (59). Descriptif : . Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

17/09/2013

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

72 - SARTHE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS

521 - 470 500 943 RCS Lille métropole. TAPIS SAINT MACLOU S.S. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle : TSM. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 146000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Commerce de détail revêtements sols et murs. Adresse : Zone d'Activités Commerciales du Moulin aux Moines, 72650 La Chapelle Saint-Aubin.
Précédent propriétaire : MONDIAL MOQUETTE. 328 412 440 RCS Lille métropole.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2013. Publication légale : Ouest France du 18/07/2013. Oppositions : Etude de Me Ribot 14, avenue Pierre Mendes France 72000 Le Mans. Descriptif : . Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

13/09/2013

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

478 - 470 500 943 RCS Nanterre. TAPIS SAINT MACLOU - T. S. M. Forme : Société anonyme. Adresse : 330 rue Carnot, 59391 Wattrelos.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 197000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : commerce de détail revêtements sols et murs. Adresse : 109-111 boulevard de Verdun, 92400 Courbevoie.
Précédent propriétaire : MONDIAL MOQUETTE. 328 412 440 RCS Lille metropole.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2013. Publication légale : Le Parisien du 18/07/2013. Oppositions : Au Mandataire Maître Hervé SEYEWETZ Notaire 13bis rue de l'Abreuvoir 92400 Courbevoie pour la validité et pour la correspondance Etude de Me delattre Notaire 56 rue du Maréchal Foch 59100 ROUBAIX. Descriptif : . Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

11/09/2013

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

78 - YVELINES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

1032 - 470 500 943 RCS Versailles. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 135000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : commerce de détail, revêtements sols et murs. Adresse : 265 267 avenue Gabriel Péri, 78360 Montesson.
Précédent propriétaire : MONDIAL MOQUETTE. 328 412 440 RCS Lille metropole.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2013. Publication légale : Le Parisien du 18/07/2013. Oppositions : Au Mandataire Me GUEGAN Catherine, Notaire à Montesson, 54 Av Paul Doumer pour la validité et pour la correspondance Chez Me Delattre, 56 rue Du Marechal Foch 59100 ROUBAIX. Descriptif : . Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

11/09/2013

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

33 - GIRONDE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

308 - 470 500 943 RCS Bordeaux. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme. Adresse : 330 rue Carnot, 59000 Xattrelos.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 94000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : commerce de détail revêtements sols et murs. Adresse : Centre Commercial Auchan, Zone Artisanale Alienor, d'Aquitaine 33300 Bordeaux.
Précédent propriétaire : MONDIAL MOQUETTE. 328 412 440 RCS Lille metropole.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2013. Publication légale : Le Républicain du 18/07/2013. Oppositions : Au Mandataire Maître GAUTHIER Fabrice 23 ave du Jeu de Paume 33200 BORDEAUX - Maître DELATTRE 56 rue du Mal Foch 59100 ROUBAIX pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : . Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

26/08/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

2426 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2012.

02/08/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

578 - 470 500 943 RCS Lille Métropole. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme. Sigle : T S M. Capital : 1785526 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

18/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Parisien (Le)/Edition nationale


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 192000 €
Date d’effet : 01/07/2013

18/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Parisien (Le) /Edition de Paris


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 185000 €
Date d’effet : 01/07/2013

18/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Parisien (Le)/Edition des Yvelines


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 135000 €
Date d’effet : 01/07/2013

18/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Parisien (Le)/Edition nationale


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 78000 €
Date d’effet : 01/07/2013

18/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Parisien (Le)/Edition nationale


Date de décision : 10/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 67000 €
Date d’effet : 01/07/2013

18/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Parisien (Le)/Edition nationale


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 174000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES DENAIN


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 197000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition LILLE


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 78000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition LILLE


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 67000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition LILLE


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 174000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition LILLE


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 192000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition LILLE


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 185000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition LILLE


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 146000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition LILLE


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 135000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition LILLE


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 409000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition LILLE


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 197000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition LILLE


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 94000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES DENAIN


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 94000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES DENAIN


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 78000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES DENAIN


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 67000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES DENAIN


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 174000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES DENAIN


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 192000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES DENAIN


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 185000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES DENAIN


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 146000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES DENAIN


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 135000 €
Date d’effet : 01/07/2013

17/07/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Voix du Nord (La)/édition VALENCIENNES DENAIN


Date de décision : 03/07/2013
Cédant : 328412440 - MONDIAL MOQUETTE, MONDIAL MOQUETTE, CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, CENTRE COMMERCIAL ENGLOS, 59320 ENNETIERES EN WEPPES
Cessionnaire : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Prix de vente : 409000 €
Date d’effet : 01/07/2013

29/06/2013

JAL

Modification of the share capital

Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord


Date de décision : 28/06/2013
La société : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, TSM, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS a subi une augmentation de son capital social désormais de 1 785 526 €
Date d'effet : 28/06/2013

10/12/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

6975 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011.

28/09/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

647 - 470 500 943 RCS Roubaix / Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme. Sigle : T S M. Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Darrousez, Jean-François, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Capital : 1588416 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

15/02/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

2469 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle : T S M. Administration : Président du conseil d'administration : RIBAULT Christophe Vice-président : JOLIVET Yvon Directeur général : BLANC Philippe Administrateur : THOMAS Guy Administrateur : RIBAULT Christophe Administrateur : T.S.2.M., représenté par MME MULLIEZ Sybille Administrateur : TAPIMA, représenté par M LECLERCQ Bertrand Administrateur : DELOZANNE Marc Administrateur : JOLIVET Yvon Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1588416 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. L'organisation de formation en qualité de prestataire de la formation professionnelle continue. Adresse de l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Augmentation de capital. Date de commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 24/01/2012.

04/02/2012

JAL

Modification of the share capital

Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord


Date de décision : 24/01/2012
La société : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, TSM, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS a subi une augmentation de son capital social désormais de 1 588 416 €
Date d'effet : 24/01/2012

25/10/2011

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

9329 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2010.

20/09/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1168 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle : T S M. Administration : Président du conseil d'administration : RIBAULT Christophe Vice-président : JOLIVET Yvon Directeur général : BLANC Philippe Administrateur : THOMAS Guy Administrateur : RIBAULT Christophe Administrateur : T.S.2.M., représenté par MME MULLIEZ Sybille Administrateur : TAPIMA, représenté par M LECLERCQ Bertrand Administrateur : DELOZANNE Marc Administrateur : JOLIVET Yvon Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1363786 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. L'organisation de formation en qualité de prestataire de la formation professionnelle continue. Adresse de l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Départ d'un administrateur. Date de commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 04/03/2011.

10/09/2011

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord


Date de décision : 15/04/2011
La société 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, TSM, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Fait l'objet du départ de Non renseignée SAS SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSE
Date d'effet : 04/03/2011

09/03/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1457 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle : T S M. Administration : Président du conseil d'administration : RIBAULT Christophe Vice-président : JOLIVET Yvon Directeur général : BLANC Philippe Administrateur : THOMAS Guy Administrateur : SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL, représenté par M GASPARD Georges Administrateur : RIBAULT Christophe Administrateur : T.S.2.M., représenté par MME MULLIEZ Sybille Administrateur : TAPIMA, représenté par M LECLERCQ Bertrand Administrateur : DELOZANNE Marc Administrateur : JOLIVET Yvon Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1363786 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. L'organisation de formation en qualité de prestataire de la formation professionnelle continue. Adresse de l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Changement d'administrateur Changement de directeur général. Date de commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 01/01/2011.

19/02/2011

JAL

Appointment of the social representative

Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord


Société faisant l'objet d'une nomination : 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, TSM, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Nominé : Monsieur Yvon JOLIVET, 22 Rue du Quai, LILLE
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Monsieur Philippe BLANC, 49 Rue Auguste Lançon, PARIS
En la fonction de : Directeur général
Date d'effet : 21/01/2011

19/02/2011

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord


Date de décision : 21/01/2011
La société 470500943 - TAPIS SAINT MACLOU, TSM, 330 RUE CARNOT, BP 149, 59150 WATTRELOS
Fait l'objet du départ de Date d'effet : 21/01/2011

26/01/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

2290 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle : T S M. Administration : Président du conseil d'administration : RIBAULT Christophe Directeur général : FAUVET Vincent Administrateur : THOMAS Guy Administrateur : SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL, représenté par M GASPARD Georges Administrateur : RIBAULT Christophe Administrateur : T.S.2.M., représenté par MME MULLIEZ Sybille Administrateur : TAPIMA, représenté par MME MULLIEZ Muriel Administrateur : MULLIEZ Fanny Administrateur : DELOZANNE Marc Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1363786 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. L'organisation de formation en qualité de prestataire de la formation professionnelle continue. Adresse de l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Changement d'administrateur. Date de commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 24/06/2010.

17/12/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

754 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle : T S M. Administration : Président du conseil d'administration : RIBAULT Christophe Directeur général : FAUVET Vincent Administrateur : THOMAS Guy Administrateur : SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL, représenté par M GASPARD Georges Administrateur : RIBAULT Christophe Administrateur : CIMOFLU, représenté par M MULLIEZ Thierry Administrateur : T.S.2.M., représenté par MME MULLIEZ Sybille Administrateur : TAPIMA, représenté par MME MULLIEZ Muriel Administrateur : MULLIEZ Fanny Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1363786 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. L'organisation de formation en qualité de prestataire de la formation professionnelle continue. Adresse de l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Changement de l'objet et de l'activité. Date de commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 01/12/2010.

12/10/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

7407 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

30/12/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

7741 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

25/06/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1461 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Sigle : T S M. Administration : Président du conseil d'administration : RIBAULT Christophe. Directeur général : FAUVET Vincent. Administrateur : THOMAS Guy. Administrateur : SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL, représenté par M GASPARD Georges. Administrateur : RIBAULT Christophe. Administrateur : CIMOFLU, représenté par M MULLIEZ Thierry. Administrateur : T.S.2.M., représenté par MME MULLIEZ Sybille. Administrateur : TAPIMA, représenté par MME MULLIEZ Muriel. Administrateur : MULLIEZ Fanny. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés. Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit. Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1363786 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse de l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Transformation en société anonyme à conseil d'administration. Date de commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 12/05/2009.

24/04/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

7259 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

12/08/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1423 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à directoire. Sigle : T S M. Administration : Président du directoire : FAUVET VincentMembre du directoire : FAUVET Vincent. Membre du directoire : CAPELIEZ Laurent. Président du conseil de surveillance : RIBAULT Christophe. Membre du conseil de surveillance : THOMAS Guy. Membre du conseil de surveillance : T.S.2.M., représenté par MME MULLIEZ Sybille. Membre du conseil de surveillance : TAPIMA, représenté par M MULLIEZ Yann Guy. Membre du conseil de surveillance : SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL, représenté par M GASPARD Georges. Membre du conseil de surveillance : RIBAULT Christophe. Membre du conseil de surveillance : CIMOFLU, représenté par M MULLIEZ Thierry. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés. Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit. Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1363786 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse de l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Changement de membres du directoire. Date de commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 13/06/2008.

15/06/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1046 - 470 500 943 RCS Roubaix-Tourcoing. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à directoire. Sigle : T S M. Administration : Président du directoire : FAUVET VincentMembre du directoire : BASEDEN Eric. Membre du directoire : FAUVET Vincent. Membre du directoire : CAPELIEZ Laurent. Président du conseil de surveillance : RIBAULT Christophe. Membre du conseil de surveillance : THOMAS Guy. Membre du conseil de surveillance : T.S.2.M.. Membre du conseil de surveillance : TAPIMA. Membre du conseil de surveillance : SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL. Membre du conseil de surveillance : RIBAULT Christophe. Membre du conseil de surveillance : CIMOFLU. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés. Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit. Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean-François. Capital : 1363786 EUR. Activité : L'industrie et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse de l’établissement principal : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos.
Commentaires : Changement membres conseil surveillance Changement de président du conseil de surveillance. Date de commencement de l’activité : 01/10/1969. Date d’effet : 22/04/2008.

11/06/2008

Bodacc A

Immatriculation

86 - VIENNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

2090 - 502 082 324 RCS Poitiers. FUTUROSOL. Forme : S.A.R.L. à associé unique. Administration : Gérant : RICHET Olivier François Hervé. Capital : 1000 EUR. Adresse : 10 rue du Commerce, 86360 Chasseneuil-du-Poitou.
Etablissement : Siège social et établissement principal. Activité : Vente et pose de revêtements de sols en tant que mandataire de la société Tapis Saint Maclou. Adresse : 10 rue du Commerce, 86360 Chasseneuil-du-Poitou.
Précédent exploitant : TAPIS SAINT MACLOU. 470 500 943 RCS Poitiers.
A dater du : 29/01/2008. Date de commencement de l’activité : 23/01/2008. Descriptif : Fonds principal reçu en gérance mandat de la société TAPIS SAINT MACLOU. Commentaires : Autre immatriculation personne morale. Date d’effet : 23/01/2008.

08/06/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

3971 - 470500943 RCS. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2006.

24/08/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

659 - Ancienne situation du siège social : RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943. RC 70-B 94. TAPIS SAINT MACLOU. Sigle : TSM. Forme : S.A. à directoire. Capital : 1 358 286 euros. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Nouvelle situation du siège social - Capital : 1 363 786 euros. Etablissement principal - Activité : industrie, commerce de tout textile et plus particulièrement, de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Date d'effet : 30 juin 2007.

05/05/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

7396 - RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943. RC 70-B 94. TAPIS SAINT MACLOU. Sigle: T S M Forme: S.A. à directoire. . Adresse du siège social: 330, rue Carnot,59150 Wattrelos. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

20/10/2006

Bodacc A

Vente et cession

0223 - RCS B 470 500 943. RC AP-B 40019. TAPIS SAINT MACLOU. Forme : S.A. à directoire. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Etablissement secondaire - Activité : achat, vente de tapis, de revêtements de sols et muraux. Adresse : 8 boulevard Voltaire, 19100 Brive. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 324 000 euros. Date d'effet : 1er septembre 2006. Précédent propriétaire : S.A.R.L. GRAU. RCS 340 898 444. Publication légale : La Montagne du 15 septembre 2006. Oppositions : Me Masmonteil, 28 boulevard Jules-Ferry, 19100 Brive, pour la validité et la correspondance.

27/09/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

0985 - RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943. RC 70-B 94. TAPIS SAINT MACLOU. Sigle : TSM. Forme : S.A. à directoire. Capital : 1 358 286 euros. Adresse du siège social : 330 rue Carnot,, 59150 Administration : président du directoire : FAUVET (Vincent). Président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Gonzague). Vice-président du conseil de surveillance : LECLERCQ (Olivier). Membres du conseil de surveillance : THOMAS (Guy) T.S.2.M. TAPIMA SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL CIMOFLU LECLERCQ (Olivier). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES BMD ASSOCIES. Commissaires aux comptes suppléants : DE REU (Benoît) DARROUSEZ (Jean-François). Ancienne administration : ancien gérant : STE T.S.2.M. Anciens associés en commandite : STE T.S.2.M. MULLIEZ (Gonzague). Ancien gérant : MULLIEZ (Gonzague). Anciens membres du conseil de surveillance : S.C. GOMA GRAS (Emmanuel). Ancien président du conseil de surveillance : GRAS (Emmanuel). Anciens membres du conseil de surveillance : STE TAPIMA STE SOCIETE MOUVALLOISE DE CONSEIL. Etablissement principal - Activité : industrie, commerce de tout textile et plus particulièrement, de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Commentaires : modification survenue sur la forme juridique. Ancienne : S.C.A. Date d'effet : 13 juin 2006.

16/11/2005

Bodacc A

Vente et cession

199 - RCS B 470 500 943. RC 05-B 258. TAPIS SAINT MACLOU. Sigle : TSM. Forme : société en commandite par action. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Etablissement secondaire - Activité : vente, pose de moquettes, de tapis, de revêtements plastiques, de tissu et d'articles d'ameublement. Adresse : 44 rue de la Grassinais, 35400 Saint-Malo. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 175 001 euros. Date de début d'activité : 19 septembre 2005. Précédent propriétaire : SOCIETE CHRISTIAN FOUGERAY & Cie S.A. RCS B 896 780 079. Publication légale : Le Paysan breton du 30 septembre 2005. Oppositions : Me Lebranchu, notaire, 61 rue Georges-Clemenceau, B.P. 33, 35403 Saint-Malo Cedex.

16/11/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

684 - RCS Saint-Malo B 483 917 027. RC 05-B 287. DYKE. Forme : S.A.R.L. à associé unique. Capital : 1 500 euros. Adresse du siège social : 44 rue de la Grassinais, 35400 Saint-Malo. Commentaires : le fonds fait l'objet d'une gérance par mandat et non d'une création comme précédemment déclaré. Modification de la date de début d'activité. Ancienne : 15 septembre 2005. Fonds reçu en location-gérance. Date de début d'activité : 19 septembre 2005. Propriétaire : SOCIETE TAPIS SAINT MACLOU. RCS B 470 500 943.

05/01/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

980 - Ancienne situation du siège social : RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943. RC 70-B 94. TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : TSM. Forme : S.C.A. Capital : 1 035 346,83 euros. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Nouvelle situation du siège social - Capital : 1 358 286 euros. Etablissement principal - Activité : industrie, commerce de tous textiles et plus particulièrement, de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Date d'effet : 7 décembre 2004.

07/08/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Roubaix-Tourcoing B 470500943 RC 70- B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : TSM. Forme : S.C.A. Capital : 1 035 346 euros. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Administration : président du conseil de surveillance : GRAS (Emmanuel). Membres du conseil de surveillance : STE CIVILE GOMA GRAS ( Emmanuel) TAPIMA STE MOUVALLOISE DE CONSEIL. Gérants : T.S. 2M MULLIEZ ( Gonzague). Commissaires aux comptes titulaires : CABINET BRACQ ET ASSOCIES STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MOLARD (Jean- Paul). Commissaires aux comptes suppléants : DESURMONT (Jean, Marie) BMD ASSOCIES. Associés en commandite : T.S. 2M MULLIEZ (Gonzague). Ancien président du conseil de surveillance : BASEDEN (Eric). Anciens membres du conseil de surveillance : BASEDEN (Eric) LECLERCQ (Bertrand) THOMAS (Guy) Etablissement principal: Activité : industrie et commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Date d'effet : 11 juin 2003.

17/12/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Roubaix-Tourcoing B 470500943 RC 70- B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : TSM. Forme : S.C.A. Capital : 1 035 346 euros. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Administration : président du conseil de surveillance : BASEDEN (Eric). Membres du conseil de surveillance : LECLERCQ (Bertrand) THOMAS (Guy) BASEDEN (Eric). Gérants : MULLIEZ (Gonzague) TS 2M. Commissaires aux comptes titulaires : CABINET BRACQ ET ASSOCIES STE D' EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MOLARD (Jean-Paul). Commissaires aux comptes suppléants : DESURMONT (Jean, Marie) B.M.D. ASSOCIES. Associés en commandite : MULLIEZ (Gonzague) TS 2M. Ancien président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann, Guy) Etablissement principal: Activité : industrie et commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Date d'effet : 17 juin 2002.

26/12/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Roubaix-Tourcoing B 470500943 RC 70- B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.C.A. Capital : 6 791 430 F. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Administration : président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann, Guy). Membres du conseil de surveillance : LECLERCQ (Bertrand) THOMAS (Guy). Gérants : MULLIEZ ( Gonzague) TS 2M. Commissaires aux comptes titulaires : CABINET BRACQ ET ASSOCIES STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MOLARD ( Jean-Paul). Commissaires aux comptes suppléants : DESURMONT (Jean, Marie) B.M.D. ASSOCIES. Associés en commandite MULLIEZ (Gonzague) TS 2M. Ancien commissaire aux comptes titulaire : VANDENBURIE (Pierre). Ancien commissaire aux comptes suppléant : MOLARD (Jean-Paul) Etablissement principal: Activité : industrie, vente d' articles de tout textile et plus particulièrement de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Date d'effet : 29 juin 2001.

21/01/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Roubaix-Tourcoing B 470500943 RC 70- B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.C.A. Capital : 6 791 430 F. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Administration : président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann, Guy). Membres du conseil de surveillance : LECLERCQ (Bertrand) THOMAS (Guy). Gérants : MULLIEZ ( Gonzague) T.S. 2M. Commissaires aux comptes titulaires : VANDENBURIE ( Pierre) CABINET BRACQ ET ASSOCIES STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES. Commissaires aux comptes suppléants : DESURMONT ( Jean, Marie) MOLARD (Jean-Paul). Ancien commissaire aux comptes suppléant : BRACQ (Léon). Ancien gérant et associé en commandite : S.A.R.L. T.S. 2M Etablissement principal: Activité : industrie et commerce de tout textile plus particulièrement, de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Date d'effet : 30 juin 2000.

24/12/2000

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 470500943 RC AP-B 573 SAINT- MACLOU. Forme : société en commandité par actions. Capital : 6 696 030 F. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59391 Wattrelos Etablissement principal: Activité : vente au détail de fournitures, de mobilier et de matériel de bureau de dessin. Adresse : 131 avenue Aristide-Briand, 92120 Montrouge Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 385 000 F. Date d'effet : 27 octobre 2000. Précédent propriétaire : SOCIETE MULTIGRAPHIC. RCS B 632041596 Publication légale: Les Petites affiches du 5 décembre 2000. Oppositions : M e Riffier, 205 avenue Georges-Clemenceau, 92000 Nanterre.

30/09/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

o. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC 70-B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T. S.M. Forme : S.A.S. Capital : 6 791 430 F. Adresse du siège social : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos. Administration : président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann, Guy) Membres du conseil de surveillance : LECLERCQ (Bertrand) THOMAS (Guy). Ancien membre du conseil de surveillance : DE BUCK (Jacques). Gérant : MULLIEZ (Gonzague) Etablissement principal: Activité : industrie et commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos. Date d'effet : 30 juin 1999 Date de début d'activité: 1er octobre 1969.

30/09/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

o. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC 70-B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T. S.M. Forme : Société en commandite par actions. Capital : 6 791 430 F. Adresse du siège social : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : ancien capital : 6 743 580 F Etablissement principal: Activité : industrie et commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos. Date d'effet : 2 septembre 1999 Date de début d'activité: 1er octobre 1969.

29/09/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Roubaix-Tourcoing B 470500943 RC 70- B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.-M. Forme : S.C.A. Capital : 6 743 580 F. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Administration : président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann, Guy). Membres du conseil de surveillance : DE BUCK (Jacques) LECLERCQ (Bertrand). Gérant : MULLIEZ ( Gonzague) Etablissement principal: Activité : industrie, commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis. Adresse : 330 rue Carnot, 59150 Wattrelos. Commentaires : apport partiel d'actif à SAINT-MACLOU PRODUCTION S.A.R. L. Date d'effet : 30 juin 1999.

12/06/1999

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix-Tourcoing 470500943 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.C.A. Adresse du siège social : 330 rue Carnot, 59391 Wattrelos Cedex ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Montauban 99-B 140. A dater du : 20 mai 1999. Activité : vente de revetements de sols, de moquettes, de tapis et de tissus collés. Adresse : 700 avenue de Paris, 82000 Montauban Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 150 000 F Date de début d'activité: 1er avril 1999. Précédent propriétaire : indivision VESSIO Germaine. RCS 780142824 RC 73-A 219. Précédent exploitant : S.A.R.L. VESSIO. RCS 349086272 RC 89-B 7 Publication légale: Le Journal du Palais de Tarn-et-Garonne du 29 avril 1999. Oppositions : Alizé Conseil, avocat, 42 avenue Gambetta, B.P. 443, 82004 Montauban Cedex.

27/10/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Propriétaire. RCS Dunkerque A 309 666 709 RC 64-A 33 KRABANSKY Raphael, Noel Français. Activité : vente à titre ambulant de boulangerie, de patisserie, de pain et de confiserie. Adresse : centre commercial 2 59760 Grande-Synthe Fonds donné en location-gérance. Commentaires : fin de la location- gérance consentie à la S.A. BOULANGERIE PATISSERIE KRABANSKY, à compter du 31 juillet 1998. Date d'effet : 1er aout 1998 Bénéficiaire: E.U.R.L. SAINT- JACQUES.

03/07/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS o. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC RC 70-B 94 TAPIS SAINT MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : Société en commandite par actions. Capital : 6 743 580 F. Adresse du siège social : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos. Commentaires : ancien capital : 6 696 030 F Etablissement principal: Activité : industrie et commerce de tous textiles plus particulièrement de tapis. Adresse : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos Date de début d'activité: 1er octobre 1969. Date d'effet : 20 janvier 1998.

30/01/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS o. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC RC 70-B 94 TAPIS SAINT MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : Société en commandite par actions. Capital : 6 696 030 F. Adresse du siège social : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos. Administration : président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann, Guy) Membres du conseil de surveillance : DE BUCK (Jacques) LECLERCQ (Bertrand). Gérant : MULLIEZ ( Gonzague). Ancien membre du conseil de surveillance : LECONTE (Sandrine) Etablissement principal: Activité : industrie et commerce de tous textiles plus particulièrement de tapis. Adresse : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos Date de début d'activité: 1er octobre 1969. Date d'effet : 31 mai 1997.

01/06/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC 70-B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 6 691 680 F. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Administration : P.-D.G. : MULLIEZ (Gonzague). Administrateurs : MULLIEZ (Yann, Guy) DE BUCK (Jacques) LECLERCQ (Bertrand) GUERMONPREZ (Marc) Mme LECONTE, née DERVILLE (Sandrine). Commissaires aux comptes titulaires : VANDENBURIE ( Pierre) CABINET BRACQ ET ASSOCIES-STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES. Commissaires aux comptes suppléants : BRACQ (Léon) DESURMONT (Jean, Marie). Anciens administrateurs : PLANCKE (Michel) SACCHI (Emmanuel) Nouvelle situation du siège social. Capital : 6 749 200 F Etablissement principal: Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Date d'effet : 30 octobre 1995.

01/06/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC 70-B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 6 696 030 F. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Administration : président du conseil de surveillance : MULLIEZ (Yann, Guy). Membres du conseil de surveillance : DE BUCK (Jacques) LECLERCQ (Bertrand) LECONTE, née DERVILLE (Sandrine). Gérant : MULLIEZ ( Gonzague) Nouvelle situation du siège social. Forme : société en commandite par actions Etablissement principal: Activité : industrie et commerce de tous textiles, plus particulièrement de tapis. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Date d'effet : 1er janvier 1997.

01/06/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC 70-B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 6 749 200 F. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos Nouvelle situation du siège social. Capital : 6 696 030 F Etablissement principal: Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Date d'effet : 18 décembre 1995.

28/01/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC 70-B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.A. Capital : 6 727 000 F. Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Administration : P.-D.G. : MULLIEZ ( Gonzague). Administrateurs : MULLIEZ ( Yann, Guy) DE BUCK (Jacques) PLANCKE (Michel) LECLERCQ (Bertrand) GUERMONPREZ (Marc) Mme LECONTE, née DERVILLE (Sandrine) SACCHI (Emmanuel). Commissaires aux comptes titulaires : VANDENBURIE (Pierre) CABINET BRACQ ET ASSOCIES-STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES. Commissaires aux comptes suppléants : BRACQ (Léon) DESURMONT (Jean, Marie). Anciens administrateurs : MULLIEZ ( Olivier) DUPREZ (Philippe) MULLIEZ ( Damien) TAPIS INVESTISSEMENT Nouvelle situation du siège social. Capital : 6 691 680 F Etablissement principal: Adresse : 330 rue Carnot 59150 Wattrelos. Date d'effet : 16 novembre 1994.

18/01/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS o. RCS Roubaix-Tourcoing B 470 500 943 RC RC 70-B 94 TAPIS SAINT-MACLOU. Sigle : T.S.M. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 6 727 000 F. Adresse du siège social : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos. Administration : président-directeur général : MULLIEZ ( Gonzague) Administrateurs : MULLIEZ ( Damien) TAPIS INVESTISSEMENT DUPREZ (Philippe) MULLIEZ (Yann, Guy). Nouveaux administrateurs : DE BUCK ( Jacques) GUERMONPREZ (Marc) MULLIEZ (Olivier). Commissaires aux comptes titulaires : VANDENBURIE (Pierre) CABINET BRACQ ET ASSOCIES SOCIETE D' EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES. Commissaires aux comptes suppléants : BRACQ (Léon) DESURMONT ( Jean-Marie) Etablissement principal: Adresse : 330, rue Carnot 59150 Wattrelos Date de début d'activité: 1er octobre 1969. Date d'effet : 17 juin 1994.

 

 

Company events history

 

Date

Description

21/09/2015

21/09/2015

21/09/2015

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

31/08/2015

Bodacc C : Deposit accounts notice

08/08/2015

08/08/2015

31/12/2014

New accounts available

02/12/2014

Bodacc C : Deposit accounts notice

08/11/2014

08/11/2014

08/11/2014

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

22/07/2014

22/07/2014

31/12/2013

New accounts available

17/10/2013

17/10/2013

26/09/2013

Bodacc A : Sale and transfer

19/09/2013

Bodacc A : Sale and transfer

17/09/2013

Bodacc A : Sale and transfer

13/09/2013

Bodacc A : Sale and transfer

11/09/2013

Bodacc A : Sale and transfer

27/08/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

26/08/2013

Bodacc C : Deposit accounts notice

02/08/2013

Bodacc B: Various editing or changing

16/07/2013

Minutes of general meeting of shareholders

16/07/2013

Capital increase

16/07/2013

Amendment

16/07/2013

Updated articles of association

10/07/2013

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer

03/07/2013

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer

03/07/2013

Modification to Establishment Address or Identifier

28/06/2013

Legal Gazette: Modification of the share capital

28/06/2013

Other modification of Establishment

17/01/2013

Collection of preferential rights activated for this company

31/12/2012

New accounts available

10/12/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

28/09/2012

Bodacc B: Various editing or changing

13/09/2012

New auditor

13/09/2012

New auditor

13/09/2012

Minutes of general meeting of shareholders

13/09/2012

Amendment

15/02/2012

Bodacc B: Various editing or changing

03/02/2012

Updated articles of association

03/02/2012

Minutes of Board meeting

03/02/2012

Capital increase

03/02/2012

Capital increase

03/02/2012

Amendment

03/02/2012

Updated articles of association

24/01/2012

Legal Gazette: Modification of the share capital

24/01/2012

Other modification of Establishment

25/10/2011

Bodacc C : Deposit accounts notice

19/10/2011

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

20/09/2011

Bodacc B: Various editing or changing

10/09/2011

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

09/09/2011

Amendment

09/09/2011

Changes to the Board of Directors

09/09/2011

Changes to the Board of Directors

09/09/2011

Minutes of Board meeting

09/03/2011

Bodacc B: Various editing or changing

04/03/2011

New ultimate parent

28/02/2011

Minutes of general meeting of shareholders

28/02/2011

Minutes of Board meeting

28/02/2011

Changes to the Board of Directors

28/02/2011

Appointment/resignation of company officers

28/02/2011

Appointment/resignation of company officers

28/02/2011

Amendment

28/02/2011

Changes to the Board of Directors

19/02/2011

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

26/01/2011

Bodacc B: Various editing or changing

21/01/2011

Legal Gazette: Appointment of the social representative

13/01/2011

Minutes of general meeting of shareholders

13/01/2011

Minutes of general meeting of shareholders

13/01/2011

Changes to the Board of Directors

13/01/2011

Changes to the Board of Directors

31/12/2010

New accounts available

17/12/2010

Bodacc B: Various editing or changing

06/12/2010

Change to corporate purpose

06/12/2010

Updated articles of association

06/12/2010

Updated articles of association

06/12/2010

Minutes of general meeting of shareholders

06/12/2010

Minutes of general meeting of shareholders

06/12/2010

Change to corporate purpose

30/11/2010

Modification of Company Activity

30/11/2010

Update of Company Activity

12/10/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

13/08/2010

New subsidiarie(s) detected

13/08/2010

New ultimate parent

13/08/2010

New parent detected

30/03/2010

Payment incident closed

26/01/2010

Payment incident detected

31/12/2009

New accounts available

30/12/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

25/06/2009

Bodacc B: Various editing or changing

16/06/2009

Minutes of Board meeting

16/06/2009

Updated articles of association

16/06/2009

Updated articles of association

16/06/2009

Private document

16/06/2009

New chairman (CEO, CoB)

16/06/2009

Minutes of general meeting of shareholders

16/06/2009

Amendment

16/06/2009

Appointment/resignation of company officers

16/06/2009

Changes to the Board of Directors

16/06/2009

Minutes of Board meeting

16/06/2009

Minutes of general meeting of shareholders

15/05/2009

Payment incident closed

12/05/2009

Modification to Establishment Address or Identifier

12/05/2009

Update of Company Legal Form

12/05/2009

Other modification of Establishment (error correction)

24/04/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

25/02/2009

Payment incident detected

31/12/2008

New accounts available

01/12/2008

Formation of Establishment

12/08/2008

New Bodacc B ads detected

12/08/2008

Bodacc B: Various editing or changing

01/08/2008

Appointment/resignation of company officers

01/08/2008

Private document

01/08/2008

Minutes of general meeting of shareholders

01/08/2008

Minutes of general meeting of shareholders

01/08/2008

Appointment/resignation of company officers

01/08/2008

Amendment

15/06/2008

Bodacc B: Various editing or changing

15/06/2008

New Bodacc B ads detected

11/06/2008

New Bodacc A ads detected

11/06/2008

Bodacc A : Registration

08/06/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

02/06/2008

Amendment

02/06/2008

Appointment/resignation of company officers

02/06/2008

Appointment/resignation of company officers

02/06/2008

Capital increase

02/06/2008

Minutes of general meeting of shareholders

02/06/2008

Minutes of general meeting of shareholders

02/06/2008

New chairman (CEO, CoB)

02/06/2008

Private document

18/04/2008

Collection of preferential rights activated for this company

31/12/2007

New accounts available

20/07/2007

Updated articles of association

20/07/2007

Private document

20/07/2007

Updated articles of association

20/07/2007

Amendment

20/07/2007

Capital increase

20/07/2007

Capital increase

20/07/2007

Minutes of general meeting of shareholders

20/07/2007

Minutes of general meeting of shareholders

30/06/2007

Other modification of Establishment

31/12/2006

New accounts available

12/09/2006

New legal form – no new category

12/09/2006

Minutes of general meeting of shareholders

12/09/2006

Minutes of general meeting of shareholders

12/09/2006

Audit or Management Report

12/09/2006

Audit or Management Report

12/09/2006

Appointment/resignation of company officers

12/09/2006

Private document

12/09/2006

Updated articles of association

12/09/2006

Updated articles of association

12/09/2006

Amendment

31/12/2005

New accounts available

20/12/2004

Private document

20/12/2004

Updated articles of association

20/12/2004

Minutes of general meeting of shareholders

20/12/2004

Capital increase

21/06/2004

Private document

21/06/2004

Minutes of general meeting of shareholders

21/06/2004

Updated articles of association

28/07/2003

Amendment

28/07/2003

Appointment/resignation of company officers

28/07/2003

Changes to the Board of Directors

28/07/2003

Private document

28/07/2003

Minutes of general meeting of shareholders

28/07/2003

New chairman (CEO, CoB)

04/12/2002

Amendment

04/12/2002

Appointment/resignation of company officers

04/12/2002

Changes to the Board of Directors

04/12/2002

Minutes of general meeting of shareholders

04/12/2002

New chairman (CEO, CoB)

04/12/2002

Private document

23/09/2002

Minutes of general meeting of shareholders

23/09/2002

Updated articles of association

23/09/2002

Private document

12/12/2001

Private document

12/12/2001

New auditor

12/12/2001

Appointment/resignation of company officers

12/12/2001

Minutes of general meeting of shareholders

05/01/2001

Appointment/resignation of company officers

05/01/2001

Minutes of general meeting of shareholders

05/01/2001

New auditor

05/01/2001

New manager

05/01/2001

Updated articles of association

05/01/2001

Private document

16/09/1999

Private document

16/09/1999

Updated articles of association

16/09/1999

Amendment

16/09/1999

Capital increase

16/09/1999

Minutes of general meeting of shareholders

15/09/1999

Appointment/resignation of company officers

15/09/1999

Private document

15/09/1999

Minutes of general meeting of shareholders

02/06/1999

Amendment

02/06/1999

Private document

18/06/1998

Amendment

18/06/1998

Capital increase

18/06/1998

Minutes of general meeting of shareholders

18/06/1998

Private document

18/06/1998

Updated articles of association

13/01/1998

Minutes of general meeting of shareholders

13/01/1998

Private document

13/01/1998

Appointment/resignation of company officers

16/05/1997

Private document

16/05/1997

New legal form – no new category

16/05/1997

New chairman (CEO, CoB)

16/05/1997

Minutes of general meeting of shareholders

16/05/1997

Minutes of Board meeting

16/05/1997

Updated articles of association

16/05/1997

Capital reduction

16/05/1997

Capital increase

16/05/1997

Appointment/resignation of company officers

16/05/1997

Amendment

16/05/1997

Changes to the Board of Directors

12/01/1996

Amendment

12/01/1996

Updated articles of association

12/01/1996

Minutes of general meeting of shareholders

12/01/1996

Minutes of Board meeting

12/01/1996

Changes to the Board of Directors

12/01/1996

Capital reduction

12/01/1996

Appointment/resignation of company officers

29/12/1995

Appointment/resignation of company officers

29/12/1995

Changes to the Board of Directors

29/12/1995

Minutes of general meeting of shareholders

23/12/1993

Minutes of Board meeting

23/12/1993

Capital reduction

23/12/1993

Updated articles of association

23/12/1993

Declaration of conformity

23/12/1993

Amendment

22/12/1993

Minutes of Board meeting

22/12/1993

Declaration of conformity

22/12/1993

Capital increase

22/12/1993

Amendment

22/12/1993

Updated articles of association

03/12/1993

Amendment

03/12/1993

Capital increase

03/12/1993

Minutes of Board meeting

03/12/1993

Updated articles of association

03/12/1993

Declaration of conformity

09/09/1993

Minutes of general meeting of shareholders

09/09/1993

Capital increase

03/05/1993

Amendment

03/05/1993

Changes to the Board of Directors

03/05/1993

Minutes of Board meeting

03/05/1993

Minutes of general meeting of shareholders

03/05/1993

Appointment/resignation of company officers

11/12/1991

Updated articles of association

11/12/1991

Minutes of general meeting of shareholders

11/12/1991

Merger

11/12/1991

Declaration of conformity

11/12/1991

Capital increase

 

 

Synthesized Accounts

 

Annual Accounts

 

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2012

Account period (month)

12

12

12

Account Type

Normal

Normal

Normal

Date of capture

17/09/2015

07/11/2014

13/08/2013

Activity Code

4753Z

4753Z

4753Z

Employees

1488

0

0

 

 

Active account

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

59,926,811

-14.6 %

70,139,000

-12.5 %

80,134,000

57,511

104100.6 %

Intangible assets

2,502,191

-12.4 %

2,856,000

-12.2 %

3,253,000

2,287

109309.3 %

Tangible assets

35,735,714

-0.2 %

35,812,000

-9.7 %

39,641,000

17,095

208941.9 %

Financial assets

21,688,908

-31.1 %

31,471,000

-15.5 %

37,240,000

2,540

853794.0 %

Net current assets

64,515,210

10.9 %

58,184,000

0.8 %

57,696,000

183,256

35105.0 %

Stocks

34,172,061

-6.9 %

36,722,000

0.9 %

36,380,000

59,799

57044.9 %

Advanced payments

503,284

0%

0

0%

0

0

0%

Receivables

27,514,780

28.2 %

21,462,000

0.7 %

21,316,000

47,786

57479.2 %

Securities and cash

2,325,086

0%

0

0%

0

40,100

5698.2 %

Prepaid expenses

-

-

-

-

-

258

-

Accounts of regularization

20,728

0%

0

0%

0

0

0%

Total Assets

124,462,749

-3.0 %

128,323,000

-6.9 %

137,830,000

270,922

45840.4 %

 

 

Passive Account

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Shareholders' equity

55,354,801

4.2 %

53,132,000

58.0 %

33,628,000

90,760

60890.3 %

Share capital

1,785,526

12.4 %

1,588,000

16.4 %

1,364,000

15,000

11803.5 %

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

11,182,034

39.5 %

8,013,000

9.7 %

7,307,000

0

0%

Liabilities

57,925,542

-13.8 %

67,178,000

-30.7 %

96,895,000

171,330

33709.3 %

Financial liabilities

25,365,837

-22.6 %

32,782,000

-48.5 %

63,675,000

28,521

88837.4 %

Advanced payments received

2,237,601

0%

0

0%

0

0

0%

Trade account payables

10,241,797

-28.1 %

14,250,000

14.6 %

12,438,000

52,729

19323.5 %

Tax and social liabilities

16,251,534

0%

0

0%

0

38,345

42282.4 %

Other debts and fixed assets liabilities

260,482

-98.4 %

16,653,000

-2.1 %

17,010,000

4,804

5322.2 %

Account regularization

3,568,664

2.2 %

3,493,000

-7.4 %

3,772,000

0

0%

Total liabilities

124,462,749

-3.0 %

128,323,000

-6.9 %

137,830,000

270,922

45840.4 %

 

 

Results

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Sales of Goods

234,208,056

1.7 %

230,375,000

-1.8 %

234,590,000

475,723

49132.0 %

Net turnover

232,668,069

1.7 %

228,744,000

-1.0 %

231,063,000

479,612

48411.7 %

of which net export turnover

4,975,186

0%

0

0%

0

0

0%

Operating charges

242,279,156

3.2 %

234,793,000

-1.1 %

237,428,000

464,771

52028.7 %

Operating profit/loss

-8,071,101

-82.7 %

-4,418,000

-55.7 %

-2,838,000

5,859

-137855.6 %

Financial income

9,959,589

0%

0

0%

0

49

20325591.8 %

Financial charges

11,686,424

-3.4 %

12,104,000

-29.9 %

17,264,000

664

1759903.6 %

Financial profit/loss

-1,726,836

85.7 %

-12,104,000

29.9 %

-17,264,000

-212

-814445.3 %

Pretax net operating income

-9,797,937

40.7 %

-16,522,000

17.8 %

-20,102,000

5,764

-170085.0 %

Extraordinary income

13,130,935

-9.8 %

14,564,000

24.1 %

11,740,000

1

1313093400.0 %

Extraordinary charges

7,228,329

81.9 %

3,974,000

0.4 %

3,958,000

391

1848577.5 %

Extraordinary profit/loss

5,902,606

-44.3 %

10,590,000

36.1 %

7,782,000

0

0%

Net result

-3,815,408

33.6 %

-5,749,000

53.1 %

-12,253,000

6,419

-59539.3 %

 

 

Accounts – Active

 

Normal Account

 

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2012

Months

12

12

12

 

 

Grand Total - Active Accounts (I to VI)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Grand Total (I to VI)

Net

124,462,749

-3.0 %

128,323,000

-6.9 %

137,830,000

Gross

CO

301,216,382

134.7 %

128,323,000

-6.9 %

137,830,000

Amortisation

1A

176,753,633

0%

0

0%

0

 

 

Non declared distributed capital (I)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

Gross

AA

0

0%

0

0%

0

 

 

Active fixed asset (II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total Active fixed asset (II)

Net

59,926,811

-14.6 %

70,139,000

-12.5 %

80,134,000

Gross

BJ

232,653,834

231.7 %

70,139,000

-12.5 %

80,134,000

Amortisation

BK

172,727,023

0%

0

0%

0

 

 

Intangible fixed assets

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R&D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CQ

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

657,721

0%

0

0%

0

Gross

AF

2,033,762

0%

0

0%

0

Amortisation

AG

1,376,041

0%

0

0%

0

Goodwill

Net

1,744,573

0%

0

0%

0

Gross

AH

2,166,908

0%

0

0%

0

Amortisation

AI

422,335

0%

0

0%

0

Other intangible fixed assets

Net

99,897

-96.5 %

2,856,000

-12.2 %

3,253,000

Gross

AJ

253,396

-91.1 %

2,856,000

-12.2 %

3,253,000

Amortisation

AK

153,499

0%

0

0%

0

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible asset

Net

2,502,191

-12.4 %

2,856,000

-12.2 %

3,253,000

 

 

Tangilble fixed assets

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Lands

Net

6,845,693

0%

0

0%

0

Gross

AN

6,960,343

0%

0

0%

0

Amortisation

AO

114,650

0%

0

0%

0

Buildings

Net

23,385,631

0%

0

0%

0

Gross

AP

99,234,002

0%

0

0%

0

Amortisation

AQ

75,848,371

0%

0

0%

0

Plant

Net

315,927

0%

0

0%

0

Gross

AR

2,412,554

0%

0

0%

0

Amortisation

AS

2,096,628

0%

0

0%

0

Other tangible fixed assets

Net

4,583,438

-87.2 %

35,812,000

-9.7 %

39,641,000

Gross

AT

33,880,643

-5.4 %

35,812,000

-9.7 %

39,641,000

Amortisation

AU

29,297,205

0%

0

0%

0

Fixed assets in construction

Net

588,889

0%

0

0%

0

Gross

AV

588,889

0%

0

0%

0

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

16,136

0%

0

0%

0

Gross

AX

16,136

0%

0

0%

0

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

Sub Total Tangible asset

Net

35,735,714

-0.2 %

35,812,000

-9.7 %

39,641,000

 

 

Financial assets

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

8,453,715

0%

0

0%

0

Gross

CU

65,173,964

0%

0

0%

0

Amortisation

CV

56,720,249

0%

0

0%

0

Inter-company receivables

Net

12,655,631

0%

0

0%

0

Gross

BB

19,353,677

0%

0

0%

0

Amortisation

BC

6,698,046

0%

0

0%

0

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

Loans

Net

10,300

0%

0

0%

0

Gross

BF

10,300

0%

0

0%

0

Amortisation

BG

0

0%

0

0%

0

Other financial assets

Net

569,262

-98.2 %

31,471,000

-15.5 %

37,240,000

Gross

BH

569,262

-98.2 %

31,471,000

-15.5 %

37,240,000

Amortisation

BI

0

0%

0

0%

0

Sub Total Financial assets

Net

21,688,908

-31.1 %

31,471,000

-15.5 %

37,240,000

 

 

Current Assets (III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total Current Assets

Net

64,515,210

10.9 %

58,184,000

0.8 %

57,696,000

Gross

CJ

68,541,819

17.8 %

58,184,000

0.8 %

57,696,000

Amortisation

CK

4,026,610

0%

0

0%

0

 

 

Stocks

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Raw materials

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BL

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BM

0

0%

0

0%

0

Work in progress (goods)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BN

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BR

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BS

0

0%

0

0%

0

Goods for resale

Net

34,172,061

-6.9 %

36,722,000

0.9 %

36,380,000

Gross

BT

36,334,021

-1.1 %

36,722,000

0.9 %

36,380,000

Amortisation

BU

2,161,960

0%

0

0%

0

Sub Total Stocks

Net

34,172,061

-6.9 %

36,722,000

0.9 %

36,380,000

 

 

Advance payments to suppliers

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Advance payments to suppliers

Net

503,284

0%

0

0%

0

Gross

BV

503,284

0%

0

0%

0

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0

 

 

Debtors

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Trade accounts receivable

Net

11,510,972

14.6 %

10,044,000

-5.4 %

10,622,000

Gross

BX

11,903,153

18.5 %

10,044,000

-5.4 %

10,622,000

Amortisation

BY

392,181

0%

0

0%

0

Other debtors

Net

14,347,017

43.0 %

10,036,000

18.0 %

8,507,000

Gross

BZ

14,347,017

43.0 %

10,036,000

18.0 %

8,507,000

Amortisation

CA

0

0%

0

0%

0

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

Sub Total debtors

Net

25,857,989

28.8 %

20,080,000

5.0 %

19,129,000

 

 

Divers

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Investment securities

Net

794,573

0%

0

0%

0

Gross

CD

2,267,041

0%

0

0%

0

Amortisation

CE

1,472,468

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

1,530,513

0%

0

0%

0

Gross

CF

1,530,513

0%

0

0%

0

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

Sub Total Divers

Net

2,325,086

0%

0

0%

0

 

 

Prepaid expenses

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Prepaid expenses

Net

1,656,791

19.9 %

1,382,000

-36.8 %

2,187,000

Gross

CH

1,656,791

19.9 %

1,382,000

-36.8 %

2,187,000

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

 

Equalization accounts (IV to VI)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Expenses of loan issue to be spread

CW3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Currency differential gain

CN3

20,728

0%

0

0%

0

Gross

20,728

0%

0

0%

0

 

 

References

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

 

Accounts – Passive

 

Grand Total - Passive Accounts (I to V)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Grand Total (I to V)

EE

124,462,749

-3.0 %

128,323,000

-6.9 %

137,830,000

 

 

Shareholder Equity (I)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total shareholders' equity (Total I)

DL

55,354,801

4.2 %

53,132,000

58.0 %

33,628,000

Equity and shareholders' equity

DA

1,785,526

12.4 %

1,588,000

16.4 %

1,364,000

Issue and merger premiums

DB

0

0%

0

0%

0

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

Legal reserve

DD

136,379

0%

0

0%

0

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

Other reserves

DG

53,791,637

-6.1 %

57,293,000

28.7 %

44,517,000

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

0%

0

0%

0

Profits or losses brought forward

DH

0

0%

0

0%

0

Profit or loss for the period

DI

-3,815,408

33.6 %

-5,749,000

53.1 %

-12,253,000

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

Special tax-allowable reserves

DK

3,456,667

0%

0

0%

0

 

 

Other capital resources (II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

 

 

Provisions for risks and charges (III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

11,182,034

39.5 %

8,013,000

9.7 %

7,307,000

Risk provisions

DP

4,104,827

-48.8 %

8,013,000

9.7 %

7,307,000

Reserves for charges

DQ

7,077,208

0%

0

0%

0

 

 

Liabilities (IV)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total Liabilities (Total IV)

EC

57,925,542

-13.8 %

67,178,000

-30.7 %

96,895,000

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

Bank loans and liabilities

DU

23,946,181

0%

0

0%

0

Sundry loans and financial liabilities

DV

1,419,656

-95.7 %

32,782,000

-48.5 %

63,675,000

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

Advance payments received for current orders

DW

2,237,601

0%

0

0%

0

Trade accounts payables

DX

10,241,797

-28.1 %

14,250,000

14.6 %

12,438,000

Tax and social security liabilities

DY

16,251,534

0%

0

0%

0

Fixed asset liabilities

DZ

0

0%

0

0%

0

Other debts

EA

260,110

-98.4 %

16,653,000

-2.1 %

17,010,000

 

 

Translation loss (V)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Translation loss (Total V)

ED

372

0%

0

0%

0

 

 

Equalization accounts

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Deferred income

EB

3,568,664

2.2 %

3,493,000

-7.4 %

3,772,000

 

 

References

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

 

 

Result account

 

1 - Operating result (I-II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Operating result (Total I-II)

GG

-8,071,101

-82.7 %

-4,418,000

-55.7 %

-2,838,000

 

 

2 - Financial result (V-VI)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Financial result (Total V-VI)

GV

-1,726,836

85.7 %

-12,104,000

29.9 %

-17,264,000

 

 

3 - Pre-tax net operating income result (I to VI)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

-9,797,937

40.7 %

-16,522,000

17.8 %

-20,102,000

 

 

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

5,902,606

-44.3 %

10,590,000

36.1 %

7,782,000

 

 

Profit or loss

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Profit or loss

HN

-3,815,408

33.6 %

-5,749,000

53.1 %

-12,253,000

 

 

Total Income (I+III+V+VII)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total Income (Total I+III+V+VII)

HL

257,298,579

5.0 %

244,939,000

-0.6 %

246,330,000

 

 

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

261,113,987

4.2 %

250,688,000

-3.1 %

258,583,000

 

 

Operating income (I)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total operating income (Total I)

FR

234,208,056

1.7 %

230,375,000

-1.8 %

234,590,000

 

 

Operating income (details)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sale of goods for resale

FC

227,789,598

0%

0

0%

0

France

FA

227,785,685

0%

0

0%

0

Export

FB

3,912

0%

0

0%

0

Sale of goods produced

FF

-35,193,063

0%

0

0%

0

France

FD

-35,193,063

0%

0

0%

0

Export

FE

0

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

40,071,533

-82.5 %

228,744,000

-1.0 %

231,063,000

France

FG

35,100,260

-84.7 %

228,744,000

-1.0 %

231,063,000

Export

FH

4,971,274

0%

0

0%

0

Net turnover

FL

232,668,069

1.7 %

228,744,000

-1.0 %

231,063,000

France

FJ

227,692,883

-0.5 %

228,744,000

-1.0 %

231,063,000

Export

FK

4,975,186

0%

0

0%

0

Stocked production

FM

0

0%

0

0%

0

Self-constructed assets

FN

35,247

0%

0

0%

0

Operating grants

FO

91,470

0%

0

0%

0

Release of reserves and provisions

FP

1,396,475

0%

0

0%

0

Other income

FQ

16,795

-99.0 %

1,631,000

-53.8 %

3,527,000

 

 

Operating charges (II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total operating charges (Total II)

GF

242,279,156

3.2 %

234,793,000

-1.1 %

237,428,000

 

 

Exploitation charges

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Purchase of goods for resale

FS

96,508,381

0%

0

0%

0

Change in stocks of goods for resale

FT

-32,624

0%

0

0%

0

Purchase of raw materials

FU

632,096

0%

0

0%

0

Change in stocks of raw materials

FV

0

0%

0

0%

0

Other external purchases and charges

FW

60,032,744

-61.1 %

154,229,000

-0.5 %

154,968,000

Tax, duty and similar payments

FX

10,905,460

0%

0

0%

0

Payroll

FY

47,859,810

0%

0

0%

0

Social security costs

FZ

18,463,594

-75.0 %

73,923,000

-3.3 %

76,420,000

 

 

Depreciation

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Depreciation of fixed assets

GA

5,505,072

-17.1 %

6,641,000

10.0 %

6,040,000

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

0

Depreciation/amortisation of current assets

GC

173,402

0%

0

0%

0

Provisions for risks and charges

GD

1,368,478

0%

0

0%

0

 

 

Other charges

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Other charges

GE

862,744

0%

0

0%

0

 

 

Operating charges (III-IV)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

 

 

Financial income (V)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total financial income (Total V)

GP

9,959,589

0%

0

0%

0

Share financial income

GJ

128,264

0%

0

0%

0

Other investment income & capitalised receivables

GK

480

0%

0

0%

0

Other interest and similar income

GL

2,364,068

0%

0

0%

0

Released provisions and transferred charges

GM

7,462,283

0%

0

0%

0

Exchange gains

GN

4,494

0%

0

0%

0

Net income from disposal of investment securities

GO

0

0%

0

0%

0

 

 

Financial charge (VI)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total financial charge (Total VI)

GU

11,686,424

-3.4 %

12,104,000

-29.9 %

17,264,000

Financial reserves and provisions

GQ

10,137,935

0%

0

0%

0

Interest and similar charges

GR

1,481,947

-87.8 %

12,104,000

-29.9 %

17,264,000

Exchange losses

GS

66,542

0%

0

0%

0

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary income (VII)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total extraordinary income (Total VII)

HD

13,130,935

-9.8 %

14,564,000

24.1 %

11,740,000

Extraordinary operating income

HA

896,441

-93.8 %

14,564,000

24.1 %

11,740,000

Extraordinary income from capital transactions

HB

10,872,585

0%

0

0%

0

Released provisions and transferred charges

HC

1,361,908

0%

0

0%

0

 

 

Extraordinary charges (VIII)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

7,228,329

81.9 %

3,974,000

0.4 %

3,958,000

Extraordinary operating charges

HE

1,316,673

-66.9 %

3,974,000

0.4 %

3,958,000

Extraordinary charges from capital transactions

HF

2,785,412

0%

0

0%

0

Extraordinary reserves and provisions

HG

3,126,245

0%

0

0%

0

 

 

Employee profit sharing (IX)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

0

0%

0

0%

-67,000

 

 

Tax on profits (X)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Tax on profits (Total X)

HK

-79,923

56.3 %

-183,000

0%

0

 

 

References

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

Of which transferred charges

A1

0

0%

0

0%

0

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

 

 

Other incomes tax return forms

 

Fixed Assets

 

Grand Total Fixed Assets (I to IV)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

OK2

17,565,224

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

OL

232,653,833

0%

0

0%

0

 

 

Research and development Charge (Total I)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

CO1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

CO2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

DO

0

0%

0

0%

0

 

 

Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value at begin of period

KD

4,132,608

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

523,252

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

LV2

201,795

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

LW

4,454,065

0%

0

0%

0

 

 

Tangible fixed assets (Total III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value at begin of period

LN

143,478,500

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

7,162,598

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NG2

7,548,532

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

NH

143,092,566

0%

0

0%

0

 

 

Financial assets (Total IV)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value at begin of period

LQ

89,494,683

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

5,427,416

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NJ2

9,814,897

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

NK

85,107,202

0%

0

0%

0

 

 

Reserve for depreciation

 

Situation and movement of reserve for depreciation - Grand total (I-II-III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Reserve for depreciation value at begin of period

ON

0

0%

0

0%

0

Increases

OP

0

0%

0

0%

0

Decreasess

OQ

0

0%

0

0%

0

Reserve for depreciation value at the end of period

OR

0

0%

0

0%

0

 

 

Research and development charge (Total I)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0

 

 

Other intangible assets (Total II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

1,332,202

0%

0

0%

0

Increases

PF

198,888

0%

0

0%

0

Decreasess

PG

1,550

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

PH

1,529,540

0%

0

0%

0

 

 

Total fixed assets amotisation (Total III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

106,844,657

0%

0

0%

0

Increases

QV

5,306,184

0%

0

0%

0

Decreases

QW

4,908,637

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

QX

107,242,204

0%

0

0%

0

 

 

Movements during period affecting charge allocated over several period

 

Deferred charges and debt issuance costs

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0

 

 

Premium refund of obligations

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Net value at begin of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

 

 

Provisions included in balance sheet

 

Grand Total (I-II-III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Value at begining of period

7C

0

0%

0

0%

0

Increases

UB

0

0%

0

0%

0

Decreases

UC

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

UD

0

0%

0

0%

0

 

 

Includes Total allocations

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Operating

UE

0

0%

0

0%

0

Financial

UG

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UJ

0

0%

0

0%

0

 

 

Includes Total Withdrawal

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Operating

UF

0

0%

0

0%

0

Financial

UH

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UK

0

0%

0

0%

0

 

 

Total regulated provisions (Total I)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Value at begining of period

3Z

0

0%

0

0%

0

Increases

TS

0

0%

0

0%

0

Decreases

TT

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

TU

0

0%

0

0%

0

 

 

Total risk and charge provisions (Total II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Value at begining of period

5Z

0

0%

0

0%

0

Increases

TV

0

0%

0

0%

0

Decreases

TW

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

TX

0

0%

0

0%

0

 

 

Total Provision for depreciation (Total III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Value at begining of period

7B

0

0%

0

0%

0

Increases

TY

0

0%

0

0%

0

Decreases

TZ

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

UA

0

0%

0

0%

0

 

State deadlines claims and debts at the end of period

 

State claims

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value

VT

47,840,200

0%

0

0%

0

1 year at most

VU

27,917,261

0%

0

0%

0

More than one year

VV

19,922,939

0%

0

0%

0

 

 

State of loans

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Claims related to holdings (gross)

UL

19,353,677

0%

0

0%

0

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

0%

0

0%

0

Loans (gross)

UP

10,300

0%

0

0%

0

Loans (1 year at most)

UR

10,300

0%

0

0%

0

Other financial assets (gross)

UT

569,262

0%

0

0%

0

Other financial assets (1 year at most)

UV

0

0%

0

0%

0

 

 

Receivables statement of assets

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Customers doubtful or disputed

VA

723,212

0%

0

0%

0

Other claims customer

UX

11,179,941

0%

0

0%

0

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts

UY

25,052

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

0

0%

0

Income taxes

VM

317,184

0%

0

0%

0

Value added tax

VB

396,481

0%

0

0%

0

Other taxes and payments assimilated

VN

0

0%

0

0%

0

State and other public - Miscellaneous

VP

5,212,172

0%

0

0%

0

Group and Associates

VC

0

0%

0

0%

0

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

8,396,128

0%

0

0%

0

 

 

Prepaid

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Prepaid

VS

1,656,791

0%

0

0%

0

 

 

State Debt

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total debt (gross)

VY

55,687,942

0%

0

0%

0

1 year at most

VZ2

54,268,286

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

1,419,656

0%

0

0%

0

More than 5 years

VZ4

0

0%

0

0%

0

 

 

Details

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

22,344,716

0%

0

0%

0

1 year at most

VG2

22,344,716

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

1,601,465

0%

0

0%

0

1 year at most

VH2

1,601,465

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

1,419,656

0%

0

0%

0

1 year at most

8A2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8A3

1,419,656

0%

0

0%

0

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

10,241,797

0%

0

0%

0

1 year at most

8B2

10,241,797

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8B3

10,241,797

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

5,496,646

0%

0

0%

0

1 year at most

8C2

5,496,646

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

6,305,792

0%

0

0%

0

1 year at most

8D2

6,305,792

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (Gross)

VW1

1,342,039

0%

0

0%

0

1 year at most

VW2

1,342,039

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

3,107,057

0%

0

0%

0

1 year at most

VQ2

3,107,057

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8J2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VI2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

V14

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

260,110

0%

0

0%

0

1 year at most

8K2

260,110

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

3,568,664

0%

0

0%

0

1 year at most

8L2

3,568,664

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0

 

 

References

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Loans made during the period

VJ

58,034

0%

0

0%

0

Debt repaid during the period

VK

4,734,870

0%

0

0%

0

 

 

Table allocation results and other information

 

Dividends distributed

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0

 

 

Commitments

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0

 

 

Other charges Externes

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0

 

 

Taxes and Fees

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0

 

 

VAT

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0

 

 

Average number of employees

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Average number of employees

YP

1,488

0%

0

0%

0

 

 

Groups and Shareholders

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Groups and Shareholders

ZR

0

-

-

-

-

 

 

Ratios

 

Structure and Liquidity

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Fixed Asset Financing

1.14

-14.9 %

1.34

2.3 %

1.31

1.64

-30.5 %

Global Debt

90 days

-15.1 %

106 days

-29.8 %

151 days

115 days

-21.7 %

Working Capital Fund overall net

49 days

32.4 %

37 days

-2.6 %

38 days

57 days

-14.0 %

Financial independence

218.23 %

34.6 %

162.08 %

206.9 %

52.81 %

223.92 %

-2.5 %

Solvability

44.47 %

7.4 %

41.40 %

69.7 %

24.40 %

39.33 %

13.1 %

Capacity debt futures

231.16 %

-

-

-

-

1,171.77 %

-80.3 %

Coverage of current assets by net working capital overall

46.24 %

10.4 %

41.88 %

-5.0 %

44.09 %

39.65 %

16.6 %

General Liquidity

0.51

-

-

-

-

0.41

24.4 %

Restricted Liquidity

0.58

-

-

-

-

0.86

-32.6 %

 

 

Management or rotation

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Need background in operating working capital

49 days

19.5 %

41 days

0%

41 days

21 days

133.3 %

Treasury

6 days

0%

0 days

0%

0 days

16 days

-62.5 %

Inventory turnover of goods

136 days

-

-

-

-

101 days

34.7 %

Average length of credit granted to customers

18 days

12.5 %

16 days

-5.9 %

17 days

21 days

-14.3 %

Average length of credit obtained suppliers

23 days

-30.3 %

33 days

13.8 %

29 days

52 days

-55.8 %

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

0 days

-

-

-

-

0 days

0%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

163 days

-

-

-

-

644 days

-74.7 %

Rotation tangible assets

162.60 %

-

-

-

-

668.64 %

-75.7 %

 

 

Profitability of the business

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Margin trading

56.44 %

0%

0.00 %

0%

0.00 %

38.92 %

45.0 %

Profitability of the business

-0.68 %

-361.5 %

0.26 %

285.7 %

-0.14 %

2.89 %

-123.5 %

Net profit

-1.64 %

34.7 %

-2.51 %

52.6 %

-5.30 %

1.57 %

-204.5 %

Growth rate of turnover (excluding VAT)

1.72 %

272.0 %

-1.00 %

-135.7 %

2.80 %

-2.29 %

175.1 %

Rates integration

32.48 %

-0.3 %

32.58 %

-1.1 %

32.93 %

24.96 %

30.1 %

Rate leasing furniture

0.00 %

0%

0.00 %

0%

0.00 %

0.00 %

0%

Work Factor

87.77 %

-11.5 %

99.21 %

-1.2 %

100.43 %

78.60 %

11.7 %

Weight interests

5.02 %

-5.1 %

5.29 %

-29.2 %

7.47 %

0.19 %

2542.1 %

 

 

Return on capital

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Cash flow from the overall profitability

2.95 %

656.4 %

0.39 %

114.5 %

-2.69 %

3.20 %

-7.8 %

Rates of economic profitability

-2.00 %

-300.0 %

1.00 %

0%

0.00 %

10.00 %

-120.0 %

Financial profitability

55,354,801.00 %

4.2 %

53,132,000.00 %

58.0 %

33,628,000.00 %

61,357.00 %

90117.6 %

Return on investment

9.75 %

31.8 %

7.40 %

43.7 %

5.15 %

7.01 %

39.1 %

 

 

Management intermediate balances

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Turnover

232,668,069

1.7 %

228,744,000

-1.0 %

231,063,000

479,612

48411.7 %

 

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Sales of goods

227,789,598

0%

0

0%

0

-

- Purchase of goods

96,508,381

0%

0

0%

0

-

+/- Stock of goods variation

-32,624

0%

0

0%

0

-

Trading margin

131,313,841 €

0%

0 €

0%

0 €

145,436 €

90189.8 %

56.44 % CA

0%

0.00 % CA

0%

0.00 % CA

39.23 % CA

43.9 %

 

 

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Sale of goods produced

4,878,470

-97.9 %

228,744,000

-1.0 %

231,063,000

-

+/- Stocked production

0

0%

0

0%

0

-

+ Self-constructed assets

35,247

0%

0

0%

0

-

Period production

4,913,717 €

-97.9 %

228,744,000 €

-1.0 %

231,063,000 €

15,522 €

31556.5 %

2.11 % CA

-97.9 %

100.00 % CA

0%

100.00 % CA

6.34 % CA

-66.7 %

 

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Trading margin

131,313,841

0%

0

0%

0

145,436

90189.8 %

+ Period Production

4,913,717

-97.9 %

228,744,000

-1.0 %

231,063,000

15,522

31556.5 %

- Purchase of raw materials

632,096

0%

0

0%

0

-

+/- Change in stocks of raw materiels

0

0%

0

0%

0

-

- Other external purchases and charges

60,032,744

-61.1 %

154,229,000

-0.5 %

154,968,000

-

Added value

75,562,718 €

1.4 %

74,515,000 €

-2.1 %

76,095,000 €

127,344 €

59237.5 %

32.48 % CA

-0.3 %

32.58 % CA

-1.1 %

32.93 % CA

24.96 % CA

30.1 %

 

 

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Added value

75,562,718 €

1.4 %

74,515,000 €

-2.1 %

76,095,000 €

127,344 €

59237.5 %

+ Operating grants

91,470

0%

0

0%

0

-

- Tax, duty and similar payments

10,905,460

0%

0

0%

0

-

- Personal charges

66,323,404

-10.3 %

73,923,000

-3.3 %

76,420,000

-

Gross operating surplus

-1,574,676 €

-366.0 %

592,000 €

282.2 %

-325,000 €

10,156 €

-15604.9 %

-0.68 % CA

-361.5 %

0.26 % CA

285.7 %

-0.14 % CA

2.89 % CA

-123.5 %

 

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Gross operating surplus

-1,574,676 €

-366.0 %

592,000 €

282.2 %

-325,000 €

10,156 €

-15604.9 %

+ Release of reserves and provisions

1,396,475

0%

0

0%

0

-

+ Other operating income

16,795

-99.0 %

1,631,000

-53.8 %

3,527,000

-

- Depreciation/ Amortisation

7,046,952

6.1 %

6,641,000

10.0 %

6,040,000

-

- Other charges

862,744

0%

0

0%

0

-

Operating result

-8,071,102 €

-82.7 %

-4,418,000 €

-55.7 %

-2,838,000 €

6,115 €

-132088.6 %

-3.47 % CA

-79.8 %

-1.93 % CA

-56.9 %

-1.23 % CA

1.98 % CA

-275.3 %

 

 

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Operating result

-8,071,102 €

-82.7 %

-4,418,000 €

-55.7 %

-2,838,000 €

6,115 €

-132088.6 %

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

-

+ Financial income

9,959,589

0%

0

0%

0

-

- Financial charges

11,686,424

-3.4 %

12,104,000

-29.9 %

17,264,000

-

Pre-tax result

-9,797,937 €

40.7 %

-16,522,000 €

17.8 %

-20,102,000 €

5,863 €

-167214.7 %

-4.21 % CA

41.7 %

-7.22 % CA

17.0 %

-8.70 % CA

1.76 % CA

-339.2 %

 

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Extraordinary income

13,130,935

-9.8 %

14,564,000

24.1 %

11,740,000

1

1313093400.0 %

- Extraordinary charges

7,228,329

81.9 %

3,974,000

0.4 %

3,958,000

-

Extraordinary result

5,902,606 €

-44.3 %

10,590,000 €

36.1 %

7,782,000 €

0 €

0%

2.54 % CA

-45.1 %

4.63 % CA

37.4 %

3.37 % CA

0.00 % CA

0%

 

 

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Pre-tax result

-9,797,937 €

40.7 %

-16,522,000 €

17.8 %

-20,102,000 €

5,863 €

-167214.7 %

Extraordinary result

5,902,606 €

-44.3 %

10,590,000 €

36.1 %

7,782,000 €

0 €

0%

- Employee profit sharing

0

0%

0

0%

-67,000

-

- Tax on profits

-79,923

56.3 %

-183,000

0%

0

-

Net result

-3,815,408 €

33.6 %

-5,749,000 €

53.1 %

-12,253,000 €

6,418 €

-59548.6 %

-1.64 % CA

34.7 %

-2.51 % CA

52.6 %

-5.30 % CA

1.57 % CA

-204.5 %

 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.66.20

UK Pound

1

Rs.98.30

Euro

1

Rs.72.41

EUR

1

Rs.72.55

Note : Above are approximate rates obtained from sources believed to be correct

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

HNA

 

 

Report Prepared by :

ANK

 


 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.