MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

356662

Report Date :

26.12.2015

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

ZAPA

 

 

Registered Office :

Zapa Zapa - Linea T 54 Rue De Lancry 75010 Paris 10

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2013

 

 

Date of Incorporation :

April 1972

 

 

Legal Form :

Simplified joint stock company

 

 

Line of Business :

Retail sale of clothing in specialized stores

 

 

No. of Employee :

100 to 199 (2013)

           

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory 

 

 

Payment Behaviour :

Slow but correct

 

 

Litigation :

Clear

 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31, 2015

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2014)

Current Rating

(31.03.2015)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 

FRANCE - ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With more than 84 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that mitigate economic inequality. France's real GDP increased by 0.4% in 2014. The unemployment rate (including overseas territories) increased from 7.8% in 2008 to 10.4% in the fourth quarter of 2014. Youth unemployment in metropolitan France decreased from a high of 25.4% in the fourth quarter of 2012 to 24.3% in the fourth quarter of 2014. Lower-than-expected growth and high spending have strained France's public finances. The budget deficit rose sharply from 3.3% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 4% of GDP in 2014, while France's public debt rose from 68% of GDP to more than 95% in 2014, and may hit 100% by 2016. Elected on a conventionally leftist platform, President Francois HOLLANDE surprised and angered many supporters with a January 2014 speech announcing a sharp change in his economic policy, recasting himself as a liberalizing reformer. The government's budget for 2014 shifted the balance of fiscal consolidation from taxes to a total of $24 billion in spending cuts. In December 2014, HOLLANDE announced additional reforms, including a plan to extend commercial business hours, liberalize professional services, and sell off $6.2-12.4 billion in state owned assets. France’s tax burden remains well above the EU average and income tax cuts over the past decade are being partly reversed, particularly for higher earners. The top rate of income tax is 41%. The government is allowing a 75% payroll tax on salaries over $1.24 million to lapse.

 

Source : CIA

Company summery

 

SIRET

722 024 700 00188

Name

ZAPA

Acronym

-

Trade name

ZAPA

Status

Economically active

Postal Address

ZAPA
ZAPA - LINEA T
54 RUE DE LANCRY
75010 PARIS 10

Share Capital

5,368,416 Euros

Telephone

-

Activity (APE)

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z)

RCS Registration

RCS Paris B 722 024 700

Formation Date

01/1972

EUR VAT Number

FR92722024700

Deregistration Date

-

Last account Date

31/12/2013

Court Registry Number

19 7 2B02470

Incorporiation Date

04/1972

Registration Court

Paris (75)

Fax

-

Nationality

France

Safe Number

FR11863885

Legal form

Simplified joint stock company

Currency

Euros

 

 

Key Financials

 

YEAR TO DATE

TURNOVER

GROSS OPERATING SURPLUS

SHAREHOLDER'S EQUITY

NET RESULT

EMPLOYEES

31/12/2013

27,768,995 €

6.34% Turnover

12,346,945 €

-635,073 €

100 to 199 employees

31/12/2011

24,966,705 €

11.78% Turnover

12,309,204 €

537,435 €

100 to 199 employees

31/12/2009

23,822,175 €

6.05% Turnover

12,356,397 €

522,823 €

100 to 199 employees

 

 

 

 

Trends

 

Profitability

Liquidity

Net Worth

 

 

Directors

 

Current Directors

5

 

 

Ultimate Holding Company

 

Name

Safe Number

Country

Company Number

ZAPA DEVELOPPEMENT

FR09701195

498615228

Affiliation links.

 

 

Judgment and Preferential

 

Judgment

No judgement

Preferential Right

No social security and tax office preferential right to date

 

 

Establishment Details

 

Type of Establishment

Head Office

Production Role

-

APE/NAF Code

4642Z

Activity

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Formation Date

03/2000

Reason for Formation

Other

Closure Date

-

Reason for Closure

-

Reactivation Date

-

Seasonality

-

Activity Nature

Wholesale or intermediary of trade

Activity Location

Office

Trading Address

54 RUE DE LANCRY 
75010 PARIS 10

Department

Paris (75)

Location Surface

-

District

1

City

PARIS 10

Status

Economically active

Business Pages FT®

VETEMENTS POUR HOMMES ET DAMES (DETAIL)

Region

Ile-de-France

Area

24

Size of Urban Area

Paris conglomeration

 

 

Ultimate Parent(s)

 

1 ultimate parent company/companies for this company

 

Company Name

Activity (APE)

APE/NAF Code

City

Post Code

ZAPA DEVELOPPEMENT

Activités des sociétés holding

6420Z

PARIS 10

75010

 

 

Other Establishment(s)

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas having at least 50% of workforce in same area

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which one activity grouping from 50 to 80% of workforce

Branches

96 branch entities in this company

 

Company Name

Company Type

APE/NAF Code

Activity

City

Post Code

ZAPA

Head Office

4771Z

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

PARIS 10

75010

ZAPA

Branch

4771Z

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

MONTLUCON

03100

ZAPA

Branch

4771Z

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

DIJON

21000

ZAPA

Branch

4771Z

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

BESANCON

25000

ZAPA

Branch

4771Z

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

BORDEAUX

33000

 

 

Workforces

 

Workforce at address

20 to 49 employees

Company workforce

100 to 199 employees

 

Commentary

 

The comments are ordered according to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative for another or can change depending on its value. This is a purely statistical decision.

 

The increase in the gearing percentage over the last two accounting periods is 79 %

The return on total assets employed is -3

The stock to turnover ratio is 27.84

The pre-tax profit is -842,354 €

High risk workforce size

The ratio total assets to total liabilities is 1.70

The sales to current assets ratio is 2.39

The net turnover is 27,768,995 €

The net current assets are 11,613,172 €

The risk provisions are 35,000 €

Department code with low risk rating

Industry code with low risk rating

The company has 5 directors

The total assets are 30,050,328 €

The liabilities are 17,651,943 €

The increase of tangible fixed assets over the last two accounting periods is 55 %

The creditor days are 44.25

The shareholder's equity is 12,346,945 €

 

 

Industry comparison

 

Activity (APE)

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z)

Industry average credit rating

44

Industry average credit limit

7,043

 

 

Collective procedures

 

No judgment information for the company

 

 

Preferential rights details and history

 

Summary of preferential rights

 

Company monitored since

23/01/2009

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

Tax office preferential rights

Number of preferential rights

0

Total amount

-

Due remaining amount

-

Date of last preferential right

-

 

Historical

Registration number

Registration date

Date of the planned end

Creditor

Amount of the debt

Due remaining amount

40803883

06/02/2008

28/04/2009

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE PARIS 10E SUD

32,713 EUR

-

Reason for closure

Crossed Off

Court

Paris

Creditor

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE PARIS 10E SUD 

Debtor

SAS ZAPA 
54 R DE LANCRY 75010 PARIS

 

 

Group Data

 

Ultimate parent company

ZAPA DEVELOPPEMENT

Direct parent

ZAPA DEVELOPPEMENT - 100 %

Group – Number of companies

2

Linkages – Number of companies

-

Number of countries

-

 

NAME

SAFE NUMBER

SIREN

PARTS

RATING

LIMIT

LAST ACCOUNT PUBLISHED

1

ZAPA DEVELOPPEMENT

FR09701195

498615228

-

97

150,000 €

31/12/2013

2

ZAPA

FR11863885

722024700

100 %

55

96,000 €

31/12/2013

 

 

Director(s)

 

Name

M. BENAYOUN ARIÉ

Manager position

President

Date of birth

02/12/1968

Place of birth

STRASBOURG (67000)

Type

Individual

Name at birth

 

 

Statutory Auditor

 

Name

M. THEAU-LAURENT JEAN-MICHEL

Manager position

Statutory auditor

Date of birth

25/11/1944

Place of birth

DJIBOUTI(DJIBOUTI)

Type

Individual

Name at birth

Name

KPMG S.A.

Name of representative

Manager position

Statutory auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

Name

FID BFEC

Name of representative

Manager position

Deputy auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

Name

SALUSTRO REYDEL

Name of representative

Manager position

Deputy auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

Previous Directors

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

Managing director

M. COHEN SALOMON

-

Managing director

M. COHEN SALOMON

01/04/1945 - ORAN(ALGERIE)

Managing director

M. COHEN SALOMON

01/04/1945 - ORAN(ALGERIE)

 

Status history

 

No Status History

 

 

Recent publications in Gazettes

 

Publication date

Gazette Name

Description

25/11/2015

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

35 - ILLE-ET-VILAINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

259 - 813 393 980 RCS Rennes. LAFAYETTE. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Capital : 1000 EUR. Adresse : 10 rue Lafond, 35700 Rennes. 
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 400000 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : un fonds de commerce de prêt à porter femmes. Adresse : 5 rue Lafayette, 35000 Rennes. 
Précédent propriétaire : ZAPA. 722 024 700 RCS Paris. 
Date de commencement de l’activité : 10/11/2015. Oppositions : Au fonds vendu 5 rue Lafayette 35000 RENNES pour la validité et pour la correspondance Etude de Me Stéphane GLOCK 19 route de Strasbourg CS 80006 67610 LA WANTZENAU. Descriptif : - Acte notarié - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

22/11/2015

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1626 - 722 024 700 RCS Paris. ZAPA. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 5368416 EUR. Adresse : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Précédent propriétaire : ZANA. 538 653 080 RCS Paris. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Oppositions : Article L.236-14 du code de commerce. Descriptif : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Soci¿t¿ absorbante : ZAPA Forme : Soci¿t¿ par actions simplifi¿e Adresse du si¿ge : 54 rue de Lancry 75010 Paris Capital : 5368416.00 EUR Num¿ro unique d'identification : 722024700 Lieu d'immatriculation : Paris. Soci¿t¿ absorbee : ZANA Forme : Soci¿t¿ par actions simplifi¿e Adresse du si¿ge : 54 rue de Lancry 75010 Paris Capital : 5000.00 EUR Num¿ro unique d'identification : 538653080 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission ¿ la soci¿t¿ absorbante est pr¿vue : actif de 338008.00 EUR - passif de 709600.00 EUR. Rapport d'¿change des droits sociaux : la soci¿t¿ absorbante d¿tenant la totalit¿ des actions de la soci¿t¿ absorb¿e, il ne sera proc¿d¿ ¿ aucune augmentation de capital par la soci¿t¿ absorbante. Montant du mali de fusion / scission : 371592.00 EUR. Date du projet commun de fusion : 02.11.2015. Date et lieu du d¿p¿t du projet au RCS au titre de chaque soci¿t¿ participante : Pour la soci¿t¿ ZAPA : 16.11.2015 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la soci¿t¿ ZANA : 16.11.2015 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

01/10/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2595 - 722 024 700 RCS Paris. ZAPA. Forme : Société par actions simplifiée (à associé unique). Administration : Directeur général partant : Cohen, Salomon, Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société partant : Cohen, Salomon. Capital : 5368416 EUR. Activité : 
Adresse du siège social : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

15/09/2015

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Echos (Les) / Le Publicateur Légal - La Vie Judiciaire


Date de décision : 29/07/2015
La société 722024700 - ZAPA, ZAPA, 54 RUE DE LANCRY, 75010 PARIS 10 
Fait l'objet du départ de Monsieur Salomon COHEN, 97 Boulevard Haussmann, 75008, PARIS 08

31/12/2014

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

33 - GIRONDE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

212 - 410 089 866 RCS Bordeaux. BMC SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 48 rue Ferdinand Buisson, 33130 Bègles. 
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 1 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : vente de prêt-à-porter femmes, chaussures, maroquinerie. Adresse : Centre Commercial Mérignac, Soleil, 33700 Mérignac. 
Précédent propriétaire : ZAPA. 722 024 700 RCS Paris. 
Date de commencement de l’activité : 01/12/2014. Publication légale : Les Echos Judiciaires Girondins du 12/12/2014. Oppositions : Au Mandataire Me Olivier DEYMES notaire à Andernos les Bains 91 Bd de la République pour la validité et pour la correspondance 54. Descriptif : Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

29/12/2014

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

5902 - 722024700 RCS. ZAPAForme : Société par actions simplifiée (à associé unique). Adresse : 54 rue de Lancry 75010 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2013.

24/12/2014

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

64 - PYRENEES-ATLANTIQUES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

790 - 753 231 877 RCS Roanne. VOODOO. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 213 Route de Charlieu, 42300 Roanne. 
Origine du fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 90000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Vente d'articles de prêt à porter féminin. Adresse : 30 rue Serviez, 64000 Pau. 
Précédent propriétaire : ZAPA. 722 024 700 RCS Paris. 
Date de commencement de l’activité : 01/10/2014. Publication légale : Petites Affiches Béarnaises du 09/12/2014. Oppositions : Scp Werbrouck-Bertails-Fournie 41, rue Emile Guichenné 64000 Pau. Descriptif : Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

24/12/2014

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

25 - DOUBS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON

243 - 753 231 877 RCS Roanne. VOODOO. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 213 route de Charlieu, 42300 Roanne. 
Origine du fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 70000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : vente d'articles de prêt à porter féminin. Adresse : 76 Grande rue, 25000 Besançon. 
Précédent propriétaire : ZAPA. 722 024 700 RCS Paris. 
Date de commencement de l’activité : 01/10/2014. Publication légale : la terre de chez nous du 05/12/2014. Oppositions : Scp Netillard-Allenbach-Aldrin-Girar 28, rue de la Préfecture BP 301 25000 Besançon. Descriptif : Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

19/12/2014

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

41 - LOIR-ET-CHER

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

192 - 753 231 877 RCS Roanne. VOODOO. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 213 Route de Charlieu, 42300 Roanne. 
Origine du fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 90000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Vente d'articles de prêt-à-porter féminin. Adresse : 22 rue du Commerce, 41000 Blois. 
Précédent propriétaire : SASU ZAPA. 722 024 700 RCS Paris. 
Date de commencement de l’activité : 01/10/2014. Publication légale : La nouvelle république du centre ou du 06/12/2014. Oppositions : Validité : SCP Voisin-Sanson - 15 rue du 18 juin 1940 - 41000 Blois Correspondance : BPM CONSEILS 50 rue Albert Thomas 42300 Roanne. Descriptif : Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

18/12/2014

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

03 - ALLIER

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON

80 - 753 231 877 RCS Roanne. VOODOO. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 213 Route de Charlieu, 42300 Roanne. 
Origine du fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 40000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Vente d'articles de prêt à porter féminin. Adresse : 64 boulevard de Courtais, 3100 Montluçon. 
Précédent propriétaire : ZAPA. 722 024 700 RCS Montluçon. 
Date de commencement de l’activité : 01/10/2014. Publication légale : LES AFFICHES DE L'ALLIER du 27/11/2014. Oppositions : SCP Stéphane MAUGARNY et Mallory de LORENZI-LE-FLECHE, notaires associés 35, rue Barathon BP 1116 03103 Montluçon Cedex. Descriptif : Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

12/12/2014

JAL

Activity or goodwill cession: Seller

Echos Judiciaires Girondins (Les)


Date de décision : 01/12/2014 
Cédant : 722024700 - ZAPA, ZAPA, 54 RUE DE LANCRY, 75010 PARIS 10
Cessionnaire : 410089866 - BMC SAS, DDP, 48 RUE FERDINAND BUISSON, 33130 BEGLES
Prix de vente : 1 €
Date d’effet : 01/12/2014 

10/12/2014

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

61 - ORNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON

827 - 753 231 877 RCS Roanne. VOODOO. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 213 route de Charlieu, 42300 Roanne. 
Origine du fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 30000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Vente d'articles de prêt-à-porter féminin. Adresse : 29 rue aux Sieurs, 61000 Alençon. 
Précédent propriétaire : ZAPA. 722 024 700 RCS Paris. 
Date de commencement de l’activité : 01/10/2014. Publication légale : Le Journal de l'Orne du 04/12/2014. Oppositions : Pour la validité en l'étude de la SCP CHATEL MARTIN sis 150 Grande Rue 61000 Alençon et pour la correspondance au cabinet BPM CONSEILS 50, rue Albert Thomas 42300 Roanne. Descriptif : Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

07/12/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

57 - MOSELLE

GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ

230 - 722 024 700 RCS Paris. ZAPA. Forme : Société par actions simplifiée. Enseigne : ZAPA - LINEA T. Adresse : 54 rue de Lancry, 75010 Paris 10. 
Origine du fonds : Acquisition par fusion. Etablissement : Etablissement principal. Activité : prêt à porter hommes, femmes, enfants, chaussures, maroquinerie, accessoires. Adresse : 18 rue Tête d'Or, 57000 Metz. 
Précédent exploitant : CHOMARAT FASHION CONCEPT. 518 308 440 RCS Lyon. 
Date de commencement de l’activité : 31/07/2014. Déclarations des créances : Tribunal d'Instance de Metz. Descriptif : Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

30/11/2014

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

843 - 722 024 700 RCS Paris. ZAPA. Forme : Société par actions simplifiée (à associé unique). Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL. Capital : 5368416 EUR. Activité : 
Adresse du siège social : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

21/11/2014

JAL

Activity or goodwill cession: Seller

Affiches de l'Allier (Les)


Date de décision : 17/11/2014 
Cédant : 722024700 - ZAPA, ZAPA, 54 RUE DE LANCRY, 75010 PARIS 10
Cessionnaire : 753231877 - VOODOO, VOODOO, 213 RTE DE CHARLIEU, 42300 ROANNE
Prix de vente : 40000 €
Date d’effet : 01/10/2014 

09/11/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

737 - 722 024 700 RCS Paris. ZAPA. Forme : Société par actions simplifiée (à associé unique). Capital : 5368416 EUR. Adresse : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Echange d'un fonds au prix stipulé de 140000,00 euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : Commerce de détail de chaussures hommes femmes et enfants. Adresse : 276 rue de Vaugirard, 75015 Paris. 
Précédent propriétaire : BIUCCI CREATION. 482 358 934 RCS Paris. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : Affiches Parisiennes du 04/10/2014. Oppositions : au fonds cédé 276 rue de Vaugirard 75015 Paris pour la validité, Service Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats de Paris 11 place Dauphine 75053 Paris Cedex 01 pour la correspondance .Descriptif : avec une soulte de 40000 euros. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

26/10/2014

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

86 - VIENNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

882 - 378 239 974 RCS Bourg-en-bresse. COTELAC. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 1360800 EUR. Adresse : rue du Professeur Luc Montagnier, Zone Artisanale en Pragnat Nord, 1500 Ambérieu-en-Bugey. 
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 80000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : fonds de commerce de vente et de prêt à porter et accessoires. Adresse : 55 et 57 Rue Gambetta, 86000 Poitiers. 
Précédent propriétaire : ZAPA. 722 024 700 RCS PARIS. 
Date de commencement de l’activité : 01/10/2014. Publication légale : Le Courrier Français du 17/10/2014. Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance SCP GRIENEISEN GRESSER GLOCK 19 Route de Strasbourg 67610 LA WANTZENAU. Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

21/10/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

1075 - 722 024 700 RCS Créteil. ZAPA. Forme : Société par actions simplifiée à associé unique. Adresse : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Apport partiel d'actif. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : prêt à porter hommes, femmes, enfants, chaussures, maroquinerie, accessoires. Adresse : Centre Commercial de la Vache, Noire Boutique 660, 94110 Arcueil. 
Précédent propriétaire : CHOMARAT FASHION CONCEPT. 518 308 440 RCS Paris. 
Date de commencement de l’activité : 31/07/2014. Publication légale : Le Publicateur Légal du 16/09/2014. Oppositions : Pas d'opposition. Descriptif : Apport partiel d'actif pour un montant ¿valu¿ ¿ 3 368 416, 00 euros. Commentaires : Apport d'un établissement secondaire/complémentaire (personne morale, uniquement).

17/10/2014

JAL

Activity or goodwill cession: Seller

Courrier Français (Le)/Edition de la Vienne et des deux -Sèvres


Date de décision : 01/10/2014 
Cédant : 722024700 - ZAPA, ZAPA, 54 RUE DE LANCRY, 75010 PARIS 10
Cessionnaire : 378239974 - COTELAC, RUE DU PROF LUC MONTAGNIER, ZA EN PRAGNAT NORD, BP 60134, 01500 AMBERIEU EN BUGEY
Prix de vente : 80000 €
Date d’effet : 01/10/2014 

10/10/2014

Bodacc B

Modification et mutation diverse

07 - ARDECHE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS

147 - 722 024 700 RCS Paris. ZAPA. Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital : 5368416 EUR. Activité : Prêt à porter hommes, femmes, enfants, chaussures, maroquinerie, accessoires. Adresse de l’établissement principal : 2 rue de Champel, 07160 Le Cheylard. 
Adresse du siège social : 54 rue De Lancry, 75010 Paris. 
Précédent exploitant : CHOMARAT FASHION CONCEPT. 518 308 440 RCS Aubenas. 
Commentaires : Apport d'un fonds suite à fusion. Date de commencement de l’activité : 31/07/2014.

05/10/2014

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

666 - 722 024 700 RCS Paris. ZAPA. Forme : Société par actions simplifiée (à associé unique). Capital : 5368416 EUR. Activité : 
Adresse du siège social : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et Société ayant participé à la fusion : CHOMARAT FASHION CONCEPT - SAS à associé unique - 18 boulevard Montmartre 75009 Paris - RCS PARIS 518 308 440.

03/10/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

51 - MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

265 - 722 024 700 RCS Paris. ZAPA. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Etablissement secondaire acquis par apport au montant évalué à 5368416 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Prêt-à-Porter hommes, femmes, enfants, chaussures, maroquinerie, accessoires. Adresse : 19 rue de l'Etape, 51100 Reims. 
Précédent propriétaire : CHOMARAT FASHION CONCEPT. 518 308 440 RCS Reims. 
Date de commencement de l’activité : 31/07/2014. Publication légale : LE PUBLICATEUR LEGAL du 16/09/2014. Déclarations des créances : Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Descriptif : Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

19/08/2014

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

38 - ISERE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

252 - 380 673 327 RCS Grenoble. SARL BARNOIN JUNIOR. Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital : 7622.45 EUR. Adresse : 6 place Docteur Léon Martin, 38000 Grenoble. 
Origine du fonds : Etablissement complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 370000 EUR. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité :Prêt à porter masculin et accessoires s'y rapportant, prêt à porter féminin, accessoires et maroquineries s'y rapportant. Adresse : 11 bis place Victor Hugo, 38000 Grenoble. 
Précédent propriétaire : ZAPA. 722 024 700 RCS Grenoble. 
Date de commencement de l’activité : 01/09/2014. Publication légale : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 15/08/2014. Oppositions : Siège du fonds vendu sis à 11 Bis, place Victor Hugo 38000 Grenoble. Descriptif : Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

15/08/2014

JAL

Activity or goodwill cession: Seller

Affiches de Grenoble et du Dauphiné (Les)


Date de décision : 31/07/2014 
Cédant : 722024700 - ZAPA, ZAPA, 54 RUE DE LANCRY, 75010 PARIS 10
Cessionnaire : 380673327 - SARL BARNOIN JUNIOR, CHATTAWAK, 6 PL DU DOCT LEON MARTIN, 38000 GRENOBLE
Prix de vente : 370000 €
Date d’effet : 01/09/2014 

27/06/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

457 - 722 024 700 RCS Paris. ZAPA (SOCIÉTÉ ABSORBANTE). Forme : Société par actions simplifiée (à associé unique). Capital : 2000000 EUR. Adresse :54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Oppositions : Article L.236-14 du code de commerce. Descriptif : Soci¿t¿ absorb¿e : CHOMORAT FASHION CONCEPT Forme : soci¿t¿ par actions simplifi¿e Adresse du si¿ge social : 18, boulevard Montmartre 75009 PARIS Capital social : 23.943.441 euros Num¿ro unique d'identification : 518 308 440 Lieu d'immatriculation : RCS PARIS Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission ¿ la soci¿t¿ absorbante est pr¿vue : Actif : 25.466.079 euros Passif : 4.110.255 euros Actif net apport¿ : 20.949.367 euros Rapport d'¿change des droits sociaux : 18,86 actions de CFC pour 1 action de ZAPA, arrondi ¿ 19 actions CFC pour 1 action ZAPA Prime de fusion : 17.580.951 euros Date du projet commun de fusion : 19 juin 2014 Date et lieu du d¿p¿t au RCS au titre de chaque soci¿t¿ participante : - le 19 juin 2014 au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS pour la soci¿t¿ ZAPA - le 19 juin 2014 au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS pour la soci¿t¿ CFC. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

08/03/2013

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

522 - 722 024 700 RCS Paris. ZAPA. Forme : Société par actions simplifiée (à associé unique). Capital : 2000000 EUR. Adresse : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 430000,00 euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Un fonds de commerce de prêt à porter féminin. Adresse : 97 rue de Courcelles, 75017 Paris. 
Précédent propriétaire : IKKS RETAIL. 479 960 965 RCS Paris. 
Date de commencement de l’activité : 14/02/2013. Publication légale : Les Petites Affiches du 26/02/2013. Oppositions : Au fonds cédé 97 rue de Courcelles 75017 Paris pour la validité, Société d' Etudes Juridiques et Fiduciaires à l' attention de Me Gabriel chausse 15 rue Honoré de Balzac BP 50025 42271 Saint Priest en Jarez pour la correspondance . Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

26/02/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 13/02/2013 
Cédant : 479960965 - IKKS RETAIL, 3 RUE D ARGOUT, 3 AU 5, 75002 PARIS 2
Cessionnaire : 722024700 - ZAPA, ZAPA, 54 RUE DE LANCRY, 75010 PARIS 10
Prix de vente : 430000 €
Date d’effet : 14/02/2013 

14/10/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

852 - 722 024 700 RCS Paris. ZAPA. Forme : Société par actions simplifiée à associé unique. Capital : 2000000 EUR. Adresse : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 500000,00 euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Un fonds de commerce de prêt-à-porter hommes, femmes et accessoires. Adresse : 56 avenue des Ternes, 75017 Paris. 
Précédent propriétaire : JS SCOOP. 350 624 003 RCS Paris. 
Date de commencement de l’activité : 20/09/2012. Publication légale : Les Petites Affiches du 02/10/2012. Oppositions : au fonds vendu 56 avenue des Ternes 75017 Paris pour la validité, Maître Stéphane Glock 9 rue de la Gare BP 6 67610 La Wantzenau pour la correspondance . Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

02/10/2012

JAL

Activity or goodwill cession

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 20/09/2012 
Cédant : 350624003 - JS SCOOP, 15 RUE PONCELET, 75017 PARIS 17
Cessionnaire : 722024700 - ZAPA, 54 RUE DE LANCRY, 75010 PARIS 10
Prix de vente : 500000 €
Date d’effet : 20/09/2012 

08/09/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

13226 - 722024700 RCS. ZAPAForme : Société par actions simplifiée à associé unique. Adresse : 54 rue de Lancry 75010 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011.

29/03/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE

390 - 722 024 700 RCS Paris. ZAPA. Forme : S.A.S. unipersonnelle. Adresse : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Achat au prix stipulé de 350000,00 euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Vente de prêt à porter féminin. Adresse : 37 rue de la Grande Chaussée, 59800 Lille. 
Précédent propriétaire : LA CHEMISERIE PARISIENNE - L C P. 394 771 075 RCS Lille. 
A dater du : 17/12/1999. Date de commencement de l’activité : 31/01/2012. Publication légale : Gazette Nord-Pas de Calais du 18/02/2012. Oppositions : Zapa 37 rue de la Grande Chaussée 59800 Lille pour la validité, Me Glock Stéphane Bp 6 - 67610 La Wantzenau pour la correspondance . Descriptif : .Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

29/02/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE

1094 - 722 024 700 RCS Lille. ZAPA. Forme : S.A.S. unipersonnelle. Adresse : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 350.000,00 EUR. Etablissement : Etablissement Second. (I.P.). Activité : Prêt à porter féminin.Enseigne : Anne FONTAINE. Adresse : 37 rue de la Grande Chaussée, 59000 Lille. 
Précédent propriétaire : LA CHEMISERIE PARISIENNE - L C P. 394 771 075 RCS Lille. 
A dater du : 17/12/1999. Date de commencement de l’activité : 17/05/1999. Publication légale : La Gazette Nord Pas de Calais du 24/02/2012. Oppositions : à l'adresse du fonds vendu pour la validité et chez Me Stéphane GLOCK BP 6 67610 LA WANTZENAU pour la correspondance. Descriptif : Commentaires :Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire). Date d’effet : 31/01/2012.

18/02/2012

JAL

Activity or goodwill cession

Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord


Date de décision : 31/01/2012 
Cédant : 394771075 - LA CHEMISERIE PARISIENNE, LCP, 50 RUE ETIENNE MARCEL, 75002 PARIS 2
Cessionnaire : 722024700 - ZAPA, 54 RUE DE LANCRY, 75010 PARIS 10
Prix de vente : 350000 €
Date d’effet : 31/01/2012 

27/01/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

506 - 722 024 700 RCS Paris. ZAPA. Forme : Société par actions simplifiée à associé unique. Enseigne : SANDRO. Capital : 2000000 EUR. Adresse : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 500000,00 euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Un fonds de commerce de prêt-à-porter, hommes, femmes, enfants, chaussures, maroquinerie, accessoires de mode et parfums. Adresse : 7 avenue Victor Hugo, 75016 Paris. 
Précédent propriétaire : SANDRO FRANCE. 399 022 458 RCS Paris. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/2012. Publication légale : Les Petites Affiches du 16/01/2012. Oppositions : au fonds vendu 7 avenue Victor Hugo 75016 Paris pour la validité, Maître Stéphane Glock 9 rue de la Gare BP6 67610 La Wantzenau pour la correspondance . Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

16/01/2012

JAL

Activity or goodwill cession

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 04/01/2012 
Cédant : 399022458 - SANDRO FRANCE, 61 RUE DE TURENNE, 75003 PARIS 3
Cessionnaire : 722024700 - ZAPA, 54 RUE DE LANCRY, 75010 PARIS 10
Prix de vente : 500000 €
Date d’effet : 01/01/2012 

25/05/2011

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

69 - RHONE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

1410 - 479 960 965 RCS Paris. IKKS RETAIL. Forme : Société par Actions Simplifiée. Adresse : 3 et 5 rue d'Argout, 75002 Paris. 
Origine du fonds : Etablissement complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 575000 EUR. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité :Vente de prêt-à-porter femmes et accessoires. Adresse : centre commercial Carrefour Ecully Grand Ouest, Chemin du Pérollier, 69130 Écully. 
Précédent propriétaire : ZAPA. 722 024 700 RCS Lyon. 
Date de commencement de l’activité : 01/04/2011. Publication légale : Petites Affiches Lyonnaises du 11/04/2011. Oppositions : Au magasin IKKS situé Local n° 5 - Centre commercial Ecully Grand-Ouest - Chemin du Pérollier - 69130 Ecully - et pour la correspondance chez Maître Stéphane Glock, SCP Grieneisen, Glock, Kranntz & Gresser, 9 rue de la Gare - 67610 La Wantzenau. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

11/04/2011

JAL

Activity or goodwill cession

Petites Affiches Lyonnaises (Les)


Date de décision : 29/03/2011 
Cédant : 722024700 - ZAPA, 54 RUE DE LANCRY, 75010 PARIS 10
Cessionnaire : 479960965 - IKKS RETAIL, 3 RUE D ARGOUT, 3 AU 5, 75002 PARIS 2
Prix de vente : 575000 €
Date d’effet : 01/04/2011 

21/12/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

12100 - 722024700 RCS. ZAPAForme : Société par actions simplifiée à associé unique. Adresse : 54 R DE LANCRY 75010 PARIS. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

02/11/2010

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

33 - GIRONDE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

377 - 722 024 700 RCS Bordeaux. ZAPA. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 350000 Euros. Etablissement : Etablissemennt complémentaire. Activité : vente au détail d'habillement pour hommes femmes et enfant et à titre accessoires celle de la vente au détail de maroquinerie chaussures et accessoires d'habillement.Adresse : 29 cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux. 
Précédent propriétaire : SARL GS 33. 419 962 634 RCS Toulouse. 
Date de commencement de l’activité : 19/07/2010. Publication légale : Les Echos Judiciaires Girondins du 05/10/2010. Oppositions : Au fonds vendu 47 crs de l'intendance 33000 BORDEAUX pour la validité et pour la correspondance Me CLARY 35 rue DE METZ 31012 TOULOUSE CEDEX 6. Descriptif : Autre achat, apport, attribution : Modification origine de fonds personne morale avec fonds acquis par achat. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

05/10/2010

JAL

Activity or goodwill cession

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS


Date de décision : 19/07/2010 
Cédant : 419962634 - SARL GS 33, GS 33 BY SAND, 29 CRS DE L INTENDANCE, 33000 BORDEAUX
Cessionnaire : 722024700 - ZAPA, 53 RUE DE LANCRY, 75010 PARIS 10
Prix de vente : 350000 €

23/07/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2160 - 722 024 700 RCS Paris. ZAPA. Forme : Société par actions simplifiée à associé unique. Administration : nomination du Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti : Cohen, Salomon. Capital : 2000000 EUR. 
Adresse du siège social : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

26/02/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2443 - 722 024 700 RCS Paris. ZAPA. Forme : Société par actions simplifiée à associé unique. Capital : 2000000 EUR. 
Adresse du siège social : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

13/01/2010

JAL

Modification of the share capital

LES PETITES AFFICHES


Date de décision : 15/12/2009
La société : 722024700 - ZAPA, 141 BD JEAN JAURES, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT a subi une augmentation de son capital social désormais de 2 000 000 € 

15/10/2009

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

78 - YVELINES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

741 - 722 024 700 RCS Versailles. ZAPA. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 160000 EUR. Adresse : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : prêt a porter féminin haut de gamme et accessoires s'y rapportant. Adresse : centre Commercial. des Galerie de Saint. Germain, Local N°38, 78100 Saint-Germain-en-Laye. 
Précédent propriétaire : WEILL BOUTIQUE. 316 067 982 RCS Paris. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : La semaine de l'Ile de France du 29/09/2009. Oppositions : Au Mandataire Me. LEFEVRE 22, Rue Carnot 78000 VERSAILLES pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : Fonds acquis par achat au prix stipul de 110000 Euros.Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

29/09/2009

JAL

Activity or goodwill cession

LA SEMAINE DE L’ILE DE FRANCE


Date de décision : 04-09-2009
Fond cédé : 316067982 - WEILL BOUTIQUE, WEILL, 10 T R DE LA SALLE, LES GALERIES DE ST GERMAIN, 78100, SAINT GERMAIN EN LAYE
Cédant : 316067982 - WEILL BOUTIQUE, 74 AV DES CHAMPS ELYSEES, GALERIE MARCHANDE DU CLARIDGE, 75008, PARIS 8
Cessionnaire : 722024700 - ZAPA, ZAPA LINEA T, 54 R DE LANCRY, 75010, PARIS 10
Prix de vente : 110 000,00 €
Eléments incorporels : 110 000,00 €

27/08/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

8586 - 722024700 RCS. ZAPAForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 54 rue de Lancry 75010 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

30/06/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1533 - 722 024 700 RCS Paris. ZAPA. Forme : Société par actions simplifiée. Enseigne : ZAPA. Capital : 160000 EUR. Activité : Négoce de prêt à porter, maroquinerie, accessoires, vente. Adresse de l’établissement principal : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Adresse du siège social : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. 
Commentaires : modification survenue sur le nom commercial.

11/09/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

10509 - 722024700 RCS. ZAPAForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 54 rue de Lancry 75010 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

02/12/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

7325 - 722 024 700. RCS Paris ZAPA. Forme: Société par actions simplifiée. Adresse du siège social: 54 rue de Lancry 75010 Paris. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

23/10/2007

Bodacc A

Vente et cession

1101 - RCS Paris 722 024 700. ZAPA. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 54 rue de Lancry, 75010 Paris. Etablissement secondaire - RC Nancy 07-B 966. A dater du : 25 septembre 2007. Activité : commercialisation en gros ou au détail d'articles textiles et d'accessoires pour l'habillement. Adresse : 17 rue Saint-Dizier, 54000 Nancy. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 300 000 euros. Date de début d'activité : 1er juillet 2007. Précédent propriétaire exploitant : S.A.R.L. ECCE OMO. RCS Nancy 344 005 434. Publication légale : Le Paysan lorrain du 27 juillet 2007. Oppositions : Me Grandjean, 22 rue du Haut-Bourgeois, 54000 Nancy.

03/07/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1719 - RCS Paris B 722 024 700. RC 72-B 2470. ZAPA. Forme : S.A.S. Capital : 160 000 euros. Adresse du siège social : 54 rue de Lancry,, 75010 Etablissement principal - Nom commercial : Zapa Linéa T. Activité : négoce de prêt-à-porter, de maroquinerie, d'accessoires et vente. Adresse : 54 rue de Lancry, 75010 Commentaires : établissement principal reçu en location-gérance du GROUPE NEW CONCEPT, RCS 380 501 072. Modification survenue sur le nom commercial et l'activité.

25/03/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1451 - RCS Paris B 722 024 700. RC 72-B 2470. ZAPA. Forme : S.A.S. Capital : 160 000 euros. Adresse du siège social : 54 rue de Lancry,, 75010 Commentaires : modification survenue sur la forme juridique et l'administration. Administration : modification du président : BENAYOUN (Arié). Administrateurs partants : MARCADE (Dominique) ABITBOL (Raphaël). Nomination d'un directeur général : COHEN (Salomon).

20/12/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1864 - RCS Paris B 722 024 700. RC 72-B 2470. ZAPA. Forme : S.A. Capital : 160 000 euros. Adresse du siège social : 54 rue de Lancry,, 75010 Commentaires : modification survenue sur l'adresse du siège social. Etablissement principal - Adresse : 54 rue de Lancry, 75010

10/12/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1633 - RCS Paris B 722 024 700. RC 72-B 2470. ZAPA. Forme : S.A. Capital : 160 000 euros. Adresse du siège social : 49 bis rue de Lancry,, 75010 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : commissaire aux comptes titulaire partant : MOITRIER (Gérard, Jacques, Paul). Commissaire aux comptes suppléant partant : NACCACHE (Claude). Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : FID BFEC. Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : THEAU-LAURENT (Jean-Michel).

10/09/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1287 - RCS Paris B 722 024 700. RC 72-B 2470. ZAPA. Forme : S.A. Capital : 160 000 euros. Adresse du siège social : 49 bis rue de Lancry,, 75010 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d'administration et directeur général partant : LETOURNEAU (Gérard). Administrateurs partants : DAHAN (Nicole) LETOURNEAU (David). Nomination du président du conseil d'administration et directeur général : BENAYOUN (Arié). Nomination d'administrateurs : MARCADE (Dominique) ABITBOL (Raphaël).

25/08/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

4411 - RCS Paris B 722 024 700. RC 72-B 2470. ZAPA. Forme: S.A. Adresse du siège social: 49 bis, R de Lancry,Paris, 75010 Paris. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

18/02/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

5311 - RCS Paris B 722 024 700. RC 72-B 2470. ZAPA. Forme: S.A. Adresse du siège social: 49 bis, R de Lancry,Paris, 75010 Paris. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

07/04/2004

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 722024700 RC 72-B 2470 ZAPA. Forme : S.A. Capital : 160 000 euros. Adresse du siège social : 49 bis rue de Lancry, 75010 Paris Etablissement principal: Activité : vente de pret-à- porter. Adresse : 49 bis rue de Lancry, 75010 Paris Etablissement Complémentaire. Activité : vente de pret-à -porter. Adresse : 82 rue d'Alésia, 75014 Paris Etablissement complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 228 673 euros Date de début d'activité: 25 avril 1972. Date d'effet : 5 janvier 2004. Précédent propriétaire : ALESIA SPORT. RCS B 712057215 Publication légale: La Gazette du Palais du 24 novembre 2003. Oppositions : Groupe Fiduciaire Fortuny, 24 rue Fortuny, 75017 Paris.

19/09/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 722024700 RC 72-B 2470 ZAPA. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification du président : LETOURNEAU (Gérard).

26/04/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 722024700 RC 72-B 2470 ZAPA. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : LETOURNEAU (Elodie, Julie, Marie). Nomination d'un administrateur : LETOURNEAU (David).

24/01/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 722024700 RC 72-B 2470 ZAPA. Forme : S.A. Capital : 160 000 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

17/06/2001

Bodacc A

Vente et cession

RCS non encore inscrit. ZAPA. Forme : S. A. Capital : 1 000 000 de F. Adresse du siège social : 49 bis rue de Lancry, 75010 Paris Etablissement principal: Activité : pret-à-porter pour hommes, femmes et enfants, d'accessoires. Adresse : 111 rue d'Antibes et 2 rue du Commandant-Vidal, 06400 Cannes Eléments incorporels dépendant de l' établissement principal acquis par achat. Date d'effet : 24 avril 2001. Précédent propriétaire : EXZOD SUD. RCS B 424108041 Publication légale: L'Avenir du 26 mai 2001. Oppositions : Cabinet Follet Bernard, 10 rue André-Chenier, 26103 Romans Cedex pour la correspondance et pour la validité au fonds.

17/10/1999

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 722024700 RC 99-B 1098 ZAPA. Forme : S.A. Adresse du siège social : 49 bis rue de Lancry, 75010 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de pret-à-porter. Adresse : 10 rue Marius-Reynaud, 13100 Aix-en-Provence Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 2 275 000 F Date de début d'activité: 1 e r juillet 1999. Précédent propriétaire : MAISON BIEGLIO. RCS B 300633633 Publication légale: Les Nouvelles publications économiques et juridiques du 16 juillet 1999. Oppositions : S.C.P. Lagier Lesage, notaires, 15 place d'Albertas, 13100 Aix-en-Provence.

24/08/1999

Bodacc A

Création d'établissement

722 024 700. RCS Paris. ZAPA. Forme : S.A. Capital : 1 000 000 de F. Adresse du siège social : 49 bis rue de Lancry, 75010 Paris. Administration : président du conseil d'administration : LETOURNEAU (Gérard) Fonds principal acquis par achat, au prix stipulé de 2 275 000 F Etablissement principal: Enseigne : Geneviève G. Activité : vetements et accessoires en cuir, bijouterie fantaisie, bimbeloterie. Adresse : 10 rue Marius-Reynaud, 13100 Aix-en-Provence. Date d'effet : 1er juillet 1999 Précédente propriétaire MAISON BIEGLIO. RCS Avignon B 300 633 633 Publication légale: Les Nouvelles Publications du 16 juillet 1999. Oppositions : Me Lagier, notaire, 15 place d'Albertas, 13100 Aix-en-Provence.

10/07/1999

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 722024700 ZAPA. Forme : S.A. Capital : 1 000 000 de F. Adresse du siège social : 49 bis rue de Lancry, 75010 Paris Etablissement principal: Activité : droit au bail. Adresse : 32 rue Grande-Chaussée, 59000 Lille Droit au bail acquis par cession au prix stipulé de 3 250 000 F. Date d'effet : 1er juin 1999. Précédent propriétaire : veuve DUBOIS, née BATTEUR Suzanne. RCS non inscrit. Publication légale: La Gazette de la région Nord Pas-de-Calais des 9 et 10 juin 1999. Oppositions : Etude de Mes Martin et Vacossin, notaires associés, 11 rue Jacquemars- Giélée, 59800 Lille.

06/11/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Paris B 722 024 700 RC RC 72- B 2470 ZAPA. Forme : S.A. Administration : suppression : administrateur : PECHEUX (André, Yves, Henri). Nomination en qualité d'administrateur : LETOURNEAU ( Elodie, Julie, Marie). Commentaires : modification survenue sur l' administration.

17/05/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 722 024 700 A dater du: 9 avril 1998 ZAPA. Forme : S.A. Capital : 1 000 000 de F. Adresse du siège social : 49 bis rue de Lancry, 75010 Paris Fonds principal acquis par cession au prix stipulé de 1 300 000 F Etablissement principal: Activité : pret- à-porter et accessoires. Adresse : 18 rue Foch, 34000 Montpellier. Date d'effet : 3 mars 1998 Précédente propriétaire S.A.R.L. D.N.G. RCS Montpellier B 343 330 205 RC 95-B 211 Publication légale: Hérault judiciaire et commercial du 26 mars 1998. Oppositions : étude de Granier (François) Bonnary (André), Fournier Montgieux ( Rémi), notaires associés, 2 rue Stanislas-Digeon, B.P. 2117, 34026 Montpellier cedex.

16/08/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 722 024 700 ZAPA. Forme : S.A. Capital : 1 000 000 de F. Adresse du siège social : 49 bis rue de Lancry 75010 Paris Etablissement principal: Adresse : centre commercial Parly II 78150 Le Chesnay Droit au bail acquis par cession au prix stipulé de 2 800 000 F. Date d'effet : 15 juillet 1997. Précédent propriétaire : LES DESSOUS S.A. R.L. RCS B 341 958 106 Publication légale: La Semaine de l'Ile-de-France du 17 juillet 1997. Oppositions : S.C.P. Herbin et Bariani 10 rue Carnot, 78000 Versailles.

06/08/1995

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 722 024 700 S.A. ZAPA. Forme : S.A. Capital : 1 000 000 de F. Adresse du siège social : 49 B rue de Lancry 75000 Paris Etablissement principal: Activité : droit au bail. Adresse : 47 cours de l' Intendance 33000 Bordeaux Droit au bail, dépendant de l'établissement principal, acquis par cession au prix stipulé de 3 890 000 F. Date d'effet : 5 juillet 1995. Précédent propriétaire : SOCIETE CLAUDIA. RCS B 321 984 635 Publication légale: Le Courrier français du 14 juillet 1995. Oppositions : Me Maigret, notaire, 33000 Bordeaux.

 

 

Company events history

 

Date

Description

25/11/2015

Bodacc A : Sale and transfer

22/11/2015

Bodacc A : Sale and transfer

16/11/2015

Private document

16/11/2015

Planned merger

01/10/2015

Bodacc B: Various editing or changing

15/09/2015

Changes to the Board of Directors

15/09/2015

Amendment

15/09/2015

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

31/12/2014

Bodacc A : Sale and transfer

29/12/2014

Bodacc C : Deposit accounts notice

24/12/2014

Bodacc A : Sale and transfer

19/12/2014

Bodacc A : Sale and transfer

18/12/2014

Bodacc A : Sale and transfer

10/12/2014

Bodacc A : Sale and transfer

07/12/2014

Bodacc A : Sale and transfer

06/12/2014

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

01/12/2014

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Seller

30/11/2014

Bodacc B: Various editing or changing

17/11/2014

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Seller

14/11/2014

New auditor

14/11/2014

Amendment

09/11/2014

Bodacc A : Sale and transfer

26/10/2014

Bodacc A : Sale and transfer

21/10/2014

Bodacc A : Sale and transfer

10/10/2014

Bodacc B: Various editing or changing

05/10/2014

Bodacc B: Various editing or changing

03/10/2014

Bodacc A : Sale and transfer

01/10/2014

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Seller

19/09/2014

Capital increase

19/09/2014

Declaration of conformity

19/09/2014

Merger

19/09/2014

Power of attorney

19/09/2014

Updated articles of association

19/09/2014

Amendment

19/08/2014

Bodacc A : Sale and transfer

31/07/2014

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Seller

21/07/2014

Audit or Management Report

27/06/2014

Bodacc A : Sale and transfer

19/06/2014

Private document

19/06/2014

Planned merger

07/02/2014

New ultimate parent

07/02/2014

New parent detected

31/12/2013

New accounts available

08/03/2013

Bodacc A : Sale and transfer

13/02/2013

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer

17/10/2012

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

14/10/2012

Bodacc A : Sale and transfer

20/09/2012

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

08/09/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

04/05/2012

Payment incident closed

29/03/2012

Bodacc A : Sale and transfer

29/02/2012

Bodacc A : Sale and transfer

31/01/2012

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

27/01/2012

Bodacc A : Sale and transfer

04/01/2012

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

31/12/2011

New accounts available

25/05/2011

Bodacc A : Sale and transfer

29/03/2011

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

31/12/2010

Update of Company Activity

31/12/2010

Modification of Company Activity

21/12/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

02/11/2010

Bodacc A : Sale and transfer

23/07/2010

Bodacc B: Various editing or changing

19/07/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

06/07/2010

Updated articles of association

06/07/2010

Changes to the Board of Directors

06/07/2010

Amendment

06/07/2010

Minutes of general meeting of shareholders

26/02/2010

Bodacc B: Various editing or changing

09/02/2010

Updated articles of association

09/02/2010

Capital increase

09/02/2010

Amendment

31/12/2009

New accounts available

15/12/2009

Legal Gazette: Modification of the share capital

15/12/2009

Other modification of Establishment

15/10/2009

Bodacc A : Sale and transfer

29/09/2009

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

27/08/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

01/08/2009

Formation of Establishment

01/08/2009

Other modification of Establishment

30/06/2009

Bodacc B: Various editing or changing

28/04/2009

Preferential right lapsed

26/01/2009

Filling of Tax Office Preferential Right

23/01/2009

Collection of preferential rights activated for this company

31/12/2008

New accounts available

11/09/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

26/06/2008

Extension of term

26/06/2008

Application and court order

06/02/2008

Unfiling of a Tax Office preferential right

06/02/2008

New Filling of Tax Office preferential right

31/12/2007

New accounts available

19/10/2007

Formation of Establishment

01/09/2007

Formation of Establishment

26/02/2007

Minutes of general meeting of shareholders

26/02/2007

Audit or Management Report

26/02/2007

Audit or Management Report

26/02/2007

Appointment/resignation of company officers

26/02/2007

Minutes of general meeting of shareholders

26/02/2007

New chairman (CEO, CoB)

26/02/2007

New legal form – new category

26/02/2007

New legal form – no new category

26/02/2007

Private document

26/02/2007

Updated articles of association

26/02/2007

Updated articles of association

26/02/2007

Changes to the Board of Directors

01/01/2007

Formation of Establishment

31/12/2006

New accounts available

29/11/2006

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

29/11/2006

Private document

29/11/2006

Minutes of Board meeting

29/11/2006

Minutes of Board meeting

29/11/2006

Amendment

29/11/2006

Updated articles of association

29/11/2006

Updated articles of association

29/11/2006

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

21/11/2006

Private document

21/11/2006

New auditor

21/11/2006

Minutes of general meeting of shareholders

21/11/2006

Minutes of general meeting of shareholders

21/11/2006

Appointment/resignation of company officers

21/11/2006

New auditor

23/08/2006

Appointment/resignation of company officers

23/08/2006

Private document

23/08/2006

Changes to the Board of Directors

23/08/2006

Minutes of Board meeting

23/08/2006

New chairman (CEO, CoB)

23/08/2006

Amendment

23/08/2006

Minutes of general meeting of shareholders

31/12/2005

New accounts available

31/12/2004

New accounts available

31/12/2003

New accounts available

09/09/2003

Amendment

09/09/2003

Minutes of Board meeting

09/09/2003

Minutes of general meeting of shareholders

09/09/2003

Private document

09/09/2003

Updated articles of association

09/09/2003

Changes to the Board of Directors

15/04/2002

Minutes of general meeting of shareholders

15/04/2002

Appointment/resignation of company officers

15/04/2002

Private document

15/04/2002

Changes to the Board of Directors

11/01/2002

Capital increase

11/01/2002

Conversion of equity to euro

11/01/2002

Private document

11/01/2002

Updated articles of association

11/01/2002

Minutes of general meeting of shareholders

19/11/2001

Minutes of general meeting of shareholders

19/11/2001

Amendment

19/11/2001

Private document

20/10/1998

Appointment/resignation of company officers

20/10/1998

Private document

20/10/1998

Minutes of general meeting of shareholders

20/10/1998

Changes to the Board of Directors

 

 

Synthesized Accounts

 

Annual Accounts

31/12/2013

31/12/2011

31/12/2009

Account period (month)

12

12

12

Account Type

Normal

Normal

Normal

Date of capture

03/12/2014

15/10/2012

16/12/2010

Activity Code

4771Z

4771Z

4771Z

Employees

0

0

0

 

Active account

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

SECTOR MEDIAN 2013

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

18,437,156

24.8 %

14,773,830

-12.9 %

16,962,753

76,281

24070.1 %

 Intangible assets

13,883,466

16.7 %

11,900,678

-9.0 %

13,080,863

40,670

34036.9 %

 Tangible assets

3,699,801

54.5 %

2,393,937

-30.5 %

3,443,677

10,502

35129.5 %

 Financial assets

853,889

78.2 %

479,215

9.4 %

438,211

1,801

47311.9 %

Net current assets

11,613,172

28.9 %

9,011,845

-17.8 %

10,960,586

91,175

12637.2 %

 Stocks

7,729,779

24.8 %

6,193,711

-7.2 %

6,677,412

40,057

19196.9 %

 Advanced payments

98,157

-60.6 %

249,340

100.7 %

124,245

0

0%

 Receivables

2,826,523

58.1 %

1,788,193

-51.0 %

3,647,761

8,530

33036.3 %

 Securities and cash

958,713

22.8 %

780,601

52.7 %

511,165

13,776

6859.3 %

 Prepaid expenses

-

-

-

-

-

338

-

Accounts of regularization

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total Assets

30,050,328

26.3 %

23,785,674

-14.8 %

27,923,339

190,260

15694.3 %

 

Passive Account

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

SECTOR MEDIAN 2013

Shareholders' equity

12,346,945

0.3 %

12,309,204

-0.4 %

12,356,397

40,453

30421.7 %

Share capital

2,000,000

0%

2,000,000

0%

2,000,000

8,000

24900.0 %

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

35,000

-83.9 %

217,000

47.1 %

147,530

0

0%

Liabilities

17,651,943

56.9 %

11,253,698

-26.9 %

15,402,347

125,192

13999.9 %

 Financial liabilities

12,248,786

85.0 %

6,621,479

-26.7 %

9,030,539

40,795

29925.2 %

 Advanced payments received

189,687

-50.8 %

385,253

27.0 %

303,281

0

0%

 Trade account payables

3,366,759

19.3 %

2,822,957

-36.5 %

4,443,865

24,263

13776.1 %

 Tax and social liabilities

1,846,494

36.1 %

1,356,513

-8.1 %

1,476,783

20,045

9112.0 %

 Other debts and fixed assets liabilities

16,654

-77.3 %

73,268

-55.6 %

164,941

5,481

203.8 %

Account regularization

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total liabilities

30,050,324

26.3 %

23,785,674

-14.8 %

27,923,339

190,260

15694.3 %

 

Results

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

SECTOR MEDIAN 2013

Sales of Goods

27,525,853

8.6 %

25,345,761

-1.8 %

25,799,856

234,782

11624.0 %

Net turnover

27,768,995

11.2 %

24,966,705

4.8 %

23,822,175

230,770

11933.2 %

 of which net export turnover

1,819,572

15.0 %

1,582,327

27.8 %

1,238,065

0

0%

Operating charges

27,215,885

15.7 %

23,530,583

-5.1 %

24,807,529

230,734

11695.4 %

Operating profit/loss

309,968

-82.9 %

1,815,178

82.9 %

992,327

4,343

7037.2 %

Financial income

4,788

1226.3 %

361

-84.6 %

2,339

0

0%

Financial charges

507,409

48.6 %

341,356

-11.6 %

386,302

1,284

39417.8 %

Financial profit/loss

-502,621

-47.4 %

-340,995

11.2 %

-383,963

-911

-55072.4 %

Pretax net operating income

-192,653

-113.1 %

1,474,183

142.3 %

608,364

2,732

-7151.7 %

Extraordinary income

86,672

-86.8 %

657,227

35.9 %

483,626

0

0%

Extraordinary charges

736,372

-53.9 %

1,596,327

262.3 %

440,665

65

1132780.0 %

Extraordinary profit/loss

-649,700

30.8 %

-939,100

-2285.9 %

42,961

0

0%

Net result

-635,073

-218.2 %

537,435

2.8 %

522,823

2,920

-21849.1 %

 

 

Accounts – Active

 

Normal Account

31/12/2013

31/12/2011

31/12/2009

Months

12

12

12

 

Grand Total - Active Accounts (I to VI)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Grand Total (I to VI)

Net

30,050,328

26.3 %

23,785,674

-14.8 %

27,923,339

Gross

CO

37,623,522

20.3 %

31,278,813

-12.1 %

35,576,612

Amortisation

1A

7,573,194

1.1 %

7,493,139

-2.1 %

7,653,273

 

Non declared distributed capital (I)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

Gross

AA

0

0%

0

0%

0

 

Active fixed asset (II)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Total Active fixed asset (II)

Net

18,437,156

24.8 %

14,773,830

-12.9 %

16,962,753

Gross

BJ

25,681,138

17.1 %

21,926,332

-8.7 %

24,020,587

Amortisation

BK

7,243,982

1.3 %

7,152,502

1.3 %

7,057,834

 

Intangible fixed assets

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R&D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CQ

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

483,001

6.0 %

455,615

-3.9 %

474,002

Gross

AF

908,532

-3.5 %

941,429

-4.3 %

983,830

Amortisation

AG

425,531

-12.4 %

485,814

-4.7 %

509,828

Goodwill

Net

13,361,465

16.7 %

11,445,063

-9.2 %

12,606,861

Gross

AH

13,361,465

16.7 %

11,445,063

-9.2 %

12,606,861

Amortisation

AI

0

0%

0

0%

0

Other intangible fixed assets

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AJ

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AK

0

0%

0

0%

0

Pre-payments and downpayments

Net

39,000

0%

0

0%

0

Gross

AL

39,000

0%

0

0%

0

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible asset

Net

13,883,466

16.7 %

11,900,678

-9.0 %

13,080,863

 

Tangilble fixed assets

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Lands

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AN

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AO

0

0%

0

0%

0

Buildings

Net

0

0%

0

0%

354

Gross

AP

3,049

0%

3,049

0.0 %

3,048

Amortisation

AQ

3,049

0%

3,049

13.2 %

2,694

Plant

Net

136,272

266.9 %

37,142

-60.6 %

94,370

Gross

AR

624,269

20.8 %

516,842

-4.1 %

539,099

Amortisation

AS

487,997

1.7 %

479,700

7.9 %

444,729

Other tangible fixed assets

Net

3,534,336

52.1 %

2,324,455

-27.7 %

3,213,946

Gross

AT

9,861,741

15.9 %

8,508,394

1.3 %

8,401,662

Amortisation

AU

6,327,405

2.3 %

6,183,939

19.2 %

5,187,716

Fixed assets in construction

Net

3,200

0%

0

0%

0

Gross

AV

3,200

0%

0

0%

0

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

25,993

-19.6 %

32,340

-76.0 %

135,007

Gross

AX

25,993

-19.6 %

32,340

-76.0 %

135,007

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

Sub Total Tangible asset

Net

3,699,801

54.5 %

2,393,937

-30.5 %

3,443,677

 

Financial assets

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

64,150

0%

0

0%

1,590

Gross

CU

64,150

0%

0

0%

914,454

Amortisation

CV

0

0%

0

0%

912,864

Inter-company receivables

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BC

0

0%

0

0%

0

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

Loans

Net

0

0%

0

0%

24,248

Gross

BF

0

0%

0

0%

24,248

Amortisation

BG

0

0%

0

0%

0

Other financial assets

Net

789,739

64.8 %

479,215

16.2 %

412,373

Gross

BH

789,739

64.8 %

479,215

16.2 %

412,373

Amortisation

BI

0

0%

0

0%

0

Sub Total Financial assets

Net

853,889

78.2 %

479,215

9.4 %

438,211

 

Current Assets (III)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Total Current Assets

Net

11,613,172

28.9 %

9,011,845

-17.8 %

10,960,586

Gross

CJ

11,942,384

27.7 %

9,352,482

-19.1 %

11,556,025

Amortisation

CK

329,212

-3.4 %

340,637

-42.8 %

595,439

 

Stocks

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Raw materials

Net

481,134

7.6 %

447,155

15.8 %

385,992

Gross

BL

496,539

0.3 %

494,910

11.2 %

445,209

Amortisation

BM

15,405

-67.7 %

47,755

-19.4 %

59,217

Work in progress (goods)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BN

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

7,248,645

26.1 %

5,746,556

-8.7 %

6,291,420

Gross

BR

7,454,093

27.7 %

5,836,071

-11.9 %

6,624,275

Amortisation

BS

205,448

129.5 %

89,515

-73.1 %

332,855

Goods for resale

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BT

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BU

0

0%

0

0%

0

Sub Total Stocks

Net

7,729,779

24.8 %

6,193,711

-7.2 %

6,677,412

 

Advance payments to suppliers

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Advance payments to suppliers

Net

98,157

-60.6 %

249,340

100.7 %

124,245

Gross

BV

98,157

-60.6 %

249,340

100.7 %

124,245

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0

 

Debtors

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Trade accounts receivable

Net

738,391

-37.4 %

1,178,773

-52.5 %

2,480,911

Gross

BX

846,750

-38.7 %

1,382,140

-48.5 %

2,684,278

Amortisation

BY

108,359

-46.7 %

203,367

0%

203,367

Other debtors

Net

1,137,024

1219.1 %

86,200

-88.5 %

751,192

Gross

BZ

1,137,024

1219.1 %

86,200

-88.5 %

751,192

Amortisation

CA

0

0%

0

0%

0

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

Sub Total debtors

Net

1,875,415

48.3 %

1,264,973

-60.9 %

3,232,103

 

Divers

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Investment securities

Net

26,661

225.5 %

8,190

-0.4 %

8,222

Gross

CD

26,661

225.5 %

8,190

-0.4 %

8,222

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

932,052

20.7 %

772,411

53.6 %

502,943

Gross

CF

932,052

20.7 %

772,411

53.6 %

502,943

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

Sub Total Divers

Net

958,713

22.8 %

780,601

52.7 %

511,165

 

Prepaid expenses

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Prepaid expenses

Net

951,108

81.8 %

523,220

25.9 %

415,658

Gross

CH

951,108

81.8 %

523,220

25.9 %

415,658

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts (IV to VI)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Expenses of loan issue to be spread

CW3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Currency differential gain

CN3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

 

References

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

 

Accounts – Passive

 

Grand Total - Passive Accounts (I to V)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Grand Total (I to V)

EE

30,050,324

26.3 %

23,785,674

-14.8 %

27,923,339

 

Shareholder Equity (I)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Total shareholders' equity (Total I)

DL

12,346,945

0.3 %

12,309,204

-0.4 %

12,356,397

Equity and shareholders' equity

DA

2,000,000

0%

2,000,000

0%

2,000,000

Issue and merger premiums

DB

0

0%

0

0%

0

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

Legal reserve

DD

200,000

374.6 %

42,141

163.4 %

16,000

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

Other reserves

DG

10,782,018

10.8 %

9,729,628

-0.9 %

9,817,573

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

0%

0

0%

0

Profits or losses brought forward

DH

0

0%

0

0%

0

Profit or loss for the period

DI

-635,073

-218.2 %

537,435

2.8 %

522,824

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

Special tax-allowable reserves

DK

0

0%

0

0%

0

 

Other capital resources (II)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

 

Provisions for risks and charges (III)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

35,000

-83.9 %

217,000

47.1 %

147,530

Risk provisions

DP

35,000

-83.9 %

217,000

47.1 %

147,530

Reserves for charges

DQ

0

0%

0

0%

0

 

Liabilities (IV)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Total Liabilities (Total IV)

EC

17,651,943

56.9 %

11,253,698

-26.9 %

15,402,347

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

Bank loans and liabilities

DU

12,228,786

87.0 %

6,540,629

-23.6 %

8,565,920

Sundry loans and financial liabilities

DV

20,000

-75.3 %

80,850

-82.6 %

464,619

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

Advance payments received for current orders

DW

189,687

-50.8 %

385,253

27.0 %

303,281

Trade accounts payables

DX

3,366,759

19.3 %

2,822,957

-36.5 %

4,443,865

Tax and social security liabilities

DY

1,846,494

36.1 %

1,356,513

-8.1 %

1,476,783

Fixed asset liabilities

DZ

0

0%

0

0%

0

Other debts

EA

218

-99.7 %

67,496

-54.4 %

147,879

 

Translation loss (V)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Translation loss (Total V)

ED

16,436

184.8 %

5,772

-66.2 %

17,062

 

Equalization accounts

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Deferred income

EB

0

0%

0

0%

0

 

References

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

Deferred income and liabilities

EG

8,020,452

11.2 %

7,209,755

-25.0 %

9,618,193

Of which current bank facilities

EH

377,077

-73.5 %

1,422,676

-12.5 %

1,625,559

 

 

Result account

 

1 - Operating result (I-II)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Operating result (Total I-II)

GG

309,968

-82.9 %

1,815,178

82.9 %

992,327

 

2 - Financial result (V-VI)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Financial result (Total V-VI)

GV

-502,621

-47.4 %

-340,995

11.2 %

-383,963

 

3 - Pre-tax net operating income result (I to VI)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

-192,653

-113.1 %

1,474,183

142.3 %

608,364

 

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

-649,700

30.8 %

-939,100

-2285.9 %

42,961

 

Profit or loss

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Profit or loss

HN

-635,073

-218.2 %

537,435

2.8 %

522,823

 

Total Income (I+III+V+VII)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Total Income (Total I+III+V+VII)

HL

27,617,313

6.2 %

26,003,349

-1.1 %

26,285,821

 

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

28,252,385

10.9 %

25,465,916

-1.2 %

25,762,998

 

Operating income (I)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Total operating income (Total I)

FR

27,525,853

8.6 %

25,345,761

-1.8 %

25,799,856

 

Operating income (details)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Sale of goods for resale

FC

22,578,360

11.9 %

20,171,716

27.7 %

15,800,768

France

FA

22,325,164

10.7 %

20,171,320

27.8 %

15,786,989

Export

FB

253,195

63838.1 %

396

-97.1 %

13,779

Sale of goods produced

FF

4,961,679

7.6 %

4,611,852

-40.6 %

7,757,549

France

FD

3,431,017

12.5 %

3,048,652

-53.4 %

6,542,378

Export

FE

1,530,662

-2.1 %

1,563,200

28.6 %

1,215,171

Sale of services

FI

228,956

25.0 %

183,137

-30.6 %

263,858

France

FG

193,241

17.5 %

164,406

-35.5 %

254,743

Export

FH

35,715

90.7 %

18,731

105.5 %

9,115

Net turnover

FL

27,768,995

11.2 %

24,966,705

4.8 %

23,822,175

France

FJ

25,949,422

11.0 %

23,384,378

3.5 %

22,584,110

Export

FK

1,819,572

15.0 %

1,582,327

27.8 %

1,238,065

Stocked production

FM

-757,105

-451.3 %

215,526

-80.8 %

1,124,758

Self-constructed assets

FN

0

0%

0

0%

0

Operating grants

FO

752

0%

0

0%

0

Release of reserves and provisions

FP

293,476

130.3 %

127,453

-82.2 %

717,996

Other income

FQ

219,735

509.1 %

36,077

-73.3 %

134,927

 

Operating charges (II)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Total operating charges (Total II)

GF

27,215,885

15.7 %

23,530,583

-5.1 %

24,807,529

 

Exploitation charges

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Purchase of goods for resale

FS

7,585,251

5.9 %

7,159,551

58.5 %

4,518,058

Change in stocks of goods for resale

FT

0

0%

0

0%

0

Purchase of raw materials

FU

746,803

-3.1 %

771,028

-53.9 %

1,672,844

Change in stocks of raw materials

FV

234,448

275.5 %

-133,590

-110.1 %

1,317,604

Other external purchases and charges

FW

9,984,775

18.4 %

8,430,989

-10.5 %

9,422,987

Tax, duty and similar payments

FX

579,316

33.0 %

435,536

16.2 %

374,763

Payroll

FY

4,272,536

11.8 %

3,821,293

-11.3 %

4,306,519

Social security costs

FZ

1,849,941

5.3 %

1,756,374

-7.3 %

1,893,735

Depreciation

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Depreciation of fixed assets

GA

1,487,421

36.8 %

1,087,086

24.4 %

873,844

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

0

Depreciation/amortisation of current assets

GC

295,987

115.6 %

137,270

-65.0 %

392,072

Provisions for risks and charges

GD

0

0%

0

0%

0

 

Other charges

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Other charges

GE

179,408

175.8 %

65,046

85.3 %

35,103

 

Operating charges (III-IV)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

 

Financial income (V)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Total financial income (Total V)

GP

4,788

1226.3 %

361

-84.6 %

2,339

Share financial income

GJ

0

0%

0

0%

0

Other investment income & capitalised receivables

GK

0

0%

0

0%

331

Other interest and similar income

GL

3,845

965.1 %

361

-77.1 %

1,578

Released provisions and transferred charges

GM

0

0%

0

0%

0

Exchange gains

GN

943

0%

0

0%

430

Net income from disposal of investment securities

GO

0

0%

0

0%

0

 

Financial charge (VI)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Total financial charge (Total VI)

GU

507,409

48.6 %

341,356

-11.6 %

386,302

Financial reserves and provisions

GQ

0

0%

0

0%

0

Interest and similar charges

GR

507,399

48.6 %

341,356

-9.7 %

377,888

Exchange losses

GS

11

0%

0

0%

8,414

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

Extraordinary income (VII)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Total extraordinary income (Total VII)

HD

86,672

-86.8 %

657,227

35.9 %

483,626

Extraordinary operating income

HA

0

0%

27,808

-81.0 %

146,614

Extraordinary income from capital transactions

HB

7,672

-98.8 %

624,419

6779.9 %

9,076

Released provisions and transferred charges

HC

79,000

1480.0 %

5,000

-98.5 %

327,936

 

Extraordinary charges (VIII)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

736,372

-53.9 %

1,596,327

262.3 %

440,665

Extraordinary operating charges

HE

690,404

-19.5 %

857,865

280.7 %

225,313

Extraordinary charges from capital transactions

HF

45,968

-93.1 %

670,062

12576.2 %

5,286

Extraordinary reserves and provisions

HG

0

0%

68,400

-67.4 %

210,066

 

Employee profit sharing (IX)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

0

0%

0

0%

0

 

Tax on profits (X)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Tax on profits (Total X)

HK

-207,281

-8720.5 %

-2,350

-101.8 %

128,502

 

References

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

Of which transferred charges

A1

12,093

315.3 %

-5,617

-102.8 %

200,000

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

2,744

0.0 %

2,743

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

12,920

189.9 %

4,457

 

 

Other incomes tax return forms

 

Fixed Assets

Grand Total Fixed Assets (I to IV)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

0

0%

19,113

Decreasess by transfers

OK2

1,337,651

31.8 %

1,015,118

-40.4 %

1,702,115

Gross value at the end of period

OL

25,681,137

17.1 %

21,926,333

-8.7 %

24,020,587

 

Research and development Charge (Total I)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

CO1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

CO2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

DO

0

0%

0

0%

0

 

Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Gross value at begin of period

KD

13,635,280

6.6 %

12,794,693

8.4 %

11,804,625

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

804,313

9641.0 %

8,257

-99.5 %

1,804,143

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

LV2

130,595

-68.6 %

416,459

2203.8 %

18,077

Gross value at the end of period

LW

14,308,997

15.5 %

12,386,491

-8.9 %

13,590,691

 

Tangible fixed assets (Total III)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Gross value at begin of period

LN

9,817,365

8.2 %

9,071,087

11.0 %

8,170,034

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

1,889,803

233.8 %

566,165

-67.6 %

1,746,106

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

0%

0

0%

19,113

Decreasess by transfers

NG2

1,188,917

106.2 %

576,627

-29.5 %

818,211

Gross value at the end of period

NH

10,518,251

16.1 %

9,060,625

-0.2 %

9,078,816

 

Financial assets (Total IV)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Gross value at begin of period

LQ

714,305

44.3 %

495,064

-58.4 %

1,189,376

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

157,722

2450.1 %

6,185

-99.4 %

1,027,524

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NJ2

18,139

-17.7 %

22,033

-97.5 %

865,825

Gross value at the end of period

NK

853,889

78.2 %

479,216

-64.5 %

1,351,075

 

 

Reserve for depreciation

 

Situation and movement of reserve for depreciation - Grand total (I-II-III)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Reserve for depreciation value at begin of period

ON

0

0%

0

0%

0

Increases

OP

0

0%

0

0%

0

Decreasess

OQ

0

0%

0

0%

0

Reserve for depreciation value at the end of period

OR

0

0%

0

0%

0

 

Research and development charge (Total I)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0

 

Other intangible assets (Total II)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

462,904

-5.9 %

492,038

-1.2 %

498,028

Increases

PF

15,222

95.3 %

7,793

-73.9 %

29,877

Decreasess

PG

52,595

275.2 %

14,018

-22.5 %

18,077

Decreasess by budget item transfer

PH

425,531

-12.4 %

485,813

-4.7 %

509,828

Total fixed assets amotisation (Total III)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

6,461,827

10.0 %

5,874,919

7.5 %

5,464,432

Increases

QV

1,472,199

36.4 %

1,079,292

24.7 %

865,562

Decreases

QW

1,115,576

288.0 %

287,523

-58.6 %

694,858

Decreasess by budget item transfer

QX

6,818,450

2.3 %

6,666,688

18.3 %

5,635,136

 

 

Movements during period affecting charge allocated over several period

 

Deferred charges and debt issuance costs

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0

 

Premium refund of obligations

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Net value at begin of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

 

 

 

 

Provisions included in balance sheet

 

Grand Total (I-II-III)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Value at begining of period

7C

428,609

-12.5 %

490,037

-52.4 %

1,029,622

Increases

UB

295,987

43.9 %

205,670

-85.3 %

1,396,936

Decreases

UC

360,384

161.0 %

138,070

-82.1 %

770,725

Value at the end of period

UD

364,212

-34.7 %

557,637

-66.3 %

1,655,833

 

Includes Total allocations

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Operating

UE

295,987

0%

0

0%

392,072

Financial

UG

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UJ

0

0%

0

0%

92,000

 

Includes Total Withdrawal

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Operating

UF

281,384

0%

0

0%

642,789

Financial

UH

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UK

79,000

0%

0

0%

127,936

 

Total regulated provisions (Total I)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Value at begining of period

3Z

0

0%

0

0%

6,336

Increases

TS

0

0%

0

0%

0

Decreases

TT

0

0%

0

0%

6,336

Value at the end of period

TU

0

0%

0

0%

0

 

Total risk and charge provisions (Total II)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Value at begining of period

5Z

114,000

-25.8 %

153,600

-13.3 %

177,130

Increases

TV

0

0%

68,400

-25.7 %

92,000

Decreases

TW

79,000

1480.0 %

5,000

-95.9 %

121,600

Value at the end of period

TX

35,000

-83.9 %

217,000

47.1 %

147,530

 

Total Provision for depreciation (Total III)

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Value at begining of period

7B

314,609

-6.5 %

336,437

-60.2 %

846,156

Increases

TY

295,987

115.6 %

137,270

-89.5 %

1,304,936

Decreases

TZ

281,384

111.5 %

133,070

-79.3 %

642,789

Value at the end of period

UA

329,212

-3.4 %

340,637

-77.4 %

1,508,303

 

 

State deadlines claims and debts at the end of period

 

State claims

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Gross value

VT

3,724,621

50.7 %

2,470,776

-42.4 %

4,287,751

1 year at most

VU

3,724,621

50.7 %

2,470,776

-42.2 %

4,272,843

More than one year

VV

0

0%

0

0%

14,908

 

State of loans

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Claims related to holdings (gross)

UL

0

0%

0

0%

0

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

0%

0

0%

0

Loans (gross)

UP

0

0%

0

0%

24,248

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

0

0%

9,340

Other financial assets (gross)

UT

789,739

64.8 %

479,216

16.2 %

412,373

Other financial assets (1 year at most)

UV

789,739

64.8 %

479,216

16.2 %

412,373

 

Receivables statement of assets

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Customers doubtful or disputed

VA

172,203

-56.8 %

398,766

25.2 %

318,571

Other claims customer

UX

674,547

-31.4 %

983,373

-58.4 %

2,365,706

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts

UY

8,678

-51.8 %

17,992

-42.6 %

31,335

Social Security and other social organizations

UZ

7,363

16.3 %

6,329

1677.8 %

356

Income taxes

VM

0

0%

0

0%

6,234

Value added tax

VB

188,217

396.1 %

37,939

22.3 %

31,026

Other taxes and payments assimilated

VN

7,460

0%

0

0%

22,217

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

0

0%

0

Group and Associates

VC

877,201

0%

0

0%

0

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

48,105

100.9 %

23,940

-96.4 %

660,022

 

Prepaid

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Prepaid

VS

951,108

81.8 %

523,220

25.9 %

415,658

 

State Debt

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Total debt (gross)

VY

17,462,257

60.7 %

10,866,445

-28.0 %

15,099,068

1 year at most

VZ2

8,020,453

11.3 %

7,207,756

-25.1 %

9,618,194

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

7,916,098

124.8 %

3,522,023

-28.2 %

4,905,039

More than 5 years

VZ4

1,525,706

1016.4 %

136,666

-76.3 %

575,835

 

Details

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

409,221

-71.5 %

1,437,038

-12.7 %

1,645,682

1 year at most

VG2

409,221

-71.5 %

1,437,038

-12.7 %

1,645,682

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

11,819,565

131.6 %

5,103,591

-26.3 %

6,920,238

1 year at most

VH2

2,377,761

64.6 %

1,444,902

0.4 %

1,439,364

More than 1 year and 5 years at most

VH3

7,916,098

124.8 %

3,522,023

-28.2 %

4,905,039

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

20,000

0%

20,000

-85.8 %

141,221

1 year at most

8A2

20,000

0%

20,000

-85.8 %

141,221

More than 1 year and 5 years at most

8A3

0

0%

0

0%

0

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

3,366,759

19.3 %

2,822,957

-36.5 %

4,443,865

1 year at most

8B2

3,366,759

19.3 %

2,822,957

-36.5 %

4,443,865

More than 1 year and 5 years at most

8B3

3,366,759

19.3 %

2,822,957

-36.5 %

4,443,865

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

455,622

16.2 %

392,013

-26.0 %

529,967

1 year at most

8C2

455,622

16.2 %

392,013

-26.0 %

529,967

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

817,132

39.5 %

585,705

-21.3 %

744,207

1 year at most

8D2

817,132

39.5 %

585,705

-21.3 %

744,207

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

2,135

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

2,135

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (Gross)

VW1

568,321

62.9 %

348,971

76.8 %

197,428

1 year at most

VW2

568,321

62.9 %

348,971

76.8 %

197,428

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

3,284

-87.3 %

25,824

398.5 %

5,180

1 year at most

VQ2

3,284

-87.3 %

25,824

398.5 %

5,180

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8J2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

62,850

-80.6 %

323,397

1 year at most

VI2

0

0%

62,850

-80.6 %

323,397

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

V14

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

218

-99.7 %

67,495

-54.4 %

147,879

1 year at most

8K2

218

-99.7 %

67,495

-54.4 %

147,879

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8L2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0

 

References

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Loans made during the period

VJ

5,146,800

2239.5 %

220,000

-89.2 %

2,036,563

Debt repaid during the period

VK

2,269,553

11.8 %

2,030,248

53.6 %

1,321,422

 

 

Table allocation results and other information

 

Dividends distributed

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0

 

Commitments

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0

 

Other charges Externes

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0

 

Taxes and Fees

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0

 

VAT

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0

 

Average number of employees

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Average number of employees

YP

0

0%

0

0%

0

 

Groups and Shareholders

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

Groups and Shareholders

ZR

0

-

-

-

-

 

 

Ratios

 

Structure and Liquidity

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

SECTOR MEDIAN 2013

Fixed Asset Financing

1.23

8.8 %

1.13

0.9 %

1.12

1.22

0.8 %

Global Debt

229 days

41.4 %

162 days

-30.5 %

233 days

182 days

25.8 %

Working Capital Fund overall net

75 days

74.4 %

43 days

-4.4 %

45 days

36 days

108.3 %

Financial independence

100.80 %

-45.8 %

185.90 %

35.9 %

136.83 %

52.40 %

92.4 %

Solvability

41.09 %

-20.6 %

51.75 %

16.9 %

44.25 %

24.68 %

66.5 %

Capacity debt futures

443.02 %

3.7 %

427.12 %

6.6 %

400.53 %

414.74 %

6.8 %

Coverage of current assets by net working capital overall

52.79 %

58.1 %

33.39 %

26.3 %

26.43 %

29.39 %

79.6 %

General Liquidity

0.46

35.3 %

0.34

-22.7 %

0.44

0.09

411.1 %

Restricted Liquidity

0.58

28.9 %

0.45

-10.0 %

0.50

0.31

87.1 %

 

Management or rotation

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

SECTOR MEDIAN 2013

Need background in operating working capital

56 days

27.3 %

44 days

-20.0 %

55 days

-2 days

2900.0 %

Treasury

8 days

188.9 %

-9 days

47.1 %

-17 days

2 days

300.0 %

Inventory turnover of goods

0 days

0%

0 days

0%

0 days

147 days

0%

Average length of credit granted to customers

11 days

-45.0 %

20 days

-51.2 %

41 days

0 days

0%

Average length of credit obtained suppliers

65 days

3.2 %

63 days

-33.0 %

94 days

49 days

32.7 %

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

179 days

-22.5 %

231 days

143.2 %

95 days

0 days

0%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

264 days

-4.3 %

276 days

5.3 %

262 days

493 days

-46.5 %

Rotation tangible assets

264.01 %

-4.2 %

275.55 %

5.0 %

262.39 %

526.99 %

-49.9 %

 

Profitability of the business

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

SECTOR MEDIAN 2013

Margin trading

53.99 %

3.6 %

52.12 %

10.1 %

47.36 %

42.62 %

26.7 %

Profitability of the business

6.34 %

-46.2 %

11.78 %

94.7 %

6.05 %

3.92 %

61.7 %

Net profit

-2.29 %

-206.5 %

2.15 %

-1.8 %

2.19 %

1.36 %

-268.4 %

Growth rate of turnover (excluding VAT)

11.22 %

133.8 %

4.80 %

144.0 %

-10.92 %

-3.01 %

472.8 %

Rates integration

30.47 %

-15.0 %

35.86 %

6.6 %

33.65 %

24.35 %

25.1 %

Rate leasing furniture

0.00 %

0%

0.00 %

0%

0.00 %

0.00 %

0%

Work Factor

72.36 %

16.2 %

62.29 %

-19.5 %

77.35 %

73.04 %

-0.9 %

Weight interests

1.83 %

33.6 %

1.37 %

-15.4 %

1.62 %

0.54 %

238.9 %

 

Return on capital

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

SECTOR MEDIAN 2013

Cash flow from the overall profitability

1.91 %

-72.6 %

6.96 %

99.4 %

3.49 %

3.55 %

-46.2 %

Rates of economic profitability

7.00 %

-56.3 %

16.00 %

128.6 %

7.00 %

9.30 %

-24.7 %

Financial profitability

12,346,945.00 %

0.3 %

12,309,204.00 %

-0.4 %

12,356,397.00 %

4,262.00 %

289598.4 %

Return on investment

-0.52 %

-111.2 %

4.64 %

9.2 %

4.25 %

5.88 %

-108.8 %

 

Management intermediate balances

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

SECTOR MEDIAN 2013

Turnover

27,768,995

11.2 %

24,966,705

4.8 %

23,822,175

230,770

11933.2 %

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

SECTOR MEDIAN 2013

Sales of goods

22,578,360

11.9 %

20,171,716

27.7 %

15,800,768

-

- Purchase of goods

7,585,251

5.9 %

7,159,551

58.5 %

4,518,058

-

+/- Stock of goods variation

0

0%

0

0%

0

-

Trading margin

14,993,109 €

15.2 %

13,012,165 €

15.3 %

11,282,710 €

91,190 €

16341.6 %

53.99 % CA

3.6 %

52.12 % CA

10.1 %

47.36 % CA

43.01 % CA

25.5 %

 

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

SECTOR MEDIAN 2013

Sale of goods produced

5,190,635

8.3 %

4,794,989

-40.2 %

8,021,407

-

+/- Stocked production

-757,105

-451.3 %

215,526

-80.8 %

1,124,758

-

+ Self-constructed assets

0

0%

0

0%

0

-

Period production

4,433,530 €

-11.5 %

5,010,515 €

-45.2 %

9,146,165 €

0 €

0%

15.97 % CA

-20.4 %

20.07 % CA

-47.7 %

38.39 % CA

0.00 % CA

0%

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

SECTOR MEDIAN 2013

Trading margin

14,993,109

15.2 %

13,012,165

15.3 %

11,282,710

91,190

16341.6 %

+ Period Production

4,433,530

-11.5 %

5,010,515

-45.2 %

9,146,165

0

0%

- Purchase of raw materials

746,803

-3.1 %

771,028

-53.9 %

1,672,844

-

+/- Change in stocks of raw materiels

234,448

275.5 %

-133,590

-110.1 %

1,317,604

-

- Other external purchases and charges

9,984,775

18.4 %

8,430,989

-10.5 %

9,422,987

-

Added value

8,460,613 €

-5.5 %

8,954,253 €

11.7 %

8,015,440 €

58,857 €

14274.9 %

30.47 % CA

-15.0 %

35.86 % CA

6.6 %

33.65 % CA

24.35 % CA

25.1 %

 

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

SECTOR MEDIAN 2013

Added value

8,460,613 €

-5.5 %

8,954,253 €

11.7 %

8,015,440 €

58,857 €

14274.9 %

+ Operating grants

752

0%

0

0%

0

-

- Tax, duty and similar payments

579,316

33.0 %

435,536

16.2 %

374,763

-

- Personal charges

6,122,477

9.8 %

5,577,667

-10.0 %

6,200,254

-

Gross operating surplus

1,759,572 €

-40.2 %

2,941,050 €

104.2 %

1,440,423 €

8,262 €

21197.2 %

6.34 % CA

-46.2 %

11.78 % CA

94.7 %

6.05 % CA

3.92 % CA

61.7 %

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

SECTOR MEDIAN 2013

Gross operating surplus

1,759,572 €

-40.2 %

2,941,050 €

104.2 %

1,440,423 €

8,262 €

21197.2 %

+ Release of reserves and provisions

293,476

130.3 %

127,453

-82.2 %

717,996

-

+ Other operating income

219,735

509.1 %

36,077

-73.3 %

134,927

-

- Depreciation/ Amortisation

1,783,408

45.7 %

1,224,356

-3.3 %

1,265,916

-

- Other charges

179,408

175.8 %

65,046

85.3 %

35,103

-

Operating result

309,967 €

-82.9 %

1,815,178 €

82.9 %

992,327 €

4,334 €

7052.0 %

1.12 % CA

-84.6 %

7.27 % CA

74.3 %

4.17 % CA

2.08 % CA

-46.2 %

 

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

SECTOR MEDIAN 2013

Operating result

309,967 €

-82.9 %

1,815,178 €

82.9 %

992,327 €

4,334 €

7052.0 %

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

-

+ Financial income

4,788

1226.3 %

361

-84.6 %

2,339

-

- Financial charges

507,409

48.6 %

341,356

-11.6 %

386,302

-

Pre-tax result

-192,654 €

-113.1 %

1,474,183 €

142.3 %

608,364 €

2,729 €

-7159.5 %

-0.69 % CA

-111.7 %

5.90 % CA

131.4 %

2.55 % CA

1.35 % CA

-151.1 %

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

SECTOR MEDIAN 2013

Extraordinary income

86,672

-86.8 %

657,227

35.9 %

483,626

0

0%

- Extraordinary charges

736,372

-53.9 %

1,596,327

262.3 %

440,665

-

Extraordinary result

-649,700 €

30.8 %

-939,100 €

-2285.9 %

42,961 €

0 €

0%

-2.34 % CA

37.8 %

-3.76 % CA

-2188.9 %

0.18 % CA

0.00 % CA

0%

 

31/12/2013

Variation

31/12/2011

Variation

31/12/2009

SECTOR MEDIAN 2013

Pre-tax result

-192,654 €

-113.1 %

1,474,183 €

142.3 %

608,364 €

2,729 €

-7159.5 %

Extraordinary result

-649,700 €

30.8 %

-939,100 €

-2285.9 %

42,961 €

0 €

0%

- Employee profit sharing

0

0%

0

0%

0

-

- Tax on profits

-207,281

-8720.5 %

-2,350

-101.8 %

128,502

-

Net result

-635,073 €

-218.2 %

537,433 €

2.8 %

522,823 €

2,913 €

-21901.3 %

-2.29 % CA

-206.5 %

2.15 % CA

-1.8 %

2.19 % CA

1.37 % CA

-267.2 %

 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.66.20

UK Pound

1

Rs.98.30

Euro

1

Rs.72.41

Euro

1

Rs.72.55

Note : Above are approximate rates obtained from sources believed to be correct

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

KIN

 

 

Report Prepared by :

TRU

 


 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.