|
Report No. : |
307381 |
|
Report Date : |
12.02.2015 |
IDENTIFICATION DETAILS
|
Name : |
DILLINGER INTERNATIONAL |
|
|
|
|
Registered Office : |
39 A 41, 39 Rue Louis Blanc, 92400 Courbevoie |
|
|
|
|
Country : |
France |
|
|
|
|
Financials (as on) : |
31.12.2013 |
|
|
|
|
Date of Incorporation : |
01/2000 |
|
|
|
|
Com. Reg. No.: |
1 428 868 343 |
|
|
|
|
Legal Form : |
Public limited company with board of directors |
|
|
|
|
Line of Business : |
Other Intermediaries in the Sale of Fuels, Ores, Metals and Chemicals. |
|
|
|
|
No. of Employees : |
10 to 19 Employee |
RATING & COMMENTS
|
MIRA’s Rating : |
Ba |
|
RATING |
STATUS |
PROPOSED CREDIT LINE |
|
|
41-55 |
Ba |
Overall operation is considered normal. Capable to meet normal
commitments. |
Satisfactory |
|
Status : |
Satisfactory |
|
|
|
|
Payment Behaviour : |
Slow but correct |
|
|
|
|
Litigation : |
Clear |
NOTES:
Any query related to this report can be made on
e-mail: infodept@mirainform.com
while quoting report number, name and date.
ECGC Country Risk Classification List – December 31, 2014
|
Country Name |
Previous Rating (30.09.2014) |
Current Rating (31.12.2014) |
|
France |
A1 |
A1 |
|
Risk Category |
ECGC
Classification |
|
Insignificant |
A1 |
|
Low |
A2 |
|
Moderate |
B1 |
|
High |
B2 |
|
Very High |
C1 |
|
Restricted |
C2 |
|
Off-credit |
D |
FRANCE - ECONOMIC
OVERVIEW
The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With at least 82 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that mitigate economic inequality. France's real GDP stagnated in 2012 and 2013. The unemployment rate (including overseas territories) increased from 7.8% in 2008 to 10.2% in 2013. Youth unemployment in metropolitan France decreased from a high of 25.4% in the fourth quarter of 2012 to 22.8% in the fourth quarter of 2013. Lower-than-expected growth and high spending have strained France's public finances. The budget deficit rose sharply from 3.3% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 4.1% of GDP in 2013, while France's public debt rose from 68% of GDP to nearly 94% over the same period. In accordance with its EU obligations, France is targeting a deficit of 3.6% of GDP in 2014 and 2.8% in 2015. The administration of President Francois HOLLANDE has implemented greater state support for employment, the separation of banks' traditional deposit taking and lending activities from more speculative businesses, increasing the top corporate and personal tax rates, including a temporary 75% tax on wages over one million euros, and hiring an additional 60,000 teachers during his five-year term. In January 2014 HOLLANDE proposed a “Responsibility Pact” aimed primarily at lowering labor costs in return for businesses’ commitment to create jobs. Despite stagnant growth and fiscal challenges, France's borrowing costs have declined in recent years because investors remain attracted to the liquidity of France’s bonds.
|
Source
: CIA |
|
Name |
DILLINGER INTERNATIONAL |
|
Activity (APE) |
Other Intermediaries in the Sale of Fuels,
Ores, Metals and Chemicals (4612B) |
EUR VAT Number |
FR48428868343 |
|
Phone |
|
Legal form |
Public limited company with board of directors |
|
Fax |
RCS Registration |
RCS Nanterre 1 428 868 343 |
|
|
|
Share capital |
700,000 Euros |
|
|
Address |
DILLINGER INTERNATIONAL |
Incorporated Date |
01/2000 |
|
Nationality |
France |
Status |
Economically active |
|
Payment Information Summary
- Trade Payment Data |
|
|
Total number of Invoices
available |
1 |
|
Total number of Invoices paid within or up to 30 days after the due date
|
1 |
|
Total number of Invoices paid more than 30 days after the due date
|
0 |
|
Total number of Invoices
currently outstanding where the due date has not yet been reached |
0 |
|
Total number of Invoices
currently outstanding beyond the due date |
0 |
This company is not under
monitoring
|
Company Name |
|
Company number |
|
|
DILLINGER HÜTTE SAARSTAHL AG |
|
|
HRB 24874 |
|
Trading to Date |
12/31/2013 |
12/31/2012 |
12/31/2011 |
|
Turnover |
6,365,205 € |
7,662,365 € |
5,257,404 € |
|
Gross Operating Surplus |
1.31 % Turnover |
1.76 % Turnover |
2.61 % Turnover |
|
Shareholders’ equity |
1,510,721 € |
1,477,721 € |
1,472,868 € |
|
Net result |
102,999 € |
74,854 € |
78,965 € |
|
Employees |
10 to 19 employees |
- |
- |
|
Activity (APE) |
Other Intermediaries in the Sale of Fuels, Ores, Metals and Chemicals
(4612B) |
||
|
RCS Registration |
RCS Nanterre 1 428 868 343 |
Share capital |
700,000 Euros |
|
Registration Court |
Nanterre (92) |
Legal form |
Public limited company with board of directors |
|
Court Registry Number |
20 1 0B09103 |
EUR VAT Number |
FR48428868343 |
|
Incorporation Date |
01/2000 |
Formation Date |
12/1999 |
|
Deregistration Date |
Last account Date |
31/12/2013 |
|
|
Nationality |
France |
||
|
Activity (APE) |
Other Intermediaries in the Sale of Fuels, Ores, Metals and Chemicals
(4612B) |
Business Pages FT® |
|
|
Postal Address |
DILLINGER INTERNATIONAL |
Trading Address |
39 RUE LOUIS BLANC |
|
Telephone |
|||
|
Fax |
|||
|
Type |
Head office |
Status |
Economically active |
|
Formation Date |
12/2010 |
Reason for formation |
Formation |
|
Closure Date |
Reason for closure |
||
|
Reactivation Date |
Production Role |
||
|
Activity Nature |
Activity Location |
||
|
Location surface |
Seasonality |
|
Department |
Region |
Ile-de-France |
|
|
District |
Area |
||
|
City |
COURBEVOIE |
Size of urban area |
|
Branches |
6 branch entities in this company |
|
Head office |
|
|
Secondary establishments |
> DILLINGER
INTERNATIONAL - Autres intermédiaires du commerce en combustibles,
métaux, minéraux et produits chimiques (4612B) in VERTOU
(44120) |
|
Regionality |
Legal unit with multiple establishments in many areas but
no one grouping more than 50% of workforce |
|
Mono-activity status |
Legal unit having all establishments with the same main
activity |
|
Workforce at address |
6 to 9 employees |
Company workforce |
10 to 19 employees |
Social security, pension funds preferential rights | Tax office preferential right |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Status of collection |
This company is not under monitoring |
|
Group Structure
|
Company Name |
SIREN |
Parts |
Last account
published |
|
|
|
|
HRB 24874 |
- |
31/12/2012 |
|
|
|
40% |
- |
|
|
|
|
HRB 23001 |
95.28% |
31/12/2012 |
|
|
|
20031659 |
100% |
31/12/2013 |
|
|
|
- |
100% |
- |
|
|
|
- |
60% |
- |
|
|
|
HRB 925 |
100% |
- |
|
|
|
331620096 |
100% |
31/12/2013 |
|
|
|
380608307 |
100% |
31/12/2013 |
|
|
|
438301210 |
100% |
31/12/2013 |
|
|
|
HRB 24162 |
50% |
31/12/2012 |
|
|
|
HRB 17840 |
50% |
31/12/2012 |
|
|
|
HRA 13639 |
53% |
31/12/2013 |
|
|
|
HRB 14512 |
90% |
31/12/2012 |
|
|
|
24167117 |
100% |
31/12/2013 |
|
|
|
428868343 |
100% |
31/12/2013 |
|
|
|
- |
100% |
- |
|
|
|
HRB 19177 |
100% |
31/12/2006 |
|
|
|
HRB 25221 |
100% |
31/12/2013 |
|
|
|
- |
100% |
- |
|
|
|
- |
100% |
- |
|
|
|
- |
100% |
- |
|
|
|
24420436 |
100% |
31/12/2013 |
|
|
|
US40529320 |
100% |
- |
|
|
|
5567658439 |
100% |
31/12/2013 |
|
|
|
- |
100% |
- |
|
|
|
- |
100% |
- |
|
|
|
06560022 |
100% |
31/12/2013 |
|
|
|
HRB 17148 |
100% |
31/12/2012 |
|
|
|
- |
50% |
- |
|
|
|
HRB 14092 |
50% |
31/12/2013 |
|
|
|
HRA 9297 |
50% |
31/12/2013 |
|
|
|
HRB 4932 |
100% |
31/12/2006 |
|
Ultimate parent company |
DILLINGER HÜTTE SAARSTAHL AG |
|
Direct parent |
A.G.DER DILLINGER HUTTENWERKE - FORGES ET ACIERIES DE
DILLING - 100 % |
|
Group – Number of companies |
33 |
|
Linkages – Number of companies |
47 |
|
Number of countries |
6 |
|
Company Name |
SIREN |
Last account |
Turnover |
|
|
KHS GMBH |
|
HRB 23042 |
31/12/2009 |
600 930 000 € |
|
SALZGITTER MANNESMANN PRECISION ETIRAG |
|
426420162 |
31/12/2013 |
168 704 000 € |
|
SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS ... |
|
410351118 |
31/12/2013 |
180 439 033 € |
|
SECOSAR |
|
552126849 |
31/12/2013 |
1 604 170 € |
|
MÜLHEIM PIPECOATINGS GMBH |
|
HRB 15450 |
31/12/2012 |
13 632 335 € |
|
ROGESA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH |
|
HRB 11122 |
31/12/2013 |
- |
|
COKES DE CARLING |
|
452611635 |
31/12/2011 |
5 792 013 € |
|
JEBENS GMBH |
|
HRB 200637 |
31/12/2006 |
77 550 009 € |
|
CONFLANDEY INDUSTRIES |
|
488559634 |
31/12/2013 |
57 097 259 € |
|
SECOSAR ETIRAGE |
|
954500559 |
31/12/2013 |
15 485 192 € |
|
SAAR-BANDSTAHL GMBH |
|
HRB 74647 |
31/12/2012 |
27 367 000 € |
|
EUROPIPE FRANCE |
|
380877340 |
31/12/2013 |
27 738 839 € |
|
BHSW BURBACHER STAHL- U. WAGGONBAU GMBH |
|
HRB 10173 |
31/12/2009 |
23 542 375 € |
|
METALLURGISCHE GESELLSCHAFT SAAR, GESELL... |
|
HRB 74970 |
31/12/2012 |
112 580 000 € |
|
ZENTRALKOKEREI SAAR GESELLSCHAFT MIT BES... |
|
HRB 24212 |
31/12/2012 |
345 282 000 € |
|
SALZGITTER MANNESMANN (FRANCE) SARL |
|
784845257 |
31/12/2012 |
2 348 913 € |
|
KHS FRANCE |
|
732071808 |
31/12/2013 |
1 962 387 € |
|
STEELWIND NORDENHAM GMBH |
|
HRB 207413 |
31/12/2012 |
- |
|
SATRANS SPEDITIONSGESELLSCHAFT MBH |
|
HRB 23841 |
31/12/2006 |
- |
|
DILLINGER NEDERLAND B.V. |
|
33112173 |
31/12/2013 |
- |
|
KALKSTEINGRUBE AUERSMACHER GMBH |
|
HRB 75220 |
31/12/2012 |
6 006 205 € |
|
EUROPIPE PROJEKT GMBH |
|
HRB 17848 |
31/12/2012 |
- |
|
CARGO-RAIL GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER... |
|
HRB 26217 |
31/12/2013 |
- |
|
DH-SOLLAC BETEILIGUNG GMBH |
|
HRB 23393 |
31/12/2013 |
- |
|
RSE PROJEKTENTWICKLUNGS-GMBH |
|
HRB 25628 |
31/12/2011 |
843 584 € |
|
NMP SYSTEMS GMBH |
|
HRB 71933 |
31/12/2012 |
- |
|
TRANS OVERSEAS B.V. |
|
24255461 |
31/12/2013 |
- |
|
SAARLUX STAHL GMBH |
|
HRB 9320 |
31/12/2009 |
- |
|
SALZGITTER-GAS |
|
- |
- |
|
|
SALZGITTER MANNESMANN GMBH |
|
HRB 200012 |
- |
- |
|
SALZGITTER MANNESMANN PRECISION GMBH |
|
HRB 20198 |
- |
- |
|
SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES GM... |
|
HRB 18154 |
- |
- |
|
SALZGITTER MANNESMANN PRÄZISROHR GMBH |
|
HRB 5965 |
- |
- |
|
SALZGITTER MANNESMANN ROHR SACHSEN GMBH |
|
HRB 25504 |
- |
- |
|
MANNESMANNRÖHREN-WERKE GMBH |
|
HRB 17993 |
- |
- |
|
GAL ZENTRALKOKEREI SAAR BESITZGESELLSCHA... |
|
HRA 21673 |
31/12/2013 |
- |
|
BERG STEEL PIPE CORP |
|
US30537029 |
- |
0 $ |
|
AG DER DILLINGER HUETTENWERKE |
|
- |
- |
- |
|
BERG EUROPIE CORPORATION |
|
- |
- |
- |
|
BERG SPIRAL CORPORATION |
|
- |
- |
- |
|
MONTAN STIFTUNG SAAR |
|
- |
- |
- |
|
SAARSTAHL AG |
|
- |
- |
- |
|
SALZGITTER MANNESMANN PRECISION SA DE CV |
|
- |
- |
- |
|
STRUKTUR HOLDING STAHL |
|
- |
- |
- |
|
TUBOS SOLDADOS ATLANTICO LTDA |
|
- |
- |
- |
|
ZENTRALKOKEREI SAAR GMBH |
|
- |
- |
- |
|
ZENTRALKOKEREI SAAR GMBH |
|
- |
- |
- |
No Status History
|
Publication date |
Gazette Name |
Description |
|
|
Bodacc C |
Comptes annuels et rapports |
|
|
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 14921 - 428868343 RCS. DILLINGER INTERNATIONAL. Forme
: Société anonyme. Adresse : 39/41 rue Louis Blanc 92400
Courbevoie. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice
clos le : 31/12/2013. |
|||
|
Bodacc C |
Comptes annuels et rapports |
|
|
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 13002 - 428868343 RCS. DILLINGER INTERNATIONAL. Forme
: Société anonyme. Adresse : 39/41 rue Louis Blanc 92400
Courbevoie. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice
clos le : 31/12/2012. |
|||
|
Bodacc B |
Modification et mutation diverse |
|
|
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 3408 - 428 868 343 RCS Nanterre. DILLINGER INTERNATIONAL.
Forme : Société anonyme. Activité : . |
|||
|
Bodacc B |
Modification et mutation diverse |
|
|
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 1646 - 428 868 343 RCS Nanterre. DILLINGER - GTS
VENTES. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur
: METZKEN Fred Uwe en fonction le 31 Décembre 2010 Commissaire aux comptes
titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 31 Décembre 2010 Commissaire
aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 31 Décembre 2010 Administrateur :
BLESSING Karlheinz en fonction le 22 Mars 2012 Administrateur : LUXENBURGER
Gunter en fonction le 24 Juillet 2012 Président Directeur général
Administrateur : ROHR Bernard en fonction le 13 Février 2013. Activité : .
|
|||
|
JAL |
Appointment of the social representative |
|
|
|
Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
|
|||
|
JAL |
Resignation / Revocation of the social representative |
|
|
|
Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
|
|||
|
Bodacc C |
Comptes annuels et rapports |
|
|
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 9689 - 428868343 RCS. DILLINGER - GTS VENTES. Forme
: Société anonyme. Adresse : 39/41 rue Louis Blanc 92400
Courbevoie. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice
clos le : 31/12/2011. |
|||
|
Bodacc B |
Modification et mutation diverse |
|
|
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 3085 - 428 868 343 RCS Nanterre. DILLINGER - GTS
VENTES. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur
: METZKEN Fred Uwe en fonction le 31 Décembre 2010 Président du conseil
d'administration et directeur général : HAMY Jean-Claude Maurice Henri en
fonction le 31 Décembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE
& ASSOCIES en fonction le 31 Décembre 2010 Commissaire aux comptes
suppléant : BEAS en fonction le 31 Décembre 2010 Administrateur : BLESSING
Karlheinz en fonction le 22 Mars 2012 Administrateur : LUXENBURGER Gunter en
fonction le 24 Juillet 2012. Activité : . |
|||
|
JAL |
Appointment of the social representative |
|
|
|
Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
|
|||
|
JAL |
Resignation / Revocation of the social representative |
|
|
|
Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
|
|||
|
Bodacc B |
Modification et mutation diverse |
|
|
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 1541 - 428 868 343 RCS Nanterre. DILLINGER - GTS
VENTES. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur
: FOCKENS Aart Paulus en fonction le 31 Décembre 2010 Administrateur :
METZKEN Fred Uwe en fonction le 31 Décembre 2010 Président du conseil
d'administration et directeur général : HAMY Jean-Claude Maurice Henri en
fonction le 31 Décembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE
& ASSOCIES en fonction le 31 Décembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant
: BEAS en fonction le 31 Décembre 2010 Administrateur : DEWISPELAERE-DAUWE
Anita en fonction le 31 Décembre 2010 Administrateur : BLESSING Karlheinz en
fonction le 22 Mars 2012. Activité : . |
|||
|
JAL |
Resignation / Revocation of the social representative |
|
|
|
Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
|
|||
|
JAL |
Appointment of the social representative |
|
|
|
Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
|
|||
|
Bodacc A |
Immatriculation |
|
|
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 674 - 428 868 343 RCS Nanterre. DILLINGER - GTS VENTES.
Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur :
FOCKENS Aart Paulus Administrateur : METZKEN Fred Uwe Président du conseil
d'administration et directeur général : HAMY Jean-Claude Maurice Henri
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux
comptes suppléant : BEAS Administrateur : DEWISPELAERE-DAUWE Anita
Administrateur : BELCHE Paul. Capital : 700000 EUR. Adresse : 39/41
rue Louis Blanc, 92400 Courbevoie. |
|||
|
JAL |
Head Office Transfer |
|
|
|
Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
|
|||
|
Bodacc C |
Comptes annuels et rapports |
|
|
|
93 - SEINE-SAINT-DENIS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 8962 - 428868343 RCS. DILLING - GTS VENTES. Forme
: Société anonyme. Adresse : 1 à 5 rue Luigi Cherubini Saint-Denis
93200 Saint-Denis. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice
clos le : 31/12/2009. |
|||
|
Bodacc B |
Modification et mutation diverse |
|
|
|
93 - SEINE-SAINT-DENIS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 1503 - 428 868 343 RCS Bobigny. DILLING - GTS VENTES. Forme
: Société anonyme. Administration : Administrateur : FOCKENS Aart
Paulus Administrateur : METZKEN Fred Uwe Président du conseil
d'administration et directeur général : HAMY Jean-Claude Maurice Henri
modification le 01 Février 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE
& ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS Administrateur :
DEWISPELAERE-DAUWE Anita Administrateur : BELCHE Paul. |
|||
|
Bodacc B |
Modification et mutation diverse |
|
|
|
93 - SEINE-SAINT-DENIS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 2797 - 428 868 343 RCS Bobigny. DILLING - GTS VENTES. Forme
: Société anonyme. Administration : Administrateur : FOCKENS Aart
Paulus Administrateur : METZKEN Fred Uwe Administrateur : HELLER Klaus
Président du conseil d'administration et directeur général : HAMY Jean-Claude
Maurice Henri modification le 01 Février 2010 Commissaire aux comptes
titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Administrateur : DEWISPELAERE-DAUWE Anita Administrateur : BELCHE Paul. |
|||
|
Bodacc C |
Comptes annuels et rapports |
|
|
|
93 - SEINE-SAINT-DENIS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 9012 - 428868343 RCS. DILLING - GTS VENTES. Forme
: Société anonyme. Adresse : 1 à 5 rue Luigi Cherubini Saint-Denis
93200 Saint-Denis. Commentaires : Comptes annuels et rapports de
l'exercice clos le : 31/12/2008. |
|||
|
Bodacc C |
Comptes annuels et rapports |
|
|
|
93 - SEINE-SAINT-DENIS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 8591 - 428868343 RCS. DILLING - GTS VENTES. Forme
: Société anonyme. Adresse : 1 à 5 rue Luigi Cherubini 93200
Saint-Denis. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice
clos le : 31/12/2007. |
|||
|
Bodacc C |
Comptes annuels et rapports |
|
|
|
93 - SEINE-SAINT-DENIS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 11346 - 428868343 RCS. DILLING - GTS VENTES. Forme
: Société anonyme. Adresse : 1 à 5 rue Luigi Cherubini 93200
Saint-Denis. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice
clos le : 31/12/2006. |
|||
|
Bodacc C |
Avis de dépôt des comptes |
|
|
|
7342 - RCS Bobigny B 428 868 343. RC 06-B 3155. DILLING GTS
VENTES. Forme: S.A. Adresse du siège social: 1, A 5 rue Luigi Cherubini,Saint
Denis, 93200 Saint-Denis. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le:
31 décembre 2005. |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
2731 - RCS B 428 868 343. RC 06-B 3155. DILLING-GTS
VENTES. Forme : S.A. Capital : 700 000 euros. Adresse du siège social : 1-5
rue Luigi-Cherubini, 93200 Saint-Denis. Administration : administrateurs :
FOCKENS (Aart, Paulus) METZKEN (Fred, Uwe) HELLER (Klaus). Président du
conseil d'administration : HAMY (Jean-Claude, Maurice, Henri). Commissaire
aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes
suppléant : BEAS. Administrateurs : DEWISPELAERE-DAUWE (Anita) BELCHE (Paul).
Etablissement principal - Activité : toutes opérations de commerce, de
transformation, parachèvenement et conditionnement de transit, consignation
ou affrètement afférentes aux produits aux sous-produits sidérurgiques et
métalurgiques de tous états de leur fabrication ainsi que de matières
premières nécessaires aux fabrications . Adresse : 1-5 rue Luigi-Cherubini,
93200 Saint-Denis. Commentaires : cette société transfère son siège de
l'immeuble La Pacific, 11-13 cours Valmy, La Défense 7, 92800 Puteaux.
Modification survenue sur l'adresse du siège social. Date d'effet : 21 avril
2006. |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
2241 - RCS Nanterre B 428 868 343. RC 00-B 79. DILLING-GTS
VENTES. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur
l'administration. Administration : administrateur partant : GASTINEAU
(Patrick). |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
2242 - RCS Nanterre B 428 868 343. RC 00-B 79. DILLING-GTS
VENTES. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur
l'administration. Administration : nomination d'un administrateur : BELCHE
(Paul). |
|||
|
Bodacc C |
Avis de dépôt des comptes |
|
|
|
3768 - RCS Nanterre B 428 868 343. RC 00-B 79. DILLING GTS
VENTES. Forme: S.A. Adresse du siège social: immeuble la Pacific la Défense
7,11-13, cours Valmy, 92800 Puteaux. Comptes annuels et rapports de l'exercice
clos le: 31 décembre 2004. |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
2827 - RCS Nanterre B 428 868 343. RC 00-B 79. DILLING GTS
VENTES. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration.
Administration : administrateur partant : DHAM (Jacques). |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
1747 - RCS Nanterre B 428 868 343. RC 00-B 79. DILLING GTS
VENTES. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur
l'administration. Administration : nomination d'un administrateur : GASTINEAU
(Patrick). |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
2005 - RCS Nanterre B 428 868 343. RC 00-B 79. DILLING GTS
VENTES. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur
l'administration. Administration : administrateurs partants : COHEN (Denis,
Nessim) VAN COPPENOLLE (Patrick). Nomination d'administrateurs : DHAM
(Jacques) DEWISPELAERE-DAUWE (Anita). |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
2945 - RCS Nanterre B 428 868 343. RC 00-B 79. DILLING GTS
VENTES. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration.
Administration : commissaire aux comptes titulaire partant : BARBIER FRINAULT
& COMPAGNIE. Commissaire aux comptes suppléant partant : GOUVERNEYRE
(Alain). Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE &
ASSOCIES. Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : BEAS. |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
RCS Nanterre B 428868343 RC 00-B 79 DILLING G.T.S. VENTES.
Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur la dénomination. |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
RCS Nanterre B 428868343 RC 00-B 79 DILLING G.T.S. VENTES FRANCE.
Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration.
Administration : président du conseil d'administration partant : LAURENT
(Marc, Maxime, Pierre) . Nomination du président du conseil d' administration
: HAMY (Jean-Claude, Maurice, Henri). |
|||
|
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
|
|
RCS Nanterre B 428868343 RC 00-B 79 DILLING G.T.S. VENTES
FRANCE. Forme : S.A. Capital : 700 000 euros. Activité : toutes opérations de
commerce, de transformation, parachèvenement et conditionnement de transit
consignation ou affrètement afférentes aux produits et sous-produits
sidérurgiques et métallurgiques de tous états de leur fabrication ainsi que
de matières premières nécessaires aux fabrications. Adresse du siège social :
immeuble La Pacific, La Défense 7, 11- 13 cours Valmy, 92800 Puteaux.
Commentaires : modification survenue sur la dénomination, le capital (
augmentation), l'activité et l' administration. La S.A. SOLLAC,. RCS Nanterre
572 219 673, fait apport à la STE P.S.V.F.,. RCS Nanterre 428 868 343, de
l'ensemble de la branche d'activité complète et autonome de commercialisation
en France de plaques produites par la STE DES FORGES ET ACIERIES DE DILLING
et par sa filiale, la S.A. G.T.S. INDUSTRIES. L'ensemble est évalué à 900 000
euros. Avec effet rétroactif au 1er janvier 2000. Administration : président
du conseil d' administration partant : VERCAEMER ( Guillaume). Nomination du
président du conseil d'administration : LAURENT ( Marc, Maxime, Pierre).
Administrateurs partants : DURAND (Chantal) FRANCK- COUQUE (Marie-Anne) JARRY
(Martine). Nomination d'administrateurs : COHEN ( Denis, Nessim) FOCKENS
(Aart, Paulus) MAULVAULT (Michel, Albert) METZKEN ( Fred, Uwe) HELLER (Klaus)
VAN COPPENOLLE (Patrick). Date d'effet : 6 juin 2000. |
|||
|
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
|
|
RCS Nanterre B 428868343 RC 00-B 79 PRODUITS SIDERURGIQUES
VENTES FRANCE - P.S.V.F. Forme : S.A. Capital : 38 200 euros. Activité : participation
à toutes entreprises, sociétés, groupements, sociétés en participation ou
associations, créées ou à créer, pouvant se rattacher à tous produits
métallurgiques ou sous-produits de l' industrie métallurgique ou minière, et
ce par tous moyens. Adresse du siège social : immeuble La Pacific, la Défense
7, 11-13, cours Valmy 92800 Puteaux. Administration : président du conseil d'
administration : VERCAEMER (Guillaume) Administrateurs : DURAND (Chantal)
FRANCK-COUQUE (Marie-Anne) JARRY ( Martine). Commissaire aux comptes
titulaire : BARBIER FRINAULT ET COMPAGNIE. Commissaire aux comptes suppléant
: GOUVERNEYRE (Alain) Cette société se constitue Date de début d' activité:
21 décembre 1999. |
|||
|
Date |
Description |
|
10/09/2014 |
Consideration of a balance sheet that has led to a
reassessment of this company's creditworthiness |
|
16/08/2014 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
31/12/2013 |
New accounts available |
|
27/07/2013 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
18/07/2013 |
Consideration of a balance sheet that has led to a
reassessment of this company's creditworthiness |
|
28/05/2013 |
Bodacc B: Various editing or changing |
|
17/05/2013 |
Updated articles of association |
|
17/05/2013 |
New company name |
|
17/05/2013 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
05/04/2013 |
Modification to Company Identifier |
|
05/04/2013 |
Update of Company Name |
|
21/02/2013 |
Bodacc B: Various editing or changing |
|
13/02/2013 |
Changes to the Board of Directors |
|
13/02/2013 |
New chairman (CEO, CoB) |
|
13/02/2013 |
Amendment |
|
31/12/2012 |
New accounts available |
|
21/12/2012 |
Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social
representative |
|
19/10/2012 |
Legal Gazette: Appointment of the social representative |
|
17/10/2012 |
Consideration of a balance sheet that has led to a
reassessment of this company's creditworthiness |
|
14/08/2012 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
01/08/2012 |
Bodacc B: Various editing or changing |
|
24/07/2012 |
Updated articles of association |
|
24/07/2012 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
24/07/2012 |
Changes to the Board of Directors |
|
13/07/2012 |
Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social
representative |
|
08/06/2012 |
Legal Gazette: Appointment of the social representative |
|
31/03/2012 |
Bodacc B: Various editing or changing |
|
22/03/2012 |
Amendment |
|
22/03/2012 |
Updated articles of association |
|
22/03/2012 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
22/03/2012 |
Changes to the Board of Directors |
|
09/03/2012 |
Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative |
|
31/12/2011 |
New accounts available |
|
24/08/2011 |
Consideration of a balance sheet that has led to a
reassessment of this company's creditworthiness |
|
26/07/2011 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
15/04/2011 |
Legal Gazette: Appointment of the social representative |
|
09/01/2011 |
Bodacc A : Registration |
|
31/12/2010 |
Registered office transferred outside jurisdiction of the
Commercial Court |
|
31/12/2010 |
Transfert du Siège hors du ressort du Tribunal de Commerce |
|
31/12/2010 |
Registration after transfer |
|
31/12/2010 |
Changement de dénomination sociale |
|
31/12/2010 |
PV d'Assemblée |
|
31/12/2010 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
31/12/2010 |
New accounts available |
|
31/12/2010 |
Updated articles of association |
|
31/12/2010 |
Statuts mis à jour |
|
31/12/2010 |
New company name |
|
15/12/2010 |
Legal Gazette: Head Office Transfer |
|
06/12/2010 |
Update of Company Name |
|
06/12/2010 |
Update of Company Head Office Identifier |
|
06/12/2010 |
Transfer of Establishment |
|
25/08/2010 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
17/02/2010 |
Bodacc B: Various editing or changing |
|
12/02/2010 |
Bodacc B: Various editing or changing |
|
04/02/2010 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
04/02/2010 |
PV d'Assemblée |
|
04/02/2010 |
Minutes of Board meeting |
|
04/02/2010 |
Changes to the Board of Directors |
|
04/02/2010 |
Modification du Conseil d'Administration |
|
04/02/2010 |
Acte modificatif |
|
04/02/2010 |
Amendment |
|
01/02/2010 |
Acte modificatif |
|
01/02/2010 |
Minutes of Board meeting |
|
01/02/2010 |
PV d'Assemblée |
|
01/02/2010 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
01/02/2010 |
Amendment |
|
31/12/2009 |
New accounts available |
|
24/08/2009 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
31/12/2008 |
New accounts available |
|
16/10/2008 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
07/03/2008 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
31/12/2007 |
New accounts available |
|
31/12/2006 |
New accounts available |
|
29/05/2006 |
Transfert du Siège hors du ressort du Tribunal de Commerce |
|
29/05/2006 |
Immatriculation suite à transfert |
|
29/05/2006 |
Registration after transfer |
|
29/05/2006 |
Modification du Conseil d'Administration |
|
29/05/2006 |
Acte sous seing privé |
|
29/05/2006 |
Private document |
|
29/05/2006 |
Appointment/resignation of company officers |
|
29/05/2006 |
Nomination/démission des organes de gestion |
|
29/05/2006 |
Minutes of Board meeting |
|
29/05/2006 |
PV du Conseil d'Administration |
|
29/05/2006 |
Statuts mis à jour |
|
29/05/2006 |
Updated articles of association |
|
29/05/2006 |
Acte modificatif |
|
06/02/2006 |
Changes to the Board of Directors |
|
06/02/2006 |
Modification du Conseil d'Administration |
|
06/02/2006 |
Acte sous seing privé |
|
06/02/2006 |
Private document |
|
06/02/2006 |
Acte modificatif |
|
06/02/2006 |
Nomination/démission des organes de gestion |
|
06/02/2006 |
Minutes of Board meeting |
|
06/02/2006 |
PV du Conseil d'Administration |
|
06/02/2006 |
Appointment/resignation of company officers |
|
31/12/2005 |
New accounts available |
|
01/07/2005 |
Acte modificatif |
|
01/07/2005 |
Modification du Conseil d'Administration |
|
01/07/2005 |
Nomination/démission des organes de gestion |
|
01/07/2005 |
Private document |
|
01/07/2005 |
PV du Conseil d'Administration |
|
01/07/2005 |
Changes to the Board of Directors |
|
01/07/2005 |
Acte sous seing privé |
|
01/07/2005 |
Appointment/resignation of company officers |
|
01/07/2005 |
Minutes of Board meeting |
|
28/06/2005 |
Nomination/démission des organes de gestion |
|
28/06/2005 |
Appointment/resignation of company officers |
|
28/06/2005 |
Private document |
|
28/06/2005 |
Acte sous seing privé |
|
28/06/2005 |
Changes to the Board of Directors |
|
28/06/2005 |
Modification du Conseil d'Administration |
|
28/06/2005 |
Acte modificatif |
|
28/06/2005 |
PV du Conseil d'Administration |
|
28/06/2005 |
Minutes of Board meeting |
|
07/06/2005 |
Acte sous seing privé |
|
07/06/2005 |
Appointment/resignation of company officers |
|
07/06/2005 |
Private document |
|
07/06/2005 |
Changement de Commissaire aux Comptes |
|
07/06/2005 |
New auditor |
|
07/06/2005 |
PV d'Assemblée |
|
07/06/2005 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
07/06/2005 |
Nomination/démission des organes de gestion |
|
31/12/2004 |
New accounts available |
|
31/12/2003 |
New accounts available |
|
22/08/2002 |
Changement de dénomination sociale |
|
22/08/2002 |
Statuts mis à jour |
|
22/08/2002 |
PV d'Assemblée |
|
22/08/2002 |
Acte sous seing privé |
|
23/04/2001 |
Changement de Président (PDG, PCA) |
|
23/04/2001 |
Modification du Conseil d'Administration |
|
23/04/2001 |
Acte modificatif |
|
23/04/2001 |
Nomination/démission des organes de gestion |
|
23/04/2001 |
PV du Conseil d'Administration |
|
23/04/2001 |
Acte sous seing privé |
|
06/09/2000 |
PV du Conseil d'Administration |
|
06/09/2000 |
Apport Partiel |
|
06/09/2000 |
Augmentation de Capital |
|
06/09/2000 |
Modification de l'objet social |
|
06/09/2000 |
Changement de dénomination sociale |
|
06/09/2000 |
PV d'Assemblée |
|
06/09/2000 |
Statuts mis à jour |
|
06/09/2000 |
Acte sous seing privé |
|
06/09/2000 |
Modification du système d'administration des S.A. |
|
06/09/2000 |
Acte modificatif |
|
06/09/2000 |
Nomination/démission des organes de gestion |
|
06/09/2000 |
Changement de Président (PDG, PCA) |
|
21/06/2000 |
Rapport des Commissaires ou du Gérant |
|
21/06/2000 |
Acte sous seing privé |
|
13/04/2000 |
Nomination/démission des organes de gestion |
|
13/04/2000 |
Acte modificatif |
|
13/04/2000 |
Requête et Ordonnance |
|
07/01/2000 |
Formation de Société |
|
07/01/2000 |
Statuts |
|
Date |
Description |
|
10/09/2014 |
Update Limit |
|
10/09/2014 |
Update Rating |
|
07/09/2014 |
Update Rating |
|
18/07/2013 |
Update Limit |
|
17/10/2012 |
Update Rating |
|
06/10/2012 |
Update Limit |
|
08/09/2012 |
Update Rating |
|
24/08/2011 |
Update Limit |
|
25/04/2011 |
Update Rating |
|
28/02/2011 |
Update of phone numbers |
|
06/12/2010 |
Formation of Head office (after transfer) |
|
Name |
M. BLESSING KARLHEINZ |
||
|
Manager position |
Administrator |
Date of birth |
12/05/1957 |
|
Place of birth |
EISLINGEN FILS(ALLEMAGNE) |
||
|
Type |
Individual |
Name at birth |
|
|
Name |
M. LUXENBURGER GUNTER |
||
|
Manager position |
Administrator |
Date of birth |
10/11/1957 |
|
Place of birth |
NEUFORWEILLER SAARLOUIS(ALLEMAGNE) |
||
|
Type |
Individual |
Name at birth |
|
|
Name |
M. ROHR BERNARD |
||
|
Manager position |
President, Managing director, Administrator |
Date of birth |
06/02/1967 |
|
Place of birth |
STRASBOURG |
||
|
Type |
Individual |
Name at birth |
|
|
Name |
M. METZKEN FRED UWE |
||
|
Manager position |
Administrator |
Date of birth |
04/08/1955 |
|
Place of birth |
SAARBRUECKEN(ALLEMAGNE) |
||
|
Type |
Individual |
Name at birth |
|
|
Manager position |
Title and name |
Date of Birth/Place
of Birth |
|
Administrator |
MME ANITA
DEWISPELAERE DAUWE |
- - - |
|
Administrator |
M GUNTER
LUXENBURGER |
11/10/1957 -
NEUFORWEILLER SAARLOUIS(ALLEMAGNE) |
FOREIGN EXCHANGE RATES
|
Currency |
Unit
|
Indian Rupees |
|
US Dollar |
1 |
Rs.62.15 |
|
|
1 |
Rs.94.72 |
|
Euro |
1 |
Rs.70.33 |
INFORMATION DETAILS
|
Analysis Done by
: |
DIV |
|
|
|
|
Report Prepared
by : |
NIT |
RATING EXPLANATIONS
|
RATING |
STATUS |
PROPOSED CREDIT LINE |
|
|
|
>86 |
Aaa |
Possesses an extremely sound financial base with the strongest
capability for timely payment of interest and principal sums |
Unlimited |
|
|
71-85 |
Aa |
Possesses adequate working capital. No caution needed for credit
transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest
and principal sums |
Large |
|
|
56-70 |
A |
Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable
factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of
interest and principal sums |
Fairly Large |
|
|
41-55 |
Ba |
Overall operation is considered normal. Capable to meet normal
commitments. |
Satisfactory |
|
|
26-40 |
B |
Capability to overcome financial difficulties seems comparatively
below average. |
Small |
|
|
11-25 |
Ca |
Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums
in default or expected to be in default upon maturity |
Limited with
full security |
|
|
<10 |
C |
Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised |
Credit not
recommended |
|
|
-- |
NB |
New Business |
-- |
|
This score serves as a reference to assess SC’s
credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated
from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of
this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated
through %) are as follows:
Financial
condition (40%) Ownership
background (20%) Payment
record (10%)
Credit history
(10%) Market trend (10%) Operational size
(10%)
This report is issued at your request without any
risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or
its officials.