MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

329619

Report Date :

03.07.2015

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

AVL LIST GMBH

 

 

Registered Office :

Hans Listplatz 1 A-8020 Graz

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

31.12.2014

 

 

Year of Incorporation :

1972

 

 

Legal Form :

Limited Liability Company

 

 

Line of Business :

  • Manufacture of motor vehicles
  • Manufacture of other general-purpose machinery

 

 

No. of Employees :

2875 (Approx.) (2015)

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory

 

 

Payment Behaviour :

No Complaints

 

 

Litigation :

Clear

 

 

NOTES:

Any query related to this report can be made on e-mail: infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31, 2015

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2014)

Current Rating

(31.03.2015)

Austria

A2

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 

 

AUSTRIA - ECONOMIC OVERVIEW

 

Austria, with its well-developed market economy, skilled labor force, and high standard of living, is closely tied to other EU economies, especially Germany's. Its economy features a large service sector, a relatively sound industrial sector, and a small, but highly developed agricultural sector. Economic growth was anemic at less than 0.5% in 2013 and 2014, and; growth in 2015 is not expected to exceed 0.5%. Austria’s 5.6% unemployment rate, while low by European standards, is at an historic high for Austria. Without extensive vocational training programs and generous early retirement, the unemployment rate would be even higher. Public finances have not stabilized even after a 2012 austerity package of expenditure cuts and new revenues. On the contrary, in 2014, the government created a “bad bank” for the troubled nationalized “Hypo Alpe Adria” bank, pushing the budget deficit up by 0.9% of GDP to 2.4% and public debt to 84.5% of the GDP. Although Austria's fiscal position compares favorably with other euro-zone countries, it faces several external risks, such as Austrian banks' continued exposure to Central and Eastern Europe, repercussions from the Hypo Alpe Adria bank collapse, political and economic uncertainties caused by the European sovereign debt crisis, the current crisis in Russia/Ukraine, the recent appreciation of the Swiss Franc, and political developments in Hungary.

 

Source : CIA

 

Company name and address

 

AVL LIST GMBH

 

Hans Listplatz 1

A-8020 Graz

 

 

Activities

 

ÖNACE 29100 50% Manufacture of motor vehicles

ÖNACE 28290 50% Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c.

 

 

Collections

 

Submitted for collection on

Submitted amount

Amount paid so far

Outstanding amount

Last status of debt collection

Status as of

2013-12-05

EUR

192,00

EUR

192,00

EUR

0,00

Payment after debt collection

2014-01-16

Summen

EUR

192,00

EUR

192,00

EUR

0,00

 

 

 

 

Financial data

 

Financial details can also be entered during the period, irrespective of the balance sheet date.

 

total turnover (total sales)

2014

EUR

590.911.314,69

(exact)

total turnover (total sales)

2013

EUR

572.860.741,98

(exact)

total turnover (total sales)

2012

EUR

554.493.922,80

(exact)

total turnover (total sales)

2011

EUR

452.441.782,87

(exact)

total turnover (total sales)

2010

EUR

329.437.662,40

(exact)

 

turnover (sales) - group

2014

EUR

1.147.683.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2013

EUR

1.046.479.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2012

EUR

1.014.851.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2011

EUR

844.933.000,00

(exact)

 

total investments

2014

EUR

55.263.340,55

(exact)

 

total company vehicles

2015

 

40

(approx.)

 

total employees

2015

 

2875

(approx.)

white collar workers

2015

 

2755

(approx.)

blue collar workers

2015

 

120

(approx.)

 

 

General company information

 

Company name

AVL List GmbH

Year of incorporation

1972

Type of company

Manufacturing

Legal form

limited liability company since 1979-09-04

Companies house number

FN 53507 m Graz  since 1979-09-06

Export

world-wide

world-wide

2015

2014

ARA-number

6883

VAT number

ATU 28752908

number - Austrian National Bank

2410

Last balance sheet:

2014

Banking connection

UniCredit Bank Austria AG

BLZ 12000

main bank connection

 

 

Locations

 

operational

A-8020 Graz, Hans-List-Platz 1

registered office

operational

A-8020 Graz, Hans Listplatz 1

registered headquarters, rented premises

 

0043 316 787

info@avl.com

operational

A-8011 Graz, Postfach 15

postbox

operational

A-4400 Steyr, Schönauer Straße 5

branch office

 

0043 7252 42450

 

operational

A-4407 Steyr Gleink, Im Stadtgut B2

branch office

 

0043 7252 48586

 

former

A-8020 Graz, Kleiststraße 48

registered office

former

A-8020 Graz, Kleiststraße 48

registered headquarters

former

A-8020 Graz, Wienerstraße 54

branch office

former

A-4400 Steyr, Pachergasse 4a

branch agency

former

A-8020 Graz, Überfuhrgasse 37

warehouse

former

A-8020 Graz, Ungergasse 14

warehouse

 

 

Private data

 

Surname

Date of birth

Address

Executive positions

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Dr. Marko Dekena

1969-06-26

A-8010 Graz

Schönbrunngasse 77

manager

1

Dr. Robert Fischer

1961-01-18

A-8010 Graz

Waldheimatweg 32

manager

0

Dr. Uwe Dieter Grebe

1965-04-29

A-8052 Graz

Spielbergweg 8

manager

0

Dipl-Ing.Dr. Prof. Helmut List

1941-12-20

A-8010 Graz

Opernring 6

manager

10

Dr. Hannes Schmüser

1968-06-29

A-8046 Graz

Forstweg 69B

manager

0

Dipl-Betriebsw. Werner Schuster

1945-11-27

A-8160 Weiz

Ponigl 30

manager

1

Dipl-Ing. Kai Uwe Voigt

1961-04-19

A-8051 Thal

Ziegelweg 1

manager

0

Dr. Josef Affenzeller

1942-06-25

A-8045 Graz Andritz

Geißlergasse 25

joint signing clerk

1

Dipl.Päd. Stephan Baron

1950-05-07

A-8042 Graz St. Peter

Dammweg 3

joint signing clerk head of personnel

0

Dipl-Ing. Werner Moser

1948-04-18

A-8045 Graz Andritz

Ursprungweg 98

joint signing clerk

0

Dipl-Ing. Michael Mühlögger

1964-03-25

A-8010 Graz

Wegenergasse 8

joint signing clerk

0

Christian Neugebauer

1959-06-12

D-61462 Königstein

Ölmühlweg 20

joint signing clerk

1

Dr. Martin Nöstlthaller-Kropf

1974-12-16

A-8043 Graz

Unterer Plattenweg 35

joint signing clerk

0

Dr. Gotthard Rainer

1949-05-24

A-8501 Lieboch

Ulmgasse 11

joint signing clerk

0

Walter Scheiffele

1965-07-13

A-8530 Deutschlandsberg

Siemensstraße 43

joint signing clerk

0

Ing. Thomas Trebitsch

1970-08-21

A-8054 Graz Straßgang

Kramerweg 6

joint signing clerk

0

Dr. Gunter Griss

1945-06-27

A-8010 Graz

Panoramagasse 120

chairman of the supervisory board

7

Dipl-Ing. Gerald List

1956-05-13

D-21521 Wolltorf

Billtal 27

deputy chairman of the supervisory board

0

Bernhard Fleischer

1963-09-19

A-8046 Stattegg

Eichenweg 15

member of the supervisory board

0

Dr. Thomas Navratil

1943-11-09

A-8020 Graz

Kleiststraße 48a (c/o)

member of the supervisory board

0

Mag. Reinhard Ortner

1949-01-06

A-1010 Wien

Graben 21

member of the supervisory board

1

Ing. Reinhard Wimmler

1957-05-25

A-8020 Graz

Kleiststraße 48 (c/o)

member of the supervisory board

0

Martin Nöstlthaller-Kropf

 

A-8020 Graz

Hans Listplatz 1(c/o)

head of accounting

0

Dr. Christian Haring

 

A-8020 Graz

Hans Listplatz 1(c/o)

head of purchasing

0


related companies

 

Company name

Address

Shareholdings in %

Since

Commercial register no.

Shares in this company are held by:

List Capital & Consulting GmbH

A-8020 Graz

Hans List Platz 1

100 %

2012-10-13

FN 53587 f

 

This company holds 100% of the shares in:

AVL DiTEST GmbH

A-8020 Graz

Alte Poststraße 156

100 %

2012-11-30

FN 184043 b

Special Purpose Powertrain GmbH

A-1120 Wien

Wagenseilgasse 3

100 %

2001-03-08

FN 206574 k

HiTEC-Gesellschaft für hochtechnologische Ausbildung und Beratung mbH

A-8020 Graz

Hans Listplatz 1

100 %

2012-12-06

FN 154818 z

Piezocryst Advanced Sensorics GmbH

A-8020 Graz

Hans Listplatz 1

100 %

2012-12-06

FN 214668 p

AVL Commercial Driveline & Tractor Engineering GmbH

A-4400 Steyr

Schönauerstraße 5

100 %

2012-12-13

FN 389157 s

 

This company holds 50% to 99% of the shares in:

qpunkt GmbH

A-8075 Hart Graz

Gewerbepark 11

75 %

2014-03-06

FN 311492 b

DTECH Steyr Dynamics & Technology Services GmbH

A-4400 Steyr

Steyrerweg 2

75 %

2013-04-25

FN 204748 a

Österreichischer Fahrzeug- und Motor-Akustik Forschungs- und Entwicklungs GmbH

A-8020 Graz

Kleiststraße 48

60 %

1996-03-23

FN 142988 b

evolaris next level GmbH

A-8010 Graz

Hugo Wolf Gasse 8/8a

50 %

2009-12-30

FN 220848 b

 

This company holds less than 50% of the shares in:

THIEN eDrives GmbH

A-6890 Lustenau

Millennium Park 11

33,33 %

2013-02-22

FN 149156 y

Kompetenzzentrum - Das virtuelle Fahrzeug, Forschungsgesellschaft mbH

A-8010 Graz

Inffeldgasse 21A

19 %

2002-08-28

FN 224755 y

AC styria Autocluster GmbH

A-8074 Grambach

Parkring 1

14,8 %

1999-12-18

FN 187962 s

AVL Cultural Foundation GmbH

A-8020 Graz

Hans Listplatz 1

1 %

2007-09-26

FN 299182 z

 

Affiliated companies and further participations:

Österreichische Fahrzeug- und Motor-Akustik Forschungs- und Entwicklungs GmbH & Co KG

A-8020 Graz

Kleiststraße 48

 

1996-05-04

FN 144581 w

List Privatstiftung

A-8010 Graz

Hans List Platz 1

 

 

FN 203987 g

e1 Business Solutions GmbH

A-8020 Graz

Hans Listplatz 1

 

 

FN 214639 x

List Beteiligungs GmbH

A-8020 Graz

Hans-List-Platz 1

 

 

FN 238348 m

AVL Consulting GmbH

A-8020 Graz

Hans Listplatz 1

 

 

FN 284219 w

 

 

Balance Sheet (absolute) all amounts in EUR

 

 

2014-12-31

Goodwill

2.010.574,00

Franchises, patents, licences, trademarks and similar rights and advantages

43.598.274,76

Advanced payments

430.535,26

Sum intangible assets

46.039.384,02

Land and leasehold rights with buildings thereon including building on land owned by third parties

5.904.282,33

Other tangible assets

1.588.651,88

Other operating and business equipment

23.163.730,58

Technical plants and machines

23.755.350,54

Advanced payments and constructions in progress

7.129.994,02

Sum tangible assets

61.542.009,35

Shares on related firms

312.314.213,76

Other shareholdings

637.004,93

Loans to related firms

61.519.110,77

Loans to firms with a shareholding relationship

286.500,00

Other financial assets, values and securities of fixed assets

1.453.579,27

Sum financial assets

376.210.408,73

Sum fixed assets

483.791.802,10

Raw-, auxiliary materials and supplies

11.323.589,34

Finished products

10.511.172,81

Outstanding service claims

65.321.096,00

Advanced payments

2.152.667,96

Received advanced payments for orders

-27.627.648,74

Sum stock

61.680.877,37

Claims from delivered goods and performed services

82.829.523,36

Claims against companies with shareholding relationship

1.849,36

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

91.504.015,78

Other claims and assets

48.403.388,22

Sum claims

222.738.776,72

Cash on hand, cheques and bank deposits

132.529.475,62

Sum cash and bank

132.529.475,62

Sum current assets

416.949.129,71

Deferred charges

1.260.107,53

Sum deferred charges

1.260.107,53

Assets

902.001.039,34

 

Subscribed/declared capital

5.000.000,00

Not committed capital reserves

123.448.503,32

Legal reserves

500.000,00

Other reserves

6.177.020,48

Balance sheet profit/balance sheet loss

171.660.652,72

Thereof profit/loss carried forward

150.354.476,04

Sum equity capital

306.786.176,52

Other reserves before taxes

58.177,00

Sum reserves before taxes

58.177,00

Investment contributions

251.762,00

Sum floor capital

251.762,00

Reserves for severance pays

31.709.930,00

Reserves for pensions

4.405.559,00

Other reserves

102.677.479,82

Sum reserves

138.792.968,82

Liabilities against credit institutes

120.004.461,75

Received advanced payments for orders

16.785.795,95

Liabilities from delivered goods and performed services

69.401.482,81

Liabilities against related firms

34.136.971,47

Liabilities against firm with shareholding relationship

1.045.682,31

Other liabilities

13.582.181,06

Other loans

200.568.944,79

Sum liabilities

455.525.520,14

 

Deferred income

586.434,86

Sum deferred income

586.434,86

Liabilities

902.001.039,34

Contingent liabilities

86.066.368,11

Balance sheet sum

902.001.039,34

 

 

P / L Account (absolute) all amounts in EUR

 

 

2014-12-31

Gross sales

590.911.314,69

Increase or decrease in finished and unfinished goods and in service claims

3.219.788,45

Other manufacturing costs capitalized

1.897.103,74

Total turnover or gross profit

596.028.206,88

 

Profits from retirement of fixed assets, except financial assets

823.075,11

Income from dissolution of reserves

4.340.589,22

Other operating profits

83.963.369,16

Other operating profits totally

89.127.033,49

 

Costs for obtained services

-92.424.271,76

Material costs

-178.534.190,66

Costs for obtained services totally

-270.958.462,42

 

Wages

-3.819.468,86

Salaries

-174.797.580,78

Costs for severance pays

-5.085.638,09

Costs for old age pension

-562.700,04

Legal fringe benefits and other payments depending on salaries

-44.743.644,42

Other social fringe benefits

-1.757.587,16

Personnel expenses totally

-230.766.619,35

 

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation

-21.996.387,65

Depreciation tangible assets / intangible assets totally

-21.996.387,65

 

Other operating costs

-147.056.653,46

Total costs

-147.056.653,46

 

Operating result totally

14.377.117,49

 

Profits from shareholdings

23.084.221,49

Income from other securities and loans of financial assets

1.949.943,42

Interest income, securties income and similar income

2.387.001,44

Profits from the retirement of and investment in financial assets

5.460,00

Disbursements from other financial assets and from securities of current assets (e.g. depreciations)

-1.384.375,00

Interest and similar disbursements

-20.400.108,31

Financial profits totally

5.642.143,04

 

Results from usual business activity totally

20.019.260,53

 

Taxes on income and profits

1.281.006,15

Taxes on income and profits totally

1.281.006,15

 

Annual surplus/annual deficit totally

21.300.266,68

 

Dissolution reserves before taxes

5.910,00

Reserves movements totally

5.910,00

 

Annual profit/annual loss totally

21.306.176,68

 

Profit and loss carried forward from previous year

150.354.476,04

Transfer of profits totally

150.354.476,04

 

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account

171.660.652,72

 

 

Key ratios

 

 

2014

Cashflow II

43.296.654,33

Debt amortisation period in years

10,27

Bank indebtedness

35,54

Equity capital share in %

34,69

Social capital share

4,00

Fixed assets coverage

70,94

Net profit ratio

3,35

Capital turnover

0,66

Return on investment in %

4,48

Cashflow in % of operating performance

7,26

Cashflow I

42.015.648,18

Gross productivity

2,58

Net productivity

1,40

Operating performance

596.028.206,88

Inventories in % of operating performance

10,34

Gross profit

325.069.744,46

 

 

Land Register

 

Note

No real estate property registered

 

 

Commercial register

 

firm (style)

11      AVL List GmbH

legal form

1      Gesellschaft mit beschränkter Haftung

registered office

1      politischer Gemeinde Graz

business adress

15      Hans-List-Platz 1
8020 Graz

capital

36      EUR 5.000.000

reference date annual accounts

1      31. Dezember

annual accounts

72      zum 31.12.2014 eingereicht am 16.06.2015

consolidated accounts

73      zum 31.12.2014 eingereicht am 16.06.2015

power of representation

1      Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten.
Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäfts-
führer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige
Vertretungsbefugnis erteilen.
1   Gesellschaftsvertrag  vom 04.09.1979                                001
1   Generalversammlungsbeschluss  vom 24.09.1979                        002
Kapitalerhöhung um ATS 7.900.000,-.
Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt Fünftens.
1   Der Gesellschaftsvertrag wurde mehrfach geändert, zuletzt           003
mit Beschluss der Generalversammlung  vom 20.04.1990
11   Generalversammlungsbeschluss  vom 08.07.1996                        004
Änderung des Gesellschaftsvertrages im § 1.
36   Gesellschaftsvertrag mit Generalversammlungsbeschluss               005
vom 17.08.2005
gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.
36   Generalversammlungsbeschluss  vom 17.08.2005                        006
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 4.418.617,33
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Punkten V., VII.,
IX., XII. und XIII.
60   Verschmelzungsvertrag  vom 20.09.2012                               007
60   Generalversammlungsbeschluss  vom 20.09.2012                        008
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
AVL Holding GmbH
(FN 177836 z)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
63   Generalversammlungsbeschluss  vom 31.10.2012                        009
Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Einfügung des
Punktes VIII.
70   Verschmelzungsvertrag  vom 29.09.2014                               010
70   Generalversammlungsbeschluss  vom 29.09.2014                        011
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
TecInvest Gesellschaft für
Technologieentwicklung m.b.H.
(FN 237533 p)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Graz.

 

proxy

K   Dipl-Ing Werner Moser, geb. 18.04.1948
1        vertritt seit 04.12.1991 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer
AA   Dr. Gotthard Rainer, geb. 24.05.1949
16        vertritt seit 01.04.1998 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer
AI   Dipl.-Päd. Stephan Baron, geb. 07.05.1950
19        vertritt seit 01.04.1999 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer
AR   Dr. Josef Affenzeller, geb. 25.06.1942
34        vertritt seit 13.06.2005 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer
BB   Dr. Martin Nöstlthaller-Kropf, geb. 16.12.1974
58        vertritt seit 01.07.2012 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer
BC   Christian Neugebauer, geb. 12.06.1959
58        vertritt seit 01.07.2012 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer
BE   DI Michael Mühlögger, geb. 25.03.1964
64        vertritt seit 15.05.2013 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer
BF   Dipl. BW Walter Scheiffele, geb. 13.07.1965
64        vertritt seit 15.05.2013 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer
BG   Thomas Trebitsch, geb. 21.08.1970
64        vertritt seit 15.05.2013 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer

 

supervisory board

T   Ing. Reinhard Wimmler, geb. 25.05.1957
1        Mitglied
X   D.I. Gerald List, geb. 13.05.1956
17        Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
Y   Dr. Gunter Griss, geb. 27.06.1945
17        Vorsitzende/r
AO   Dr. Thomas Navratil, geb. 09.11.1943
31        Mitglied
AV   Bernhard Fleischer, geb. 19.09.1963
44        Mitglied
BA   Mag. Reinhard Ortner, geb. 06.01.1949
55        Mitglied

 

managing director

B   Prof.Dr.hc.Dipl.Ing. Helmut List, geb. 20.12.1941
1        vertritt seit 06.09.1979 selbständig
AJ   Dipl.Bw. Werner Schuster, geb. 27.11.1945
20        vertritt seit 25.06.1999 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
AN   Dr. Robert Fischer, geb. 18.01.1961
30        vertritt seit 01.12.2003 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
AY   Dr. Marko Dekena, geb. 26.06.1969
52        vertritt seit 12.07.2010 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
AZ   Dipl.Ing. Kai Uwe Voigt, geb. 19.04.1961
54        vertritt seit 20.09.2010 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
BD   Dr. Uwe Dieter Grebe, geb. 29.04.1965
61        vertritt seit 15.10.2012 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
BH   Dr Hannes Schmüser, geb. 29.06.1968
67        vertritt seit 17.01.2014 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen

 

shareholder

U   List Capital & Consulting GmbH
60        ....................  EUR 5.000.000
60        ...............................................  EUR 5.000.000
-------------------------------------------------------
Summen:           EUR 5.000.000              EUR 5.000.000

 

general table

Landesgericht für ZRS Graz
1 datenersterfasst am 06.10.1993             Geschäftsfall 902 Fr   853/93 i
Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
4 eingetragen am 25.10.1994                  Geschäftsfall  27 Fr  5087/94 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.10.1994
6 eingetragen am 05.10.1995                  Geschäftsfall  27 Fr  5289/95 t
amtswegige Nachbearbeitung
eingetragen am 05.10.1995                  Geschäftsfall  27 Fr  5917/95 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.09.1995
8 eingetragen am 20.02.1996                  Geschäftsfall  27 Fr   664/96 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.01.1996
9 eingetragen am 30.05.1996                  Geschäftsfall  27 Fr  2733/96 t
Antrag auf Änderung  eingelangt am 10.05.1996
10 eingetragen am 04.07.1996                  Geschäftsfall  27 Fr  3387/96 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.06.1996
11 eingetragen am 13.08.1996                  Geschäftsfall  27 Fr  4001/96 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.07.1996
15 eingetragen am 20.01.1998                  Geschäftsfall  27 Fr    21/98 x
amtswegige Berichtigung
16 eingetragen am 06.05.1998                  Geschäftsfall  27 Fr  2436/98 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.04.1998
17 eingetragen am 14.11.1998                  Geschäftsfall  27 Fr 10714/98 x
Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.11.1998
19 eingetragen am 06.07.1999                  Geschäftsfall  27 Fr  4156/99 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 06.04.1999
20 eingetragen am 06.07.1999                  Geschäftsfall  27 Fr  6942/99 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.07.1999
25 eingetragen am 08.02.2001                  Geschäftsfall  27 Fr  1179/01 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.02.2001
30 eingetragen am 23.12.2003                  Geschäftsfall  27 Fr 14557/03 i
Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.11.2003
31 eingetragen am 08.01.2004                  Geschäftsfall  27 Fr    37/04 s
Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 31.12.2003
34 eingetragen am 23.06.2005                  Geschäftsfall  47 Fr  3641/05 x
Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.06.2005
36 eingetragen am 30.11.2005                  Geschäftsfall  47 Fr  5342/05 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.09.2005
44 eingetragen am 20.02.2007                  Geschäftsfall  47 Fr   257/07 m
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.01.2007
52 eingetragen am 27.07.2010                  Geschäftsfall  47 Fr  2443/10 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.07.2010
54 eingetragen am 05.10.2010                  Geschäftsfall  47 Fr  3558/10 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.09.2010
55 eingetragen am 18.01.2011                  Geschäftsfall  47 Fr  5240/10 t
Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.12.2010
58 eingetragen am 24.07.2012                  Geschäftsfall  47 Fr  6043/12 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.06.2012
60 eingetragen am 13.10.2012                  Geschäftsfall  47 Fr  8604/12 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.09.2012
61 eingetragen am 31.10.2012                  Geschäftsfall  47 Fr  9457/12 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 01.10.2012
62 eingetragen am 12.12.2012                  Geschäftsfall  47 Fr 10440/12 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.12.2012
63 eingetragen am 10.01.2013                  Geschäftsfall  47 Fr 10102/12 i
Antrag auf Änderung  eingelangt am 15.11.2012
64 eingetragen am 08.06.2013                  Geschäftsfall  47 Fr  2358/13 f
Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.05.2013
67 eingetragen am 04.02.2014                  Geschäftsfall  47 Fr   238/14 x
Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.01.2014
70 eingetragen am 24.10.2014                  Geschäftsfall  47 Fr  4942/14 p
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.09.2014
71 eingetragen am 11.04.2015                  Geschäftsfall  47 Fr   993/15 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.04.2015
72 eingetragen am 20.06.2015                  Geschäftsfall  47 Fr  1743/15 v
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 16.06.2015
73 eingetragen am 24.06.2015                  Geschäftsfall  47 Fr  1740/15 p
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 16.06.2015

 

 

Historical development

 

Year of incorporation

1972

Date of registration

1979-09-06

 

Change in share capital

 

from

to

asset

 

 

2005-11-30

ATS

8.000.000,00

2005-11-30

 

EUR

5.000.000,00

 

Former executives

 

from

to

position

name

 

1997-01-30

manager

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans List

 

1998-11-14

manager

Ing. Alfred Marek

 

1999-07-06

manager

Dipl-Ing. Rudolf Leitner

 

2000-10-18

manager

Dipl-Ing. Gerald Kirchmayer

1996-07-04

2005-05-12

manager

Dipl-Ing. Frank Mundorff

 

2005-05-12

manager

Dr. Johann Stubenberg

 

2010-01-30

joint signing clerk

Dipl-Ing. Heimo Denk

2005-07-26

2012-07-24

joint signing clerk

Mag. Gerhard Koiner

1993-10-06

1998-11-14

chairman of the supervisory board

Dr. Gerald Heidinger

1996-05-30

1998-11-14

deputy chairman of the supervisory board

Dr. Gunter Griss

 

1993-10-06

member of the supervisory board

Dr. Gerald Heidinger

 

1998-11-14

member of the supervisory board

Dipl-Ing. Gerald List

1998-11-14

2004-01-08

member of the supervisory board

DDr. Eduard Lechner

1993-10-06

2007-02-20

member of the supervisory board

Erwin Trummer

 

2009-05-26

member of the supervisory board

Dr. Rolf Murmann

2009-05-26

2010-11-18

member of the supervisory board

Mag. Friedrich Rothwangl

1997-01-30

2005-12-02

joint signing clerk

Dipl-Ing. Michael Ksela

 

2005-05-12

manager

Dipl-Ing. Karl Wojik

2005-05-12

2006-05-17

manager

Dr. Andreas Eppinger

2005-05-12

2006-07-12

manager

Dr. Kurt Kirsten

2006-06-07

2006-11-11

manager

Manfred Schon

1998-11-14

2010-07-27

manager

Prof. Dipl.Ing. Dr. Franz Moser

1997-09-17

2010-10-05

manager

Dr. Friedrich Radke

2007-12-15

2011-06-07

manager

Patrick Signargout

2006-11-11

2012-10-31

manager

Dipl. Verw. Wiss. Michael Blickle

1998-05-06

2000-10-18

joint signing clerk

Dr. Johann Berger

 

2000-10-18

joint signing clerk

Dipl-Ing.Dr. Klaus Mayer

 

2000-10-18

joint signing clerk

Peter Meurer

1997-01-30

2000-10-18

joint signing clerk

Mag. Tom Holger Wästfelt

1999-07-06

2002-12-18

joint signing clerk

Dipl-Ing. Andreas Maron

2002-12-18

2005-07-26

joint signing clerk

Dipl-Ing. Burkard Emil Balzer

2002-12-18

2005-12-02

joint signing clerk

Paul Blijham

 

Former shareholders

 

from

to

position

name

1993-10-06

2000-12-21

partner

List Capital & Consulting GmbH

2000-12-21

2012-10-13

partner

AVL Holding GmbH

 

Former shareholdings

 

from

to

company name

1997-01-30

2002-02-16

HiTEC-Gesellschaft für hochtechnologische Ausbildung und Beratung mbH

1999-06-18

2008-06-17

AKUSTIKKOMPETENZZENTRUM Gesellschaft für Akustik- forschung m.b.H.

2005-12-20

2008-11-29

Spielberg NEU Projektentwicklung GmbH

2003-08-22

2009-02-11

International Management Center Graz GmbH

2005-04-20

2011-02-01

HyCentA Research GmbH

2003-02-18

2011-10-11

Kompetenzzentrum für umweltfreundliche Stationärmotoren Gesellschaft m.b.H. in Liquidation

2002-12-25

2004-10-12

Styrian Airways Beteiliguns AG & Co KEG

2003-09-10

2009-04-23

International Management Center Graz GmbH & Co KG

 

Mergers

 

On

position

name

2014-10-24

merged with

TecInvest Gesellschaft für Technologieentwicklung m.b.H.

2012-10-13

merged with

AVL Holding GmbH


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.63.57

UK Pound

1

Rs.99.20

Euro

1

Rs.70.35

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

DIV

 

 

Report Prepared by :

VNT

 

               

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

 

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

 

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

 

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

 

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

 

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

 

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

 

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

Credit not recommended

 

--

NB

New Business

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.