|
Report No. : |
326175 |
|
Report Date : |
08.06.2015 |
IDENTIFICATION DETAILS
|
Name : |
ARMAND THIERY SAS |
|
|
|
|
Registered Office : |
Armand Thiery Sas At Sas 2 B Rue De Villiers 92309 Levallois Perret
Cedex |
|
|
|
|
Country : |
France |
|
|
|
|
Financials (as on) : |
31.12.2013 |
|
|
|
|
Date of Incorporation : |
January 1991 |
|
|
|
|
Legal Form : |
Simplified joint stock company |
|
|
|
|
Line of Business : |
Retail sale of clothing in specialized stores. |
|
|
|
|
No. of Employee : |
2 000 to 4 999 employees |
RATING & COMMENTS
|
MIRA’s Rating : |
Ba |
|
RATING |
STATUS |
PROPOSED CREDIT LINE |
|
|
41-55 |
Ba |
Overall operation is considered normal. Capable to meet normal
commitments. |
Satisfactory |
|
Status : |
Satisfactory |
|
|
|
|
Payment Behaviour : |
No complaints |
|
|
|
|
Litigation : |
Clear |
NOTES :
Any query related to this report can be made
on e-mail : infodept@mirainform.com
while quoting report number, name and date.
ECGC Country Risk Classification List – December 31, 2014
|
Country Name |
Previous Rating (30.09.2014) |
Current Rating (31.12.2014) |
|
France |
A1 |
A1 |
|
Risk Category |
ECGC
Classification |
|
Insignificant |
A1 |
|
Low |
A2 |
|
Moderate |
B1 |
|
High |
B2 |
|
Very High |
C1 |
|
Restricted |
C2 |
|
Off-credit |
D |
FRANCE ECONOMIC OVERVIEW
The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With more than 84 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that mitigate economic inequality. France's real GDP increased by 0.4% in 2014. The unemployment rate (including overseas territories) increased from 7.8% in 2008 to 10.5% in 2014. Youth unemployment in metropolitan France decreased from a high of 25.4% in the fourth quarter of 2012 to 24.3% in the fourth quarter of 2014. Lower-than-expected growth and high spending have strained France's public finances. The budget deficit rose sharply from 3.3% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 4.3% of GDP in 2014, while France's public debt rose from 68% of GDP to more than 92% over the same period. Elected on a conventionally leftist platform, President Francois HOLLANDE surprised and angered many supporters with a January 2014 speech announcing a sharp change in his economic policy, recasting himself as a liberalizing reformer. The government's budget for 2014 shifted the balance of fiscal consolidation from taxes to a total of $24 billion in spending cuts. In December 2014, HOLLANDE announced additional reforms, including a plan to extend commercial business hours, liberalize professional services and sell off $6.2-12.4 billion in state owned assets. France’s tax burden remains well above the EU average and income tax cuts over the past decade are being partly reversed, particularly for higher earners. The top rate of income tax is 41%. The government is allowing a 75% payroll tax on salaries over $1.24 million to lapse.
|
Source
: CIA |
|
Name |
ARMAND THIERY SAS |
||
|
Acronym |
AT SAS |
||
|
Trade name |
- |
||
|
Status |
Economically active |
||
|
Postal Address |
ARMAND THIERY SAS |
||
|
Share Capital |
25,140,540 Euros |
||
|
Incorporiation Date |
01/1991 |
||
|
Activity (APE) |
Retail sale of clothing in specialized
stores (4771Z) |
RCS Registration |
RCS Nanterre B 380 622 332 |
|
Formation Date |
10/1990 |
EUR VAT Number |
FR80380622332 |
|
Deregistration Date |
- |
Last account Date |
31/12/2013 |
|
Court Registry Number |
19 9 6B00130 |
Telephone |
04 42 94 91 60 |
|
Registration Court |
Nanterre (92) |
Fax |
- |
|
Nationality |
France |
||
|
Legal form |
Simplified joint stock company |
||
|
Currency |
Euros |
||
|
Year to date |
Turnover |
Gross operating surplus |
Shareholder's equity |
Net result |
Employees |
|
31/12/2013 |
419,512,489 € |
13.32% Turnover |
230,443,723 € |
27,429,187 € |
2 000 to 4 999 employees |
|
31/12/2011 |
415,546,166 € |
17.13% Turnover |
207,918,442 € |
34,731,950 € |
- |
|
31/12/2010 |
408,616,122 € |
19.38% Turnover |
198,074,668 € |
54,523,440 € |
- |
|
Name |
Country |
Company Number |
|
|
SOCIETE IMMOBILIERE ET MOBILIERE DE MONTAGNY |
308705425 |
||
|
Current Directors |
6 |
|
No social security and tax office preferential right to date |
|
Total number of Invoices available |
99 |
|
Total number of Invoices paid within or up to 30 days after the
due date |
89 |
|
Total number of Invoices paid more than 30 days after the dues
date |
7 |
|
Total number of Invoices currently outstanding where the due date has
not yet been reached |
3 |
|
Total number of Invoices currently outstanding beyond the due date |
0 |
|
Profitability |
|
|
Liquidity |
|
|
Net Worth |
|
Type of Establishment |
Head Office |
Production Role |
- |
|
APE/NAF Code |
4771Z |
Activity |
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé |
|
Formation Date |
05/2011 |
Reason for Formation |
Formation |
|
Closure Date |
- |
Reason for Closure |
- |
|
Reactivation Date |
- |
Seasonality |
- |
|
Activity Nature |
Other |
Activity Location |
Office |
|
Trading Address |
2 B RUE DE VILLIERS |
Department |
- |
|
Location Surface |
- |
District |
- |
|
City |
LEVALLOIS PERRET |
Status |
Economically active |
|
Business Pages FT® |
VETEMENTS POUR HOMMES (DETAIL) |
Region |
Ile-de-France |
|
Area |
- |
||
|
Size of Urban Area |
- |
1 ultimate parent company/companies for this company
|
Company Name |
Activity (APE) |
APE/NAF Code |
City |
Post Code |
|
SOCIETE IMMOBILIERE ET MOBILIERE DE MONTAGNY |
Activités des sociétés holding |
6420Z |
ROANNE |
42300 |
|
Regionality |
Legal unit with multiple establishments in many areas but no one
grouping more than 50% of workforce |
|
Mono-activity status |
Legal unit with multiple establishments having main activities in many
divisions, which one activity grouping from 80 to 99% of workforce |
|
Branches |
591 branch entities in this company |
|
Company Name |
Company Type |
APE/NAF Code |
Activity |
City |
Post Code |
|
ARMAND THIERY SAS |
Head Office |
4771Z |
Retail
sale of clothing in specialized stores |
LEVALLOIS PERRET |
92300 |
|
ARMAND THIERY SAS |
Branch |
4771Z |
Retail
sale of clothing in specialized stores |
NICE |
06300 |
|
ARMAND THIERY SAS |
Branch |
4771Z |
Retail
sale of clothing in specialized stores |
NICE |
06300 |
|
ARMAND THIERY SAS |
Branch |
4771Z |
Retail
sale of clothing in specialized stores |
SAINT LAURENT DU VAR |
06700 |
|
ARMAND THIERY SAS |
Branch |
4771Z |
Retail
sale of clothing in specialized stores |
PONT SAINTE MARIE |
10150 |
|
Workforce at address |
Workforce unknown |
Company workforce |
2 000 to 4 999 employees |
The comments are ordered according to the class of risk. Companies are
compared with regard to other companies of the same type. Thus a positive
comment for one category can be negative for another or can change depending on
its value. This is a purely statistical decision.
|
The shareholder's equity is 230,443,723 € |
|
|
The ratio total assets to total liabilities is 4 |
|
|
The creditor days are 32.02 |
|
|
The decrease in the gearing percentage over the last two accounting
periods is 46 % |
|
|
The liabilities are 73,894,713 € |
|
|
The net current assets are 130,112,074 € |
|
|
The net turnover is 419,512,489 € |
|
|
The pre-tax profit is 41,326,238 € |
|
|
The risk provisions are 2,954,282 € |
|
|
The total assets are 307,292,718 € |
|
|
Low risk workforce size |
|
|
The company has 6 directors |
|
|
Industry code with low risk rating |
|
|
Department code with low risk rating |
|
|
The sales to current assets ratio is 3.22 |
|
|
The stock to turnover ratio is 12.31 |
|
|
The return on total assets employed is 13.45 |
|
No judgment information for the company |
|
Company monitored since |
04/02/2008 |
||
|
Status of Monitoring |
No social security and tax office preferential right to date |
||
|
Number of preferential rights |
0 |
|
Total amount |
- |
|
Due remaining amount |
- |
|
Date of last preferential right |
- |
|
Registration number |
Registration date |
Date of the planned end |
Creditor |
Amount of the debt |
Due remaining amount |
|||||||||
|
Hide |
40802432 |
03/03/2008 |
02/04/2008 |
TRESORERIE DE BORDEAUX EST |
11,096 EUR |
- |
||||||||
|
||||||||||||||
Summary of
preferential rights
|
Company monitored since |
04/02/2008 |
||
|
Status of Monitoring |
No social security and tax office preferential right to date |
||
Tax office
preferential rights
|
Number of preferential rights |
0 |
|
Total amount |
- |
|
Due remaining amount |
- |
|
Date of last preferential right |
- |
|
Registration number |
Registration date |
Date of the planned end |
Creditor |
Amount of the debt |
Due remaining amount |
|||||||||
|
Hide |
40802432 |
03/03/2008 |
02/04/2008 |
TRESORERIE DE BORDEAUX EST |
11,096 EUR |
- |
||||||||
|
||||||||||||||
|
Ultimate parent company |
SOCIETE IMMOBILIERE ET MOBILIERE DE MONTAGNY |
|
|
Direct parent |
SOCIETE IMMOBILIERE ET MOBILIERE DE MONTAGNY - 100 % |
|
|
Group – Number of companies |
4 |
|
|
Linkages – Number of companies |
||
|
Number of countries |
||
|
Display
only where participation % > 33 % |
Display all
participations |
|
|
Name |
SIREN |
Parts |
Last account published |
|
1 |
SOCIETE IMMOBILIERE ET MOBILIERE DE MONTAGNY |
308705425 |
- |
31/12/2013 |
|
2 |
ARMAND THIERY SAS |
380622332 |
100 % |
31/12/2013 |
|
3 |
GESTABENE S.A. |
B83602 |
99.98 % |
31/12/2014 |
|
SOCIETE MONEGASQUE DES MAGASINS |
- |
97 % |
- |
|
|
GRANGE TAMBOUR PARTICIPATIONS |
452511702 |
24 % |
31/12/2013 |
|
|
LE SAUZAY |
519592828 |
10 % |
31/12/2013 |
|
No Linkages information available for the company. |
|
Name |
SA EXCO FIDOGEST |
|||
|
Name of representative |
||||
|
Manager position |
Limited partner |
Date of birth |
- |
|
|
Place of birth |
||||
|
Type |
Moral person |
Name at birth |
||
|
Name |
M. DUC BERNARD |
|||
|
Manager position |
Vice-president |
Date of birth |
30/12/1944 |
|
|
Place of birth |
ST ETIENNE |
|||
|
Type |
Individual |
Name at birth |
||
|
Name |
M. DEVEAUX LUCIEN ERNEST MARIE |
|||
|
Manager position |
President |
Date of birth |
17/11/1940 |
|
|
Place of birth |
ROANNE |
|||
|
Type |
Individual |
Name at birth |
||
|
Name |
M. VIGNON FRANCOIS-REGIS |
|||
|
Manager position |
Sleeping partner |
Date of birth |
08/03/1969 |
|
|
Place of birth |
ROANNE |
|||
|
Type |
Individual |
Name at birth |
||
|
Name |
M. DEVEAUX RODOLPHE |
|||
|
Manager position |
President of the management board |
Date of birth |
14/12/1975 |
|
|
Place of birth |
ROANNE |
|||
|
Type |
Individual |
Name at birth |
||
|
Name |
M. GERGELE RENÉ |
|||
|
Manager position |
Managing director |
Date of birth |
09/08/1952 |
|
|
Place of birth |
ROANNE |
|||
|
Type |
Individual |
Name at birth |
||
View the directors
history for this company
If you want to view the directors history, please click on the link view
details.
|
Manager position |
Title and name |
Date of Birth/Place of Birth |
|
|
President of the supervisory council |
M. DEVEAUX LUCIEN ERNEST MARIE |
17/11/1940 - ROANNE |
|
|
Managing director |
M. GERGELE RENÉ |
09/08/1952 - ROANNE |
|
No Status History |
|
Publication date
|
Gazette Name |
Description |
|
|
Hide |
27/11/2014 |
Bodacc A |
Vente et cession : Vendeur |
|
14 - CALVADOS GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CAEN 193 - 712 044 502 RCS Évry. SOCIETE RIU
AUBLET ET COMPAGNIE. Forme : Société anonyme. Capital : 1764507.86
EUR. Adresse : 4 bis rue Diderot, Zone d'Activités Commerciales de la
Noue Rousse, 91240 Saint-Michel-sur-Orge. |
|||
|
Hide |
30/10/2014 |
JAL |
Activity or goodwill cession: Seller |
|
Agriculteur
normand (L')/Edition du Calvados
|
|||
|
Hide |
28/10/2014 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
14 - CALVADOS GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN 53 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT
SAS. Capital : 25140540 EUR. Adresse : 2 bis rue de Villiers,
92309 Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
23/10/2014 |
JAL |
Activity or goodwill cession: Buyer |
|
Agriculteur
normand (L')/Edition du Calvados
|
|||
|
Hide |
24/08/2014 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
80 - SOMME GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 1338 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par Actions Simplifiée. Sigle : AT-SAS.
Adresse : 2 bis rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
16/08/2014 |
Bodacc C |
Comptes annuels et rapports |
|
92 -
HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 14507 - 380622332 RCS. ARMAND THIERY
SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 2
Bis rue de Villiers 92309 Levallois Perret Cedex. Commentaires :
Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2013. |
|||
|
Hide |
08/08/2014 |
JAL |
Activity or goodwill cession: Buyer |
|
Action agricole
picarde (L')
|
|||
|
Hide |
25/04/2014 |
JAL |
Start of rent-management |
|
Essor
(L')/Edition de l'Isère
|
|||
|
Hide |
02/08/2013 |
JAL |
Start of rent-management |
|
Journal spécial
des sociétés (Le)
|
|||
|
Hide |
02/08/2013 |
Bodacc C |
Comptes annuels et rapports |
|
92 -
HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 12282 - 380622332 RCS. ARMAND THIERY
SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 2
Bis rue de Villiers 92309 Levallois Perret Cedex. Commentaires :
Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2012. |
|||
|
Hide |
18/07/2013 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
14 - CALVADOS GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX 114 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 25140540
EUR. Adresse : 2 Bis rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
09/07/2013 |
JAL |
Activity or goodwill cession: Buyer |
|
Pays d'Auge (Le)
|
|||
|
Hide |
18/11/2012 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
10 - AUBE GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE TROYES 70 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SA. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT.
Adresse : 2 bis rue de Villiers, 92309 Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
06/11/2012 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
75 - PARIS GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 394 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT-SAS.
Adresse : 2 bis rue de Villiers, 92309 Levallois Perret. |
|||
|
Hide |
05/11/2012 |
JAL |
Activity or goodwill cession: Buyer |
|
Petites Affiches
Matot Braine (Les)
|
|||
|
Hide |
24/10/2012 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
10 - AUBE GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE TROYES 216 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SA. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT.
Adresse : 2 bis rue de Villiers, 92309 Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
18/10/2012 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
59 - NORD GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES 427 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT
SAS. Adresse : 2 bis rue de Villiers, 92309 Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
11/10/2012 |
JAL |
Activity or goodwill cession: Buyer |
|
Petites affiches
(Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
|
|||
|
Hide |
10/10/2012 |
JAL |
Activity or goodwill cession: Buyer |
|
Est Eclair (L')
|
|||
|
Hide |
06/10/2012 |
JAL |
Activity or goodwill cession: Buyer |
|
Gazette Nord Pas
de Calais/Edition du Nord
|
|||
|
Hide |
23/08/2012 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
13 -
BOUCHES-DU-RHONE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE 321 - 380 622 332 RCS Marseille. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT
SAS. Adresse : 2bis rue de Villiers, 92309 Levallois Perret Cedex. |
|||
|
Hide |
22/08/2012 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
62 -
PAS-DE-CALAIS GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BOULOGNE-SUR-MER 681 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT
SAS. Adresse : 2B rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
08/08/2012 |
JAL |
Activity or goodwill cession |
|
Gazette Nord Pas
de Calais/Edition du Pas de Calais
|
|||
|
Hide |
26/07/2012 |
Bodacc C |
Comptes annuels et rapports |
|
92 -
HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 11953 - 380622332 RCS. ARMAND THIERY
SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 2
Bis rue de Villiers 92309 Levallois Perret Cedex. Commentaires : Comptes
annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011. |
|||
|
Hide |
11/07/2012 |
Bodacc B |
Modification et mutation diverse |
|
92 -
HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 3481 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT
SAS. Administration : Président et membre du conseil de surveillance :
DEVEAUX Lucien Ernest Marie modification le 02 Août 2006 Commissaire aux
comptes suppléant : VIGNON Francois-Regis en fonction le 23 Juillet 2003
Commissaire aux comptes titulaire : SA EXCO FIDOGEST en fonction le 23
Juillet 2003 Membre du conseil de surveillance : VON TSCHAMMER UND QUARITZ
Carl Thibaud en fonction le 02 Août 2006 Président du directoire : DEVEAUX
Rodolphe modification le 18 Septembre 2009 Membre du directoire : DEVEAUX
Frédérique modification le 18 Septembre 2009 Membre du conseil de
surveillance : DUC Bernard en fonction le 18 Septembre 2009 Directeur général
- membre du directoire : GERGELE René modification le 21 Septembre 2009
Membre du conseil de surveillance : BARRAL Arnaud en fonction le 03 Juillet
2012 Vice président et membre du conseil de surveillance : DUC Bernard en
fonction le 03 Juillet 2012. Activité : . |
|||
|
Hide |
08/07/2012 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
94 -
VAL-DE-MARNE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL 948 - 380 622 332 RCS Créteil. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 25140540
EUR. Adresse : 2 Bis rue de Villiers, 92309 Levallois Perret Cedex. |
|||
|
Hide |
29/06/2012 |
JAL |
Resignation / Revocation of the social representative |
|
Petites affiches
(Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
|
|||
|
Hide |
29/06/2012 |
JAL |
Appointment of the social representative |
|
Petites affiches
(Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
|
|||
|
Hide |
26/06/2012 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
19 - CORREZE GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BRIVE 314 - 380 622 332 RCS Brive. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 25140540
EUR. Adresse : 2b rue de Villiers, 92309 Levallois Perret Cedex. |
|||
|
Hide |
15/06/2012 |
JAL |
Activity or goodwill cession |
|
Montagne
(La)/Edition Tulle
|
|||
|
Hide |
07/06/2012 |
JAL |
Activity or goodwill cession |
|
Gazette du
palais (La)
|
|||
|
Hide |
19/05/2012 |
JAL |
Activity or goodwill cession |
|
Nouvelles
Publications (Les)
|
|||
|
Hide |
20/03/2012 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
02 - AISNE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN 68 - 380 622 332 RCS Saint-Quentin. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT
SAS. Capital : 25140540 EUR. Adresse : 2 bis rue de Villiers,
92309 Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
16/03/2012 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
77 -
SEINE-ET-MARNE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN 627 - 380 622 332 RCS Melun. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT
SAS. Adresse : 2 bis rue de Villiers, 92309 Levallois Perret, 92300
Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
13/03/2012 |
JAL |
Activity or goodwill cession |
|
Picardie La
Gazette
|
|||
|
Hide |
04/03/2012 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
91 - ESSONNE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY 563 - 380 622 332 RCS Evry. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 25140540
EUR. Adresse : 2 Bis rue de Villiers, 92309 Levallois Perret Cedex. |
|||
|
Hide |
02/03/2012 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
56 - MORBIHAN GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT 268 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT
SAS. Adresse : 2 bis rue de Villiers, 92309 Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
24/02/2012 |
JAL |
Activity or goodwill cession |
|
Paysan Breton
(Le)/Edition du Morbihan
|
|||
|
Hide |
21/02/2012 |
JAL |
Activity or goodwill cession |
|
Semaine de
l'Ile-de-France (La)
|
|||
|
Hide |
21/02/2012 |
JAL |
Activity or goodwill cession |
|
Pays Briard (Le)
|
|||
|
Hide |
11/12/2011 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
64 -
PYRENEES-ATLANTIQUES GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU 993 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT
SAS. Adresse : 2bis rue de Villiers, 92309 Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
11/12/2011 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
64 -
PYRENEES-ATLANTIQUES GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE 905 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERRY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT-SAS.
Adresse : 2b rue de Villiers, 92309 Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
01/11/2011 |
JAL |
Activity or goodwill cession |
|
Petites Affiches
Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques (Les)
|
|||
|
Hide |
02/08/2011 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
30 - GARD GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 252 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SA. Forme : Société par Actions Simplifiée. Sigle : AT-SA.
Adresse : 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
13/07/2011 |
Bodacc B |
Modification et mutation diverse |
|
92 -
HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NANTERRE 3147 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT
SAS. Activité : . |
|||
|
Hide |
06/07/2011 |
JAL |
Activity or goodwill cession |
|
Commercial du
Gard (Le)
|
|||
|
Hide |
25/11/2010 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
36 - INDRE GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CHÂTEAUROUX 554 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT
SAS. Adresse : 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
03/11/2010 |
Bodacc B |
Modification et mutation diverse |
|
92 -
HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 2109 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT
SAS. Administration : Président et membre du conseil de surveillance :
DEVEAUX Lucien Ernest Marie modification le 02 Août 2006 Vice président et
membre du conseil de surveillance : LECOMTE Jean-Francois modification le 18
Septembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : VIGNON Francois-Regis en
fonction le 23 Juillet 2003 Commissaire aux comptes titulaire : SA EXCO
FIDOGEST en fonction le 23 Juillet 2003 Membre du conseil de surveillance :
VON TSCHAMMER UND QUARITZ Carl Thibaud en fonction le 02 Août 2006 Président
du directoire : DEVEAUX Rodolphe modification le 18 Septembre 2009 Membre du
directoire : DEVEAUX Frédérique modification le 18 Septembre 2009 Membre du
conseil de surveillance : DUC Bernard en fonction le 18 Septembre 2009
Directeur général - membre du directoire : GERGELE René modification le 21
Septembre 2009. |
|||
|
Hide |
20/10/2010 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
36 - INDRE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂTEAUROUX 425 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT
SAS. Adresse : 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
07/09/2010 |
Bodacc C |
Comptes annuels et rapports |
|
92 -
HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 5704 - 380622332 RCS. ARMAND THIERY SAS.
Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 46 rue
Raspail 92593 Levallois Perret Cedex. Commentaires : Comptes annuels
et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009. |
|||
|
Hide |
27/08/2010 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
49 -
MAINE-ET-LOIRE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS 707 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT
SAS. Capital : 25140540 EUR. Adresse : 46 rue Raspail, 92593
Levallois-Perret Cedex. |
|||
|
Hide |
25/08/2010 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
49 -
MAINE-ET-LOIRE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS 529 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT
SAS. Adresse : 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret Cedex. |
|||
|
Hide |
12/08/2010 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
03 - ALLIER GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE MONTLUÇON 7 - 380 622 332 RCS Montluçon. ARMAND
THIERRY. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 25140540
EUR. Adresse : 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
23/07/2010 |
JAL |
Activity or goodwill cession |
|
ANGERS SEGRE
|
|||
|
Hide |
15/04/2010 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
64 -
PYRENEES-ATLANTIQUES GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE 1273 - Réctificatif. |
|||
|
Hide |
28/02/2010 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
64 -
PYRENEES-ATLANTIQUES GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE 1206 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERRY SA. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT-SA.
Adresse : 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
12/02/2010 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
13 -
BOUCHES-DU-RHONE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE 181 - 380 622 332 RCS Marseille. ARMAND
THIERY SA. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 25140540
EUR. Adresse : 46 rue de Raspail, 92593 Levallois Perret Cedex. |
|||
|
Hide |
08/02/2010 |
JAL |
Activity or goodwill cession |
|
MARSEILLE
L'HEBDO
|
|||
|
Hide |
26/11/2009 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
43 - HAUTE-LOIRE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY 785 - 380 622 332 RCS Le Puy-en-Velay. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT
SAS. Adresse : 46 rue Raspail, 92300 Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
09/10/2009 |
JAL |
Activity or goodwill cession |
|
DOCUMENTS LES
ACTUALITES PROFESSIONNELLES
|
|||
|
Hide |
29/09/2009 |
Bodacc B |
Modification et mutation diverse |
|
92 -
HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 1613 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT
SAS. Administration : Président et membre du conseil de surveillance :
DEVEAUX Lucien Ernest Marie modification le 02 Août 2006 Vice président et
membre du conseil de surveillance : LECOMTE Jean-Francois modification le 18
Septembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : VIGNON Francois-Regis en
fonction le 23 Juillet 2003 Commissaire aux comptes titulaire : SA EXCO
FIDOGEST en fonction le 23 Juillet 2003 Membre du conseil de surveillance :
VON TSCHAMMER UND QUARITZ Carl Thibaud en fonction le 02 Août 2006 Président
du directoire : DEVEAUX Rodolphe modification le 18 Septembre 2009 Membre du
directoire : DEVEAUX Frédérique modification le 18 Septembre 2009 Membre du
directoire : JACQUIER Ingrid modification le 09 Août 2006 Membre du conseil
de surveillance : DUC Bernard en fonction le 18 Septembre 2009 Directeur
général - membre du directoire : GERGELE France en fonction le 18 Septembre
2009. |
|||
|
Hide |
24/08/2009 |
Bodacc C |
Comptes annuels et rapports |
|
92 -
HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 6613 - 380622332 RCS. ARMAND THIERY SAS.
Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 46 rue
Raspail 92593 Levallois Perret Cedex. Commentaires : Comptes annuels
et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008. |
|||
|
Hide |
18/08/2009 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
87 -
HAUTE-VIENNE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES 624 - 380 622 332 RCS Nanterre. ARMAND
THIERY SAS. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : AT
SAS. Adresse : 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret. |
|||
|
Hide |
14/11/2008 |
Bodacc C |
Comptes annuels et rapports |
|
92 -
HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NANTERRE 8576 - 380622332 RCS. ARMAND THIERY SAS.
Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 46 rue
Raspail 92593 Levallois Perret Cedex. Commentaires : Comptes annuels
et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007. |
|||
|
Hide |
06/03/2008 |
Bodacc A |
Vente et cession : Acheteur |
|
13 -
BOUCHES-DU-RHONE GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE 254 - 380 622 332 RCS Marseille. ARMAND
THIERY SA. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 25140540
EUR. Adresse : 46 rue Raspail, 92593 Levallois Perret Cedex. |
|||
|
Hide |
26/10/2007 |
Bodacc C |
Avis de dépôt des comptes |
|
5353 - 380 622 332. RCS Nanterre ARMAND
THIERY SAS. Sigle: AT SAS Forme: Société par actions simplifiée. Adresse du
siège social: 46 rue Raspail 92593 Levallois Perret Cedex. Comptes annuels et
rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006. |
|||
|
Hide |
15/02/2007 |
Bodacc A |
Vente et cession |
|
1433 - RCS Nanterre 380 622 332. STE
ARMAND THIERY. Forme : S.A.S. Capital : 25 140 540 euros. Adresse du siège social
: 46 rue Raspail, 92300 Levallois-Perret. Etablissement principal - Activité
: vente au détail de prêt-à-porter féminin. Adresse : place Saint-Eusèbe et
20 rue du Temple (angle), 89300 Auxerre. Etablissement principal acquis par
achat au prix stipulé de 607 000 euros. Date d'effet : 1er août 2005.
Précédent propriétaire exploitant : STE STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER S.A.S. RCS
Bobigny 338 880 180. Publication légale : Les Terres de Bourgogne du 9
septembre 2005. Oppositions : au fonds pour la validité et Ordre des Avocats,
11 place Dauphine, 75001 Paris, pour la correspondance. |
|||
|
Hide |
21/11/2006 |
Bodacc C |
Avis de dépôt des comptes |
|
6367 - RCS Nanterre B 380 622 332. RC 96-B
130. ARMAND THIERY SAS. Forme: SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. Adresse du
siège social: 46, rue Raspail,92593 Levallois-Perret-Cedex. Comptes annuels
et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005. |
|||
|
Hide |
10/10/2006 |
Bodacc A |
Vente et cession |
|
0661 - RCS Créteil B 487 493 199. NEW LOOK
FRANCE. Forme : S.A.S. Capital : 37 000 euros. Adresse du siège social :
53-55 rue Hélène-Muller, 94320 Thiais. Etablissement secondaire - Activité :
vente d'équipements de la personne. Adresse : centre commercial Euralille,
59000 Lille. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 500
000 euros, à l'exclusion de tout autre droit et élément pouvant constituer le
fonds, notamment à l'exclusion formelle de l'enseigne, du nom commercial et
des marques. Date d'effet : 1er septembre 2006. Précédent propriétaire
exploitant : ARMAND THIERRY S.A.S. RCS Nanterre B 380 622 332. Publication
légale : La Gazette Nord-Pas de Calais du 14 septembre 2006. Oppositions :
S.C.P. Charlot et Graveline, 11 rue Bayard, 59000 Lille, pour la validité et
Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats, 11 place Dauphine, 75001 Paris,
pour la correspondance. |
|||
|
Hide |
25/08/2006 |
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
4547 - RCS Nanterre B 380 622 332. RC 96-B
130. ARMAND THIERY S.A.S. Sigle : AT SAS. Forme : S.A.S. Commentaires :
modification survenue sur l'administration. Administration : modification du
président et membre du conseil de surveillance : DEVEAUX (Lucien, Ernest,
Marie). Nomination de membres du conseil de surveillance : VON TSCHAMMER UN
QUARITZ (Carl, Thibaud) DEVEAUX (Rodolphe). Nomination d'un vice-président et
membre du conseil de surveillance : DEVAUX (Frédérique) (Nom d'usage : VON
TSCHAMMER UND QUARITZ). Nomination d'un membre du directoire : JACQUIER
(Ingrid). |
|||
|
Hide |
17/08/2006 |
Bodacc A |
Vente et cession |
|
0698 - RCS Nanterre 380 622 332. ARMAND
THIERY. Forme : S.A.S. Capital : 25 140 540 euros. Adresse du siège social : 46
rue Raspail, 92593 Levallois-Perret. Administration : président : LECOMTE
(Jean-François). Etablissement principal - Enseigne : Patrick Blum. Activité
: chemiserie. Adresse : 58 Grand'rue, 67500 Haguenau. Etablissement principal
acquis par achat au prix stipulé de 500 000 euros. Date d'effet : 1er juillet
2006. Précédent propriétaire : PATRICK BLUM S.A.S. RCS Strasbourg B 648 501
104. Publication légale : Les Affiches moniteur du 7 juillet 2006.
Oppositions : Me Ruhard, notaire, 48 rue du Général-Leclerc, 67540 Ostwald. |
|||
|
Hide |
22/11/2005 |
Bodacc C |
Avis de dépôt des comptes |
|
3409 - RCS Nanterre B 380 622 332. RC 96-B
130. ARMAND THIERY SAS. Forme: SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. Adresse du siège
social: 46, rue Raspail,92593 Levallois-Perret-Cedex. Comptes annuels et
rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004. |
|||
|
Hide |
08/11/2005 |
Bodacc A |
Vente et cession |
|
262 - RCS Nanterre B 380 622 332. ARMAND
THIERRY S.A.S. Sigle : AT SAS. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 46
rue Raspail, 92593 Levallois-Perret Cedex. Etablissement secondaire -
Activité : nouveautés, confection et tissu. Adresse : 52 rue Noël-Ballay,
28000 Chartres. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de
198 470 euros, en ce compris la clientièle, l'achalandage et le droit au
bail. Date de début d'activité : 15 septembre 2005. Précédent propriétaire :
GAULTIER-ROUZE (Liliane). RCS Chartres 302 808 175. Publication légale :
L'Echo de Brou du 11 octobre 2005. Oppositions : au fonds et Etude de Me
Bertin (Jacques), avocat, 38 boulevard Bonne-Nouvelle, 75010 Paris, pour la
correspondance. |
|||
|
Hide |
12/05/2005 |
Bodacc A |
Vente et cession |
|
528 - RCS B 380 622 332. A dater du : 23 février
1996. RC 96-B 126. ARMAND THIERY S.A.S. Sigle : AT-SA. Forme : S.A.S. Adresse
du siège social : 46 rue Raspail, 92300 Levallois-Perret. Etablissement
principal - Adresse : 49 rue Saint-Martin, 02000 Soissons. Etablissement
secondaire - Activité : vente de prêt-à-porter pour femmes. Adresse : centre
commercial Centre Deux, 42100 Saint-Etienne. Etablissement secondaire acquis
par achat au prix stipulé de 580 000 euros. Date de début d'activité : 1er
janvier 1995. Date d'effet : 20 mai 2005. Précédent propriétaire : BESSONS
S.A.S. RCS B 329 924 229. Publication légale : Les Petites affiches de la
Loire du 2 mai 2005. Oppositions : au fonds pour la validité et Me
Dumortier-Meynier (Isabelle), 9 place des Terres, 75017 Paris. |
|||
|
Hide |
16/01/2005 |
Bodacc C |
Avis de dépôt des comptes |
|
2164 - RCS Nanterre B 380 622 332. RC 96-B
130. ARMAND THIERY SAS. Forme: SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. Adresse du
siège social: 46, rue Raspail,92593 Levallois-Perret-Cedex. Comptes annuels et
rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2003. |
|||
|
Hide |
27/08/2004 |
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
RCS Annecy 380460212 RC 91-B 44 BALE.
Forme : S.A.R.L. Capital : 101 400 euros. Adresse du siège social : 36 rue Carnot,
74000 Annecy. Commentaires : dissolution de la société suite à la
transmission universelle du patrimoine à la STE ARMAND THIERRY S.A.S.,. RCS
Nanterre 380 622 332, 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret Cedex. Sur le
plan fiscal, la dissolution prendra effet au 1 e r juillet 2004. Date d'effet
: 14 mai 2004. |
|||
|
Hide |
12/03/2004 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380622332 ARMAND THIERY
S.A.S. Sigle : AT S.A.S. Forme : S.A. Adresse du siège social : 46 rue Raspail,
92593 Levallois-Perret Cedex Etablissement principal: Activité : droit au
bail. Adresse : passage du Cadran, 105 rue Nationale et 48 rue
Georges-Clemenceau, 49300 Cholet Droit au bail, dépendant de l'établissement
principal, acquis par achat au prix stipulé de 192 562 euros Date de début
d'activité: 1 e r février 2004. Précédent propriétaire : S.A.R.L. LE CADRAN.
RCS Angers 383048048 Publication légale: Le Courrier de l'Ouest du 13
décembre 2003. Oppositions : M e Lesbaudy, notaire, 28 avenue du Maréchal-Foch,
49300 Cholet. |
|||
|
Hide |
06/01/2004 |
Bodacc A |
Vente et cession |
|
RCS non encore inscrit. CAROLL
INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 8 513 251 euros. Adresse du siège social
: 38 rue du Hameau, 75015 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de
pret-à-porter et d'accessoires de mode masculins ou féminins. Adresse : 1 rue
Royale, 74000 Annecy Etablissement secondaire acquis par achat au prix
stipulé de 1 219 592 euros Date de début d'activité: 1 e r décembre 2003.
Précédent propriétaire : ARMAND THIERY S.A.S. RCS Nanterre 380622332
Publication légale: Eco des Pays de Savoie du 12 décembre 2003. Oppositions :
M e Naz (Jean-Marc), 43 rue Vaugelas, 74000 Annecy et M e Vincent Gérard, 29
avenue Georges- Mandel, 75016 Paris, pour la correspondance. |
|||
|
Hide |
03/08/2003 |
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
RCS Nanterre B 380622332 RC 96-B 130
ARMAND THIERY S.A.S. Sigle : AT SAS. Forme : S.A.S. Commentaires :
modification survenue sur l'administration. Administration : commissaire aux
comptes titulaire partant : CABINET A.C. UNION. Commissaire aux comptes
suppléant partant : FLEURY (Jean-Marc). Nomination d'un commissaire aux
comptes suppléant : VIGNON (François-Régis). Nomination d'un commissaire aux
comptes titulaire : S.A. EXCO FIDOGEST. |
|||
|
Hide |
23/02/2003 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Soissons B 380622332 A dater du: 11 février
2003 RC 03-B 24 ARMAND THIERY S. A.S. Forme : S.A.S. Adresse du siège social
: 46 rue Raspail, 92300 Levallois- Perret Etablissement principal: Activité :
droit au bail. Adresse : 49 rue Saint-Martin, 02000 Soissons Droit au bail,
dépendant de l'établissement principal, acquis par achat au prix stipulé de
376 592 euros Date de début d'activité: 1 e r mars 2003. Date d'effet : 17
janvier 2003. Précédent propriétaire : GENERALE CHAUSSURES S.A. RCS B
335780060 Publication légale: L' Aisne Nouvelle du 4 février 2002 et
rectificatif du 8 février 2002. Oppositions : au fonds pour la validité et
pour la correspondance, Générale Chaussures, Z.A.C. La Neuvillette, rue du
Docteur-Robert-Creuzat, 51100 Reims. |
|||
|
Hide |
11/09/2002 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS B 380622332 RC 96-B 406 ARMAND THIERY
S.A. Sigle : ATSA. Forme : S.A. à conseil d'administration. Adresse du siège
social : 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret Cedex ETABLISSEMENT
SECONDAIRE. Activité : vente de pret-à- porter féminin et d'accessoires de
mode s'y rapportant. Adresse : Grand Littoral n° 49, niveau II, 13015
Marseille Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 228
674 euros Date de début d'activité: 4 mars 2002. Précédent propriétaire :
PROMOD. RCS 685420606 Publication légale: Les Nouvelles publications du 27
mars 2002. Oppositions : au fonds. |
|||
|
Hide |
18/07/2002 |
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
RCS Nanterre B 380622332 RC 96-B 130 ARMAND
THIERY SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. Sigle : AT SAS. Forme : S.A.S.
Commentaires : modification survenue sur la dénomination et le sigle. |
|||
|
Hide |
09/07/2002 |
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
RCS Nanterre B 380622332 RC 96-B 130
ARMAND THIERY S.A. Sigle : ATSA. Forme : S. A.S. Commentaires : modification
survenue sur la forme juridique et l' administration. Administration :
modification d'un directeur général : DEVEAUX (Lucien, Ernest, Marie). Modification
du président : LECOMTE ( Jean-François). Administrateurs partants : STE
HOLDING DISTRIBUTION, représentée par EUVRARD (Erik) JACQUIER (Ingrid). |
|||
|
Hide |
18/12/2001 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
Rectificatif: Annonce numéro: 723 Date de
parution: 20 novembre 2001 Page: 46 Numéro de parution: 228 A Dans la mention
de la date d'effet, au lieu de : 1 e r février 2001 lire. RCS Nanterre
380622332 ARMAND THIERY Date de début d' activité: 1 e r février 2002. |
|||
|
Hide |
20/11/2001 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre 380622332 ARMAND THIERY.
Forme : S.A. Capital : 25 140 540 euros. Adresse du siège social : 46 rue
Raspail, 92593 Levallois-Perret. Administration : gérant : LECOMTE (Jean,
François) Etablissement principal: Activité : droit au bail. Adresse : 67
Grand-rue, 67500 Haguenau Droit au bail dépendant de l'établissement
principal acquis par achat au prix stipulé de 1 250 000 F. Date d'effet : 1 e
r février 2001. Précédent propriétaire : CHAUSSURES FLESCH S.A. RCS
Strasbourg B 778759621 Publication légale: Les Affiches moniteur du 26
octobre 2001. Oppositions : M e Ruhard, notaire, 48 rue du Général- Leclerc,
67540 Ostwald. |
|||
|
Hide |
26/10/2001 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre 380622332 ARMAND THIERY.
Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A Nom commercial: Armand Thiery. Adresse du siège
social : 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret Cedex ETABLISSEMENT
SECONDAIRE RC Alès 01-B 179. A dater du : 4 octobre 2001. Enseigne : Armand
Thiery. Activité : vente au détail d' articles d'habillement et
d'accessoires. Adresse : 4 rue Saint-Vincent, 30100 Alès Etablissement
secondaire acquis par achat au prix stipulé de 8 000 000 de F Date de début
d'activité: 18 septembre 2001. Précédent propriétaire : BUISSON Jean, Henri.
RCS 328397864 RC 83- B 97 Publication légale: Le Réveil du Midi du 21
septembre 2001. Oppositions : à l'attention de M e Arnal (Jean-Luc), avocat,
8 rue Eugène-Lisbonne, Montpellier et au fonds. |
|||
|
Hide |
21/09/2001 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre 380622332 ARMAND THIERY.
Forme : S.A. Capital : 164 856 000 F. Adresse du siège social : 46 rue Raspail,
92593 Levallois-Perret Etablissement principal: Adresse : 103 rue Anatole-
France, 69100 Villeurbanne Droit au bail, dépendant de l'établissement
principal, acquis par achat au prix stipulé de 1 000 000 de F. Date d'effet :
10 juillet 2001. Précédent propriétaire : GILPAT. RCS Lyon 412549933
Publication légale: Le Tout Lyon et le Moniteur judiciaire réunis du 30 aout
2001. Oppositions : Cabinet Céfidès, Le Britannia, batiment C, 20 boulevard
Eugène-Deruelle, 69003 Lyon. |
|||
|
Hide |
10/07/2001 |
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
RCS Nanterre B 380622332 RC 96-B 130
ARMAND THIERY S.A. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Capital : 25 140 540 euros.
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation). |
|||
|
Hide |
30/08/2000 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS B 380622332 A dater du: 11 aout 2000
RC 00-B 177 ARMAND THIERY S.A. Forme : S.A. à conseil d'administration.
Adresse du siège social : 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret Cedex ETABLISSEMENT
SECONDAIRE. Activité : vente au détail d'articles d' habillement et
d'accessoires. Adresse : 1 rue Charles-de-Gaulle, 42300 Roanne Etablissement
secondaire acquis par achat au prix stipulé de 1 450 000 F Date de début
d'activité: 1 e r juillet 2000. Précédent propriétaire : MOUSSERIN Bernard.
RCS A 312112535 Publication légale: Les Petites affiches de la Loire du 7
juillet 2000. Oppositions : M e Suchet, notaire, 5 rue Paul-Bert, 42300
Roanne. |
|||
|
Hide |
30/08/2000 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS B 380622332 A dater du: 11 aout 2000
RC 00-B 177 ARMAND THIERY S.A. Forme : S.A. à conseil d'administration.
Adresse du siège social : 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret Cedex ETABLISSEMENT
SECONDAIRE. Activité : vente au détail d'articles d' habillement et
d'accessoires. Adresse : 1 rue Charles-de-Gaulle, 42300 Roanne Etablissement
secondaire acquis par achat au prix stipulé de 700 000 F Date de début
d'activité: 1 e r juillet 2000. Date d'effet : 1 e r aout 2000. Précédent
propriétaire : S.A.R.L. CAROLE C. RCS B 353688385 Publication légale: Le Pays
roannais du 4 aout 2000. Oppositions : S. C.P. Matocq Vard, 18 rue Beaulieu,
B.P. 66, 42312 Roanne. |
|||
|
Hide |
25/07/2000 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 RC 96-B 130
ARMAND THIERY S.A. Forme : S.A. Capital : 164 856 000 F. Adresse du siège
social : 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret-. Administration :
président-directeur général : LE COMTE (Jean-François) Droit au bail
dépendant du fonds principal acquis par achat, au prix stipulé de 1 000 000
de F Etablissement principal: Activité : droit au bail. Adresse : 8 rue du
Commerce, 74100 Annemasse. Date d'effet : 30 juin 2000 Précédente propriétaire-exploitante
CYTISE DE J. TARANTOLA. RCS Thonon-les- Bains B 384 682 720 Publication
légale: Le Messager du 22 juin 2000. Oppositions : cabinet d'avocats
Mermet-Pauly et Baltazard, 2 rue Alfred-Bastin, 74100 Annemasse. |
|||
|
Hide |
18/06/2000 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS B 380622332 RC 00-B 74 ARMAND THIERY
S.A. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : 46 rue Raspail,
92593 Levallois-Perret Cedex Etablissement principal: Activité : fabrication,
commercialisation de tous produits à caractère industriel, de confection
masculine et féminine, vente en gros et au détail de vetements pour hommes et
femmes toutes opérations se rapportant, directement ou indirectement, aux
activités en rapport avec le textile et ses dérivés. Adresse : 18 rue de la
Résistance, 24100 Bergerac Etablissement principal acquis par achat au prix
stipulé de 4 000 000 de F Date de début d'activité: 28 avril 2000. Précédent
propriétaire : SADOVET. RCS B 326725702 Publication légale: Sud-Ouest du 5
mai 2000. Oppositions : S.C.P. Auzie Diligent-Jaros, 4 avenue Admirat, 46300
Gourdon. |
|||
|
Hide |
01/03/2000 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS B 380622332 RC 00-B 56 ARMAND THIERY S.A.
Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : 46 rue Raspail,
92593 Levallois-Perret Cedex ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de
pret-à-porter et de tous accessoires s'y rapportant. Adresse : 33 ter et 35
rue des Merciers et 3-5 rue Bujaud, 17000 La Rochelle Etablissement
secondaire acquis par achat au prix stipulé de 200 000 F Date de début d'
activité: 15 février 2000. Précédent propriétaire : BENGUIGUI Jean. RCS A
731770871 Publication légale: Sud-Ouest du 15 octobre 1999. Oppositions :
S.C.P. Legrain Delaroche et Miller Franiatte, huissier, 28 rue du Collège,
17000 La Rochelle. |
|||
|
Hide |
11/01/2000 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS B 380 622 332 RC 96-B 00128 ARMAND THIERRY
S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : 46 rue Raspail, 92593
Levallois-Perret cedex Fonds secondaire acquis par fusion au montant évalué à
868 820 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : fabrication, commercialisation
tous produits. Adresse : centre commercial Cap 3000, 06700
Saint-Laurent-du-Var. Date d'effet : 1er janvier 1999 Précédente propriétaire
SOCIETE LE HOME DU BAIN RC 83-B 121. |
|||
|
Hide |
17/08/1999 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 RC 96-B 107
ARMAND THIERY S.A. Forme : S.A. Capital : 164 856 000 F. Adresse du siège
social : 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret cedex Deux fonds acquis par
cession, au prix global stipulé de 4 300 000 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE.
Activité : vente au détail dans le domaine vestimentaires de pret-à-porter
masculin, féminin, pour enfants. Adresse : 18 rue Bossuet, 21000 Dijon
ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente au détail dans le domaine
vestimentaires de pret-à-porter masculin, féminin, pour enfants. Adresse : 20
rue Bossuet, 21000 Dijon. Date d'effet : 14 aout 1999 Précédente
propriétaire-exploitante DIFFUSION DU PRET-A-PORTER. RCS Troyes B 780 079 489
RC 74-B 137 Publication légale: Le Bien Public du 19 juillet 1999.
Oppositions : S.C.P. Laureau Cléon Mugneret, notaires associés, 23 rue
Jacques-Cellerier, 21000 Dijon. |
|||
|
Hide |
18/07/1999 |
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
RCS Nanterre B 380622332 RC 96-B 130 ARMAND
THIERY S.A. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Commentaires : modification
survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un
administrateur : JACQUIER (Ingrid). |
|||
|
Hide |
17/07/1999 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380622332 ARMAND THIERY.
Forme : S.A. Capital : 164 856 000 F. Adresse du siège social : 46 rue
Raspail, 92300 Levallois-Perret Etablissement principal: Activité : droit au
bail. Adresse : 11 rue Serviez, 64000 Pau Droit au bail acquis par achat au prix
stipulé de 530 000 F. Date d'effet : 1er septembre 1999. Précédent
propriétaire : BARTHELEMY Gérard. RCS non inscrit. FRICOU Anne-Marie. RCS non
inscrit. Publication légale: Les Petites affiches des Pyrénées-Atlantiques du
16 juin 1999. Oppositions : S.C.P. Madar et Danguy, avocats, 9 rue
Montpensier, Pau. |
|||
|
Hide |
19/06/1999 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre 380622332 ARMAND THIERY.
Forme : S.A. Capital : 164 856 000 F. Adresse du siège social : 46 rue Raspail,
92593 Levallois-Perret Cedex. Administration : gérant : LECOMTE (Jean-
François) ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de tous articles, de
produits se rapportant à la personne et à la maison. Adresse : 23-25 rue de
Genève, 73100 Aix-les-Bains Droit au bail pour le temps en restant à courir
dépendant de l'établissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de
600 000 F Date de début d'activité: 1er septembre 1999. Précédent
propriétaire : ROBERT PHILIPPE ET Cie. RCS Chambéry B 745520791 Publication
légale: La Maurienne du 28 mai 1999. Oppositions : au fonds. |
|||
|
Hide |
27/04/1999 |
Bodacc A |
Vente et cession |
|
RCS non encore inscrit ARMAND THIERY.
Forme : S.A. Capital : 164 856 000 F. Adresse du siège social : 46 rue Raspail
92593 Levallois-Perret Etablissement principal: Adresse : 46 rue Raspail
92593 Levallois-Perret ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Adresse : 94-98 cours Gimon
13300 Salon-de-Provence Droit au bail acquis par achat au prix stipulé de 1
600 000 F. Date d'effet : 1er avril 1999. Précédent propriétaire : VOLLMAR-
RIFFATERRE Christian. RCS Salon-de- Provence A 637 371 048 RC 76-A 291
Publication légale: Le Commercial du 2 avril 1999. Oppositions : Me Chaumard,
avocat, 85 boulevard de la République, 13300 Salon-de-Provence. |
|||
|
Hide |
14/11/1998 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 SOCIETE ARMAND
THIERY. Forme : S.A. Capital : 164 856 000 F. Adresse du siège social : 46 rue
Raspail 92 - Levallois-Perret Etablissement principal: Activité : pret-
à-porter féminin. Adresse : centre commercial régional Villeneuve 2 59 -
Villeneuve-d'Ascq Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de
800 000 F. Date d'effet : 1er novembre 1998. Précédent propriétaire : S. A.
GERARD PASQUIER PARIS. RCS Roubaix- Tourcoing B 408 213 502 Publication
légale: La Gazette de la région Nord Pas-de-Calais du 24 octobre 1998.
Oppositions : Etude de Me Corpechot, notaire associé, 93 rue Saint-Lazare,
75009 Paris pour la correspondance et en l'étude de Me Delommez, notaire, 6
rue Gallieni, B.P. 718, 59657 Villeneuve-d'Ascq pour la validité. |
|||
|
Hide |
27/10/1998 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 A dater du: 1er
octobre 1998 ARMAND THIERY S.A. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Adresse du
siège social : 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret cedex Fonds secondaire
acquis par achat, au prix stipulé de 5 800 000 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC
Annecy 98-B 503. Activité : pret-à-porter féminin. Adresse : 1 rue Royale, 2
rue Notre-Dame, 74000 Annecy Date de début d'activité: 1er octobre 1998
Précédente propriétaire-exploitante MONTANIER Adèle. RCS A 392 029 732 RC
93-A 311 Publication légale: L'Agriculteur normand du 2 octobre 1998.
Oppositions : étude Naz Barrucand Pacaud, 43 rue Vaugelas, Annecy. |
|||
|
Hide |
25/09/1998 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS *. RCS Bobigny B 380 622 332 ARMAND THIERY.
Forme : S.A. Capital : 164 856 000 F. Adresse du siège social : 46, rue
Raspail 92300 Levallois-Perret Etablissement principal: Activité : droit au
bail. Adresse : local commercial no 216, centre commercial régional de Rosny
2 93110 Rosny-sous-Bois Droit au bail acquis par cession au prix stipulé de 3
000 000 de F. Date d'effet : 2 aout 1998. Précédent propriétaire : : MARC
Allan Publication légale: Les Petites Affiches du 24 juin 1998. Oppositions :
séquestre juridique de l'ordre des avocats, 11, place Dauphine, 75053
Paris-Louvre et au fonds pour la validité. |
|||
|
Hide |
07/05/1998 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 A dater du: 20
février 1998 ARMAND THIERY S.A. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Nom
commercial: Armand Thierry. Adresse du siège social : 46 rue Raspail, 92593
Levallois-Perret cedex Fonds secondaire acquis par achat au prix stipulé de 5
400 000 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Metz 98-B 113. Enseigne : Armand
Thiery. Activité : magasin de vente au détail d' articles d'habillement.
Adresse : 7 En Chaplerue, 57000 Metz Date de début d' activité: 5 février
1998. Précédent propriétaire : MASDURAUD Claude. RCS 410 776 009 Publication
légale: Affiches Moniteur des Soumissions du 16 janvier 1998. Oppositions : étude
de Me Doyen, 11 rue Chatillon, 57000 Metz. |
|||
|
Hide |
12/03/1998 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 RC 98-B 37
ARMAND THIERY S.A. Sigle : A.T. Forme : S. A. Enseigne : Armand Thiery Nom commercial:
Armand Thiery. Adresse du siège social : 46 rue Raspail, 92593
Levallois-Perret cedex Fonds principal acquis par achat au prix stipulé de 1
750 000 F Etablissement principal: Activité : confection pour hommes, femmes
et accessoires, bonneterie , nouveautés. Adresse : 81 rue du Commerce, 41000
Blois. Date d'effet : 1er janvier 1998 Précédents propriétaires CHARDON Yves
CHARDON Francis. RCS non inscrits. Publication légale: La Renaissance du
Loir-et-Cher du 26 septembre 1997. Oppositions : Me Malard, notaire, Chemery,
41700 Contres. |
|||
|
Hide |
28/02/1998 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 ARMAND THIERRY.
Sigle : A.T. Forme : S.A. Capital : 164 856 000 F. Adresse du siège social : 46
rue Raspail 92300 Levallois-Perret Etablissement principal: Activité : vente
au détail d'habillement. Adresse : 46 rue Raspail 92300 Levallois-Perret
ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Adresse : 7 En Chaplerue 57000 Metz Etablissement
secondaire acquis par achat au prix stipulé de 5 400 000 F. Date d'effet : 2
février 1998. Précédent propriétaire : MASDURAUD Claude ,conjoint MUSA
(Hélène). RCS Metz A 410 776 009 RC 97-A 38 Publication légale: Les Affiches
moniteur des soumissions du 16 janvier 1998. Oppositions : Mes Doyen et
Mourer, 11 rue de Chatillon, 57000 Metz. |
|||
|
Hide |
11/01/1998 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 ARMAND THIERRY
S.A. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Capital : 164 856 000 F. Adresse du siège
social : 46 rue Raspail 92300 Levallois- Perret ETABLISSEMENT SECONDAIRE.
Activité : droit au bail des locaux dépendant d'un ensemble immobilier.
Adresse : 1 rue Notre-Dame 54000 Nancy Droit au bail acquis par achat au prix
stipulé de 500 000 F. Date d'effet : 2 janvier 1998. Précédent propriétaire :
SOCIETE COMMERCIALE D'ARTICLES POUR LA MAISON. RCS Nancy B 316 768 050
Publication légale: Les Tablettes lorraines du 21 novembre 1997. Oppositions
: Me Ducamp, 42 boulevard Malesherbes, 75008 Paris et chez Me Cuif, 2 place
A.-Maginot, 54000 Nancy pour la validité. |
|||
|
Hide |
16/08/1997 |
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 RC 96-B 130
ARMAND THIERY S.A. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Commentaires : modification
survenue sur l'administration. Administration : commissaire aux comptes
titulaire partant : CABINET MAZARS S.A. Nomination du commissaire aux comptes
titulaire : CABINET A.C. UNION. Commissaire aux comptes suppléant partant :
DE CAMBOURG (Patrick). Nomination du commissaire aux comptes suppléant :
FLEURY (Jean-Marc). |
|||
|
Hide |
05/08/1997 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS *. RCS Bobigny B 380 622 332 ARMAND
THIERY S.A. Forme : S.A. Capital : 164 856 000 F. Adresse du siège social : 46,
rue Raspail 92593 Levallois-Perret Etablissement principal: Activité : pret-
à-porter féminin et accessoires. Adresse : centre commercial Parinor 93606
Aulnay- sous-Bois Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de
3 100 000 F. Date d'effet : 8 juillet 1997. Précédent propriétaire : :
PROMOD. RCS RCS B 685 420 606 Publication légale: Petites Affiches du 11
juillet 1997. Oppositions : Me Jeulin Bernard, 10, avenue Jeanne-d'Arc, 93600
Aulnay-sous- Bois. |
|||
|
Hide |
10/07/1997 |
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 RC 96-B 130
ARMAND THIERY S.A. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Commentaires : modification
survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : SARFATTI
( Henri, Louis). |
|||
|
Hide |
07/05/1997 |
Bodacc A |
Vente et cession |
|
RCS non encore inscrite. ARMAND THIERRY
S.A. Forme : S.A. Capital : 164 856 000 F. Adresse du siège social : 46 rue Raspail,
92- Levallois-Perret Fonds principal acquis par achat au prix stipulé de 1
350 000 F Etablissement principal: Activité : confection hommes, dames ,
enfants, chemiserie, bonneterie. Adresse : 31 rue Franklin-Roosevelt, 49400
Saumur. Date d'effet : 8 janvier 1997 Précédente propriétaire-exploitante GO
PRET A PORTER G.OBADIA. RCS Saumur B 351 494 109 RC 89-B 128 Publication
légale: Le Courrier de l'Ouest du 19 février 1997. Oppositions : Me Jumel,
mandataire judiciaire liquidateur, 15 rue des Paiens, 49400 Saumur. |
|||
|
Hide |
28/11/1996 |
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
RCS *. RCS Nanterre B 380 622 332 RC RC
96-B 130 ARMAND THIERY S.A. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Administration : président
du conseil d'administration : LECOMTE (Jean-François) Directeur général et
administrateur : DEVEAUX ( Lucien, Ernest, Marie). Administrateurs : SARFATTI
(Henri, Louis) SOCIETE HOLDING DISTRIBUTION. Commissaire aux comptes
titulaire : CABINET MAZARS S.A. Commissaire aux comptes suppléant : DE
CAMBOURG ( Patrick). Commentaires : modification survenue sur
l'administration. |
|||
|
Hide |
10/09/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 SOCIETE ARMAND THIERY
S.A. Forme : S.A. Capital : 164 856 000 F. Adresse du siège social : 46 rue
Raspail, 92593 Levallois-Perret cedex. Administration : gérant : LECOMTE (
Jean-François) Fonds secondaire acquis par achat, au prix stipulé de 200 000
F ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : négoce de vetements pour hommes,
femmes et enfants. Adresse : lots 127, 128, 129 et 130, 228 avenue Alfred-
Motte, 59100 Roubaix. Date d'effet : 1er aout 1996 Précédente propriétaire
SOCIETE BIDERMANN EUROPE S.A. RCS Paris B 320 508 930 Publication légale: La
Gazette du 9 aout 1996. Oppositions : au siège social de la société Armand
Thiery. |
|||
|
Hide |
26/05/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 ARMAND THIERY S.A.
Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Capital : . Adresse du siège social : 46 rue
Raspail 92593 Levallois-Perret Cedex ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Nimes 96-B
189. Activité : vente au détail de vetements pour hommes, femmes et enfants ?
accessoires d'habillement. Adresse : 6 rue du Général-Perrier, B.P. 1275
30015 Nimes Etablissement secondaire acquis par apport-fusion au montant
évalué à 1 812 388 F Date de début d'activité: 1er janvier 1995. Précédent
propriétaire : SOCIETE DES MAGASINS ARMAND THIERY Publication légale: Les
Petites affiches du 8 janvier 1996. |
|||
|
Hide |
09/05/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 ARMAND THIERY.
Forme : S.A. Adresse du siège social : 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret
cedex Fonds secondaire acquis par apport, au montant évalué à 321 844 034 F
ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Avignon 96-B 112. Activité : magasin de vente au
détail d' articles d' habillement. Adresse : centre commercial Capsud, route
de Marseille, 84000 Avignon Date de début d'activité: 1er janvier 1995
Précédente propriétaire MAGASINS ARMAND THIERY SOMAT. RCS B 552 016 545
Publication légale: Les Petites Affiches du 8 janvier 1996 déclaration de
créances: au greffe du tribunal de commerce de Nanterre. |
|||
|
Hide |
09/05/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 ARMAND THIERY.
Forme : S.A. Adresse du siège social : 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret
cedex ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Avignon 96-B 112. Adresse : centre commercial
Capsud, route de Marseille, 84000 Avignon Fonds complémentaire acquis par
apport, au montant évalué à 321 844 034 F Etablissement Complémentaire.
Activité : fabrication et vente en France et dans tous pays, de vetements,
confection, draperies , nouveautés. Adresse : 42 cours Jean-Jaurès, 84000
Avignon. Date d'effet : 1er janvier 1995 Précédente propriétaire SOCIETE DES
MAGASINS ARMAND THIERY. RCS B 552 016 545 Publication légale: Les Petites
Affiches du 8 janvier 1996 déclaration de créances: au greffe du tribunal de
commerce de Nanterre. |
|||
|
Hide |
02/05/1996 |
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 ARMAND THIERY
S.A. Forme : S.A. Capital : . Adresse du siège social : 46 rue Raspail 95593 Levallois-Peret
Cedex ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Agen 96-B 38. Activité : vente au détail de
vetements, d' accessoires pour hommes, femmes et enfants. Adresse : 45-47
boulevard de la République 47000 Agen Etablissement secondaire acquis par
apport-fusion Date de début d'activité: 1er janvier 1995. |
|||
|
Hide |
26/04/1996 |
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
RCS *. RCS Nanterre B 380 622 332 RC RC
96-B 130 ARMAND THIERY S.A. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Administration : président
du conseil d'administration : LECOMTE (Jean-François) Administrateurs
SARFATTI (Henri, Louis) DEVEAUX ( Lucien, Ernest, Marie) SOCIETE HOLDING
DISTRIBUTION. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS S.A.
Commissaire aux comptes suppléant : DE CAMBOURG (Patrick). Commentaires :
modification survenue sur l' administration. |
|||
|
Hide |
17/04/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 A dater du: 13 mars
1996 ARMAND THIERY S.A. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Adresse du siège
social : 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret cedex Fonds secondaire acquis
par fusion-absorption au montant évalué à 321 844 034 F ETABLISSEMENT
SECONDAIRE RC Montpellier 96-B 321. Activité : industrie et commerce du
vetement , draperies, nouveautés, confections et accessoires, général,
confection achat, vente de tous articles et vetements. Adresse : 1 rue de la
Loge, B.P. 2158, 34207 Montpellier Date de début d'activité: 1er janvier 1995
Précédente propriétaire SOCIETE DES MAGASINS ARMAND THIERY SOMAT. RCS B 552
016 545 RC 71-B 117 Publication légale: Les Petites Affiches du 6 janvier
1996 déclaration de créances: au greffe du tribunal de commerce de Nanterre. |
|||
|
Hide |
16/04/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 A dater du: 7
mars 1996 ARMAND THIERY S.A. Forme : S. A. Adresse du siège social : 46 rue
Raspail, 92593 Levallois-Perret cedex Fonds secondaire acquis par apport au montant
global, évalué à 321 844 034 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC 96-B 107. Activité
: industrie et commerce en France et en tous pays du vetement , des
draperies, des nouveautés et confections et de tous articles et accessoires
se rattachant à l' habillement en général. Adresse : 15 place Darcy, 21000
Dijon Date de début d'activité: 1er janvier 1995 Précédente
propriétaire-exploitante S.A. SOCIETE DES MAGASINS ARMAND THIERY. RCS
Nanterre B 552 016 545 RC 71-B 66 Publication légale: Les Petites Affiches du
8 janvier 1996 déclaration de créances: au greffe du tribunal de commerce de
Nanterre. |
|||
|
Hide |
12/04/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS. RCS B 380 622 332 RC RC 96-B 265 ARMAND
THIERY S.A. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : 46, rue
Raspail 92593 Levallois-Perret cedex Fonds principal acquis par apport au
montant évalué à 321 844 034 F Etablissement principal: Activité :
fabrication et commercialisation de tous produits à caractère industriel et
notamment réalisation de confection masculine. Adresse : centre commercial
Les Trois-Fontaines 95003 Cergy- Pontoise Date de début d'activité: 1er
janvier 1995. Précédent propriétaire : : SOCIETE DES MAGASINS ARMAND THIERY
SOMAT. RCS RCS B 552 016 545 Publication légale: Les Petites Affiches du 8
janvier 1996. Oppositions : au fonds. |
|||
|
Hide |
11/04/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 ARMAND THIERRY
S.A. Forme : S.A. Capital : . Adresse du siège social : 46 rue Raspail 95593
Levallois-Perret Cedex ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Antibes 96-B 128. Activité
: vente au détail de vetements pour hommes, femmes et enfants, d' accessoires
d'habillement. Adresse : centre commercial Cap 3000 06700 Saint-
Laurent-du-Var Etablissement secondaire acquis par apport au montant évalué à
1 812 388 F Date de début d'activité: 1er janvier 1995. Précédent
propriétaire : SOCIETE DES MAGASINS ARMAND THIERRY- SOMAT. RCS B 552 016 545
RC 73-B 117 Publication légale: Les Petites affiches du 8 janvier 1996
déclaration de créances: au tribunal de commerce d' Antibes. |
|||
|
Hide |
09/04/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 RC 96-B 130 ARMAND
THIERY S.A. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : 46 rue
Raspail, 92593 Levallois-Perret cedex Fonds secondaire acquis par apport, au
montant évalué à 321 844 034 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Marseille 96-B
406. Activité : fabrication et commerce de vetements pour hommes femmes et
enfants et accessoires d' habillement. Adresse : 36-38 rue Saint- Ferreol,
13001 Marseille Date de début d'activité: 1er janvier 1995 Précédente
propriétaire SOCIETE DES MAGASINS ARMAND THIERY - SOMAT. RCS B 552 016 545 RC
71-B 505 Publication légale: Les Petites Affiches du 8 janvier 1996
déclaration de créances: au greffe du tribunal de commerce de Nanterre. |
|||
|
Hide |
06/04/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 ARMAND THIERY
S.A. Sigle : A.T.- S.A. Forme : S. A. Adresse du siège social : 46, rue
Raspail, 92300 Levallois-Perret ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC 96-B 18. Activité
: confection, vente d'articles et accessoires, vetements en tous genres.
Adresse : 13-15, rue Gambetta, 50100 Cherbourg Fonds secondaire acquis par
fusion-absorption au montant évalué à : 321 844 034 F. Date d'effet : 1er
janvier 1995 Précédente propriétaire SOCIETE DES MAGASINS ARMAND THIERY -
SOMAT. RCS B 552 016 545 RC 78-B 42 Publication légale: Les Petites Affiches
du 8 janvier 1996 déclaration de créances: au tribunal de commerce de
Cherbourg. |
|||
|
Hide |
04/04/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 ARMAND THIERY S.A.
Sigle : A.T.-S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : 46 rue Raspail,
92593 Levallois-Perret Fonds secondaire acquis par apport, au montant évalué
à 321 844 034 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Bayonne 96-B 116. Activité :
vente au détail d'habillement. Adresse : 4-6 rue Thiers, B.P. 8266, 64104
Bayonne Date de début d'activité: 1er janvier 1995 Précédente
propriétaire-exploitante SOMAT. RCS B 552 016 545 RC 73-B 76 Publication
légale: Les Petites Affiches du 8 janvier 1996 déclaration de créances: au greffe
du tribunal de commerce de Bayonne. |
|||
|
Hide |
04/04/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 RC 96-B 130
ARMAND THIERY S.A. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : 46
rue Raspail, 92593 Levallois-Perret Fonds secondaire acquis par apport
global, au montant évalué à 321 844 034 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Sens
96-B 24. Activité : commerce de tissus, confections en gros et détail, modes.
Adresse : 69 rue de la République, 89100 Sens. Date d'effet : 1er janvier
1995 Précédente propriétaire S.A. SOCIETE DES MAGASINS ARMAND THIERY - SOMAT.
RCS Sens B 552 016 545 RC 73-B 32 Publication légale: Les Petites Affiches du
8 janvier 1996 déclaration de créances: au greffe du tribunal de commerce de
Nanterre. |
|||
|
Hide |
03/04/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nice B 380 622 332 RC 96-B 216 ARMAND
THIERY S.A. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Capital : 164 856 000 F. Activité
: fabrication, commercialisation de tous produits à caractère industriel,
notamment la réalisation de confection masculine. Adresse du siège social :
46 rue Raspail, 92100 Levallois-Perret cedex Fonds secondaire acquis par
apport fusion au montant global évalué à 321 844 034 F ETABLISSEMENT
SECONDAIRE. Activité : commerce au détail de vetements , confection hommes,
femmes, enfants. Adresse : 37 avenue Jean-Médecin, 06000 Nice. Date d'effet :
1er janvier 1995 Précédente propriétaire SOCIETE DES MAGASINS ARMAND THIERY -
SOMAT. RCS B 552 016 545 Publication légale: Les Petites Affiches du 8
janvier 1996. |
|||
|
Hide |
29/03/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 ARMAND THIERRY
S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : 46 rue Raspail, 92593
Levallois-Perret Fonds secondaire acquis par fusion, au montant évalué à 321
844 034 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Romans 96-B 101. Activité : vente au
détail d'habillement. Adresse : 28 avenue Victor-Hugo, 26000 Valence Date de
début d'activité: 1er janvier 1996 Précédente propriétaire-exploitante
SOCIETE DES MAGASINS ARMAND THIERRY. RCS B 552 016 545 RC 73-B 104
Publication légale: Les Petites Affiches du 8 janvier 1996. |
|||
|
Hide |
29/03/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 ARMAND THIERY
S.A. Sigle : AT-SA. Forme : S.A. Adresse du siège social : 46 rue Raspail,
92593 Levallois-Perret cedex Fonds secondaire acquis par apport (actif net)
au montant évalué à 321 844 034 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Nancy 96-B
0083. Activité : vente de vetements et accessoires pour hommes, femmes et
enfants. Adresse : 2-4 rue Saint-Jean, 54000 Nancy Date de début d'activité:
1er janvier 1995 Précédente propriétaire S.A. SOCIETE DES MAGASINS ARMAND
THIERY. RCS B 552 016 545 RC 83-B 0262 Publication légale: Les Petites
Affiches du 8 janvier 1996 déclaration de créances: au greffe du tribunal de
commerce de Nanterre. |
|||
|
Hide |
27/03/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 ARMAND THIERY
S.A. Forme : S.A. Capital : . Adresse du siège social : 46 rue Raspail 92593
Levallois-Perret Cedex ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Nevers 96-B 31. Activité :
confection, achat et vente de vetements. Adresse : 67 rue du Commerce 58000
Nevers Etablissement secondaire acquis par apport au montant évalué à 321 844
034 F Date de début d'activité: 1er janvier 1995. Précédent propriétaire :
SOCIETE DES MAGASINS ARMAND THIERRY. RCS Nevers B 552 016 545 RC 71-B 40
Publication légale: Les Petites affiches du 8 janvier 1996 déclaration de
créances: au tribunal de commerce de Nevers. |
|||
|
Hide |
16/03/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 A dater du: 9 février
1996 ARMAND THIERRY S.A. Sigle : A.T.- S.A. Forme : S.A. Adresse du siège
social : 46, rue Raspail, 92300 Levallois-Perret ETABLISSEMENT SECONDAIRE
Toulouse B RC 96-B 285. Activité : industrie et commerce du vetement des
draperies, nouveautés, confections et accessoires en général. Adresse :
32-34, rue Alsace-Lorraine, B. P. 506, 31011 Toulouse Fonds secondaire acquis
par fusion-absorption au montant évalué à : 321 844 034 F. Date d'effet : 1er
janvier 1995 Précédente propriétaire SOCIETE DES MAGASINS ARMAND THIERY
SOMAT. RCS B 552 016 545 RC 73-B 233 Publication légale: Les Petites Affiches
du 8 janvier 1996. |
|||
|
Hide |
10/03/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS B 380 622 332 RC 96-B 210 ARMAND
THIERY S.A. Sigle : A.T. SA. Forme : S.A. Capital : . Adresse du siège social
: 46 rue Raspail 92593 Levallois-Perret Cedex Etablissement principal:
Adresse : place du Théatre, B.P. 5066 83000 Toulon. Activité : nouveautés,
confection Etablissement principal acquis par apport au montant évalué à 321
844 034 F Date de début d'activité: 1er janvier 1995. Précédent propriétaire
: SOCIETE DES MAGASINS ARMAND THIERY-SOMAT. RCS B 552 016 545 Publication
légale: Les Petites affiches du 8 janvier 1996. Oppositions : S.A. Armand
Thiery, 46 rue Raspail, 92593 Levallois-Perret Cedex. |
|||
|
Hide |
03/03/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 RC 96-B 130
ARMAND THIERY S.A. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Capital : 164 856 000 F. Adresse
du siège social : 46 rue Raspail 92593 Levallois-Perret Cedex Etablissement
principal: Adresse : 46 rue Raspail 92593 Levallois-Perret Cedex. Activité :
fabrication et commercialisation de tous produits à caractère industriel,
notamment réalisation de confection masculine et féminine vente en gros et au
détail de vetements pour hommes et femmes et généralement toutes opérations
se rapportant directement ou indirectement aux activités en rapport avec le
textiles et ses dérivés ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Adresse : centre commercial
Les Quatre Temps, casier n° 288 92092 Paris-La Défense Cedex 25. Activité :
magasin de confection pour hommes Etablissement secondaire acquis par apport
au montant global évalué à 321 844 034 F Date de début d'activité: 5 octobre
1990. Date d'effet : 1er janvier 1995. Précédent propriétaire : SOCIETE DES
MAGASINS ARMAND THIERY SOMAT. RCS B 552 016 545 Publication légale: Les
Petites affiches du 8 janvier 1996. Oppositions : au tribunal de commerce de
Nanterre. |
|||
|
Hide |
22/02/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS *. RCS Corbeil B 380 622 332 RC RC
96-B 331 ARMAND THIERY S.A. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Adresse du siège
social : 46, rue Raspail 92593 Levallois-Perret cedex ETABLISSEMENT
SECONDAIRE. Activité : magasin de vente au détail d'articles d' habillement.
Adresse : centre commercial régional Evry 2, C.E. Nationale 110 91022 Evry
cedex Etablissement secondaire acquis par apport au montant évalué à 321 844
034 F Date de début d' activité: 1er janvier 1995. Précédent propriétaire : :
SOCIETE DES MAGASINS ARMAND THIERY - SOMAT. RCS RCS B 552 016 545 Publication
légale: Les Petites Affiches du 8 janvier 1996 déclaration de créances: au
greffe du tribunal de commerce de Nanterre. |
|||
|
Hide |
22/02/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS *. RCS Bobigny B 380 622 332 RC RC
96-B 516 ARMAND THIERY. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Capital : 164 856 000
F. Adresse du siège social : 46, rue Raspail 92593 Levallois-Perret cedex
Etablissement principal: Activité : magasin de confection pour hommes.
Adresse : centre commercial Rosny Boutique, 208, avenue Général-de-Gaulle
93117 Rosny-sous-Bois ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : magasin de vente
au détail d'articles d'habillement. Adresse : Arcades no 176 93193 Noisy-le-
Grand cedex Etablissement secondaire acquis par apport au montant évalué à
321 844 034 F Date de début d'activité: 1er janvier 1995. Précédent
propriétaire : SOCIETE DES MAGASINS ARMAND THIERY - SOMAT. RCS RCS B 552 016
545 Publication légale: Les Petites Affiches du 8 janvier 1996 déclaration de
créances: au greffe du tribunal de commerce de Bobigny. |
|||
|
Hide |
22/02/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS *. RCS Bobigny B 380 622 332 RC RC 96-B
516 ARMAND THIERY. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social :
46, rue Raspail 92593 Levallois-Perret cedex Etablissement principal:
Activité : magasin de confection pour hommes. Adresse : centre commercial
Rosny, Boutique 208, avenue Général-de-Gaulle 93117 Rosny-sous-Bois
Etablissement principal acquis par apport au montant évalué à 321 844 034 F
Date de début d' activité: 1er janvier 1995. Précédent propriétaire : :
SOCIETE DES MAGASINS ARMAND THIERY. RCS RCS B 552 016 545 Publication légale:
Les Petites Affiches du 8 janvier 1996 déclaration de créances: au greffe du
tribunal de commerce de Bobigny. |
|||
|
Hide |
28/01/1996 |
Bodacc A |
Création d'établissement |
|
RCS Nanterre B 380 622 332 RC 96-B 130
ARMAND THIERY S.A. Sigle : A.T. S.A. Forme : S.A. Capital : 164 856 000 F.
Activité : fabrication et commercialisation de tous produits à caractère
industriel notamment réalisation de confection masculine et féminine. Vente
en gros et au détail de vetements pour hommes et femmes. Généralement toutes
opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités en
rapport avec le textile et ses dérivés. Adresse du siège social : 46 rue
Raspail 92593 Levallois-Perret Cedex. Administration : président du conseil
d'administration : LECOMTE (Jean-François). Administrateurs : BOUCHEZ
(Dominique, Etienne, Louis, Marie, Joseph) SARFATTI (Henri, Louis) DEVEAUX (
Lucien, Ernest, Marie). Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS
S.A. Commissaire aux comptes suppléant : DE CAMBOURG (Patrick) Fonds acquis
par apport au montant évalué à 321 844 034 F. Commentaires : cette société
transfère son siège du 114 rue de Turenne, 75003 Paris. Ancien RC : 91-B 1205
Date de début d'activité: 5 octobre 1990. Date d'effet : 1er janvier 1995.
Précédent propriétaire : SOCIETE DES MAGASINS ARMAND THIERY-SOMAT. RCS B 552
016 545 Publication légale: Les Petites affiches du 8 janvier 1996
déclaration de créances: au tribunal de commerce de Nanterre. |
|||
|
Hide |
26/10/1995 |
Bodacc B |
Modifications et mutations diverses |
|
RCS *. RCS Paris B 380 622 332 RC RC 91- B
1205 TURENNE S.A. Sigle : T.S.A. Forme : S.A. Administration :
président-directeur général : BOUCHEZ (Dominique, Etienne, Louis, Marie,
Joseph) Administrateurs : SARFATTI (Henri, Louis) DEVEAUX ( Lucien, Ernest,
Marie). Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS S.A. Commissaire
aux comptes suppléant : DE CAMBOURG (Patrick). Commentaires : modification
survenue sur l' administration. |
|||
|
Date |
Description |
|
28/05/2015 |
Update Limit |
|
28/05/2015 |
Update Rating |
|
13/05/2015 |
Update Limit |
|
13/05/2015 |
Update Rating |
|
11/03/2015 |
Update Limit |
|
11/03/2015 |
Update Rating |
|
24/02/2015 |
Payment incident detected |
|
27/11/2014 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
28/10/2014 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
01/10/2014 |
Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Seller |
|
30/09/2014 |
Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer |
|
24/08/2014 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
16/08/2014 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
07/08/2014 |
Update Limit |
|
07/08/2014 |
Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of
this company's creditworthiness |
|
28/07/2014 |
Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer |
|
11/04/2014 |
Legal Gazette: Start of rent-management |
|
02/04/2014 |
Invalid balance sheet |
|
20/02/2014 |
Update Rating |
|
20/02/2014 |
Update Limit |
|
31/12/2013 |
New accounts available |
|
06/12/2013 |
Update Rating |
|
06/12/2013 |
Update Limit |
|
21/11/2013 |
Payment incident detected |
|
15/10/2013 |
Update Rating |
|
15/10/2013 |
Update Limit |
|
06/09/2013 |
New subsidiarie(s) detected |
|
16/08/2013 |
Formation of Establishment |
|
02/08/2013 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
01/08/2013 |
Legal Gazette: Start of rent-management |
|
18/07/2013 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
28/06/2013 |
Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer |
|
07/06/2013 |
Disengagement in other companies |
|
29/11/2012 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
29/11/2012 |
Updated articles of association |
|
18/11/2012 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
12/11/2012 |
Formation of Establishment |
|
06/11/2012 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
24/10/2012 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
18/10/2012 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
15/10/2012 |
Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer |
|
01/10/2012 |
Legal Gazette: Activity or goodwill cession |
|
01/10/2012 |
Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer |
|
25/08/2012 |
Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of
this company's creditworthiness |
|
23/08/2012 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
22/08/2012 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
26/07/2012 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
24/07/2012 |
Legal Gazette: Activity or goodwill cession |
|
11/07/2012 |
Bodacc B: Various editing or changing |
|
08/07/2012 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
03/07/2012 |
Appointment/resignation of company officers |
|
03/07/2012 |
Amendment |
|
29/06/2012 |
Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative |
|
26/06/2012 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
07/06/2012 |
Legal Gazette: Activity or goodwill cession |
|
31/05/2012 |
Legal Gazette: Appointment of the social representative |
|
24/04/2012 |
Legal Gazette: Activity or goodwill cession |
|
20/03/2012 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
16/03/2012 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
04/03/2012 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
02/03/2012 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
01/02/2012 |
Legal Gazette: Activity or goodwill cession |
|
31/01/2012 |
Legal Gazette: Activity or goodwill cession |
|
31/12/2011 |
New accounts available |
|
11/12/2011 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
01/12/2011 |
Formation of Establishment |
|
02/11/2011 |
Other modification of Establishment |
|
02/11/2011 |
Update of Company Workforce |
|
02/11/2011 |
Formation of Establishment |
|
14/10/2011 |
Legal Gazette: Activity or goodwill cession |
|
02/08/2011 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
18/07/2011 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
13/07/2011 |
Bodacc B: Various editing or changing |
|
05/07/2011 |
Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial
Court |
|
05/07/2011 |
Amendment |
|
05/07/2011 |
Updated articles of association |
|
04/07/2011 |
Update of Company Head Office Identifier |
|
04/07/2011 |
Transfer of Establishment |
|
01/07/2011 |
Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of
this company's creditworthiness |
|
01/07/2011 |
Legal Gazette: Activity or goodwill cession |
|
02/05/2011 |
Formation of Establishment |
|
02/05/2011 |
Modification to Establishment Address or Identifier |
|
31/12/2010 |
New accounts available |
|
25/11/2010 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
03/11/2010 |
Bodacc B: Various editing or changing |
|
25/10/2010 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
25/10/2010 |
Appointment/resignation of company officers |
|
25/10/2010 |
Amendment |
|
20/10/2010 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
07/09/2010 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
27/08/2010 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
25/08/2010 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
13/08/2010 |
New subsidiarie(s) detected |
|
13/08/2010 |
New ultimate parent |
|
13/08/2010 |
New parent detected |
|
12/08/2010 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
05/08/2010 |
Updated articles of association |
|
05/08/2010 |
Amendment |
|
27/07/2010 |
Updated articles of association |
|
27/07/2010 |
Appointment/resignation of company officers |
|
27/07/2010 |
Amendment |
|
26/07/2010 |
Updated articles of association |
|
26/07/2010 |
Amendment |
|
15/07/2010 |
Legal Gazette: Activity or goodwill cession |
|
15/04/2010 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
28/02/2010 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
12/02/2010 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
08/02/2010 |
Legal Gazette: Activity or goodwill cession |
|
31/12/2009 |
New accounts available |
|
26/11/2009 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
09/10/2009 |
Legal Gazette: Activity or goodwill cession |
|
29/09/2009 |
Bodacc B: Various editing or changing |
|
18/09/2009 |
New chairman (CEO, CoB) |
|
18/09/2009 |
Changes to the Board of Directors |
|
18/09/2009 |
Appointment/resignation of company officers |
|
18/09/2009 |
Amendment |
|
18/09/2009 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
24/08/2009 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
18/08/2009 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
31/12/2008 |
New accounts available |
|
14/11/2008 |
Bodacc C : Deposit accounts notice |
|
02/04/2008 |
Preferential right lapsed |
|
14/03/2008 |
New Filling of Tax Office preferential right |
|
06/03/2008 |
Bodacc A : Sale and transfer |
|
06/03/2008 |
New Bodacc A ads detected |
|
03/03/2008 |
Unfiling of a Tax Office preferential right |
|
04/02/2008 |
Collection of preferential rights activated for this company |
|
31/12/2007 |
New accounts available |
|
31/12/2006 |
New accounts available |
|
02/08/2006 |
Amendment |
|
02/08/2006 |
Appointment/resignation of company officers |
|
02/08/2006 |
Change to the administration of a public limited company |
|
02/08/2006 |
Private document |
|
02/08/2006 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
31/12/2005 |
New accounts available |
|
31/12/2004 |
New accounts available |
|
31/12/2003 |
New accounts available |
|
23/07/2003 |
Private document |
|
23/07/2003 |
New auditor |
|
23/07/2003 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
23/07/2003 |
Appointment/resignation of company officers |
|
23/07/2003 |
Amendment |
|
26/06/2002 |
Changes to the Board of Directors |
|
26/06/2002 |
Updated articles of association |
|
26/06/2002 |
Private document |
|
26/06/2002 |
New legal form – no new category |
|
26/06/2002 |
New legal form – new category |
|
26/06/2002 |
New chairman (CEO, CoB) |
|
26/06/2002 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
26/06/2002 |
Appointment/resignation of company officers |
|
07/05/2002 |
New legal form – new category |
|
07/05/2002 |
Audit or Management Report |
|
07/05/2002 |
Private document |
|
19/10/2001 |
Merger |
|
19/10/2001 |
Declaration of conformity |
|
19/10/2001 |
Amendment |
|
19/10/2001 |
Minutes of Board meeting |
|
19/10/2001 |
Updated articles of association |
|
19/10/2001 |
Private document |
|
19/10/2001 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
13/09/2001 |
Private document |
|
13/09/2001 |
Audit or Management Report |
|
12/07/2001 |
Private document |
|
12/07/2001 |
Planned merger |
|
25/06/2001 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
25/06/2001 |
Updated articles of association |
|
25/06/2001 |
Private document |
|
25/06/2001 |
Conversion of equity to euro |
|
25/06/2001 |
Capital increase |
|
08/06/2001 |
Appointment/resignation of company officers |
|
08/06/2001 |
Application and court order |
|
08/06/2001 |
Amendment |
|
13/09/1999 |
Declaration of conformity |
|
13/09/1999 |
Private document |
|
13/09/1999 |
Amendment |
|
13/09/1999 |
Updated articles of association |
|
13/09/1999 |
Merger |
|
13/09/1999 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
15/07/1999 |
Private document |
|
15/07/1999 |
Audit or Management Report |
|
02/07/1999 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
02/07/1999 |
Private document |
|
02/07/1999 |
Appointment/resignation of company officers |
|
02/07/1999 |
Changes to the Board of Directors |
|
28/06/1999 |
Planned merger |
|
28/06/1999 |
Private document |
|
19/05/1999 |
Application and court order |
|
19/05/1999 |
Appointment/resignation of company officers |
|
19/05/1999 |
Amendment |
|
25/02/1999 |
Appointment/resignation of company officers |
|
25/02/1999 |
Application and court order |
|
29/07/1997 |
New auditor |
|
29/07/1997 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
29/07/1997 |
Appointment/resignation of company officers |
|
29/07/1997 |
Private document |
|
24/06/1997 |
Amendment |
|
24/06/1997 |
Appointment/resignation of company officers |
|
24/06/1997 |
Changes to the Board of Directors |
|
24/06/1997 |
Private document |
|
24/06/1997 |
Minutes of Board meeting |
|
09/11/1996 |
Minutes of Board meeting |
|
09/11/1996 |
Appointment/resignation of company officers |
|
09/11/1996 |
Amendment |
|
09/11/1996 |
Private document |
|
10/04/1996 |
Minutes of Board meeting |
|
10/04/1996 |
Changes to the Board of Directors |
|
10/04/1996 |
Appointment/resignation of company officers |
|
10/04/1996 |
Amendment |
|
12/01/1996 |
Merger |
|
12/01/1996 |
Updated articles of association |
|
12/01/1996 |
Registration after transfer |
|
12/01/1996 |
Private document |
|
12/01/1996 |
New company name |
|
12/01/1996 |
New chairman (CEO, CoB) |
|
12/01/1996 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
12/01/1996 |
Minutes of Board meeting |
|
12/01/1996 |
Declaration of conformity |
|
12/01/1996 |
Articles of association |
|
12/01/1996 |
Appointment/resignation of company officers |
|
10/01/1996 |
Appointment/resignation of company officers |
|
10/01/1996 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
10/01/1996 |
Changes to the Board of Directors |
|
10/01/1996 |
Registered office transferred outside jurisdiction of the Commercial
Court |
|
10/01/1996 |
Amendment |
|
10/01/1996 |
New company name |
|
18/12/1995 |
Amendment |
|
18/12/1995 |
Audit or Management Report |
|
23/11/1995 |
Planned merger |
|
23/11/1995 |
Amendment |
|
23/11/1995 |
Private document |
|
10/10/1995 |
Amendment |
|
10/10/1995 |
Changes to the Board of Directors |
|
10/10/1995 |
Minutes of Board meeting |
|
10/10/1995 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
10/10/1995 |
Appointment/resignation of company officers |
|
09/10/1995 |
Application and court order |
|
30/12/1993 |
Amendment |
|
30/12/1993 |
Minutes of Board meeting |
|
30/12/1993 |
Changes to the Board of Directors |
|
02/03/1993 |
Amendment |
|
02/03/1993 |
Fund deposit certificate |
|
02/03/1993 |
Capital increase |
|
02/03/1993 |
Declaration of conformity |
|
02/03/1993 |
Updated articles of association |
|
02/03/1993 |
Minutes of general meeting of shareholders |
|
02/03/1993 |
Minutes of Board meeting |
Annual Accounts
|
31/12/2013 |
31/12/2011 |
31/12/2010 |
||||
|
Account period (month) |
12 |
12 |
12 |
|||
|
Account Type |
Normal |
Normal |
Normal |
|||
|
Date of capture |
06/08/2014 |
24/08/2012 |
30/06/2011 |
|||
|
Activity Code |
4771Z |
4771Z |
4771Z |
|||
|
Employees |
2384 |
2228 |
2227 |
Active account
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
Sector Median 2013 |
||
|
Capital not called |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0 |
0% |
|
Total fixed assets |
177,180,644 |
3.2 % |
171,667,204 |
0.1 % |
171,554,139 |
76,920 |
230245.5 % |
|
Intangible assets |
85,089,607 |
5.5 % |
80,685,583 |
1.2 % |
79,738,170 |
41,346 |
205698.9 % |
|
Tangible assets |
67,571,916 |
-3.0 % |
69,647,059 |
-1.1 % |
70,429,453 |
10,616 |
636440.1 % |
|
Financial assets |
24,519,119 |
14.9 % |
21,334,560 |
-0.2 % |
21,386,516 |
1,765 |
1389085.2 % |
|
Net current assets |
130,112,074 |
25.0 % |
104,070,911 |
-5.1 % |
109,611,579 |
91,636 |
141888.7 % |
|
Stocks |
51,632,919 |
22.6 % |
42,100,781 |
4.1 % |
40,434,837 |
40,283 |
128075.5 % |
|
Advanced payments |
66,310 |
1308.8 % |
4,707 |
-88.0 % |
39,097 |
0 |
0% |
|
Receivables |
41,259,879 |
-4.9 % |
43,370,438 |
33.9 % |
32,384,589 |
8,519 |
484227.7 % |
|
Securities and cash |
37,152,963 |
99.8 % |
18,594,980 |
-49.4 % |
36,753,052 |
14,034 |
264635.4 % |
|
Prepaid expenses |
- |
- |
- |
- |
- |
356 |
- |
|
Accounts of regularization |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0 |
0% |
|
Total Assets |
307,292,718 |
11.4 % |
275,738,115 |
-1.9 % |
281,165,719 |
191,044 |
160749.2 % |
Passive Account
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
Sector Median 2013 |
||
|
Shareholders' equity |
230,443,723 |
10.8 % |
207,918,442 |
5.0 % |
198,074,668 |
41,620 |
553591.7 % |
|
Share capital |
25,140,540 |
0% |
25,140,540 |
0% |
25,140,540 |
8,000 |
314156.8 % |
|
Other capital resources |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0 |
0% |
|
Risk Provisions |
2,954,282 |
-11.4 % |
3,332,812 |
30.1 % |
2,562,425 |
0 |
0% |
|
Liabilities |
73,894,713 |
14.6 % |
64,486,856 |
-19.9 % |
80,528,625 |
125,132 |
58953.4 % |
|
Financial liabilities |
6,231,215 |
-48.4 % |
12,068,020 |
26.4 % |
9,550,340 |
41,033 |
15085.9 % |
|
Advanced payments received |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0 |
0% |
|
Trade account payables |
36,800,338 |
66.7 % |
22,079,391 |
-8.6 % |
24,157,147 |
24,127 |
152430.8 % |
|
Tax and social liabilities |
24,341,480 |
1.3 % |
24,040,246 |
-40.8 % |
40,629,458 |
20,021 |
121479.7 % |
|
Other debts and fixed assets liabilities |
3,038,697 |
1.1 % |
3,005,966 |
-7.0 % |
3,231,673 |
5,176 |
58613.1 % |
|
Account regularization |
3,482,980 |
5.8 % |
3,293,231 |
11.3 % |
2,960,007 |
0 |
0% |
|
Total liabilities |
307,292,718 |
11.4 % |
275,738,114 |
-1.9 % |
281,165,719 |
191,045 |
160748.3 % |
Results
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
Sector Median 2013 |
||
|
Sales of Goods |
424,534,999 |
1.5 % |
418,351,217 |
1.2 % |
413,465,877 |
235,963 |
179815.9 % |
|
Net turnover |
419,512,489 |
1.0 % |
415,546,166 |
1.7 % |
408,616,122 |
231,756 |
180914.7 % |
|
of which net export turnover |
5,741,997 |
-0.6 % |
5,777,453 |
0% |
0 |
0 |
0% |
|
Operating charges |
382,723,317 |
5.4 % |
363,026,396 |
4.3 % |
348,136,785 |
231,993 |
164872.3 % |
|
Operating profit/loss |
41,811,682 |
-24.4 % |
55,324,821 |
-15.3 % |
65,329,092 |
4,475 |
934343.7 % |
|
Financial income |
3,073,869 |
0.0 % |
3,074,054 |
-13.9 % |
3,569,472 |
0 |
0% |
|
Financial charges |
222,543 |
61.7 % |
137,608 |
-10.6 % |
153,875 |
1,295 |
17084.8 % |
|
Financial profit/loss |
2,851,325 |
-2.9 % |
2,936,446 |
-14.0 % |
3,415,597 |
-914 |
312231.9 % |
|
Pretax net operating income |
44,663,008 |
-23.3 % |
58,261,267 |
-15.2 % |
68,744,689 |
2,859 |
1562363.1 % |
|
Extraordinary income |
9,402,291 |
82.1 % |
5,164,444 |
-83.1 % |
30,631,915 |
0 |
0% |
|
Extraordinary charges |
8,473,778 |
21.2 % |
6,989,426 |
21.5 % |
5,753,962 |
63 |
13450341.3 % |
|
Extraordinary profit/loss |
928,513 |
150.9 % |
-1,824,982 |
-107.3 % |
24,877,953 |
0 |
0% |
|
Net result |
27,429,187 |
-21.0 % |
34,731,950 |
-36.3 % |
54,523,440 |
2,985 |
918800.7 % |
Normal Account
|
31/12/2013 |
31/12/2011 |
31/12/2010 |
|||
|
Months |
12 |
12 |
12 |
Grand Total - Active Accounts (I to VI)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Grand Total (I to VI) |
Net |
307,292,718 |
11.4 % |
275,738,115 |
-1.9 % |
281,165,719 |
|
Gross |
CO |
471,582,340 |
14.1 % |
413,475,206 |
2.0 % |
405,475,146 |
|
Amortisation |
1A |
164,289,621 |
19.3 % |
137,737,091 |
10.8 % |
124,309,427 |
Non declared distributed capital (I)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Non declared distributed capital (I) |
AA3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Gross |
AA |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Active fixed asset (II)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Total Active fixed asset (II) |
Net |
177,180,644 |
3.2 % |
171,667,204 |
0.1 % |
171,554,139 |
|
Gross |
BJ |
338,959,636 |
10.2 % |
307,485,071 |
4.5 % |
294,115,926 |
|
Amortisation |
BK |
161,778,992 |
19.1 % |
135,817,867 |
10.8 % |
122,561,787 |
Intangible fixed assets
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Start-up cost |
Net |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Gross |
AB |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Amortisation |
AC |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
R&D expenses |
Net |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Gross |
CX |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Amortisation |
AE |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Distributorships, patents |
Net |
2,584,641 |
16.7 % |
2,213,952 |
-4.9 % |
2,327,173 |
|
Gross |
AF |
13,615,923 |
8.0 % |
12,607,770 |
9.3 % |
11,538,185 |
|
Amortisation |
AG |
11,031,282 |
6.1 % |
10,393,818 |
12.8 % |
9,211,012 |
|
Goodwill |
Net |
82,308,217 |
6.4 % |
77,354,997 |
0.8 % |
76,745,487 |
|
Gross |
AH |
82,308,217 |
6.4 % |
77,354,997 |
0.8 % |
76,745,487 |
|
Amortisation |
AI |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Other intangible fixed assets |
Net |
196,749 |
-82.4 % |
1,116,634 |
67.8 % |
665,510 |
|
Gross |
AJ |
196,749 |
-82.4 % |
1,116,634 |
67.8 % |
665,510 |
|
Amortisation |
AK |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Pre-payments and downpayments |
Net |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Gross |
AL |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Amortisation |
AM |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Sub Total Intangible asset |
Net |
85,089,607 |
5.5 % |
80,685,583 |
1.2 % |
79,738,170 |
Tangilble fixed assets
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Lands |
Net |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Gross |
AN |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Amortisation |
AO |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Buildings |
Net |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Gross |
AP |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Amortisation |
AQ |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Plant |
Net |
10,680,586 |
-19.8 % |
13,321,591 |
-9.7 % |
14,750,549 |
|
Gross |
AR |
56,854,540 |
6.7 % |
53,274,999 |
4.8 % |
50,848,716 |
|
Amortisation |
AS |
46,173,954 |
15.6 % |
39,953,408 |
10.7 % |
36,098,167 |
|
Other tangible fixed assets |
Net |
56,432,074 |
0.4 % |
56,192,768 |
2.7 % |
54,715,077 |
|
Gross |
AT |
161,005,829 |
13.7 % |
141,663,409 |
7.3 % |
131,967,685 |
|
Amortisation |
AU |
104,573,754 |
22.4 % |
85,470,641 |
10.6 % |
77,252,608 |
|
Fixed assets in construction |
Net |
459,256 |
246.1 % |
132,700 |
-86.2 % |
963,827 |
|
Gross |
AV |
459,256 |
246.1 % |
132,700 |
-86.2 % |
963,827 |
|
Amortisation |
AW |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Advances and payments on account |
Net |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Gross |
AX |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Amortisation |
AY |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Sub Total Tangible asset |
Net |
67,571,916 |
-3.0 % |
69,647,059 |
-1.1 % |
70,429,453 |
Financial assets
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Associates at equity |
Net |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Gross |
CS |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Amortisation |
CT |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Other participations |
Net |
788,633 |
0% |
788,633 |
-26.6 % |
1,073,715 |
|
Gross |
CU |
788,633 |
0% |
788,633 |
-26.6 % |
1,073,715 |
|
Amortisation |
CV |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Inter-company receivables |
Net |
4,911,669 |
67.0 % |
2,941,136 |
0.3 % |
2,933,640 |
|
Gross |
BB |
4,911,669 |
67.0 % |
2,941,136 |
0.3 % |
2,933,640 |
|
Amortisation |
BC |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Other investment securities |
Net |
5,746,945 |
0% |
5,746,945 |
0.0 % |
5,746,845 |
|
Gross |
BD |
5,746,945 |
0% |
5,746,945 |
0.0 % |
5,746,845 |
|
Amortisation |
BE |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Loans |
Net |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Gross |
BF |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Amortisation |
BG |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Other financial assets |
Net |
13,071,872 |
10.2 % |
11,857,846 |
1.9 % |
11,632,316 |
|
Gross |
BH |
13,071,872 |
10.2 % |
11,857,846 |
1.9 % |
11,632,316 |
|
Amortisation |
BI |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Sub Total Financial assets |
Net |
24,519,119 |
14.9 % |
21,334,560 |
-0.2 % |
21,386,516 |
Current Assets (III)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Total Assets |
Net |
130,112,074 |
25.0 % |
104,070,911 |
-5.1 % |
109,611,579 |
|
Gross |
CJ |
132,622,703 |
25.1 % |
105,990,134 |
-4.8 % |
111,359,217 |
|
Amortisation |
CK |
2,510,628 |
30.8 % |
1,919,223 |
9.8 % |
1,747,638 |
Stocks
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Raw materials |
Net |
1,715,776 |
-36.6 % |
2,707,827 |
23.5 % |
2,193,272 |
|
Gross |
BL |
1,715,776 |
-38.7 % |
2,798,574 |
17.1 % |
2,389,747 |
|
Amortisation |
BM |
0 |
0% |
90,747 |
-53.8 % |
196,475 |
|
Work in progress (goods) |
Net |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Gross |
BN |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Amortisation |
BO |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Work in progress (services) |
Net |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Gross |
BP |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Amortisation |
BQ |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Semi-finished and finished products |
Net |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Gross |
BR |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Amortisation |
BS |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Goods for resale |
Net |
49,917,143 |
26.7 % |
39,392,954 |
3.0 % |
38,241,565 |
|
Gross |
BT |
52,253,620 |
27.1 % |
41,120,118 |
3.6 % |
39,703,403 |
|
Amortisation |
BU |
2,336,476 |
35.3 % |
1,727,164 |
18.2 % |
1,461,838 |
|
Sub Total Stocks |
Net |
51,632,919 |
22.6 % |
42,100,781 |
4.1 % |
40,434,837 |
Advance payments to suppliers
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Advance payments to suppliers |
Net |
66,310 |
1308.8 % |
4,707 |
-88.0 % |
39,097 |
|
Gross |
BV |
66,310 |
1308.8 % |
4,707 |
-88.0 % |
39,097 |
|
Amortisation |
BW |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Debtors
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Trade accounts receivable |
Net |
1,465,099 |
-55.9 % |
3,319,718 |
223.8 % |
1,025,256 |
|
Gross |
BX |
1,639,251 |
-52.1 % |
3,421,030 |
206.9 % |
1,114,581 |
|
Amortisation |
BY |
174,151 |
71.9 % |
101,312 |
13.4 % |
89,325 |
|
Other debtors |
Net |
13,853,590 |
25.3 % |
11,054,034 |
148.0 % |
4,457,704 |
|
Gross |
BZ |
13,853,590 |
25.3 % |
11,054,034 |
148.0 % |
4,457,704 |
|
Amortisation |
CA |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Capital subscribed and called up |
Net |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Gross |
CB |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Amortisation |
CC |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Sub Total debtors |
Net |
15,318,689 |
6.6 % |
14,373,752 |
162.2 % |
5,482,960 |
Divers
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Investment securities |
Net |
20,137,588 |
876.9 % |
2,061,455 |
-83.9 % |
12,795,179 |
|
Gross |
CD |
20,137,588 |
876.9 % |
2,061,455 |
-83.9 % |
12,795,179 |
|
Amortisation |
CE |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Cash and cash equivalents |
Net |
17,015,375 |
2.9 % |
16,533,525 |
-31.0 % |
23,957,873 |
|
Gross |
CF |
17,015,375 |
2.9 % |
16,533,525 |
-31.0 % |
23,957,873 |
|
Amortisation |
CG |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Sub Total Divers |
Net |
37,152,963 |
99.8 % |
18,594,980 |
-49.4 % |
36,753,052 |
Prepaid expenses
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Prepaid expenses |
Net |
25,941,190 |
-10.5 % |
28,996,686 |
7.8 % |
26,901,629 |
|
Gross |
CH |
25,941,190 |
-10.5 % |
28,996,686 |
7.8 % |
26,901,629 |
|
Amortisation |
CI |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Equalization accounts (IV to VI)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Multi-period charges |
CW3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Gross |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
|
Premiums on redemption of bonds |
CM3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Gross |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
|
Currency differential gain |
CN3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Gross |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
References
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Due within one year |
CP |
4,911,669 |
0% |
0 |
0% |
2,933,640 |
|
Due after one year |
CR |
0 |
0% |
0 |
0% |
18,452,876 |
Grand Total - Passive Accounts (I to V)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Grand Total (I to V) |
EE |
307,292,718 |
11.4 % |
275,738,114 |
-1.9 % |
281,165,719 |
Shareholder Equity (I)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Total shareholders' equity (Total I) |
DL |
230,443,723 |
10.8 % |
207,918,442 |
5.0 % |
198,074,668 |
|
Equity and shareholders' equity |
DA |
25,140,540 |
0% |
25,140,540 |
0% |
25,140,540 |
|
Issue and merger premiums |
DB |
2,587,421 |
0% |
2,587,421 |
1.8 % |
2,541,663 |
|
Revaluation differentials |
DC |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Of which equity differential |
EK |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Legal reserve |
DD |
2,514,054 |
0% |
2,514,054 |
0% |
2,514,054 |
|
Statutory or contractual reserve |
DE |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Special regulated reserves |
DF |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Of which special reserve of provisions for current fluctuation |
B1 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Other reserves |
DG |
178,722,292 |
3538.9 % |
4,911,382 |
0% |
4,911,382 |
|
Of which reserve for buying originals works from alive artists |
EJ |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Profits or losses brought forward |
DH |
-8,242,800 |
-106.1 % |
134,330,746 |
27.4 % |
105,458,899 |
|
Profit or loss for the period |
DI |
27,429,187 |
-21.0 % |
34,731,950 |
-36.3 % |
54,523,440 |
|
Investment grants |
DJ |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Special tax-allowable reserves |
DK |
2,293,027 |
-38.1 % |
3,702,349 |
24.0 % |
2,984,690 |
Other capital resources (II)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Total other capital resources (Total II) |
DO |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Income from participating securities |
DM |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Conditional loans |
DN |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Provisions for risks and charges (III)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Total provisions for risks and charges (Total III) |
DR |
2,954,282 |
-11.4 % |
3,332,812 |
30.1 % |
2,562,425 |
|
Risk provisions |
DP |
2,954,282 |
-11.4 % |
3,332,812 |
30.1 % |
2,562,425 |
|
Reserves for charges |
DQ |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Liabilities (IV)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Total Liabilities (Total IV) |
EC |
73,894,713 |
14.6 % |
64,486,856 |
-19.9 % |
80,528,625 |
|
Convertible debentures |
DS |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Other debentures |
DT |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Bank loans and liabilities |
DU |
6,211,751 |
-48.4 % |
12,037,186 |
70.9 % |
7,044,565 |
|
Sundry loans and financial liabilities |
DV |
19,464 |
-36.9 % |
30,834 |
-98.8 % |
2,505,775 |
|
Of which participating loans |
EI |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Advance payments received for current orders |
DW |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Trade accounts payables |
DX |
36,800,338 |
66.7 % |
22,079,391 |
-8.6 % |
24,157,147 |
|
Tax and social security liabilities |
DY |
24,341,480 |
1.3 % |
24,040,246 |
-40.8 % |
40,629,458 |
|
Fixed asset liabilities |
DZ |
1,882,459 |
-17.5 % |
2,282,522 |
-6.8 % |
2,448,076 |
|
Other debts |
EA |
1,156,238 |
59.8 % |
723,444 |
-7.7 % |
783,597 |
Translation loss (V)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Translation loss (Total V) |
ED |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Equalization accounts
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Deferred income |
EB |
3,482,980 |
5.8 % |
3,293,231 |
11.3 % |
2,960,007 |
References
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Of which tax-allowable reserve |
EF |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Deferred income and liabilities |
EG |
70,769,713 |
9.7 % |
64,486,856 |
-19.9 % |
80,528,625 |
|
Of which current bank facilities |
EH |
585,836 |
-95.1 % |
12,037,186 |
70.9 % |
7,044,564 |
1 - Operating result (I-II)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Operating result (Total I-II) |
GG |
41,811,682 |
-24.4 % |
55,324,821 |
-15.3 % |
65,329,092 |
2 - Financial result (V-VI)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Financial result (Total V-VI) |
GV |
2,851,325 |
-2.9 % |
2,936,446 |
-14.0 % |
3,415,597 |
3 - Pre-tax net operating income result (I to VI)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI) |
GW |
44,663,008 |
-23.3 % |
58,261,267 |
-15.2 % |
68,744,689 |
4 - Extraordinary result (VII-VIII)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Extraordinary result (Total VII-VIII) |
HI |
928,513 |
150.9 % |
-1,824,982 |
-107.3 % |
24,877,953 |
Profit or loss
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Profit or loss |
HN |
27,429,187 |
-21.0 % |
34,731,950 |
-36.3 % |
54,523,440 |
Total Income (I+III+V+VII)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Total Income (Total I+III+V+VII) |
HL |
437,011,159 |
2.4 % |
426,589,715 |
-4.7 % |
447,667,264 |
Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X) |
HM |
409,581,975 |
4.5 % |
391,857,765 |
-0.3 % |
393,143,826 |
Operating income (I)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Total operating income (Total I) |
FR |
424,534,999 |
1.5 % |
418,351,217 |
1.2 % |
413,465,877 |
Operating income (details)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Sale of goods for resale |
FC |
418,398,038 |
1.0 % |
414,456,977 |
1.7 % |
407,625,540 |
|
France |
FA |
412,656,520 |
1.0 % |
408,679,524 |
0.3 % |
407,625,540 |
|
Export |
FB |
5,741,518 |
-0.6 % |
5,777,453 |
0% |
0 |
|
Sale of goods produced |
FF |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
France |
FD |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Export |
FE |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Sale of services |
FI |
1,114,451 |
2.3 % |
1,089,189 |
10.0 % |
990,582 |
|
France |
FG |
1,113,972 |
2.3 % |
1,089,189 |
10.0 % |
990,582 |
|
Export |
FH |
479 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Net turnover |
FL |
419,512,489 |
1.0 % |
415,546,166 |
1.7 % |
408,616,122 |
|
France |
FJ |
413,770,492 |
1.0 % |
409,768,713 |
0.3 % |
408,616,122 |
|
Export |
FK |
5,741,997 |
-0.6 % |
5,777,453 |
0% |
0 |
|
Stocked production |
FM |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Self-constructed assets |
FN |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Operating grants |
FO |
0 |
0% |
1,896 |
-57.5 % |
4,460 |
|
Release of reserves and provisions |
FP |
3,179,591 |
115.2 % |
1,477,557 |
-48.4 % |
2,864,456 |
|
Other income |
FQ |
1,842,919 |
39.0 % |
1,325,598 |
-33.1 % |
1,980,839 |
Operating charges (II)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Total operating charges (Total II) |
GF |
382,723,317 |
5.4 % |
363,026,396 |
4.3 % |
348,136,785 |
Exploitation charges
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Purchase of goods for resale |
FS |
146,749,484 |
-0.9 % |
148,122,415 |
3.5 % |
143,151,114 |
|
Change in stocks of goods for resale |
FT |
-1,032,095 |
24.2 % |
-1,361,522 |
57.1 % |
-3,173,398 |
|
Purchase of raw materials |
FU |
6,954,825 |
-7.7 % |
7,532,337 |
1.5 % |
7,419,674 |
|
Change in stocks of raw materials |
FV |
111,967 |
127.5 % |
-407,795 |
0.1 % |
-408,105 |
|
Other external purchases and charges |
FW |
131,780,867 |
14.8 % |
114,788,147 |
6.0 % |
108,253,462 |
|
Tax, duty and similar payments |
FX |
8,299,542 |
3.3 % |
8,036,850 |
6.5 % |
7,547,789 |
|
Payroll |
FY |
48,860,830 |
5.7 % |
46,216,705 |
0.6 % |
45,925,947 |
|
Social security costs |
FZ |
21,897,744 |
2.1 % |
21,442,933 |
3.6 % |
20,707,723 |
Depreciation
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Depreciation of fixed assets |
GA |
16,644,714 |
-1.5 % |
16,892,966 |
2.9 % |
16,414,561 |
|
Amortisation of fixed assets |
GB |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Depreciation/amortisation of current assets |
GC |
1,101,876 |
119.8 % |
501,287 |
-11.5 % |
566,254 |
|
Provisions for risks and charges |
GD |
486,661 |
-27.7 % |
673,128 |
7.0 % |
629,287 |
Other charge
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Other charges |
GE |
866,898 |
47.2 % |
588,945 |
-46.6 % |
1,102,477 |
Operating charges (III-IV)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III) |
GH |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV) |
GI |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Financial income (V)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Total financial income (Total V) |
GP |
3,073,869 |
0.0 % |
3,074,054 |
-13.9 % |
3,569,472 |
|
Share financial income |
GJ |
375,875 |
194.6 % |
127,606 |
-81.6 % |
693,244 |
|
Other investment income & capitalised receivables |
GK |
0 |
0% |
0 |
0% |
6,086 |
|
Other interest and similar income |
GL |
2,696,297 |
-8.4 % |
2,943,788 |
2.6 % |
2,869,344 |
|
Released provisions and transferred charges |
GM |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Exchange gains |
GN |
1,696 |
-36.2 % |
2,660 |
233.3 % |
798 |
|
Net income from disposal of investment securities |
GO |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Financial charge (VI)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Total financial charge (Total VI) |
GU |
222,543 |
61.7 % |
137,608 |
-10.6 % |
153,875 |
|
Financial reserves and provisions |
GQ |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Interest and similar charges |
GR |
219,749 |
62.1 % |
135,559 |
-11.9 % |
153,837 |
|
Exchange losses |
GS |
2,794 |
36.4 % |
2,049 |
5292.1 % |
38 |
|
Net loss from disposal of investment securities |
GT |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Extraordinary income (VII)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Total extraordinary income (Total VII) |
HD |
9,402,291 |
82.1 % |
5,164,444 |
-83.1 % |
30,631,915 |
|
Extraordinary operating income |
HA |
2,414,440 |
225.5 % |
741,782 |
180.7 % |
264,271 |
|
Extraordinary income from capital transactions |
HB |
5,318,690 |
58.8 % |
3,349,279 |
-87.8 % |
27,447,219 |
|
Released provisions and transferred charges |
HC |
1,669,161 |
55.5 % |
1,073,383 |
-63.2 % |
2,920,425 |
Extraordinary charges (VIII)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Total extraordinary charges (Total VIII) |
HH |
8,473,778 |
21.2 % |
6,989,426 |
21.5 % |
5,753,962 |
|
Extraordinary operating charges |
HE |
2,048,964 |
62254.4 % |
3,286 |
-79.4 % |
15,913 |
|
Extraordinary charges from capital transactions |
HF |
6,046,632 |
25.4 % |
4,821,593 |
3.5 % |
4,660,358 |
|
Extraordinary reserves and provisions |
HG |
378,180 |
-82.5 % |
2,164,547 |
100.9 % |
1,077,691 |
Employee profit sharing (IX)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Employee profit sharing (Total IX) |
HJ |
4,265,286 |
-9.9 % |
4,731,922 |
-42.8 % |
8,277,546 |
Tax on profits (X)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Tax on profits (Total X) |
HK |
13,897,051 |
-18.1 % |
16,972,413 |
-44.9 % |
30,821,658 |
References
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Of which equipment leases |
HP |
2,123,194 |
113.9 % |
992,413 |
5530.7 % |
17,625 |
|
Of which property leases |
HQ |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Of which transferred charges |
A1 |
2,555,442 |
193.9 % |
869,498 |
-19.9 % |
1,085,177 |
|
Of which trader's own contributions |
A2 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Of which royalties on licences and patents (income) |
A3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Of which royalties on licences and patents (charges) |
A4 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Other incomes tax
return forms
Fixed Assets
Grand Total Fixed
Assets (I to IV)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Gross value at begin of period |
OG |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Increasess due to revaluation |
OH |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Decreasess, acquisitions, creations, contributions |
OJ |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Decreasess by budget item transfer |
OK1 |
3,485,268 |
219.2 % |
1,091,786 |
-83.7 % |
6,681,400 |
|
Decreasess by transfers |
OK2 |
10,174,172 |
9.3 % |
9,304,266 |
-43.5 % |
16,473,055 |
|
Gross value at the end of period |
OL |
338,959,636 |
10.2 % |
307,485,071 |
4.5 % |
294,115,930 |
Research and development Charge (Total I)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Gross value at begin of period |
CZ |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Increasess due to revaluation |
KB |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Increasess, acquisitions, creations, contributions |
KC |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Decreasess by budget item transfer |
CO1 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Decreasess by transfers |
CO2 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Gross value at the end of period |
DO |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Gross value at begin of period |
KD |
95,006,571 |
6.8 % |
88,949,183 |
4.9 % |
84,829,875 |
|
Increasess due to revaluation |
KE |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Increasess, acquisitions, creations, contributions |
KF |
3,219,288 |
35.1 % |
2,382,416 |
-51.8 % |
4,940,311 |
|
Decreasess by budget item transfer |
LV1 |
1,454,880 |
913.8 % |
143,507 |
73.7 % |
82,622 |
|
Decreasess by transfers |
LV2 |
650,089 |
498.1 % |
108,690 |
-85.3 % |
738,380 |
|
Gross value at the end of period |
LW |
96,120,891 |
5.5 % |
91,079,402 |
2.4 % |
88,949,184 |
Tangible fixed assets (Total III)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Gross value at begin of period |
LN |
210,639,594 |
14.6 % |
183,780,229 |
-0.3 % |
184,277,434 |
|
Increasess due to revaluation |
LO |
0 |
0% |
0 |
0% |
6,597,224 |
|
Increasess, acquisitions, creations, contributions |
LP |
18,534,607 |
-10.6 % |
20,741,989 |
45.3 % |
14,275,419 |
|
Decreasess by budget item transfer |
NG1 |
2,030,388 |
114.1 % |
948,279 |
-85.6 % |
6,598,778 |
|
Decreasess by transfers |
NG2 |
8,824,187 |
3.8 % |
8,502,831 |
-42.4 % |
14,771,069 |
|
Gross value at the end of period |
NH |
218,319,626 |
11.9 % |
195,071,108 |
6.1 % |
183,780,230 |
Financial assets (Total IV)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Gross value at begin of period |
LQ |
24,407,042 |
14.1 % |
21,386,517 |
-0.8 % |
21,565,959 |
|
Increasess due to revaluation |
LR |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Increasess, acquisitions, creations, contributions |
LS |
811,974 |
26.7 % |
640,789 |
-18.3 % |
784,163 |
|
Decreasess by budget item transfer |
NJ1 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Decreasess by transfers |
NJ2 |
699,896 |
1.0 % |
692,746 |
-28.1 % |
963,606 |
|
Gross value at the end of period |
NK |
24,519,120 |
14.9 % |
21,334,560 |
-0.2 % |
21,386,516 |
Reserve for depreciation
Situation and movement of reserve for depreciation - Grand total
(I-II-III)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Reserve for depreciation value at begin of period |
ON |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Increases |
OP |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Decreasess |
OQ |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Reserve for depreciation value at the end of period |
OR |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Research and development charge (Total I)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Reserve for depreciation value at begin of period |
CY |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Increases |
PB |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Decreasess |
PC |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Decreasess by budget item transfer |
PD |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Other intangible assets (Total II)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Reserve for depreciation value at begin of period |
PE |
10,553,929 |
14.6 % |
9,211,013 |
5.4 % |
8,741,341 |
|
Increases |
PF |
905,579 |
-27.6 % |
1,251,173 |
29.3 % |
967,309 |
|
Decreasess |
PG |
428,226 |
526.4 % |
68,368 |
-86.3 % |
497,637 |
|
Decreasess by budget item transfer |
PH |
11,031,283 |
6.1 % |
10,393,818 |
12.8 % |
9,211,013 |
Total fixed assets amotisation (Total III)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Reserve for depreciation value at begin of period |
QU |
138,034,106 |
21.8 % |
113,350,777 |
3.8 % |
109,156,714 |
|
Increases |
QV |
15,739,135 |
-1.3 % |
15,948,603 |
-20.6 % |
20,095,939 |
|
Decreases |
QW |
3,025,530 |
-21.9 % |
3,875,329 |
-75.6 % |
15,901,876 |
|
Decreasess by budget item transfer |
QX |
150,747,711 |
20.2 % |
125,424,051 |
10.7 % |
113,350,777 |
Movements during period affecting charge allocated over several period
Deferred charges and debt issuance costs
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Gross value at begin of period |
Z91 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Increases |
Z92 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Depreciation of fixed assets during period |
Z9 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Decreasess by budget item transfer |
B1 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Premium refund of obligations
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Net value at begin of period |
SP1 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Increases |
SP2 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Depreciation of fixed assets during period |
SP |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Net value at the end of period |
SR |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Provisions included in balance sheet
Grand Total (I-II-III)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Value at begining of period |
7C |
8,084,531 |
10.8 % |
7,294,754 |
-25.0 % |
9,721,225 |
|
Increases |
UB |
1,966,873 |
-41.1 % |
3,341,074 |
48.6 % |
2,247,891 |
|
Decreases |
UC |
2,293,465 |
36.4 % |
1,681,442 |
-64.0 % |
4,674,363 |
|
Value at the end of period |
UD |
7,757,939 |
-13.4 % |
8,954,386 |
22.8 % |
7,294,753 |
Includes Total allocations
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Operating |
UE |
1,588,537 |
35.0 % |
1,176,526 |
0.5 % |
1,170,342 |
|
Financial |
UG |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Exceptional |
UJ |
378,335 |
-82.5 % |
2,164,548 |
100.9 % |
1,077,549 |
Includes Total Withdrawal
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Operating |
UF |
624,149 |
2.6 % |
608,059 |
-65.3 % |
1,754,079 |
|
Financial |
UH |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Exceptional |
UK |
1,669,316 |
55.5 % |
1,073,383 |
-63.2 % |
2,920,284 |
Total regulated provisions (Total I)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Value at begining of period |
3Z |
3,006,272 |
0.7 % |
2,984,690 |
-7.7 % |
3,234,527 |
|
Increases |
TS |
378,335 |
-78.2 % |
1,734,043 |
69.9 % |
1,020,549 |
|
Decreases |
TT |
1,091,580 |
7.4 % |
1,016,383 |
-20.0 % |
1,270,386 |
|
Value at the end of period |
TU |
2,293,027 |
-38.1 % |
3,702,350 |
24.0 % |
2,984,690 |
Total risk and charge provisions (Total II)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Value at begining of period |
5Z |
3,242,603 |
26.5 % |
2,562,425 |
-46.3 % |
4,770,629 |
|
Increases |
TV |
486,661 |
-55.9 % |
1,103,633 |
66.9 % |
661,087 |
|
Decreases |
TW |
774,982 |
132.6 % |
333,246 |
-88.4 % |
2,869,291 |
|
Value at the end of period |
TX |
2,954,282 |
-11.4 % |
3,332,812 |
30.1 % |
2,562,425 |
Total Provision for depreciation (Total III)
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Value at begining of period |
7B |
1,835,656 |
5.0 % |
1,747,638 |
1.8 % |
1,716,069 |
|
Increases |
TY |
1,101,876 |
118.9 % |
503,398 |
-11.1 % |
566,255 |
|
Decreases |
TZ |
426,903 |
28.7 % |
331,812 |
-37.9 % |
534,685 |
|
Value at the end of period |
UA |
2,510,629 |
30.8 % |
1,919,224 |
9.8 % |
1,747,639 |
State deadlines claims and debts at the end of period
State claims
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Gross value |
VT |
59,417,574 |
2.0 % |
58,270,735 |
23.9 % |
47,039,872 |
|
1 year at most |
VU |
37,085,585 |
8.2 % |
34,267,382 |
53.6 % |
22,316,441 |
|
More than one year |
VV |
22,331,989 |
-7.0 % |
24,003,353 |
-2.9 % |
24,723,431 |
State of loans
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Claims related to holdings (gross) |
UL |
4,911,669 |
67.0 % |
2,941,136 |
0.3 % |
2,933,640 |
|
Claims related to shareholdings (1 year at most) |
UM |
4,911,669 |
67.0 % |
2,941,136 |
0.3 % |
2,933,640 |
|
Loans (gross) |
UP |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Loans (1 year at most) |
UR |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Other financial assets (gross) |
UT |
13,071,872 |
10.2 % |
11,857,846 |
1.9 % |
11,632,316 |
|
Other financial assets (1 year at most) |
UV |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Receivables statement of assets
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Customers doubtful or disputed |
VA |
272,333 |
63.5 % |
166,524 |
9.4 % |
152,175 |
|
Other claims customer |
UX |
1,366,918 |
-58.0 % |
3,254,507 |
238.2 % |
962,406 |
|
Receivables represent Loaned Securities |
UU |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Provision for depreciation previously established |
UQ |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Personnel and associated accounts |
UY |
7,974 |
159.1 % |
3,077 |
-61.2 % |
7,936 |
|
Social Security and other social organizations |
UZ |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Income taxes |
VM |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Value added tax |
VB |
909,811 |
22.8 % |
740,832 |
26.7 % |
584,636 |
|
Other taxes and payments assimilated |
VN |
0 |
0% |
7,852 |
0% |
0 |
|
State and other public - Miscellaneous |
VP |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Group and Associates |
VC |
6,849,145 |
12.6 % |
6,083,498 |
0% |
0 |
|
Accounts receivable (including claims relating to the operation of
pension titles) |
VR |
6,086,661 |
44.3 % |
4,218,776 |
9.1 % |
3,865,132 |
Prepaid
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Prepaid |
VS |
25,941,191 |
-10.5 % |
28,996,687 |
7.8 % |
26,901,629 |
State Debt
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Total debt (gross) |
VY |
73,894,713 |
14.6 % |
64,486,857 |
-19.9 % |
80,528,625 |
|
1 year at most |
VZ2 |
70,769,713 |
9.7 % |
64,486,857 |
-19.9 % |
80,528,625 |
|
More than 1 year and 5 years at most |
VZ3 |
3,125,000 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
More than 5 years |
VZ4 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Details
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Convertible bonds (gross) |
7Y1 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
1 year at most |
7Y2 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
More than 1 year and 5 years at most |
7Y3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Other bonds (gross) |
7Z1 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
1 year at most |
7Z2 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
More than 1 year and 5 years at most |
7Z3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross) |
VG1 |
586,751 |
-95.1 % |
12,037,186 |
70.9 % |
7,044,565 |
|
1 year at most |
VG2 |
586,751 |
-95.1 % |
12,037,186 |
70.9 % |
7,044,565 |
|
More than 1 year and 5 years at most |
VG3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross) |
VH1 |
5,625,000 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
1 year at most |
VH2 |
2,500,000 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
More than 1 year and 5 years at most |
VH3 |
3,125,000 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Loans and various financial liabilities (gross) |
8A1 |
19,465 |
-36.9 % |
30,835 |
-98.8 % |
2,505,774 |
|
1 year at most |
8A2 |
19,465 |
-36.9 % |
30,835 |
-98.8 % |
2,505,774 |
|
More than 1 year and 5 years at most |
8A3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Suppliers and associated accounts (gross) |
8B1 |
36,800,338 |
66.7 % |
22,079,391 |
-8.6 % |
24,157,148 |
|
1 year at most |
8B2 |
36,800,338 |
66.7 % |
22,079,391 |
-8.6 % |
24,157,148 |
|
More than 1 year and 5 years at most |
8B3 |
36,800,338 |
66.7 % |
22,079,391 |
-8.6 % |
24,157,148 |
|
Personnel and associated accounts (gross) |
8C1 |
9,584,363 |
-4.0 % |
9,983,060 |
-27.4 % |
13,751,215 |
|
1 year at most |
8C2 |
9,584,363 |
-4.0 % |
9,983,060 |
-27.4 % |
13,751,215 |
|
More than 1 year and 5 years at most |
8C3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Social Security and other social organizations (gross) |
8D1 |
7,320,280 |
22.9 % |
5,956,364 |
-7.2 % |
6,418,966 |
|
1 year at most |
8D2 |
7,320,280 |
22.9 % |
5,956,364 |
-7.2 % |
6,418,966 |
|
More than 1 year and 5 years at most |
8D3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Taxes on profits (gross) |
8E1 |
0 |
0% |
0 |
0% |
12,420,910 |
|
1 year at most |
8E2 |
0 |
0% |
0 |
0% |
12,420,910 |
|
More than 1 year and 5 years at most |
8E3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
VAT (Gross) |
VW1 |
4,655,473 |
-13.0 % |
5,353,727 |
0.7 % |
5,319,002 |
|
1 year at most |
VW2 |
4,655,473 |
-13.0 % |
5,353,727 |
0.7 % |
5,319,002 |
|
More than 1 year and 5 years at most |
VW3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Backed Obligations (gross) |
VX1 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
1 year at most |
VX2 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
More than 1 year and 5 years at most |
VX3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Other taxes and assimilated (gross) |
VQ1 |
2,781,364 |
1.2 % |
2,747,095 |
1.0 % |
2,719,366 |
|
1 year at most |
VQ2 |
2,781,364 |
1.2 % |
2,747,095 |
1.0 % |
2,719,366 |
|
More than 1 year and 5 years at most |
VQ3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Assets and liabilities associated accounts (gross) |
8J1 |
1,882,460 |
-17.5 % |
2,282,522 |
-6.8 % |
2,448,076 |
|
1 year at most |
8J2 |
1,882,460 |
-17.5 % |
2,282,522 |
-6.8 % |
2,448,076 |
|
More than 1 year and 5 years at most |
8J3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
More than 5 years |
8J4 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Groups and associates (gross) |
VI1 |
398,894 |
117.8 % |
183,133 |
-39.1 % |
300,486 |
|
1 year at most |
VI2 |
398,894 |
117.8 % |
183,133 |
-39.1 % |
300,486 |
|
More than 1 year and 5 years at most |
VI3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
More than 5 years |
V14 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Other liabilities (gross) |
8K1 |
757,345 |
40.2 % |
540,312 |
11.8 % |
483,111 |
|
1 year at most |
8K2 |
757,345 |
40.2 % |
540,312 |
11.8 % |
483,111 |
|
More than 1 year and 5 years at most |
8K3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Debt representative of borrowed securities (gross) |
SZ1 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
1 year at most |
SZ2 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
More than 1 year and 5 years at most |
SZ3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Products in advance (gross) |
8L1 |
3,482,980 |
5.8 % |
3,293,231 |
11.3 % |
2,960,007 |
|
1 year at most |
8L2 |
3,482,980 |
5.8 % |
3,293,231 |
11.3 % |
2,960,007 |
|
More than 1 year and 5 years at most |
8L3 |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
References
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Loans made during the period |
VJ |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Debt repaid during the period |
VK |
2,500,000 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Table allocation results and other information
Dividends distributed
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Dividends |
ZE |
0 |
0% |
0 |
0% |
43,010,930 |
Commitments
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Commitments leasing furniture |
YQ |
0 |
0% |
0 |
0% |
129,094 |
|
Commitments Real Estate Leasing |
YR |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Effects brought to the discount and unmatured |
YS |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Other charges Externes
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Subcontracting |
YT |
0 |
0% |
0 |
0% |
19,014,451 |
|
Rentals, rental charges and condominiums |
XQ |
0 |
0% |
0 |
0% |
59,861,528 |
|
Staff outside the company |
YU |
0 |
0% |
0 |
0% |
75,212 |
|
Remuneration intermediaries and fees (excluding fees) |
SS |
0 |
0% |
0 |
0% |
2,016,681 |
|
Fees, commissions and brokerage |
YV |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
Other accounts |
ST |
0 |
0% |
0 |
0% |
27,285,588 |
|
Total Other purchases and external |
ZJ |
0 |
0% |
0 |
0% |
108,253,460 |
Taxes and Fees
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Business tax |
YW |
0 |
0% |
0 |
0% |
4,639,393 |
|
Other taxes and payments assimilated |
9Z |
0 |
0% |
0 |
0% |
2,908,396 |
|
Total taxes and fees |
YX |
0 |
0% |
0 |
0% |
7,547,789 |
VAT
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Amount VAT collected |
YY |
0 |
0% |
0 |
0% |
79,122,546 |
|
Total VAT on goods and services |
YZ |
0 |
0% |
0 |
0% |
48,792,059 |
Average number of employees
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Average number of employees |
YP |
2,384 |
7.0 % |
2,228 |
0.0 % |
2,227 |
Groups and Shareholders
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
||
|
Groups and Shareholders |
ZR |
0 |
- |
- |
- |
- |
Structure and Liquidity
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
Sector Median 2013 |
||
|
Fixed Asset Financing |
1.18 |
4.4 % |
1.13 |
1.8 % |
1.11 |
1.23 |
-4.1 % |
|
Global Debt |
63 days |
12.5 % |
56 days |
-21.1 % |
71 days |
181 days |
-65.2 % |
|
Working Capital Fund overall net |
53 days |
55.9 % |
34 days |
21.4 % |
28 days |
37 days |
43.2 % |
|
Financial independence |
3,698.21 % |
114.7 % |
1,722.89 % |
-16.9 % |
2,074.01 % |
53.32 % |
6835.9 % |
|
Solvability |
74.99 % |
-0.5 % |
75.40 % |
7.0 % |
70.45 % |
25.21 % |
197.5 % |
|
Capacity debt futures |
7,465.58 % |
332.2 % |
1,727.30 % |
-38.6 % |
2,811.74 % |
425.79 % |
1653.3 % |
|
Coverage of current assets by net working capital overall |
48.78 % |
-2.7 % |
50.11 % |
54.3 % |
32.48 % |
30.04 % |
62.4 % |
|
General Liquidity |
0.52 |
-1.9 % |
0.53 |
89.3 % |
0.28 |
0.09 |
477.8 % |
|
Restricted Liquidity |
1.05 |
28.0 % |
0.82 |
12.3 % |
0.73 |
0.32 |
228.1 % |
Management or rotation
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
Sector Median 2013 |
||
|
Need background in operating working capital |
2 days |
-66.7 % |
6 days |
131.6 % |
-19 days |
-1 days |
300.0 % |
|
Treasury |
31 days |
416.7 % |
6 days |
-76.9 % |
26 days |
2 days |
1450.0 % |
|
Inventory turnover of goods |
129 days |
27.7 % |
101 days |
-1.0 % |
102 days |
147 days |
-12.2 % |
|
Average length of credit granted to customers |
1 days |
-66.7 % |
3 days |
200.0 % |
1 days |
0 days |
0% |
|
Average length of credit obtained suppliers |
47 days |
56.7 % |
30 days |
3.4 % |
29 days |
49 days |
-4.1 % |
|
Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises |
49 days |
-35.5 % |
76 days |
-34.5 % |
116 days |
0 days |
0% |
|
Inventory turnover of intermediate and finished products in the
industrial enterprise |
- |
- |
- |
- |
- |
490 days |
- |
|
Rotation tangible assets |
192.16 % |
-9.8 % |
213.02 % |
-4.2 % |
222.34 % |
526.15 % |
-63.5 % |
Profitability of the business
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
Sector Median 2013 |
||
|
Margin trading |
65.00 % |
0.9 % |
64.42 % |
-1.6 % |
65.50 % |
42.57 % |
52.7 % |
|
Profitability of the business |
13.32 % |
-22.2 % |
17.13 % |
-11.6 % |
19.38 % |
3.98 % |
234.7 % |
|
Net profit |
6.54 % |
-21.8 % |
8.36 % |
-37.3 % |
13.34 % |
1.38 % |
373.9 % |
|
Growth rate of turnover (excluding VAT) |
0.00 % |
0% |
1.70 % |
-63.0 % |
4.59 % |
-3.01 % |
0% |
|
Rates integration |
32.17 % |
-9.0 % |
35.34 % |
-5.8 % |
37.53 % |
24.41 % |
31.8 % |
|
Rate leasing furniture |
0.51 % |
112.5 % |
0.24 % |
0% |
0.00 % |
0.00 % |
0% |
|
Work Factor |
52.43 % |
13.8 % |
46.07 % |
6.0 % |
43.45 % |
73.08 % |
-28.3 % |
|
Weight interests |
0.05 % |
66.7 % |
0.03 % |
-25.0 % |
0.04 % |
0.55 % |
-90.9 % |
Return on capital
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
Sector Median 2013 |
||
|
Cash flow from the overall profitability |
10.22 % |
-20.7 % |
12.89 % |
18.3 % |
10.90 % |
3.59 % |
184.7 % |
|
Rates of economic profitability |
24.00 % |
-25.0 % |
32.00 % |
-15.8 % |
38.00 % |
9.27 % |
158.9 % |
|
Financial profitability |
230,443,723.00 % |
10.8 % |
207,918,442.00 % |
5.0 % |
198,074,668.00 % |
5,066.00 % |
4548729.9 % |
|
Return on investment |
11.68 % |
-26.3 % |
15.85 % |
-39.8 % |
26.33 % |
5.87 % |
99.0 % |
Management intermediate balances
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
Sector Median 2013 |
||
|
Turnover |
419,512,489 |
1.0 % |
415,546,166 |
1.7 % |
408,616,122 |
231,756 |
180914.7 % |
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
Sector Median 2013 |
||
|
Sales of goods |
418,398,038 |
1.0 % |
414,456,977 |
1.7 % |
407,625,540 |
- |
|
|
- Purchase of goods |
146,749,484 |
-0.9 % |
148,122,415 |
3.5 % |
143,151,114 |
- |
|
|
+/- Stock of goods variation |
-1,032,095 |
24.2 % |
-1,361,522 |
57.1 % |
-3,173,398 |
- |
|
|
Trading margin |
272,680,649 €
|
1.9 % |
267,696,084 €
|
0.0 % |
267,647,824 €
|
91,820 €
|
296874.7 % |
|
65.00 % CA
|
0.9 % |
64.42 % CA
|
-1.6 % |
65.50 % CA
|
42.96 % CA
|
51.3 % |
|
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
Sector Median 2013 |
||
|
Sale of goods produced |
1,114,451 |
2.3 % |
1,089,189 |
10.0 % |
990,582 |
- |
|
|
+/- Stocked production |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
- |
|
|
+ Self-constructed assets |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
- |
|
|
Period production |
1,114,451 €
|
2.3 % |
1,089,189 €
|
10.0 % |
990,582 €
|
0 €
|
0% |
|
0.27 % CA
|
3.8 % |
0.26 % CA
|
8.3 % |
0.24 % CA
|
0.00 % CA
|
0% |
|
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
Sector Median 2013 |
||
|
Trading margin |
272,680,649 |
1.9 % |
267,696,084 |
0.0 % |
267,647,824 |
91,820 |
296874.7 % |
|
+ Period Production |
1,114,451 |
2.3 % |
1,089,189 |
10.0 % |
990,582 |
0 |
0% |
|
- Purchase of raw materials |
6,954,825 |
-7.7 % |
7,532,337 |
1.5 % |
7,419,674 |
- |
|
|
+/- Change in stocks of raw materiels |
111,967 |
127.5 % |
-407,795 |
0.1 % |
-408,105 |
- |
|
|
- Other external purchases and charges |
131,780,867 |
14.8 % |
114,788,147 |
6.0 % |
108,253,462 |
- |
|
|
Added value |
134,947,441 €
|
-8.1 % |
146,872,584 €
|
-4.2 % |
153,373,375 €
|
59,782 €
|
225632.6 % |
|
32.17 % CA
|
-9.0 % |
35.34 % CA
|
-5.8 % |
37.53 % CA
|
24.41 % CA
|
31.8 % |
|
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
Sector Median 2013 |
||
|
Added value |
134,947,441 €
|
-8.1 % |
146,872,584 €
|
-4.2 % |
153,373,375 €
|
59,782 €
|
225632.6 % |
|
+ Operating grants |
0 |
0% |
1,896 |
-57.5 % |
4,460 |
- |
|
|
- Tax, duty and similar payments |
8,299,542 |
3.3 % |
8,036,850 |
6.5 % |
7,547,789 |
- |
|
|
- Personal charges |
70,758,574 |
4.6 % |
67,659,638 |
1.5 % |
66,633,670 |
- |
|
|
Gross operating surplus |
55,889,325 €
|
-21.5 % |
71,177,992 €
|
-10.1 % |
79,196,376 €
|
8,446 €
|
661664.5 % |
|
13.32 % CA
|
-22.2 % |
17.13 % CA
|
-11.6 % |
19.38 % CA
|
3.98 % CA
|
234.7 % |
|
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
Sector Median 2013 |
|
|
55,889,325 €
|
-21.5 % |
71,177,992 €
|
-10.1 % |
79,196,376 €
|
8,446 €
|
661664.5 % |
|
3,179,591 |
115.2 % |
1,477,557 |
-48.4 % |
2,864,456 |
- |
|
|
1,842,919 |
39.0 % |
1,325,598 |
-33.1 % |
1,980,839 |
- |
|
|
18,233,251 |
0.9 % |
18,067,381 |
2.6 % |
17,610,102 |
- |
|
|
866,898 |
47.2 % |
588,945 |
-46.6 % |
1,102,477 |
- |
|
|
41,811,686 €
|
-24.4 % |
55,324,821 €
|
-15.3 % |
65,329,092 €
|
4,459 €
|
937592.0 % |
|
9.97 % CA
|
-25.1 % |
13.31 % CA
|
-16.8 % |
15.99 % CA
|
2.11 % CA
|
372.5 % |
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
Sector Median 2013 |
||
|
Operating result |
41,811,686 €
|
-24.4 % |
55,324,821 €
|
-15.3 % |
65,329,092 €
|
4,459 €
|
937592.0 % |
|
+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
- |
|
|
+ Financial income |
3,073,869 |
0.0 % |
3,074,054 |
-13.9 % |
3,569,472 |
- |
|
|
- Financial charges |
222,543 |
61.7 % |
137,608 |
-10.6 % |
153,875 |
- |
|
|
Pre-tax result |
44,663,012 €
|
-23.3 % |
58,261,267 €
|
-15.2 % |
68,744,689 €
|
2,854 €
|
1564826.8 % |
|
10.65 % CA
|
-24.0 % |
14.02 % CA
|
-16.6 % |
16.82 % CA
|
1.38 % CA
|
671.7 % |
|
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
Sector Median 2013 |
||
|
Extraordinary income |
9,402,291 |
82.1 % |
5,164,444 |
-83.1 % |
30,631,915 |
0 |
0% |
|
- Extraordinary charges |
8,473,778 |
21.2 % |
6,989,426 |
21.5 % |
5,753,962 |
- |
|
|
Extraordinary result |
928,513 €
|
150.9 % |
-1,824,982 €
|
-107.3 % |
24,877,953 €
|
0 €
|
0% |
|
0.22 % CA
|
150.0 % |
-0.44 % CA
|
-107.2 % |
6.09 % CA
|
0.00 % CA
|
0% |
|
31/12/2013 |
Variation |
31/12/2011 |
Variation |
31/12/2010 |
Sector Median 2013 |
||
|
Pre-tax result |
44,663,012 €
|
-23.3 % |
58,261,267 €
|
-15.2 % |
68,744,689 €
|
2,854 €
|
1564826.8 % |
|
Extraordinary result |
928,513 €
|
150.9 % |
-1,824,982 €
|
-107.3 % |
24,877,953 €
|
0 €
|
0% |
|
- Employee profit sharing |
4,265,286 |
-9.9 % |
4,731,922 |
-42.8 % |
8,277,546 |
- |
|
|
- Tax on profits |
13,897,051 |
-18.1 % |
16,972,413 |
-44.9 % |
30,821,658 |
- |
|
|
Net result |
27,429,188 €
|
-21.0 % |
34,731,950 €
|
-36.3 % |
54,523,438 €
|
2,984 €
|
919108.7 % |
|
6.54 % CA
|
-21.8 % |
8.36 % CA
|
-37.3 % |
13.34 % CA
|
1.39 % CA
|
370.5 % |
|
![]()
FOREIGN EXCHANGE RATES
|
Currency |
Unit
|
Indian Rupees |
|
US Dollar |
1 |
Rs.63.89 |
|
|
1 |
Rs.97.98 |
|
Euro |
1 |
Rs.71.82 |
INFORMATION DETAILS
|
Analysis Done by
: |
RAS |
|
|
|
|
Report Prepared
by : |
ANK |
RATING EXPLANATIONS
|
RATING |
STATUS |
PROPOSED CREDIT LINE |
|
|
>86 |
Aaa |
Possesses an extremely sound financial base with the strongest
capability for timely payment of interest and principal sums |
Unlimited |
|
71-85 |
Aa |
Possesses adequate working capital. No caution needed for credit
transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest
and principal sums |
Large |
|
56-70 |
A |
Financial & operational base are regarded healthy. General
unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for
payment of interest and principal sums |
Fairly Large |
|
41-55 |
Ba |
Overall operation is considered normal. Capable to meet normal
commitments. |
Satisfactory |
|
26-40 |
B |
Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below
average. |
Small |
|
11-25 |
Ca |
Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums
in default or expected to be in default upon maturity |
Limited with
full security |
|
<10 |
C |
Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised |
Credit not
recommended |
|
-- |
NB |
New Business |
-- |
This score serves as a reference to assess SC’s
credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated
from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of
this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated
through %) are as follows:
Financial
condition (40%) Ownership
background (20%) Payment
record (10%)
Credit history
(10%) Market trend (10%) Operational size
(10%)
This report is issued at your request without any
risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL)
or its officials.