MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

327540

Report Date :

20.06.2015

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

J. CHRISTOF GESELLSCHAFT M.B.H.

 

 

Registered Office :

Plabutscherstraße 115 A-8051 Graz Gösting

 

 

Country :

Austria 

 

 

Financials (as on) :

31.12.2013

 

 

Date of Establishment :

20.06.1988

 

 

Legal Form :

Limited Liability Company

 

 

Line of Business :

  • Manufacture of metal structures and parts of structures
  • Construction of utility projects for electricity and telecommunications

 

 

No. of Employees :

524 Exact (2015)

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

B

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

Small

 

Status :

Moderate

 

 

Payment Behaviour :

Slow but correct

 

 

Litigation :

Clear

 

 

NOTES:

Any query related to this report can be made on e-mail: infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – December 31, 2014

 

Country Name

Previous Rating

(30.09.2014)

Current Rating

(31.12.2014)

Austria

A2

A2

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 

 

AUSTRIA - ECONOMIC OVERVIEW

 

Austria, with its well-developed market economy, skilled labor force, and high standard of living, is closely tied to other EU economies, especially Germany's. Its economy features a large service sector, a relatively sound industrial sector, and a small, but highly developed agricultural sector. Economic growth was anemic at less than 0.5% in 2013 and 2014, and; growth in 2015 is not expected to exceed 0.5%. Austria’s 5.6% unemployment rate, while low by European standards, is at an historic high for Austria. Without extensive vocational training programs and generous early retirement, the unemployment rate would be even higher. Public finances have not stabilized even after a 2012 austerity package of expenditure cuts and new revenues. On the contrary, in 2014, the government created a “bad bank” for the troubled nationalized “Hypo Alpe Adria” bank, pushing the budget deficit up by 0.9% of GDP to 2.4% and public debt to 84.5% of the GDP. Although Austria's fiscal position compares favorably with other euro-zone countries, it faces several external risks, such as Austrian banks' continued exposure to Central and Eastern Europe, repercussions from the Hypo Alpe Adria bank collapse, political and economic uncertainties caused by the European sovereign debt crisis, the current crisis in Russia/Ukraine, the recent appreciation of the Swiss Franc, and political developments in Hungary.

 

 

Source : CIA

 

 

Company name and address

 

J. CHRISTOF GESELLSCHAFT M.B.H.

 

Plabutscherstraße 115

A-8051 Graz Gösting

 

Phone:

(0043) 316 685500

Fax:

(0043) 316 685500 - 800

E-mail:

k.gruber@christof-group.at

E-mail:

office@christof-group.at

Internet:

http://www.christof-group.at

 

 

Activities

ÖNACE 25110 70% Manufacture of metal structures and parts of structures

ÖNACE 42220 30% Construction of utility projects for electricity and telecommunications

 

 

Financial data

Financial details can also be entered during the period, irrespective of the balance sheet date.

 

total turnover (total sales)

2014

EUR

60.000.000,00

(estimated)

total turnover (total sales)

2013

EUR

59.745.599,79

(exact)

total turnover (total sales)

2012

EUR

51.704.062,14

(exact)

total turnover (total sales)

2011

EUR

81.408.133,33

(exact)

total turnover (total sales)

2010

EUR

91.823.510,26

(exact)

 

turnover (sales) - abbreviated financial year

2012

EUR

51.704.062,14

(exact)

 

total investments

2013

EUR

2.805.017,00

(exact)

 

total company vehicles

2015

 

80

(approx.)

 

total employees

2015

 

524

(exact)

 

 

General company information

 

Company name

J. Christof Gesellschaft m.b.H.

Year of incorporation

1988

Type of company

Manufacturing

Legal form

limited liability company since 1988-05-25

Companies House number

FN 47620 f Graz  since 1988-06-20

Import

Germany

Germany

2015

2014

Export

European Union

European Union

2015

2014

VAT number

ATU 28797406

number - Austrian National Bank

917176

Last balance sheet:

2013

Banking connection

Bankhaus Krentschker&Co. Aktiengesellschaft

BLZ 19520

main bank connection

UniCredit Bank Austria AG

BLZ 12000

secondary banking connection

Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges.

BLZ 20815

secondary banking connection

 

 

Locations

 

operational

A-8051 Graz Gösting, Plabutscherstr. 115

registered office

 

0043 316 685500

 

operational

A-8051 Graz Gösting, Plabutscherstraße 115

registered headquarters, owned property

 

0043 664 3259947

0043 316 685500

k.gruber@christof-group.at

office@christof-group.at

operational

A-8101 Gratkorn, Conceptstraße 1

main administration

operational

A-1220 Wien, Lobgrundstraße 2

branch office, rented premises

 

0043 1 2858716

 

operational

A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 34

branch agency, rented premises

 

0043 512 345800

 

former

A-1120 Wien, Altmannsdorferstraße 21-23/5/1

branch office

former

A-1210 Wien, Deublergasse 18

office

former

A-1010 Wien, Stadiongasse 5

office

former

A-2320 Schwechat, Concorde Businesspark C 2/14

office

former

A-8010 Graz, Glacisstraße 37

registered headquarters

former

A-1210 Wien, Gerasdorferstraße 151

branch office

former

A-8051 Graz Gösting, Plabutscherstraße 115

registered office

 

 

Private data

 

Surname

Date of birth

Address

Executive positions

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Johann Christof

1960-09-13

A-8010 Graz

Weg zum Reinerkogel 19

manager partner head of sales head of marketing head of personnel

7

MBA. Günter Dörflinger

1957-03-22

A-8010 Graz

Weg zum Reinerkogel 45

manager

11

Mag. Gernot Schieszler

1970-04-14

A-8043 Graz Kroisbach

Schwarzbauerweg 16d

manager

3

Mag. Manfred Ferlitz

1960-02-21

A-8042 Graz St. Peter

Unterer Breitenweg 29a

joint signing clerk head of accounting

1

Ing. Peter Schidler

1968-01-24

A-8081 Heiligenkreuz Waasen

Edelstaudne 108

joint signing clerk

0

Dipl-Ing. Gerhard Stroissnig

1955-10-25

A-8054 Graz Straßgang

Weblingerstraße 88g

joint signing clerk

0

Stefan Christof

1977-12-09

MC-98000 Monaco

Avenue des Citronniers 2

chairman of the supervisory board

5

Johann Christof

1938-12-04

A-8101 Gratkorn

Hart 17

deputy chairman of the supervisory board

3

Oliver Christof

1980-08-26

MC-98000 Monaco

Avenue des Citronniers Le Mira 2

member of the supervisory board

2

Peter Kolleger

1960-05-16

A-8152 Södingberg

Södingberg 46

member of the supervisory board

1

Wolfgang Nössing

1960-09-07

A-8580 Köflach

Spielplatzstraße 14

member of the supervisory board

1

Johann Edler

1944-12-13

A-8103 Rein

Seelens 211

head of purchasing

0

Michael Jud

 

A-8051 Graz Gösting

Plabutscherstraße 115(c/o)

head of purchasing

0

Mag. Josef Kormann

 

A-8051 Graz Gösting

Plabutscherstraße 115(c/o)

head of EDP

0

 

 

related companies

 

Company name

Address

Shareholdings in %

Since

Commercial register no.

Shares in this company are held by:

Christof Holding AG

A-8051 Graz Gösting

Plabutscherstraße 115

99 %

2003-08-05

FN 233467 i

 

 

 

 

 

Johann Christof

A-8010 Graz

Weg zum Reinerkogel 19

1 %

1993-09-08

 

 

 

 

 

 

This company holds 50% to 99% of the shares in:

anlagenbau holzmann Planungs- und Konstruktions- GmbH

A-3400 Klosterneuburg

Inkustraße 1-7/I/2/8

76 %

2013-03-16

FN 272012 v

Legal proceeding number 136198A

Opening of legal proceeding 2012-11-20

Status quo of legal proceeding since 2013-02-27

Legal proceeding code 07750

Status quo of legal proceeding Reorganisation plan (without self administration) has been fulfilled

 

 

 

 

 

Affiliated companies and further participations:

ARGE Fernwärmesysteme IMG-JCH

A-8051 Graz Gösting

Plabutscherstraße 115

 

1999-09-01

 

 

 

 

 

 

ARGE Tankserv Rohrer - J. Christof - KO-BRA

A-8712 Proleb

Landstraße 35

 

2005-08-01

 

 

 

 

 

 

ARGE Fernwärmesysteme IMG-JCH-2

A-8051 Thal

Plabutscherstraße 115

 

2002-09-19

 

 

 

 

 

 

Schoeller-Bleckmann Nitec GmbH

A-2630 Ternitz

Hauptstraße 2

 

 

FN 142305 y

 

 

 

 

 

CMB Maschinenbau & Handels GmbH

A-8101 Gratkorn

Conceptstrasse 1

 

 

FN 39631 g

 

 

 

 

 

ace Apparatebau construction & engineering GmbH

A-8501 Lieboch

Hans Thalhammerstraße 18

 

 

FN 188824 h

 

 

 

 

 

Christof International Management GmbH

A-1010 Wien

Eßlinggasse 17/2

 

 

FN 223131 i

 

 

 

 

 

CW Business Air Bedarfsflug- unternehmen GmbH & Co KG

A-8101 Gratkorn

Conceptstraße 1

 

 

FN 285178 f

 

 

 

 

 

CW - Immobilienverwaltungs GmbH & Co KG

A-8051 Graz Gösting

Plabutscherstraße 115

 

 

FN 293590 a

 

 

 

 

 

Christof Electrics GmbH & Co KG

A-1230 Wien

Lastenstraße 19

 

 

FN 403235 v

 

 

 

 

 

RIA Rohr- und Industrieanlagenbau- gesellschaft m.b.H.

A-8010 Graz

Glacisstraße 37

 

 

FN 145039 v

 

 

 

 

 

PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH

A-9431 St. Stefan Lavanttal

Wolkersdorf 46

 

 

FN 265578 g

 

 

 

 

 

QSE Quality-Safety-Engineering GmbH

A-8051 Graz Gösting

Plabutscherstraße 115

 

 

FN 278407 y

 

 

 

 

 

CW Business Air Bedarfsflugunternehmen GmbH

A-8010 Graz

Baumschulgasse 3

 

 

FN 285176 b

 

 

 

 

 

J. Christof Apparatebau Beteiligungs GmbH

A-8051 Graz Gösting

Plabutscherstraße 115

 

 

FN 304732 k

 

 

 

 

 

Greentech Energiesysteme GmbH

A-8051 Graz Gösting

Plabutscherstraße 115

 

 

FN 309764 k

 

 

 

 

 

REP Renewable Energy Products GmbH

A-8051 Graz Gösting

Plabutscherstraße 115

 

 

FN 374959 k

 

 

 

 

 

CW-Immobilienverwaltungs GmbH

A-8101 Gratkorn

Conceptstraße 1

 

 

FN 383733 p

 

 

Balance Sheet (absolute) all amounts in EUR

 

 

2013-12-31

Franchises, patents, licences, trademarks and similar rights and advantages

14.647,84

Sum intangible assets

14.647,84

Land and leasehold rights with buildings thereon including building on land owned by third parties

4.077.018,46

Other operating and business equipment

679.914,67

Technical plants and machines

131.139,48

Sum tangible assets

4.888.072,61

Shares on related firms

237.638,89

Loans to related firms

2.409.465,49

Other financial assets, values and securities of fixed assets

286.956,78

Sum financial assets

2.934.061,16

Sum fixed assets

7.836.781,61

Raw-, auxiliary materials and supplies

315.271,75

Outstanding service claims

18.252.285,61

Received advanced payments for orders

-12.366.966,51

Sum stock

6.200.590,85

Claims from delivered goods and performed services

10.166.559,84

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

16.564.192,54

Other claims and assets

1.737.596,06

Sum claims

28.468.348,44

Other securities

502.238,30

Sum securities and shares

502.238,30

Cash on hand, cheques and bank deposits

150.157,86

Sum cash and bank

150.157,86

Sum current assets

35.321.335,45

Deferred charges

48.729,12

Sum deferred charges

48.729,12

Assets

43.206.846,18

 

Subscribed/declared capital

1.000.000,00

Not committed capital reserves

6.010.016,05

Legal reserves

100.000,00

Balance sheet profit/balance sheet loss

-637.496,29

Thereof profit/loss carried forward

971.644,62

Sum equity capital

6.472.519,76

Other reserves before taxes

167.530,51

Sum reserves before taxes

167.530,51

Investment contributions

125.876,60

Sum floor capital

125.876,60

Reserves for severance pays

6.587.055,33

Other reserves

7.232.153,69

Sum reserves

13.819.209,02

Liabilities against credit institutes

11.265.397,66

Received advanced payments for orders

277.532,36

Liabilities from delivered goods and performed services

3.402.638,30

Liabilities against related firms

1.199.723,60

Other liabilities

6.476.418,37

Sum liabilities

22.621.710,29

 

Liabilities

43.206.846,18

Contingent liabilities

12.150.000,00

Balance sheet sum

43.206.846,18

 

 

P / L Account (absolute) all amounts in EUR

 

 

2013-12-31

Gross sales

59.745.599,79

Increase or decrease in finished and unfinished goods and in service claims

9.113.996,89

Total turnover or gross profit

68.859.596,68

 

Profits from retirement of fixed assets, except financial assets

85.680,32

Income from dissolution of reserves

5.805,77

Other operating profits

5.265.619,65

Other operating profits totally

5.357.105,74

 

Costs for obtained services

-16.844.989,82

Material costs

-7.312.420,05

Costs for obtained services totally

-24.157.409,87

 

Wages

-19.348.576,49

Salaries

-7.466.724,09

Costs for severance pays

-1.138.714,28

Legal fringe benefits and other payments depending on salaries

-7.907.521,60

Other social fringe benefits

-32.664,37

Personnel expenses totally

-35.894.200,83

 

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation

-586.627,29

Depreciation tangible assets / intangible assets totally

-586.627,29

 

Other operating costs

-15.751.839,11

Other taxes

-88.372,42

Total costs

-15.840.211,53

 

Operating result totally

-2.261.747,10

 

Income from other securities and loans of financial assets

28.194,45

Profits from the retirement of and investment in financial assets  and securities of current assets

78.015,97

Interest income, securties income and similar income

151.182,13

Disbursements from other financial assets and from securities of current assets (e.g. depreciations)

-30.984,74

Interest and similar disbursements

-375.025,91

Financial profits totally

-148.618,10

 

Results from usual business activity totally

-2.410.365,20

 

Taxes on income and profits

717.181,81

Taxes on income and profits totally

717.181,81

 

Annual surplus/annual deficit totally

-1.693.183,39

 

Dissolution reserves before taxes

131.474,17

Transfer to reserves before taxes

-47.431,69

Reserves movements totally

84.042,48

 

Annual profit/annual loss totally

-1.609.140,91

 

Profit and loss carried forward from previous year

971.644,62

Transfer of profits totally

971.644,62

 

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account

-637.496,29

 

 

Key ratios

 

 

2013

Cashflow II

-1.106.556,10

Bank indebtedness

26,07

Equity capital share in %

15,76

Social capital share

15,24

Fixed assets coverage

170,38

Net profit ratio

-3,50

Capital turnover

1,59

Return on investment in %

-4,71

Cashflow in % of operating performance

-1,60

Cashflow I

-1.823.737,91

Gross productivity

1,91

Net productivity

1,24

Operating performance

68.859.596,68

Inventories in % of operating performance

9,00

Gross profit

44.702.186,81

 

 

Land Register

 

Last check

2014-08-29

 

Entry number

Cadastral community

Journal number

1762

Gösting                              ST 63112

7505/2009

 

Section A – type of property:

GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLäCHE  GST-ADRESSE
538/3     GST-Fläche              8919
Baufl.(Gebäude)         3224
Sonstige                5695
(Werksgelände)                Plabutscherstraße 107
Plabutscherstraße 115

Section B – ownership structure:

1 ANTEIL: 1/1
J. Christof Gesellschaft m.b.H. (FN 47620 f)
ADR: Plabutscherstraße 115, Graz   8051
j 23881/2000 IM RANG 21902/2000 Kaufvertrag 2000-09-04 Eigentumsrecht

Section C – encumbrances:

1  a 5505/1940 4708/1957
DIENSTBARKEIT Unterlassung, einem anderen Elektrizitätswerk
oder sonstige Energie erzeugenden Unternehmen die Legung
von Leitungen bzw Vorrichtungen zur Leitung von
Elektrizität oder sonstiger Energie zu gestatten, solange
auf der in der EZ 1011 GB Lend eingetragenen Liegenschaft
ein Elektrizitätswerk oder ein anderes sonstige Energie
erzeugendes Unternehmen betrieben wird, für GB Lend EZ 1011
b 15837/1970 übertragung der vorangehenden Eintragung(en)
aus EZ 1217
c 7505/2009 EZ 3187 KG 63108 Andritz weiteres herrschendes Gut
2  a 15837/1970 21872/1978 771/1991
DIENSTBARKEIT Errichtung und Betrieb einer Umspannstelle
auf Gst 538/3 gem P 3 d Kaufvertrag 1970-11-02 für
Elektrizitätswerk Gösting V. Franz
3  a 15837/1970 21872/1978 771/1991
DIENSTBARKEIT Führung von Hoch- und Niederspannungskabeln
über Gst 538/3 gem P 3 d Kaufvertrag 1970-11-02 für
Elektrizitätswerk Gösting V. Franz
5  a 13114/1971 768/1991 769/1991
DIENSTBARKEIT Errichtung, Führung und Wartung des
Aufschließungskanales gem P V Servituts-Kaufvertrag
1971-04-21 hins Gst 538/3 für Gst 536/1 EZ 1771
8  a 12717/1975 21872/1978 769/1991 770/1991
DIENSTBARKEIT Errichtung und Erhaltung von Leitungsanlagen
hins Gst 538/3 gem Bescheid 1975-08-26 für
Elektrizitätswerk Gösting V. Franz
10  a 2378/1978 768/1991
DIENSTBARKEIT Abwasserabführung und Kanaleinschlauchung,
sowie Wartung der Einschlauchungskanäle gem P X c
Kaufvertrag 1977-11-23 hins Gst 538/3 für
a) Gst 538/1 EZ 1652
b) Gst 537/1 EZ 1290
11  a 34002/1983 771/1991
DIENSTBARKEIT der Duldung, der Führung, der Errichtung und
des Betriebes einer unterirdischen Gasrohrleitung sowie
einer Ergas-Reduzier-Meßstation über GSt 538/3 gem Pkt I,
II und V Dienstbarkeitsvertrag 1983-09-02 zugunsten
GRAZER STADTWERKE AKTIENGESELLSCHAFT
12  a 17171/1990 Pfandurkunde 1989-12-11
PFANDRECHT                                 Höchstbetrag 14,300.000,--
für BANKHAUS KRENTSCHKER & Co Aktiengesellschaft
b gelöscht
13  a 10043/1972 21873/1978
DIENSTBARKEIT Duldung der Führung von Hoch- und
Niederspannungskabeln über Gst 538/3 für Elektrizitätswerk
Gösting V. Franz
c 768/1991 769/1991 übertragung der vorangehenden
Eintragung(en) aus EZ 1847 1848
15    gelöscht
Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS

 

 

Commercial register

 

firm (style)

1      J. Christof Gesellschaft m.b.H.

legal form

1      Gesellschaft mit beschränkter Haftung

registered office

1      politischer Gemeinde Graz

business adress

1      Plabutscherstr. 115
8051 Graz

capital

9      EUR 1.000.000

reference date annual accounts

34      31. Dezember

annual accounts

40      zum 31.12.2013 eingereicht am 19.09.2014

consolidated accounts

13      zum 29.02.2004 eingereicht am 16.12.2004

power of representation

12      Mit Gesellschafterbeschluss oder durch Beschluss der
Generalversammlung wird, wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis bestimmt.
1   Gesellschaftsvertrag  vom 25.05.1988                                001
1   Generalversammlungsbeschluss  vom 13.02.1989                        002
Kapitalerhöhung um ATS 1.000.000,-.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ II und IV.
1   Der Gesellschaftsvertrag wurde mehrfach geändert, zuletzt           003
mit Beschluss der Generalversammlung  vom 01.03.1990
9   Gesellschaftsvertrag mit Generalversammlungsbeschluss               004
vom 05.11.2002
gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ IX, zweiter Absatz
9   Generalversammlungsbeschluss  vom 05.11.2002                        005
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 890.990,75
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § IV
9   Generalversammlungsbeschluss  vom 05.11.2002                        006
Änderung des Gesellschaftsvertrages
Streichung des § XIII und neue Durchnumerierung
12   Generalversammlungsbeschluss  vom 11.08.2004                        007
Änderung des Gesellschaftsvertrages im § VIII
26   Generalversammlungsbeschluss  vom 18.01.2011                        008
Änderung des Gesellschaftsvertrages im § VII
34   Generalversammlungsbeschluss  vom 06.11.2012                        009
Änderung des Gesellschaftsvertrages im § VI
35   Verschmelzungsvertrag  vom 06.11.2012                               010
35   Generalversammlungsbeschluss  vom 06.11.2012                        011
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Tank Farm Revamp GmbH
(FN 293089 p)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Graz.

 

proxy

C   Mag. Manfred Ferlitz, geb. 21.02.1960
31        vertritt seit 01.06.2012 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer
G   DI Gerhard Stroissnig, geb. 25.10.1955
31        vertritt seit 01.06.2012 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer
M   Ing. Peter Schidler, geb. 24.01.1968
31        vertritt seit 01.06.2012 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer

 

supervisory board

H   Stefan Christof, geb. 09.12.1977
38        Vorsitzende/r
K   Peter Kollegger, geb. 16.05.1960
28        Mitglied
L   Wolfgang Nössing, geb. 07.09.1960
28        Mitglied
N   Johann Christof, geb. 04.12.1938
38        Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
P   Oliver Christof, geb. 26.08.1980
38        Mitglied

 

managing director

A   Johann Christof, geb. 13.09.1960
38        vertritt seit 30.04.2014 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
I   Günter Dörflinger, MBA, geb. 22.03.1957
31        vertritt seit 01.06.2012 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
J   Mag. Gernot Schieszler, geb. 14.04.1970
31        vertritt seit 01.06.2012 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen

 

shareholder

A   Johann Christof, geb. 13.09.1960
10        .......................  EUR 10.000
10        ..................................................  EUR 10.000
D   Christof Holding AG
10        ......................  EUR 990.000
10        .................................................  EUR 990.000
-------------------------------------------------------
Summen:           EUR 1.000.000              EUR 1.000.000

 

general table

Landesgericht für ZRS Graz
1 Ersterfassung abgeschlossen am 08.09.1993  Geschäftsfall 907 Fr   679/93 s
Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
2 eingetragen am 01.03.1994                  Geschäftsfall  27 Fr  1167/94 x
Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.02.1994
3 eingetragen am 04.08.1995                  Geschäftsfall  27 Fr  3862/95 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.07.1995
9 eingetragen am 17.12.2002                  Geschäftsfall  27 Fr 14395/02 m
Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.11.2002
10 eingetragen am 05.08.2003                  Geschäftsfall  27 Fr  9707/03 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 31.07.2003
12 eingetragen am 19.08.2004                  Geschäftsfall  27 Fr  9316/04 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.07.2004
13 eingetragen am 22.12.2004                  Geschäftsfall  27 Fr 13230/04 t
Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 16.12.2004
18 eingetragen am 09.11.2007                  Geschäftsfall  51 Fr  3522/07 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.10.2007
20 eingetragen am 08.07.2009                  Geschäftsfall  51 Fr  2335/09 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.06.2009
26 eingetragen am 11.02.2011                  Geschäftsfall  51 Fr   634/11 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 31.01.2011
28 eingetragen am 16.04.2011                  Geschäftsfall  51 Fr  2215/11 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.03.2011
29 eingetragen am 20.04.2011                  Geschäftsfall  51 Fr  2401/11 f
Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.04.2011
31 eingetragen am 14.06.2012                  Geschäftsfall  51 Fr  3786/12 a
Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.06.2012
34 eingetragen am 16.11.2012                  Geschäftsfall  51 Fr  7284/12 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.11.2012
35 eingetragen am 22.11.2012                  Geschäftsfall  51 Fr  7304/12 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 15.11.2012
38 eingetragen am 08.05.2014                  Geschäftsfall  51 Fr  1374/14 x
Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.05.2014
39 eingetragen am 23.05.2014                  Geschäftsfall  51 Fr  1626/14 t
Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.05.2014
40 eingetragen am 01.10.2014
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 19.09.2014

 

 

Historical development

 

Year of incorporation

1988

Date of registration

1988-06-20

Change in share capital

 

from

to

asset

 

 

2002-12-17

ATS

1.500.000,00

2002-12-17

 

EUR

1.000.000,00

Former executives

 

from

to

position

name

2004-08-19

2006-09-15

manager

Dipl-Ing. Wolfgang Körner

 

2010-11-17

manager

Johann Christof

2005-04-02

2011-04-16

manager

Johann Edler

2005-04-02

2012-06-14

manager

Mag. Manfred Ferlitz

2010-06-16

2012-09-11

manager

Dipl-Ing. Wolfgang Körner

 

2014-05-08

manager

Dipl-Ing. Klaus Zink

 

2004-08-19

individual signing clerk

Johann Edler

 

2004-08-19

individual signing clerk

Mag. Manfred Ferlitz

2004-08-19

2005-04-02

joint signing clerk

Johann Edler

2004-08-19

2005-04-02

joint signing clerk

Mag. Manfred Ferlitz

2005-04-02

2011-04-20

joint signing clerk

Mag. Thomas Michael Sattler

2011-02-11

2014-05-08

chairman of the supervisory board

Johann Christof

2011-02-11

2014-05-08

deputy chairman of the supervisory board

Stefan Christof

2011-02-11

2012-06-14

member of the supervisory board

MBA. Günter Dörflinger

2011-02-11

2012-06-14

member of the supervisory board

Mag. Gernot Schieszler

2012-06-14

2014-05-08

member of the supervisory board

Johann Christof

Former shareholdings

 

from

to

company name

2007-01-31

2011-04-28

CW Business Air Bedarfsflugunternehmen GmbH

2009-02-11

2011-04-30

CW Business Air Bedarfsflug- unternehmen GmbH & Co KG

 

2000-10-17

SAE Vermietungsgesellschaft m.b.H. in Liqu.

1998-12-24

2005-04-12

PMS Elektrotechnik GmbH

1999-11-16

2005-06-03

ace Apparatebau construction & engineering GmbH

2008-04-16

2008-07-08

J. Christof Apparatebau Beteiligungs GmbH

1998-06-03

2004-12-30

ICON Anlagenbau GmbH

1999-05-28

2005-06-02

Lasal Anlagenbau GmbH

1998-07-07

2005-09-27

Print Radio Medienbeteiligungsges.m.b.H.in Liqu.

Mergers

 

On

position

name

2012-11-22

merged with

Tank Farm Revamp GmbH

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.63.82

UK Pound

1

Rs.101.26

Euro

1

Rs.72.36

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

RAS

 

 

Report Prepared by :

VNT

 

               

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

 

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

 

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

 

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

 

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

 

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

 

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

 

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

Credit not recommended

 

--

NB

New Business

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.