MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

312372

Report Date :

14.03.2015

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT

 

 

Registered Office :

33 Rue  Du  Quatre  Septembre, 75002 Paris  2

 

 

Country :

France

 

 

Date of Incorporation :

December 1954

 

 

Com. Reg. No.:

B  542  110  960

 

 

Legal Form :

Public  limited  company  with  board  of  directors Public  limited  company  with  board  of  directors

 

 

Line of Business :

Other monetary intermediation

 

[We tried to confirm / obtain the detailed activity but the same is not available from any sources]

 

 

No. of Employee :

20 to  49  employees

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory

 

 

Payment Behaviour :

No complaints

 

 

Litigation :

Clear

 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – December 31, 2014

 

Country Name

Previous Rating

(30.09.2014)

Current Rating

(31.12.2014)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 

FRANCE - ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With at least 82 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that mitigate economic inequality. France's real GDP stagnated in 2012 and 2013. The unemployment rate (including overseas territories) increased from 7.8% in 2008 to 10.2% in 2013. Youth unemployment in metropolitan France decreased from a high of 25.4% in the fourth quarter of 2012 to 22.8% in the fourth quarter of 2013. Lower-than-expected growth and high spending have strained France's public finances. The budget deficit rose sharply from 3.3% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 4.1% of GDP in 2013, while France's public debt rose from 68% of GDP to nearly 94% over the same period. In accordance with its EU obligations, France is targeting a deficit of 3.6% of GDP in 2014 and 2.8% in 2015. The administration of President Francois HOLLANDE has implemented greater state support for employment, the separation of banks' traditional deposit taking and lending activities from more speculative businesses, increasing the top corporate and personal tax rates, including a temporary 75% tax on wages over one million euros, and hiring an additional 60,000 teachers during his five-year term. In January 2014 HOLLANDE proposed a “Responsibility Pact” aimed primarily at lowering labor costs in return for businesses’ commitment to create jobs. Despite stagnant growth and fiscal challenges, France's borrowing costs have declined in recent years because investors remain attracted to the liquidity of France’s bonds.

 

Source : CIA

 

Company name and address

 

Name

BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT

 

Acronym

-

 

 

 

Trade  name

-

 

 

 

Type  of  Establishment

Head  Office

 

 

 

Postal  Address

BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT

 

 

 

 

33 RUE  DU  QUATRE  SEPTEMBRE

 

 

 

 

75002 PARIS  2

 

 

 

 

 

 

 

 

Telephone

09 52 92 46 54

 

 

 

Share  Capital

103,312,500 Euros

 

 

 

Incorporiation  Date

12/1954

 

Nationality

France

APE/NAF  Code

6419Z

 

Currency

Euros

Activity  (APE)

Other monetary intermediation

 

Last  account  Date

31/12/2011

Formation  Date

01/1954

 

Fax

-

Deregistration  Date

-

 

 

 

EUR  VAT  Number

FR46542110960

 

Legal  form

Public  limited  company  with  board  of  directors

Court  Registry  Number

19 5 4B11096

 

 

 

Registration  Court

Paris  (75)

 

RCS  Registration

RCS  Paris  B  542  110  960

 

 

Ultimate  Holding  Company

 

 

 

 

Name

Country

Company  Number

BNP  PARIBAS

 

662042449

Affiliation  links.

2757 companies  in  the  international  Group  Structure  from  68  countries.

 

 


Directors

 

Current  Directors

4

 

 

Preferential  Right

 

No  social  security  and  tax  office  preferential  right  to  date

           

 

Payment  Information  Summary  –  Trade  Payment  Data

 

Total  number  of  Invoices  available

33

Total  number  of  Invoices  paid  within  or  up  to  30  days  after  the  due  date

31

Total  number  of  Invoices  paid  more  than  30  days  after  the  dues  date

2

Total  number  of  Invoices  currently  outstanding  where  the  due  date  has  not  yet  been  reached

0

Total  number  of  Invoices  currently  outstanding  beyond  the  due  date

0

 

 

Trends

 

 

 

 

There  are  no  trends  available  for  a  company

 

 

 

 

Establishment Details

 

Type  of  Establishment

Head  Office

Production  Role

-

APE/NAF  Code

6419Z

Activity

Other monetary intermediation

Formation  Date

03/2008

Reason  for  Formation

Formation

Closure  Date

-

Reason  for  Closure

-

Reactivation  Date

-

Seasonality

-

Activity  Nature

-

Activity  Location

-

Trading  Address

33 RUE  DU  QUATRE  SEPTEMBRE

Department

 

 

 

 

Paris  (75)

 

75002 PARIS  2

 

 

Location  Surface

-

District

-

City

PARIS  2

Status

Economically  active

Business  Pages  FT®

-

Region

Ile-de-France

 

 

Area

-

 

 

Size  of  Urban  Area

-

 

 

Ultimate  Parent(s)

 

 

 

 

1 ultimate  parent  company/companies  for  this  company

 

 

 

 

Company  Name

Activity  (APE)

APE/NAF  Code

City

Post  Code

BNP  PARIBAS

Other monetary intermediation

6419Z

PARIS  9

75009

 

 

Other  Establishment(s)

 

 

 

 

Regionality

Legal  unit  with  all  establishments  in  same  area

 

Mono-activity  status

Legal  unit  having  all  establishments  with  the  same  main  activity

Branches

2 branch  entities  in  this  company

 

 

Company  Name

Company  Type

APE/NAF  Code

Activity

City

Post  Code

BNP  PARIBAS  WEALTH MANAGEMENT

Head  Office

6419Z

Autres  intermédiations

PARIS  2

75002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monétaires

 

 

BNP  PARIBAS  WEALTH MANAGEMENT

Branch

6419Z

Autres  intermédiations

PARIS  9

75009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monétaires

 

 

BNP  PARIBAS  WEALTH MANAGEMENT

Branch

6419Z

Autres  intermediations monétaires

PARIS  8

75008

 

 

Workforces

 

Workforce  at  address

20 to  49  employees

Company  workforce

20 to  49  employees

 

 


 

Collective  procedures

 

No  judgment  information  for  the  company

 

 

Preferential  rights  details  and  history

 

Summary  of  preferential  rights

 

Company  monitored  since

22/10/2010

Status  of  Monitoring

No  social  security  and  tax  office  preferential  right  to  date

 

 

Group  Data

 

 

Ultimate  parent  company

BNP  PARIBAS

 

 

 

 

 

 

 

Direct  parent

BNP  PARIBAS  -  100  %

 

 

 

 

 

 

 

Group  -  Number  of  companies

1117

 

 

 

 

 

 

 

Linkages  -  Number  of  companies

2757

 

 

 

 

 

 

 

Number  of  countries

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME

SIREN

PARTS

 

LAST

 

 

 

 

 

ACCOUNT

 

 

 

 

 

PUBLISHED

1

BNP  PARIBAS

662042449

-

-

2

VIGEO

443055215

0.75 %

31/12/2013

 

RBS  INTERNATIONAL  SECURITIES  SERVICES  LTD

-

100 %

-

-

 

SINGAPORE  EMMA  FINANCE  1

428750343

100 %

31/12/2013

 

BNP  PARIBAS  MERCHANT  BANKING  ASIA  LTD

-

100 %

-

-

 

LEVAL  20

411993157

Majority

31/12/2014

 

BNP  PARIBAS  HOME  LOAN  SFH

454084211

100 %

31/12/2005

 

DIAXONHIT

414488171

1.59 %

31/12/2013

 

BNP  PARIBAS  ZAO

-

100 %

-

-

 

CREDIT  LOGEMENT  ASSURANCE

384643342

10 %

-

 

TAITBOUT  PARTICIPATION  4  SNC

433912771

99 %

31/12/2006

 

MGI COUTIER

344844998

2.62 %

31/12/2013

 

BNP  PARIBAS  MARTINIQUE

393095757

100 %

-

2

BANCWEST  CORP

-

100 %

$

-

3

CFB  COMMUNITY  DEVELOPMENT  CORPORATION

-

100 %

-

-

3

BANK  OF  THE  WEST

-

83.22 %

$

-

4

ESSEX  CRÉDIT  CORPORATION

-

100 %

-

-

 

BANCWEST  INVESTMENT  SERVICES  INC

-

100 %

-

 

 

BW  INSURANCE  AGENCY  INC

-

100 %

-

 

 

COMMERCIAL  FEDERAL  AFFORDABLE  HOUSING

INC

 

 

 

 

 

COMMERCIAL  FEDERAL  COMMUNITY

 

 

 

 

 

 

-

100 %

 

-

 

DEVELOPMENT  CORPORATION

 

 

 

 

 

COMMERCIAL  FEDERAL  INSURANCE  CORP

-

100 %

$

-

 

COMMERCIAL  FEDERAL  SERVICE  CORPORATION

-

100 %

 

-

3

FIRST  HAWAÏAN  BANK

-

100 %

 

-

4

FHL  SPC  ONE  INC

-

100 %

 

-

 

There  are  more  than  25  companies  in  the  group. 

 

Shareholders

 

BNP  PARIBAS :  100%

 

BNP  PARIBAS

 

Linkages

 

COMPANY  NAME

SIREN

LAST

TURNOVER

 

 

 

ACCOUNT

PUBLISHED

 

 

BNP  PARIBAS

FC013447

31/12/2013

38,666,264,333

£

UNICREDIT,  SOCIETA'  PER  AZIONI  IN  FORMA

 

 

 

£

 

RM1179152

31/12/2013

12,265,235,453

£

ABBREVIATA  UNICREDIT  S.P.A.

 

 

 

£

BARCLAYS  PLC

00048839

31/12/2013

36,907,000,000

£

BARCLAYS  BANK  PLC

01026167

31/12/2013

58,176,000,000

£

CRFP  8

439916784

31/12/2013

0

£

SWAN  LANE  INVESTMENTS  LIMITED

02793078

30/11/2013

0

£

BNP  PARIBAS

MI731270

-

-

£

SAS  RUE  LA  BOETIE

439208190

31/12/2012

0

£

CARREFOUR  PROPERTY  FRANCE

775632169

31/12/2013

136,711,021

£

UNICREDIT  BANK  AG

HRB  42148

31/12/2013

6,927,000,000

£

CARREFOUR  NEDERLAND  B.V.

33261494

31/12/2013

-

£

CREDIT  AGRICOLE  PRIVATE  BANKING

533015939

31/12/2013

8,299,271

£

BANCA  NAZIONALE  DEL  LAVORO  S.P.A.  O  IN FORMA  CONTRATTA  BNL  S.P.A.

RM1156071

-

-

£

ODYSSEUS  (MARTINS)  INVESTMENTS LIMITED

03019710

31/12/2013

2,536,378

£

BORINDALE  INVESTMENTS  LIMITED

05308738

29/06/2013

0

£

LUSSAC  INVESTMENTS  LIMITED

07885212

31/12/2012

0

£

BARLEY  INVESTMENTS  LIMITED

04109369

31/12/2013

0

£

BNP  PARIBAS  LEASING  SOLUTIONS

B105096

31/12/2013

-

£

CARREFOUR

652014051

31/12/2013

0

£

CARREFOUR  ITALIA  S.P.A.

MI1616525

31/12/2013

26,404,371

£

CARREFOUR  FRANCE

672050085

31/12/2013

244,166,415

£

CREDIT  AGRICOLE  ASSURANCE

451746077

31/12/2010

8,000,000

£

SAS  MERISMA

480096551

31/12/2013

0

£

COMMERZBANK  AKTIENGESELLSCHAFT

HRB  32000

31/12/2013

18,079,000,000

£

 

 

 

 

 

COMPANY  NAME

SIREN

LAST

TURNOVER

 

 

 

ACCOUNT

 

 

 

 

PUBLISHED

 

 

ABSA  BANK  LIMITED

FC016195

31/12/2013

3,498,208,042

£

HYPOTHEKENBANK  FRANKFURT  AG

HRB  45701

31/12/2013

3,938,000,000

£

CASSA  DI  RISPARMIO  DI  PARMA  E  PIACENZA

 

 

 

£

S.P.A.  O  IN  FORMA  ABBREVIATA,

PR212837

-

-

£

CARIPARMA  S.P.A.

 

 

 

£

IMMOBILIERE  CARREFOUR

323439786

31/12/2013

359,617,504

£

BARCLAYS  CAPITAL  SECURITIES  LIMITED

01929333

31/12/2013

1,361,260,000

£

CONFORAMA  DEVELOPPEMENT

530637149

30/06/2013

14,134,000

£

 

 

Shareholder(s)

 

Name

BNP  PARIBAS  SA

 

 

Name  of  representative

M  MILLER  FRANCIS

 

 

Manager  position

Administrator

Date  of  birth

09/05/1962

Place  of  birth

PARIS  75019

 

 

Type

Moral  person

Name  at  birth

 

 

 

Director(s)

 

Name

M.  ZNAGUI  MOHAMED  REDOUAN

 

 

Manager  position

Managing  director,  Administrator     Date  of  birth

 

14/05/1963

Place  of  birth

TANGER(MAROC)

 

 

Type

Individual

Name  at  birth

 

Name

M.  MAUGARNY  OLIVIER

 

 

Manager  position

Administrator

Date  of  birth

26/03/1961

Place  of  birth

BRON  (69500)

 

 

Type

Individual

Name  at  birth

 

Name

M.  LECOMTE  VINCENT

 

 

Manager  position

Chairman  of  the  Board

Date  of  birth

30/06/1964

Place  of  birth

BOULOGNE-BILLANCOURT

(92100)

 

 

Type

Individual

Name  at  birth

 

 

 

Previous  Directors

 

Manager  position

Title  and  name

Date  of  Birth/Place  of  Birth

Chairman  of  the  Board

M.  PAPIASSE  ALAIN

16/04/1955  -  ROSNY  SOUS  BOIS

Delegated  managing  director

M.  LONGHINI  MICHEL

-

Delegated  managing  director

M.  ROUACH  MICHEL

30/07/1958  -  MEKNES  MAROC

Administrator

BNP  PARIBAS  SA

-

Administrator

BNP  PARIBAS  SA

22/05/1964  -  BOULOGNE  BILLANCOURT  92100

Administrator

BNP  PARIBAS  SA

22/05/1964  -  BOULOGNE  BILLANCOURT  92100

Administrator

BNP  PARIBAS

22/05/1964  -  BOULOGNE  BILLANCOURT

Administrator

M.  BRIERE  JEAN-BAPTISTE

10/07/1963  -  VERSAILLES

Administrator

M.  FORTI  FELIX

26/08/1951  -  ALEXANDRIE  EGYPTE

Administrator

M.  LONGHINI  MICHEL

-

Administrator

M.  MUSSEAU  HUBERT

17/06/1971  -  VERSAILLES

Administrator

M.  ROUACH  MICHEL

30/07/1958  -  MEKNES  MAROC

 

 

Status  history

 

No  Status  History

 

 

Recent  publications  in  Gazettes

 

Publication  date

Gazette  Name

Description

30/07/2014

Bodacc  C

Comptes  annuels  et  rapports

 

 

75 -  PARIS

 

GREFFE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  PARIS

 

17013 -  542110960  RCS.  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT.  Forme  :  Société  anonyme.  Adresse  :  33  rue  du  Quatre-Septembre  75002  Paris. Commentaires  :  Comptes  annuels  et  rapports  de  l'exercice  clos  le  :  31/12/2013.

 

16/05/2014

Bodacc  B

Modification  et  mutation  diverse

 

 

75 -  PARIS

 

GREFFE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  PARIS

 

1544 -  542  110  960  RCS  Paris.  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT.  Forme  :  Société  anonyme.  Administration  :  modification  de  l'Administrateur  BNP PARIBAS  SA  représenté  par  ,  Miller  Francis  Adresse  :  12  rue  Pierre  Curie  95600  Eaubonne.  Capital  :  103312500  EUR.  Activité  :  . Adresse  du  siège  social  :  33  rue  du  Quatre-Septembre,  75002  Paris.

 

Commentaires  :  modification  survenue  sur  le  représentant  permanent.

 

22/07/2013

Bodacc  C

Comptes  annuels  et  rapports

 

 

75 -  PARIS

 

GREFFE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  PARIS

 

10547 -  542110960  RCS.  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT.  Forme  :  Société  anonyme.  Adresse  :  33  rue  du  Quatre-Septembre  75002  Paris. Commentaires  :  Comptes  annuels  et  rapports  de  l'exercice  clos  le  :  31/12/2012.

 

06/07/2012

Bodacc  C

Comptes  annuels  et  rapports

 

 

75 -  PARIS

 

GREFFE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  PARIS

 

14259 -  542110960  RCS.  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT.  Forme  :  Société  anonyme.  Adresse  :  33  rue  du  Quatre-Septembre  75002  Paris. Commentaires  :  Comptes  annuels  et  rapports  de  l'exercice  clos  le  :  31/12/2011.

 

13/06/2012

Bodacc  B

Modification  et  mutation  diverse

 

 

75 -  PARIS

 

GREFFE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  PARIS

 

3015 -  542  110  960  RCS  Paris.  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT.  Forme  :  Société  anonyme.  Administration  :  Commissaire  aux  comptes  titulaire  partant  : PRICEWATERHOUSECOOPERS  AUDIT  (SA),  nomination  du  Commissaire  aux  comptes  titulaire  :  MAZARS  SA,  Commissaire  aux  comptes  suppléant  partant  : Chaumartin,  Anik,  nomination  du  Commissaire  aux  comptes  suppléant  :  Barbet-Massin,  Michel.  Capital  :  103312500  EUR.  Activité  :  . Adresse  du  siège  social  :  33  rue  du  Quatre-Septembre,  75002  Paris.

 

Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration.

 

23/11/2011

Bodacc  B

Modification  et  mutation  diverse

 

 

75 -  PARIS

 

GREFFE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  PARIS

 

1912 -  542  110  960  RCS  Paris.  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT.  Forme  :  Société  anonyme.  Administration  :  modification  du  Directeur  général  et Administrateur  Znagui,  Mohamed  Redouan,  Administrateur  partant  :  Musseau,  Hubert.  Capital  :  103312500  EUR.  Activité  :  . Adresse  du  siège  social  :  33  rue  du  Quatre-Septembre,  75002  Paris.

 

Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration.

 

09/11/2011

Bodacc  B

Modification  et  mutation  diverse

 

 

75 -  PARIS

 

GREFFE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  PARIS

 

1434 -  542  110  960  RCS  Paris.  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT.  Forme  :  Société  anonyme.  Administration  :  Directeur  général  et  Administrateur  partant :  Rouach,  Michel,  nomination  du  Directeur  général  et  Administrateur  :  Znagui,  Mohamed.  Capital  :  103312500  EUR.  Activité  :  . Adresse  du  siège  social  :  33  rue  du  Quatre-Septembre,  75002  Paris.

 

Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration.

 

18/10/2011

JAL

Resignation  /  Revocation  of  the  social  representative

 

 

Petites  affiches  (Les)  -  La  Loi  -  Le  Quotidien  juridique  -  archives  commerciales  de  la  France

 

Date  de  décision  :  01/09/2011

 

La  société  542110960  -  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT,  33  RUE  DU  QUATRE  SEPTEMBRE,  75002  PARIS  2 Fait  l'objet  du  départ  de  Monsieur  Michel  ROUACH

 

Date  d'effet  :  01/09/2011

 

18/10/2011

JAL

Appointment  of  the  social  representative

 

 

Petites  affiches  (Les)  -  La  Loi  -  Le  Quotidien  juridique  -  archives  commerciales  de  la  France

 

Société  faisant  l'objet  d'une  nomination  :  542110960  -  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT,  33  RUE  DU  QUATRE  SEPTEMBRE,  75002  PARIS  2 Nominé  :  Monsieur  Mohamed,  Redouan  ZNAGUI,  94220  CHARENTON  LE  PONT

 

En  la  fonction  de  :  Directeur  général

 

Date  d'effet  :  01/09/2011

 

 

            Page 8 of 19

 

Publication  date

Gazette  Name

Description

13/07/2011

JAL

Appointment  of  the  social  representative

 

 

Journal  spécial  des  sociétés  (Le)

 

Société  faisant  l'objet  d'une  nomination  :  480762467  -  PHITRUST  PARTENAIRES,  41  RUE  BOISSY  D'ANGLAS,  75008  PARIS  8 Nominé  :  Monsieur  Xavier  DE  BAYSER,  75008  PARIS  08

 

En  la  fonction  de  :  Membre  du  Conseil  de  Surveillance Nominé  :

 

En  la  fonction  de  :  Membre  du  Conseil  de  Surveillance Date  d'effet  :  08/06/2011

 

12/07/2011

Bodacc  C

Comptes  annuels  et  rapports

 

 

75 -  PARIS

 

GREFFE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  PARIS

 

10802 -  542110960  RCS.  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT.  Forme  :  Société  anonyme.  Adresse  :  33  rue  du  Quatre-Septembre  75002  Paris. Commentaires  :  Comptes  annuels  et  rapports  de  l'exercice  clos  le  :  31/12/2010.

 

12/06/2011

Bodacc  B

Modification  et  mutation  diverse

 

 

75 -  PARIS

 

GREFFE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  PARIS

 

1633 -  542  110  960  RCS  Paris.  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT.  Forme  :  Société  anonyme.  Administration  :  Administrateur  partant  :  Briere,  JeanBaptiste  Marie.  Capital  :  103312500  EUR.  Activité  :  .

 

Adresse  du  siège  social  :  33  rue  du  Quatre-Septembre,  75002  Paris. Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration.

 

12/06/2011

Bodacc  B

Modification  et  mutation  diverse

 

 

75 -  PARIS

 

GREFFE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  PARIS

 

1634 -  542  110  960  RCS  Paris.  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT.  Forme  :  Société  anonyme.  Administration  :  Commissaire  aux  comptes  suppléant partant  :  Coll,  Pierre,  nomination  du  Commissaire  aux  comptes  suppléant  :  Chaumartin,  Anik.  Capital  :  103312500  EUR.  Activité  :  . Adresse  du  siège  social  :  33  rue  du  Quatre-Septembre,  75002  Paris.

 

Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration.

 

25/05/2011

JAL

Resignation  /  Revocation  of  the  social  representative

 

 

Petites  affiches  (Les)  -  La  Loi  -  Le  Quotidien  juridique  -  archives  commerciales  de  la  France

 

Date  de  décision  :  24/03/2011

 

La  société  542110960  -  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT,  33  RUE  DU  QUATRE  SEPTEMBRE,  75002  PARIS  2 Fait  l'objet  du  départ  de  Date  d'effet  :  24/03/2011

 

31/08/2010

Bodacc  B

Modification  et  mutation  diverse

 

 

75 -  PARIS

 

GREFFE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  PARIS

 

766 -  542  110  960  RCS  Paris.  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT.  Forme  :  Société  anonyme.  Administration  :  Président  du  conseil  d'administration  partant :  Debiesse,  Francois  Louis,  nomination  du  Président  du  conseil  d'administration  :  Lecomte,  Vincent,  modification  du  Directeur  général  et  Administrateur  Rouach, Michel,  Directeur  général  et  Administrateur  partant  :  Longhini,  Michel.  Capital  :  103312500  EUR.

 

Adresse  du  siège  social  :  33  rue  du  Quatre-Septembre,  75002  Paris.

 

Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration.

 

28/07/2010

JAL

Resignation  /  Revocation  of  the  social  representative

 

 

LES  PETITES  AFFICHES

 

Date  de  décision  :  05/07/2010

 

La  société  542110960  -  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT,  33  RUE  DU  QUATRE  SEPTEMBRE,  75002  PARIS  2 Fait  l'objet  du  départ  de  Monsieur  François  DEBIESSE

 

28/07/2010

JAL

Resignation  /  Revocation  of  the  social  representative

 

 

LES  PETITES  AFFICHES

 

Date  de  décision  :  05/07/2010

 

La  société  542110960  -  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT,  33  RUE  DU  QUATRE  SEPTEMBRE,  75002  PARIS  2 Fait  l'objet  du  départ  de  Monsieur  Michel  LONGHINI

 

28/07/2010

JAL

Resignation  /  Revocation  of  the  social  representative

 

 

LES  PETITES  AFFICHES

 

Date  de  décision  :  05/07/2010

 

La  société  542110960  -  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT,  33  RUE  DU  QUATRE  SEPTEMBRE,  75002  PARIS  2 Fait  l'objet  du  départ  de  Monsieur  Michel  ROUACH

 

28/07/2010

JAL

Appointment  of  the  social  representative

 

 

LES  PETITES  AFFICHES

 

Société  faisant  l'objet  d'une  nomination  :  542110960  -  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT,  33  RUE  DU  QUATRE  SEPTEMBRE,  75002  PARIS  2 Nominé  :  Monsieur  Vincent  LECOMTE,  29  RUE  29  RUE  DE  SURESNES,  92380  GARCHES

 

En  la  fonction  de  :  Président  du  Conseil  d'Administration

 

Date  d'effet  :  05/07/2010

 

12/07/2010

Bodacc  C

Comptes  annuels  et  rapports

 

 

75 -  PARIS

 

GREFFE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  PARIS

 

9866 -  542110960  RCS.  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT.  Forme  :  Société  anonyme.  Adresse  :  33  R  DU  QUATRE  SEPTEMBRE  75002  PARIS. Commentaires  :  Comptes  annuels  et  rapports  de  l'exercice  clos  le  :  31/12/2009.

 

 

            Page 9 of 19

 

Publication  date

Gazette  Name

Description

24/02/2010

Bodacc  B

Modification  et  mutation  diverse

 

 

75 -  PARIS

 

GREFFE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  PARIS

 

2409 -  542  110  960  RCS  Paris.  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT.  Forme  :  Société  anonyme.  Capital  :  103312500  EUR. Adresse  du  siège  social  :  33  rue  du  Quatre-Septembre,  75002  Paris.

 

Commentaires  :  modification  survenue  sur  le  capital  (augmentation).

 

27/08/2009

Bodacc  C

Comptes  annuels  et  rapports

 

 

75 -  PARIS

 

GREFFE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  PARIS

 

8236 -  542110960  RCS.  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT.  Forme  :  Société  anonyme.  Adresse  :  33  rue  du  Quatre-Septembre  75002  Paris. Commentaires  :  Comptes  annuels  et  rapports  de  l'exercice  clos  le  :  31/12/2008.

 

11/08/2009

Bodacc  B

Modification  et  mutation  diverse

 

 

75 -  PARIS

 

GREFFE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  PARIS

 

1767 -  542  110  960  RCS  Paris.  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT.  Forme  :  Société  anonyme.  Administration  :  modification  du  Président  du  conseil d'administration  Debiesse,  Francois  Louis,  Président  du  conseil  d'administration  partant  :  Papiasse,  Alain  Pascal,  modification  du  Directeur  général  et Administrateur  Longhini,  Michel,  Administrateur  partant  :  Ravenne  Epouse  Fraysse,  nom  d'usage  :  Ravenne-Fraysse,  Jocelyne  Claudie,  nomination  de l'Administrateur  :  Maugarny,  Olivier.  Capital  :  89250000  EUR.

 

Adresse  du  siège  social  :  33  rue  du  Quatre-Septembre,  75002  Paris. Commentaires  :  modification  survenue  sur  le  capital  (augmentation)  et  l'administration.

 

04/11/2008

Bodacc  B

Modification  et  mutation  diverse

 

 

75 -  PARIS

 

GREFFE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  PARIS

 

1369 -  542  110  960  RCS  Paris.  BNP  PARIBAS  WEALTH  MANAGEMENT.  Forme  :  Société  anonyme.  Administration  :  nomination  du  Directeur  général  délègué  et Administrateur  :  Longhini,  Michel,  Administrateur  partant  :  Forti,  Felix  Serge.  Capital  :  75000000  EUR.

 

Adresse  du  siège  social  :  33  rue  du  Quatre-Septembre,  75002  Paris.

 

Commentaires  :  modification  survenue  sur  la  dénomination  et  l'administration.

 

21/08/2008

Bodacc  C

Comptes  annuels  et  rapports

 

 

75 -  PARIS

 

GREFFE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  PARIS

 

11254 -  542110960  RCS.  BNP  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme  :  Société  anonyme.  Adresse  :  33  rue  du  Quatre-Septembre  75002  Paris.  Commentaires  : Comptes  annuels  et  rapports  de  l'exercice  clos  le  :  31/12/2007.

 

15/08/2008

Bodacc  B

Modification  et  mutation  diverse

 

 

75 -  PARIS

 

GREFFE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  PARIS

 

1077 -  542  110  960  RCS  Paris.  BNP  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme  :  Société  anonyme.  Capital  :  75000000  EUR.  Adresse  de  l’établissement  principal  :  33 rue  du  Quatre-Septembre,  75002  Paris.

 

Adresse  du  siège  social  :  33  rue  du  Quatre-Septembre,  75002  Paris. Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'adresse  du  siège.

 

04/12/2007

Bodacc  C

Avis  de  dépôt  des  comptes

 

 

10156 -  542  110  960.  RCS  PARIS  BNP  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme:  Société  anonyme.  Adresse  du  siège  social:  1  boulevard  Haussmann  75009  Paris. Comptes  annuels  et  rapports  de  l'exercice  clos  le:  31  décembre  2006.

 

22/07/2007

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

1072 -  RCS  Paris  B  542  110  960.  RC  54-B  11096.  BNP  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme  :  S.A.  Capital  :  75  000  000  d'euros.  Adresse  du  siège  social  :  1 boulevard  Haussmann,,  75009  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'activité.  Etablissement  principal  -  Activité  :  toutes  opérations  de  banque,  prestations de  services  d'investissement  et  courtage  d'assurances.  Adresse  :  1  boulevard  Haussmann,  75009

 

05/09/2006

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

2284 -  RCS  Paris  B  542  110  960.  RC  54-B  11096.  BNP  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme  :  S.A.  Capital  :  75  000  000  d'euros.  Adresse  du  siège  social  :  1 boulevard  Haussmann,,  75009  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration.  Administration  :  commissaire  aux  comptes  titulaire  partant  :  BARBIER FRINAULT  &  AUTRES.  Commissaire  aux  comptes  suppléant  partant  :  OLIVIER  (Richard).  Administrateur  partant  :  BEGO  (Jean,  Emile).  Nomination  d'un administrateur  :  MUSSEAU  (Hubert).  Nomination  d'un  commissaire  aux  comptes  titulaire  :  DELOITTE  &  ASSOCIES.  Nomination  d'un  commissaire  aux  comptes suppléant  :  BEAS.

 

25/08/2006

Bodacc  C

Avis  de  dépôt  des  comptes

 

 

4098 -  RCS  Paris  B  542  110  960.  RC  54-B  11096.  BNP  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme:  S.A.  Adresse  du  siège  social:  1,  boulevard  Haussmann,Paris,  75009 Paris.  Comptes  annuels  et  rapports  de  l'exercice  clos  le:  31  décembre  2005.

 

24/08/2006

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

0986  -  RCS  Paris  B  542  110  960.  RC  54-B  11096.  BNP  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme  :  S.A.  Capital  :  75  000  000  d'euros.  Adresse  du  siège  social  :  1 boulevard  Haussmann,,  75009  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration.  Administration  :  directeur  général  délégué  et  administrateur  partant  : NOEL  (Thierry).  Nomination  d'un  directeur  général  délégué  et  administrateur  :  ROUACH  (Michel).

 

09/09/2005

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

571 -  RCS  Paris  B  542  110  960.  RC  54-B  11096.  BNP  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme  :  S.A.  Capital  :  75  000  000  d'euros.  Commentaires  :  modification  survenue sur  le  capital  (augmentation).

 

07/05/2005

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

1665 -  RCS  Paris  B  542  110  960.  RC  54-B  11096.  BNP  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme  :  S.A.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration. Administration  :  président  du  conseil  d'administration  partant  :  LEVY  dit  GARBOUA  (Vivien).  Nomination  du  président  du  conseil  d'administration  :  PAPIASSE (Alain,  Pascal).  Modification  d'un  administrateur  :  BNP  PARIBAS  S.A.  Administrateur  partant  :  LE  VERNOY  (Eric,  Grégoire).  Nomination  d'administrateurs  :  BRIERE (Jean-Baptiste,  Marie)  FORTI  (Félix,  Serge).  Commissaire  aux  comptes  titulaire  partant  :  SALUSTRO  REYDEL.  Nomination  d'un  commissaire  aux  comptes  titulaire :  PRICEWATERHOUSECOOPERS  AUDIT  S.A.  Commissaire  aux  comptes  suppléant  partant  :  CHEVREUX  (François).  Nomination  d'un  commissaire  aux  comptes suppléant  :  COLL  (Pierre).

 

15/04/2005

Bodacc  C

Avis  de  dépôt  des  comptes

 

 

4017 -  RCS  Paris  B  542  110  960.  RC  54-B  11096.  BNP  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme:  S.A.  Adresse  du  siège  social:  1,  boulevard  Haussmann,75009  Paris. Comptes  annuels  et  rapports  de  l'exercice  clos  le:  31  décembre  2004.

 

 

Publication  date

Gazette  Name

Description

28/11/2003

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542110960  RC  54-B  11096  BNP  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme  :  S.A.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration.  Administration  : modification  d'un  directeur  général  délégué  et  administrateur  :  NOEL  (  Thierry).  Modification  d'un  administrateur  :  FRAYSSE,  née  RAVENNE  (  Jocelyne,  Claudie)  ( Nom  d'usage  :  RAVENNE-FRAYSSE).  Administrateur  partant  :  MICHON  (Xavier,  Marie).

 

25/06/2003

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542110960  RC  54-B  11096  B.N.  P.  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme  :  S.A.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration.  Administration  : modification  d'un  administrateur  :  BNP  PARIBAS  S.A.  Administrateur  partant  :  LEBEAU  (Gérard).  Nomination  d'un  administrateur  :  BEGO  (Jean,  Emile).

 

25/06/2003

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542110960  RC  54-B  11096  B.N.  P.  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme  :  S.A.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration.  Administration  : nomination  d'un  administrateur  :  NOEL  (  Thierry).

 

22/01/2003

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542110960  RC  54-B  11096  B.N.  P.  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme  :  S.A.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration.  Administration  : modification  d'un  directeur  général  délégué  et  administrateur  :  FRAYSSE,  née  RAVENNE  (Jocelyne,  Claudie)  (  Nom  d'  usage  :  RAVENNE-FRAYSSE).  Nomination d'  un  directeur  général  et  administrateur  :  DEBIESSE  (François,  Louis).

 

16/08/2002

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542110960  RC  54-B  11096  B.N.  P.  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme  :  S.A.  Capital  :  68  672  406  euros.  Adresse  du  siège  social  :  1  boulevard Haussmann,  75009  Paris.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  le  capital  (augmentation).  Effet  rétroactif  de  l'apport  partiel  au  1  e  r  janvier  2002.

 

15/02/2002

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542110960  RC  54-B  11096  BNP  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme  :  S.A.  Capital  :  53  822  406  euros.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  le capital  (  augmentation)  et  l'administration.  Administration  :  nomination  d'un  administrateur  :  LE  VERNOY  (Eric,  Grégoire).

 

26/12/2001

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542110960  RC  54-B  11096  BNP  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme  :  S.A.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration.  Administration  : administrateur  partant  :  QUINTARD  (  Henri,  Marc,  Didier).

 

26/12/2001

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542110960  RC  54-B  11096  BNP  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme  :  S.A.  Capital  :  9  314  923,42  euros.  Adresse  du  siège  social  :  1  boulevard Haussmann,  75009  Paris.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  le  capital  (augmentation).

 

11/03/2001

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542110960  RC  54-B  11096  BNP  PARIBAS  PRIVATE  BANK.  Forme  :  S.A.  Capital  :  6  308  775,22  euros.  Adresse  du  siège  social  :  1  boulevard Haussmann,  75009  Paris.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  la  dénomination,  le  capital  (augmentation),  l'adresse  du  siège  social  et  l'adresse  de  l' établissement  principal  Etablissement  principal:  Adresse  :  1  boulevard  Haussmann,  75009  Paris.

 

29/10/2000

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542110960  RC  54-B  11096  BANQUE  DE  LA  CITE.  Forme  :  S.A.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration.  Administration  :  présidents d'honneur  non  administrateurs  partants  :  HENRY  DE  VILLENEUVE  (Xavier)  DARDEL  (Jean-  Baptiste).  Administrateur  partant  :  STE  IMMOBILIERE  DE  RESIDENCESIMRESID  S.A.R.  L.  Commissaires  aux  comptes  titulaires  partants  :  SURET  (Claude)  LATOUCHE  (  Christian).  Commissaires  aux  comptes  suppléants  partants  : FIDUCIAL  AUDIT  STE  FIDUCIAIRE  DU  CHATELET.

 

29/10/2000

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542110960  RC  54-B  11096  BANQUE  DE  LA  CITE.  Forme  :  S.A.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration.  Administration  :  nomination d'un  administrateur  :  MICHON  (Xavier,  Marie).

 

23/03/2000

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

*.  RCS  Paris  B  542  110  960  RC  54-B  11096  BANQUE  DE  LA  CITE.  Forme  :  S.A.  Activité  :  toutes  opérations  de  banque,  prestations  de  services  d'  investissement. Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'activité  et  l'administration.  Administration  :  suppression  :  président  du  conseil  d'  administration  :  PORCHEROT (Claude,  Jean).  Nomination  en  qualité  de  président  du  conseil  d'administration  :  LEVY  (Vivien),  dit  Garboua  Suppression  :  directeur  général  et  administrateur  : JOIGNOT  (Michel).  Nomination  en  qualité  de  directeur  général  et  administrateur  :  Mme  FRAYSSE,  née  RAVENNE  (Jocelyne,  Claudie),  (  nom  d'usage  :  RAVENNEFRAYSSE).  Modification  :  administrateur  BANQUE  NATIONALE  DE  PARIS.  Suppression  :  administrateur  :  RITS  (Bernard).  Nomination  en  qualité  d'administrateur  : QUINTARD  (Henri,  Marc,  Didier).

 

25/07/1999

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542110960  RC  54-B  11096  BANQUE  DE  LA  CITE.  Forme  :  S.A.  Capital  :  6  307  103  euros.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  le  capital  ( diminution)  et  l'administration.  Administration  :  nomination  des  commissaires  aux  comptes  titulaires  :  BARBIER  FRINAULT  ET  AUTRES  SALUSTRO  REYDEL. Nomination  des  commissaires  aux  comptes  suppléants  :  OLIVIER  (Richard)  CHEVREUX  (François).

 

27/06/1999

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542110960  RC  54-B  11096  BANQUE  DE  LA  CITE.  Forme  :  S.A.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration.  Administration  :  président du  conseil  d'administration  partant  :  AUBERT  (Jean-Pierre).  Modification  du  président  du  conseil  d'  administration  :  PORCHEROT  (Claude,  Jean).  Administrateur partant  :  DUPUIS  (  Jean,  Charles,  Alcide).

 

27/12/1998

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542  110  960  RC  54-B  11096  BANQUE  DE  LA  CITE.  Forme  :  S.A.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration.  Administration  :  directeur général  et  administrateur  partant  :  HAMON  (Michel).  Nomination  du  directeur  général  et  administrateur  :  JOIGNOT  (Michel).

 

08/03/1998

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542  110  960  RC  54-B  11096  BANQUE  DE  LA  CITE.  Forme  :  S.A.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'administration.  Administration  : administrateur  partant  :  BEAUDELET  (  Raymond).

 

24/07/1997

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542  110  960  RC  54-B  11096  BANQUE  DE  LA  CITE.  Forme  :  S.A.  Capital  :  43  002  975  F.  Activité  :  toutes  opérations  de  banque,  prestations  de services  d'investissement,  réalisation  de  toutes  opérations  de  courtage  en  matière  d'assurance.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  le  capital  ( augmentation),  l'activité  et  l'  administration.  Administration  :  modification  du  directeur  général  et  administrateur  :  HAMON  (Michel).

 

21/11/1996

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  *.  RCS  Paris  B  542  110  960  RC  RC  54-  B  11096  BANQUE  DE  LA  CITE.  Forme  :  S.A.  Administration  :  président  du  conseil  d'  administration  :  AUBERT  (JeanPierre).  Présidents  d'honneur  non  administrateurs  :  HENRY  DE  VILLENEUVE  (  Xavier)  DARDEL  (Jean-Baptiste)  Directeur  général  non  administrateur  :  HAMON (Michel).  Administrateurs  :  DUPUIS  (Jean,  Charles,  Alcide)  SOCIETE  IMMOBILIERE  DE  RESIDENCES  IMRESID  S.A.R.L.  BEAUDELET  (Raymond)  BANQUE NATIONALE  DE  PARIS  LEBEAU  (  Gérard)  RITS  (Bernard)  PORCHEROT  (  Claude,  Jean).  Commissaires  aux  comptes  titulaires  :  SURET  (Claude)  LATOUCHE (Christian).  Commissaires  aux  comptes  suppléants  :  FIDUCIAL  AUDIT  SOCIETE  FIDUCIAIRE  DU  CHATELET.  Commentaires  :  modification  survenue  sur l'administration.

 

 

 

Publication  date

Gazette  Name

Description

15/09/1996

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542  110  960  RC  54-B  11096  BANQUE  DE  LA  CITE.  Forme  :  S.A.  Capital  :  38  003  025  F.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  le  capital.

 

23/06/1996

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542  110  960  RC  54-B  11096  BANQUE  DE  LA  CITE.  Forme  :  S.A.  Administration  :  président  du  conseil  d'  administration  :  AUBERT  (Jean-Pierre). Présidents  d'honneur  non  administrateurs  :  HENRY  DE  VILLENEUVE  (  Xavier)  DARDEL  (Jean-Baptiste).  Directeur  général  non  administrateur  :  HAMON  (Michel). Administrateurs  :  DUPUIS  (Jean,  Charles,  Alcide)  STE  IMMOBILIERE  DE  RESIDENCES-IMRESID  S.A.R.  L.  BEAUDELET  (Raymond)  BANQUE  NATIONALE  DE  PARIS DREYER  (Jean-  Pierre,  Fabien)  LEBEAU  (Gérard)  RITS  (Bernard).  Commissaires  aux  comptes  titulaires  :  SURET  (Claude)  LATOUCHE  (Christian).  Commissaires aux  comptes  suppléants  :  FIDUCIAL  AUDIT  STE  FIDUCIAIRE  DU  CHATELET.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'  administration.

 

19/05/1996

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542  110  960  RC  54-B  11096  BANQUE  DE  LA  CITE.  Forme  :  S.A.  Administration  :  président  du  conseil  d'  administration  :  AUBERT  (Jean-Pierre). Présidents  d'honneur  non  administrateurs  :  HENRY  DE  VILLENEUVE  (  Xavier)  DARDEL  (Jean-Baptiste).  Directeur  général  non  administrateur  :  BLANC  (JeanPierre).  Administrateurs  :  DUPUIS  (Jean,  Charles,  Alcide)  STE  IMMOBILIERE  DE  RESIDENCES-IMRESID  S.A.R.  L.  BEAUDELET  (Raymond)  BANQUE  NATIONALE  DE PARIS  DREYER  (Jean-  Pierre,  Fabien)  LEBEAU  (Gérard)  RITS  (Bernard).  Commissaires  aux  comptes  titulaires  :  SURET  (Claude)  LATOUCHE  (Christian). Commissaires  aux  comptes  suppléants  :  FIDUCIAL  AUDIT  STE  FIDUCIAIRE  DU  CHATELET.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'  administration.

 

02/04/1996

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542  110  960  RC  54-B  11096  BANQUE  DE  LA  CITE.  Forme  :  S.A.  Administration  :  président  du  conseil  d'  administration  :  DREYER  (Jean-Pierre, Fabien).  Présidents  d'honneur  non  administrateurs  :  HENRY  DE  VILLENEUVE  (  Xavier)  DARDEL  (Jean-Baptiste).  Directeur  général  et  administrateur  :  BLANC (Jean-Pierre).  Administrateurs  :  DUPUIS  (Jean,  Charles,  Alcide)  STE  IMMOBILIERE  DE  RESIDENCES-IMRESID  S.A.R.  L.  BEAUDELET  (Raymond)  BANQUE NATIONALE  DE  PARIS  LEBEAU  (Gérard)  RITS  (Bernard).  Commissaires  aux  comptes  titulaires  :  SURET  (Claude)  LATOUCHE  (Christian).  Commissaires  aux comptes  suppléants  :  FIDUCIAL  AUDIT  STE  FIDUCIAIRE  DU  CHATELET.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'  administration.

 

06/08/1995

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS  Paris  B  542  110  960  RC  54-B  11096  BANQUE  DE  LA  CITE.  Forme  :  S.A.  Administration  :  président  du  conseil  d'  administration  :  DREYER  (Jean-Pierre, Fabien).  Président  d'honneur  et  administrateur  :  HENRY  DE  VILLENEUVE  (  Xavier).  Président  d'honneur  non  administrateur  :  DARDEL  (Jean-Baptiste).  Directeur général  et  administrateur  :  BLANC  (Jean-Pierre).  Administrateurs  :  DUPUIS  (Jean,  Charles,  Alcide)  STE  IMMOBILIERE  DE  RESIDENCES-IMRESID  S.A.R.  L. BEAUDELET  (Raymond)  BANQUE  NATIONALE  DE  PARIS  LEBEAU  (Gérard)  RITS  (Bernard).  Commissaires  aux  comptes  titulaires  :  SURET  (Claude)  LATOUCHE (Christian).  Commissaires  aux  comptes  suppléants  :  FIDUCIAL  AUDIT  STE  FIDUCIAIRE  DU  CHATELET.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'  administration.

 

04/08/1995

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

 

RCS.  RCS  B  542  110  960  RC  RC  54-B  11096  BANQUE  DE  LA  CITE.  Forme  :  S.A.  Administration  :  président  du  conseil  d'  administration  :  DREYER  (Jean-Pierre, Fabien).  Président  honneur  et  administrateur  :  HENRY  DE  VILLENEUVE  (  Xavier).  Président  d'honneur  non  administrateur  :  DARDEL  (Jean-Baptiste)  Directeur général  et  administrateur  :  BLANC  (Jean-Pierre).  Administrateurs  :  DUPUIS  (Jean-Charles,  Alcide)  SOCIETE  IMMOBILIERE  DE  RESIDENCES  IMRESID  S.A.R.  L. BEAUDELET  (Raymond)  BANQUE  NATIONALE  DE  PARIS  SAHUT  D'IZARV  (  Philippe)  LEBEAU  (Gérard)  RITS  (  Bernard).  Commissaires  aux  comptes  titulaires  : SURET  (Claude)  LATOUCHE  (  Christian).  Commissaires  aux  comptes  suppléants  :  FIDUCIAL  AUDIT  SOCIETE  FIDUCIAIRE  DU  CHATELET.  Commentaires  : modification  survenue  sur  l'  administration.

 

25/06/1995

Bodacc  B

Modifications  et  mutations  diverses

 

RCS  Paris  B  542  110  960  RC  54-B  11096  BANQUE  DE  LA  CITE.  Forme  :  S.A.  Activité  :  toutes  opérations  de  banque,  réalisation  de  toutes  opérations  de  courtage

 

 

en  matière  d'assurances.  Commentaires  :  modification  survenue  sur  l'activité.

 

 

 

Company  events  history

 

Date

Description

30/07/2014

Bodacc  C  :  Deposit  accounts  notice

08/07/2014

Invalid  balance  sheet

20/06/2014

Invalid  balance  sheet

18/06/2014

Invalid  balance  sheet

16/05/2014

Bodacc  B:  Various  editing  or  changing

30/04/2014

Appointment/resignation  of  company  officers

30/04/2014

Amendment

22/07/2013

Bodacc  C  :  Deposit  accounts  notice

23/08/2012

Consideration  of  a  balance  sheet  that  has  led  to  a  reassessment  of  this  company's  creditworthiness

06/07/2012

Bodacc  C  :  Deposit  accounts  notice

13/06/2012

Bodacc  B:  Various  editing  or  changing

29/05/2012

Amendment

29/05/2012

New  auditor

09/03/2012

Consideration  of  a  balance  sheet  that  has  led  to  a  reassessment  of  this  company's  creditworthiness

07/01/2012

New  subsidiarie(s)  detected

31/12/2011

New  accounts  available

02/12/2011

Update  of  participations  in  other  companies

23/11/2011

Bodacc  B:  Various  editing  or  changing

09/11/2011

Bodacc  B:  Various  editing  or  changing

08/11/2011

Changes  to  the  Board  of  Directors

08/11/2011

Amendment

24/10/2011

Amendment

24/10/2011

Updated  articles  of  association

24/10/2011

Changes  to  the  Board  of  Directors

24/10/2011

Appointment/resignation  of  company  officers

18/10/2011

Legal  Gazette:  Resignation  /  Revocation  of  the  social  representative

 

 

Date

Description

01/09/2011

Legal  Gazette:  Appointment  of  the  social  representative

12/07/2011

Bodacc  C  :  Deposit  accounts  notice

12/06/2011

Bodacc  B:  Various  editing  or  changing

08/06/2011

Legal  Gazette:  Appointment  of  the  social  representative

27/05/2011

Amendment

27/05/2011

Changes  to  the  Board  of  Directors

27/05/2011

New  auditor

25/05/2011

Legal  Gazette:  Resignation  /  Revocation  of  the  social  representative

31/12/2010

New  accounts  available

22/10/2010

Collection  of  preferential  rights  activated  for  this  company

31/08/2010

Bodacc  B:  Various  editing  or  changing

13/08/2010

Appointment/resignation  of  company  officers

13/08/2010

Amendment

13/08/2010

Minutes  of  Board  meeting

13/08/2010

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

13/08/2010

New  chairman  (CEO,  CoB)

13/08/2010

Changes  to  the  Board  of  Directors

28/07/2010

Legal  Gazette:  Resignation  /  Revocation  of  the  social  representative

22/07/2010

Legal  Gazette:  Appointment  of  the  social  representative

12/07/2010

Bodacc  C  :  Deposit  accounts  notice

03/05/2010

Update  of  participations  in  other  companies

03/05/2010

Disengagement  in  other  companies

03/05/2010

New  participations  in  other  companies

03/05/2010

New  subsidiarie(s)  detected

24/02/2010

Bodacc  B:  Various  editing  or  changing

04/02/2010

Amendment

04/02/2010

Audit  or  Management  Report

04/02/2010

Capital  increase

04/02/2010

Fund  deposit  certificate

04/02/2010

Updated  articles  of  association

31/12/2009

New  accounts  available

27/08/2009

Bodacc  C  :  Deposit  accounts  notice

11/08/2009

Bodacc  B:  Various  editing  or  changing

23/07/2009

Audit  or  Management  Report

23/07/2009

Capital  increase

23/07/2009

Capital  increase

23/07/2009

Changes  to  the  Board  of  Directors

23/07/2009

Changes  to  the  Board  of  Directors

23/07/2009

Fund  deposit  certificate

23/07/2009

Fund  deposit  certificate

23/07/2009

Minutes  of  Board  meeting

23/07/2009

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

23/07/2009

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

23/07/2009

New  chairman  (CEO,  CoB)

23/07/2009

Private  document

23/07/2009

Updated  articles  of  association

23/07/2009

Updated  articles  of  association

23/07/2009

Audit  or  Management  Report

23/07/2009

Appointment/resignation  of  company  officers

23/07/2009

Amendment

23/07/2009

Appointment/resignation  of  company  officers

04/11/2008

Bodacc  B:  Various  editing  or  changing

04/11/2008

New  Bodacc  B  ads  detected

17/10/2008

New  company  name

17/10/2008

New  company  name

17/10/2008

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

17/10/2008

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

17/10/2008

Minutes  of  Board  meeting

17/10/2008

Changes  to  the  Board  of  Directors

17/10/2008

Changes  to  the  Board  of  Directors

17/10/2008

Appointment/resignation  of  company  officers

 

 

Date

Description

17/10/2008

Amendment

17/10/2008

Private  document

17/10/2008

Updated  articles  of  association

17/10/2008

Updated  articles  of  association

19/09/2008

Modification  to  Company  Identifier

19/09/2008

Update  of  Company  Name

21/08/2008

Bodacc  C  :  Deposit  accounts  notice

15/08/2008

New  Bodacc  B  ads  detected

15/08/2008

Bodacc  B:  Various  editing  or  changing

11/07/2008

Registered  office  transferred  inside  jurisdiction  of  the  Commercial  Court

11/07/2008

Private  document

11/07/2008

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

11/07/2008

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

11/07/2008

Minutes  of  Board  meeting

11/07/2008

Minutes  of  Board  meeting

11/07/2008

Capital  increase

11/07/2008

Amendment

11/07/2008

Registered  office  transferred  inside  jurisdiction  of  the  Commercial  Court

11/07/2008

Updated  articles  of  association

11/07/2008

Updated  articles  of  association

12/03/2008

Transfer  of  Establishment

12/03/2008

Update  of  Company  Head  Office  Identifier

31/12/2006

New  accounts  available

09/08/2006

Amendment

09/08/2006

Private  document

09/08/2006

New  auditor

09/08/2006

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

09/08/2006

Minutes  of  Board  meeting

09/08/2006

Changes  to  the  Board  of  Directors

09/08/2006

Appointment/resignation  of  company  officers

28/06/2006

Amendment

28/06/2006

Private  document

28/06/2006

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

28/06/2006

Minutes  of  Board  meeting

28/06/2006

Changes  to  the  Board  of  Directors

28/06/2006

Appointment/resignation  of  company  officers

31/12/2005

New  accounts  available

30/08/2005

Updated  articles  of  association

30/08/2005

Private  document

30/08/2005

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

30/08/2005

Fund  deposit  certificate

30/08/2005

Capital  increase

30/03/2005

New  chairman  (CEO,  CoB)

30/03/2005

Power  of  attorney

30/03/2005

Private  document

30/03/2005

New  auditor

30/03/2005

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

30/03/2005

Minutes  of  Board  meeting

30/03/2005

Fund  deposit  certificate

30/03/2005

Changes  to  the  Board  of  Directors

30/03/2005

Amendment

30/03/2005

Appointment/resignation  of  company  officers

31/12/2004

New  accounts  available

21/05/2004

Capital  increase

21/05/2004

Private  document

21/05/2004

Updated  articles  of  association

21/05/2004

Amendment

21/05/2004

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

31/12/2003

New  accounts  available

18/11/2003

Minutes  of  Board  meeting

18/11/2003

Private  document

 

 

Date

Description

18/11/2003

Changes  to  the  Board  of  Directors

18/11/2003

Appointment/resignation  of  company  officers

18/11/2003

Amendment

12/06/2003

Appointment/resignation  of  company  officers

12/06/2003

Amendment

12/06/2003

Changes  to  the  Board  of  Directors

12/06/2003

Private  document

12/06/2003

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

12/06/2003

Minutes  of  Board  meeting

09/01/2003

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

09/01/2003

Minutes  of  Board  meeting

09/01/2003

Amendment

09/01/2003

Appointment/resignation  of  company  officers

09/01/2003

Changes  to  the  Board  of  Directors

09/01/2003

Private  document

05/08/2002

Amendment

05/08/2002

Private  document

05/08/2002

Partial  contribution

05/08/2002

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

05/08/2002

Minutes  of  Board  meeting

05/08/2002

Declaration  of  conformity

05/08/2002

Capital  increase

05/08/2002

Audit  or  Management  Report

05/08/2002

Updated  articles  of  association

23/05/2002

Private  document

23/05/2002

Foreign  document

23/05/2002

Audit  or  Management  Report

27/03/2002

Private  document

27/03/2002

Planned  merger

27/03/2002

Partial  contribution

26/02/2002

Application  and  court  order

26/02/2002

Amendment

04/02/2002

Appointment/resignation  of  company  officers

04/02/2002

Capital  increase

04/02/2002

Changes  to  the  Board  of  Directors

04/02/2002

Fund  deposit  certificate

04/02/2002

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

04/02/2002

Private  document

04/02/2002

Updated  articles  of  association

13/12/2001

Private  document

13/12/2001

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

13/12/2001

Minutes  of  Board  meeting

13/12/2001

Changes  to  the  Board  of  Directors

13/12/2001

Capital  increase

13/12/2001

Appointment/resignation  of  company  officers

13/12/2001

Amendment

13/12/2001

Updated  articles  of  association

23/10/2001

Audit  or  Management  Report

23/10/2001

Private  document

27/09/2001

Partial  contribution

27/09/2001

Amendment

27/09/2001

Private  document

19/09/2001

Application  and  court  order

19/09/2001

Amendment

13/02/2001

Capital  reduction

13/02/2001

Updated  articles  of  association

13/02/2001

Registered  office  transferred  inside  jurisdiction  of  the  Commercial  Court

13/02/2001

Private  document

13/02/2001

Partial  contribution

13/02/2001

New  company  name

13/02/2001

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

 

           

Date

Description

13/02/2001

Minutes  of  Board  meeting

13/02/2001

Declaration  of  conformity

13/02/2001

Capital  increase

13/02/2001

Amendment

19/12/2000

Audit  or  Management  Report

19/12/2000

Private  document

31/10/2000

Partial  contribution

31/10/2000

Amendment

31/10/2000

Private  document

13/10/2000

Changes  to  the  Board  of  Directors

13/10/2000

Minutes  of  Board  meeting

13/10/2000

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

13/10/2000

Private  document

13/10/2000

Amendment

13/10/2000

Appointment/resignation  of  company  officers

13/10/2000

New  auditor

08/03/2000

Private  document

08/03/2000

New  chairman  (CEO,  CoB)

08/03/2000

Minutes  of  Board  meeting

08/03/2000

Amendment

08/03/2000

Changes  to  the  Board  of  Directors

08/03/2000

Appointment/resignation  of  company  officers

01/01/2000

Appointment/resignation  of  company  officers

01/01/2000

Application  and  court  order

15/12/1999

Application  and  court  order

15/12/1999

Amendment

27/08/1999

Amendment

27/08/1999

Declaration  of  conformity

27/08/1999

Minutes  of  Board  meeting

27/08/1999

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

27/08/1999

Private  document

08/07/1999

New  auditor

08/07/1999

Private  document

08/07/1999

Updated  articles  of  association

08/07/1999

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

08/07/1999

Conversion  of  equity  to  euro

08/07/1999

Changes  to  the  Board  of  Directors

08/07/1999

Capital  reduction

08/07/1999

Appointment/resignation  of  company  officers

28/06/1999

Partial  contribution

28/06/1999

Planned  merger

28/06/1999

Private  document

14/06/1999

New  chairman  (CEO,  CoB)

14/06/1999

Private  document

14/06/1999

Minutes  of  Board  meeting

14/06/1999

Changes  to  the  Board  of  Directors

14/06/1999

Appointment/resignation  of  company  officers

14/06/1999

Amendment

14/12/1998

Appointment/resignation  of  company  officers

14/12/1998

Changes  to  the  Board  of  Directors

14/12/1998

Minutes  of  Board  meeting

14/12/1998

Private  document

14/12/1998

Amendment

20/02/1998

Private  document

20/02/1998

Minutes  of  Board  meeting

20/02/1998

Changes  to  the  Board  of  Directors

20/02/1998

Appointment/resignation  of  company  officers

20/02/1998

Amendment

08/09/1997

Private  document

08/09/1997

Appointment/resignation  of  company  officers

08/07/1997

Updated  articles  of  association

 

Date

Description

08/07/1997

Private  document

08/07/1997

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

08/07/1997

Changes  to  the  Board  of  Directors

08/07/1997

Change  to  corporate  purpose

08/07/1997

Capital  increase

08/07/1997

Appointment/resignation  of  company  officers

06/11/1996

Amendment

06/11/1996

Appointment/resignation  of  company  officers

06/11/1996

Changes  to  the  Board  of  Directors

06/11/1996

Minutes  of  Board  meeting

06/11/1996

Private  document

30/08/1996

Amendment

30/08/1996

Reconstitution  of  net  assets

30/08/1996

Private  document

30/08/1996

Minutes  of  Board  meeting

30/08/1996

Fund  deposit  certificate

30/08/1996

Continuation  of  business  despite  loss  of  equity

30/08/1996

Capital  reduction

30/08/1996

Capital  increase

30/08/1996

Updated  articles  of  association

07/06/1996

Minutes  of  Board  meeting

07/06/1996

Appointment/resignation  of  company  officers

07/06/1996

Amendment

02/05/1996

New  chairman  (CEO,  CoB)

02/05/1996

Amendment

15/03/1996

Minutes  of  Board  meeting

15/03/1996

Changes  to  the  Board  of  Directors

15/03/1996

Amendment

21/07/1995

Minutes  of  Board  meeting

21/07/1995

Changes  to  the  Board  of  Directors

21/07/1995

Amendment

15/06/1995

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

15/06/1995

Updated  articles  of  association

15/06/1995

Minutes  of  Board  meeting

15/06/1995

Appointment/resignation  of  company  officers

15/06/1995

Capital  increase

15/06/1995

Changes  to  the  Board  of  Directors

15/06/1995

Amendment

08/06/1995

Change  to  corporate  purpose

08/06/1995

Continuation  of  business  despite  loss  of  equity

08/06/1995

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

08/06/1995

Updated  articles  of  association

08/06/1995

Capital  increase

08/06/1995

Amendment

21/11/1994

Minutes  of  Board  meeting

21/11/1994

Changes  to  the  Board  of  Directors

21/11/1994

Appointment/resignation  of  company  officers

21/11/1994

Amendment

21/11/1994

New  chairman  (CEO,  CoB)

25/08/1994

Change  to  corporate  purpose

25/08/1994

Updated  articles  of  association

25/08/1994

Reconstitution  of  net  assets

25/08/1994

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

25/08/1994

Minutes  of  Board  meeting

25/08/1994

Fund  deposit  certificate

25/08/1994

Continuation  of  business  despite  loss  of  equity

25/08/1994

Capital  increase

25/08/1994

Amendment

22/07/1994

Minutes  of  Board  meeting

22/07/1994

Changes  to  the  Board  of  Directors

22/07/1994

Amendment

 

 

 

Date

Description

20/05/1994

Amendment

20/05/1994

Appointment/resignation  of  company  officers

20/05/1994

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

20/05/1994

Changes  to  the  Board  of  Directors

20/05/1994

Minutes  of  Board  meeting

07/10/1993

Minutes  of  Board  meeting

07/10/1993

Amendment

07/10/1993

Changes  to  the  Board  of  Directors

07/10/1993

Appointment/resignation  of  company  officers

01/07/1993

Amendment

01/07/1993

Planned  merger

04/06/1993

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

04/06/1993

Changes  to  the  Board  of  Directors

04/06/1993

Appointment/resignation  of  company  officers

04/06/1993

Amendment

04/06/1993

Minutes  of  Board  meeting

12/05/1993

Amendment

16/04/1993

Audit  or  Management  Report

16/04/1993

Amendment

22/01/1993

Application  and  court  order

24/12/1992

Minutes  of  Board  meeting

24/12/1992

Fund  deposit  certificate

24/12/1992

Declaration  of  conformity

24/12/1992

Capital  increase

24/12/1992

Amendment

24/12/1992

Updated  articles  of  association

23/10/1992

Amendment

23/10/1992

Minutes  of  Board  meeting

23/10/1992

Changes  to  the  Board  of  Directors

23/10/1992

Appointment/resignation  of  company  officers

16/06/1992

Amendment

16/06/1992

Minutes  of  general  meeting  of  shareholders

16/06/1992

New  chairman  (CEO,  CoB)

16/06/1992

Appointment/resignation  of  company  officers

16/06/1992

Minutes  of  Board  meeting

16/06/1992

Changes  to  the  Board  of  Directors

11/02/1992

Amendment

11/02/1992

Appointment/resignation  of  company  officers

11/02/1992

Minutes  of  Board  meeting

 

 

Bank  Accounts

 

 

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

Months

12

12

12

 

 

Accounts  -  Active

 

 

 

31/12/2011

Variation

31/12/2010

Variation

31/12/2009

Claims  on  credit institutions

BA1

12,237,294,000

-10.6 %

13,684,571,000

44.6 %

9,461,048,000

Loans  and advances  to

BA2

3,008,664,000

5.0 %

2,864,422,000

46.6 %

1,953,780,000

customers

 

 

 

 

 

 

Grand  Total

Active  Accounts    

BA3

15,804,654,000

-8.5 %

17,274,749,000

43.4 %

12,050,344,000

 

 

 

Accounts  -  Passive 

 

 

 

31/12/2011

Variation

31/12/2010

Variation

31/12/2009

Deposits  from  credit    BP1

 

6,190,330,000

-2.2 %

6,327,926,000

203.3 %

2,086,163,000

Accounts  payable

 

 

 

 

 

 

 

BP2

9,126,023,000

0%

0

0%

9,476,862,000

to  customers

 

 

 

 

 

 

Subscribed  capital

BP3

103,313,000

0%

103,313,000

0%

103,313,000

Premium

BP4

174,680,000

0%

174,680,000

0%

174,680,000

Reserves

BP5

10,331,000

0%

10,331,000

37.7 %

7,500,000

Goodwill

 

 

 

 

 

 

 

BP6

0

0%

0

0%

0

Revaluation

 

 

 

 

 

 

Retained  earnings

BP7

1,829,000

-96.6 %

54,249,000

-4.8 %

56,995,000

Result  for  the  year

BP8

1,911,000

-80.0 %

9,568,000

-74.6 %

37,622,000

Grand  Total

Passive  Accounts

BP9

15,804,654,000

-8.5 %

17,274,749,000

43.4 %

12,050,344,000

 

 

 

Results

 

 

 

31/12/2011

Variation

31/12/2010

Variation

31/12/2009

Interest  income

BR1

156,259,000

44.5 %

108,170,000

-18.5 %

132,746,000

Interest  expenses

BR2

107,495,000

38.3 %

77,746,000

-22.7 %

100,544,000

Results

BR3

1,911,000

-80.0 %

9,568,000

-74.6 %

37,622,000

 

 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.62.67

UK Pound

1

Rs.93.16

Euro

1

Rs.66.42

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

RAS

 

 

Report Prepared by :

ASH

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.