MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

349759

Report Date :

19.11.2015

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

 

 

Formerly known as :

FRESENIUS PHARMA AUSTRIA GMBH

 

FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

 

 

Registered Office :

Hafnerstraße 36 A-8055 Graz Puntigam

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

31.12.2014

 

 

Date of Incorporation :

1947

 

 

Legal Form :

Limited Liability Company

 

 

Line of Business :

  • Manufacture of pharmaceutical preparations
  • Wholesale of pharmaceutical products

 

 

No. of Employee :

54 (approx.)

           

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory

 

 

Payment Behaviour :

No complaints

 

 

Litigation :

Clear

 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31, 2015

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2014)

Current Rating

(31.03.2015)

Austria

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 

AUSTRIA ECONOMIC OVERVIEW

 

Austria, with its well-developed market economy, skilled labor force, and high standard of living, is closely tied to other EU economies, especially Germany's. Its economy features a large service sector, a relatively sound industrial sector, and a small, but highly developed agricultural sector. Economic growth was anemic at less than 0.5% in 2013 and 2014, and growth in 2015 is not expected to exceed 0.5%. Austria's 5.6% unemployment rate, while low by European standards, is at an historic high for Austria. Without extensive vocational training programs and generous early retirement, the unemployment rate would be even higher. Public finances have not stabilized even after a 2012 austerity package of expenditure cuts and new revenues. On the contrary, in 2014, the government created a "bad bank" for the troubled nationalized "Hypo Alpe Adria" bank, pushing the budget deficit up by 0.9% of GDP to 2.4% and public debt to 84.5% of the GDP. Although Austria's fiscal position compares favorably with other euro-zone countries, it faces several external risks, such as Austrian banks' continued exposure to Central and Eastern Europe, repercussions from the Hypo Alpe Adria bank collapse, political and economic uncertainties caused by the European sovereign debt crisis, the current crisis in Russia/Ukraine, the recent appreciation of the Swiss Franc, and political developments in Hungary.

 

Source : CIA


Company name and address

 

FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

 

Hafnerstraße 36

A-8055 Graz Puntigam

 

Phone:

(0043) 316 249

Fax:

(0043) 316 249 - 1422

E-mail:

info@fresenius.at

Internet:

http://www.fresenius-kabi.at

 

 

Activities

 

ÖNACE 21200 75% Manufacture of pharmaceutical preparations

ÖNACE 46461 25% Wholesale of pharmaceutical products

 

 

Financial data

 

Financial details can also be entered during the period, irrespective of the balance sheet date.

 

total turnover (total sales)

2014

EUR

339.058.156,86

(exact)

total turnover (total sales)

2013

EUR

345.067.763,13

(exact)

total turnover (total sales)

2012

EUR

369.353.608,17

(exact)

total turnover (total sales)

2011

EUR

327.247.881,24

(exact)

total turnover (total sales)

2010

EUR

272.300.384,46

(exact)

 

total company vehicles

2015

 

54

(approx.)

 

total employees

2015

 

766

(approx.)

white collar workers

2015

 

440

(exact)

blue collar workers

2015

 

326

(exact)

 

 

General company information

 

Company name

Fresenius Kabi Austria GmbH

Year of incorporation

1947

Type of company

Manufacturing

Legal form

limited liability company since 1969-12-04

Companies house number

FN 78256 h Graz  since 1969-12-30

Import

world-wide

2015

Export

world-wide

2015

DVR number

0662721

ARA-number

1846

VAT number

ATU 22978400

number - Austrian National Bank

83046

Last balance sheet:

2014

Banking connection

UniCredit Bank Austria AG

BLZ 12000

main bank connection

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft

BLZ 14000

secondary banking connection

Raiffeisen Bank International AG

BLZ 31000

secondary banking connection

 

 

Locations

 

operational

A-8055 Graz Puntigam, Hafnerstraße 36

registered office

operational

A-4020 Linz, Estermannstraße 17

registered branch office

operational

A-8055 Graz Puntigam, Hafnerstraße 36

registered headquarters, owned property

 

0043 316 249

info@fresenius.at

operational

A-4020 Linz, Estermannstraße 17

secondary branch, rented premises

 

0043 732 7651

 

former

A-1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 119

branch office

former

A-4020 Linz, Estermannstraße 17

registered office

former

A-1030 Wien, Erdbergstraße 8

secondary branch

 

 

Private data

 

Surname

Date of birth

Address

Executive positions

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Christoph Wilhelm Funke

1968-03-06

A-8055 Graz

Hafnerstraße 36

manager

0

Oskar Haszonits

1961-10-19

A-8010 Kainbach

Lanngweg 20

manager

0

Mag. Thomas Dekum

1973-04-27

A-4020 Linz

Estermannstraße 17

joint signing clerk head of sales

0

Dr. Jörg Heinrich

1970-11-20

A-8055 Graz

Hafnerstraße 36

joint signing clerk

0

Mag.(FH) Andrej Mieth

1972-02-03

A-8043 Graz Kroisbach

Mariatrosterstraße 113

joint signing clerk head of sales head of marketing

0

Mag. Heinz Peter Riesner

1968-08-26

A-8077 Gössendorf

Gärtnerstraße 5

joint signing clerk

0

Dipl-Ing. Gundolf Sabathiel

1963-02-12

A-5310 Mondsee

Am Gaisberg 29

joint signing clerk

0

Dr. Johann Schlögl

1968-09-29

A-8055 Graz Puntigam

Hafnerstraße 36

joint signing clerk

0

Christer Mats Henriksson

1967-04-12

D-61346 Bad Homburg

Else Körnerstraße 1

chairman of the supervisory board

0

Dr. Michael Schönhofen

1961-01-28

D-61352 Bad Homburg vor der Höhe

Else Krönerstraße 1

deputy chairman of the supervisory board

0

Stanislav Jerinic

1961-05-15

A-8055 Graz

Hafnerstraße 36

member of the supervisory board

0

Dr. Carolin Kröner

1979-04-06

A-8055 Graz Puntigam

Hafnerstraße 36

member of the supervisory board

0

Johann Schwarz

1957-02-12

A-4020 Linz

Estermannstraße 17

member of the supervisory board

0

Mag. Gerlinde Neugebauer

 

A-8055 Graz Puntigam

Hafnerstraße 36(c/o)

head of accounting

0

Peter Meirold

 

A-8055 Graz Puntigam

Hafnerstraße 36(c/o)

head of purchasing

0

Ing. Harald Leitgeb

 

A-8055 Graz Puntigam

Hafnerstraße 36(c/o)

technical director

0

Mag. Dunja Mühlbacher

 

A-8151 Hitzendorf

Reiteregg 6(c/o)

head of personnel

0

 

 

related companies

 

Company name

Address

Shareholdings in %

Since

Commercial register no.

Shares in this company are held by:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

D-60323 Frankfurt

Friedrichstraße 2-6

99,87 %

2001-03-03

 

Fresenius HemoCare GmbH

D-61352 Bad Homburg v.d.H.

Else Krönerstraße 1

0,13 %

2015-07-08

 

 

 

Balance Sheet (absolute)

 

all amounts in EUR

 

 

2014-12-31

Franchises, patents, licences, trademarks and similar rights and advantages

17.440.881,71

Sum intangible assets

17.440.881,71

 

Land and leasehold rights with buildings thereon including building on land owned by third parties

31.523.378,38

Other operating and business equipment

5.676.199,70

Technical plants and machines

38.068.982,39

Advanced payments and constructions in progress

14.367.111,48

Sum tangible assets

89.635.671,95

 

Shares on related firms

461.711.392,76

Other financial assets, values and securities of fixed assets

5.349.685,50

Sum financial assets

467.061.078,26

 

Sum fixed assets

574.137.631,92

 

Raw-, auxiliary materials and supplies

9.700.513,02

Unfinished products

4.592.232,01

Finished products

19.563.053,39

Sum stock

33.855.798,42

 

Claims from delivered goods and performed services

27.941.770,42

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

77.714.958,01

Other claims and assets

5.164.722,38

Sum claims

110.821.450,81

 

Cash on hand, cheques and bank deposits

534.398,27

Sum cash and bank

534.398,27

 

Sum current assets

145.211.647,50

 

Deferred charges

453.675,49

Sum deferred charges

453.675,49

Assets

719.802.954,91

 

Subscribed/declared capital

3.500.000,00

Committed capital reserves

442.278,40

Not committed capital reserves

151.805.423,96

Legal reserves

350.000,00

Free reserves

13.741.505,85

Balance sheet profit/balance sheet loss

66.355.449,80

Thereof profit/loss carried forward

9.437.478,38

Sum equity capital

236.194.658,01

 

Valuation reserves and other reserves before taxes

3.933.590,81

Sum reserves before taxes

3.933.590,81

 

Investment contributions

12.731,17

Sum floor capital

12.731,17

 

Reserves for severance pays

8.796.947,00

Reserves for pensions

7.500.593,00

Tax reserves

1.793.800,49

Other reserves

17.329.869,28

Sum reserves

35.421.209,77

 

Liabilities against credit institutes

14.000.000,00

Liabilities from delivered goods and performed services

17.397.890,66

Liabilities against related firms

400.742.735,03

Other liabilities

12.083.225,46

Sum liabilities

444.223.851,15

 

Deferred income

16.914,00

Sum deferred income

16.914,00

 

Liabilities and shareholders'equity

719.802.954,91

Balance sheet sum

719.802.954,91

 

 

 

P / L Account (absolute)

 

all amounts in EUR

 

 

2014-12-31

Gross sales

339.058.156,86

Increase or decrease in finished and unfinished goods and in service claims

901.107,93

Other manufacturing costs capitalized

71.230,00

Total turnover or gross profit

340.030.494,79

 

Other operating profits

29.824.033,66

Other operating profits totally

29.824.033,66

 

Material costs and expenses for obtained services

-164.091.169,85

Costs for obtained services totally

-164.091.169,85

 

Personnel expenses

-57.486.041,41

Personnel expenses totally

-57.486.041,41

 

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation

-10.172.719,35

Depreciation tangible assets / intangible assets totally

-10.172.719,35

 

Other operating costs

-71.145.433,32

Total costs

-71.145.433,32

 

Operating result totally

66.959.164,52

 

Profits from shareholdings

14.164.100,00

Income from other securities and loans of financial assets

104.118,00

Profits from the retirement of and investment in financial assets  and securities of current assets

167.670,80

Interest income, securties income and similar income

6.815,30

Interest and similar disbursements

-9.809.421,71

Financial profits totally

4.633.282,39

 

Results from usual business activity totally

71.592.446,91

 

Taxes on income and profits

-14.793.800,49

Taxes on income and profits totally

-14.793.800,49

 

Annual surplus/annual deficit totally

56.798.646,42

 

Dissolution reserves before taxes

119.325,00

Reserves movements totally

119.325,00

 

Annual profit/annual loss totally

56.917.971,42

 

Profit and loss carried forward from previous year

9.437.478,38

Transfer of profits totally

9.437.478,38

 

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account

66.355.449,80

 

 

 

Key ratios

 

 

2014

Cashflow II

66.971.365,77

Debt amortisation period in years

7,15

Bank indebtedness

1,94

Equity capital share in %

33,36

Social capital share

2,26

Fixed assets coverage

44,66

Net profit ratio

21,05

Capital turnover

0,47

Return on investment in %

11,30

Cashflow in % of operating performance

19,69

Cashflow I

81.765.166,26

Gross productivity

5,91

Net productivity

3,06

Operating performance

340.030.494,79

Inventories in % of operating performance

9,95

Gross profit

175.939.324,94

 

 

Land Register

 

Last check

2015-04-01

 

Entry number

Cadastral community

Journal number

1276

Straßgang                            ST 63122

3646/2014

 

Section A – type of property:

GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
98/3   G GST-Fläche        *    27744
Bauf.(10)              11443
Gärten(10)              5182
Sonst(50)              11119  Hafnerstraße 36
Legende:
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude)
Gärten(10): Gärten (Gärten)
Sonst(50): Sonstige (Betriebsflächen)
1  a 13394/1950 Verpflichtung zur Gehsteigherstellung hins Gst 98/3
(A 10/3-1867/3-50 Pe)
b 3387/1976 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 14
2  a 9804/1964 Sicherheitszone Flughafen Graz hins Gst 98/3
b 3387/1976 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 14
3  a 14215/1981 Tauschvertrag 1980-10-29 Zuschreibung Teilfläche(n) Gst
.106, Einbeziehung in Gst 98/3
4  a 1883/1964 Verpflichtung zur Abtretung eines Teiles des Gst 106 hier
98/3 gem Bescheid Magitrat Graz, Rechtsamt 1963-12-02, A 3 G 1060/63
b 14215/1981 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 1044
5  a 14215/1981 Teilung Gst 98/3 in 98/3 u 98/8
6  a gelöscht

Section B – ownership structure:

1 ANTEIL: 1/1
Fresenius Kabi Austria GmbH
ADR: Hafnerstr. 36   8055
c 18298/1999 Urkunde 1997-06-25 Eigentumsrecht

Section C – encumbrances:

1  a 14820/1976
DIENSTBARKEIT Duldung der Errichtung und des Bestandes
eines Sichtschutzwaldes auf Teil des Gst 98/3 gem Par 5
Grundabtretungs- und Dienstbarkeitsbestellungsvertrag
1976-09-01 zugunsten Stadt Graz für den öffentlichen
Gemeingebrauch
2  a 610/1979
DIENSTBARKEIT Verlegung von Erdgasleitungen, Errichtung von
technischen Anlagen, Betreten, Befahren mit Fahrzeugen
aller Art auf Gst 98/3 gem Pkt 1 2 Dienstbarkeitsvertrag
1978-11-07 für Steirische Ferngas-Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
3  a 18906/1993
DIENSTBARKEIT Errichtung, Bestand, Duldung unterird.
Gasrohrleitung ,Erdgas-Reduzier- bzw. Meßstation gem PKT
1.-3. Vertrag 1993-07-27 auf Gst 98/3 für
Grazer Stadtwerke Aktiengesellschaft
4  a 3646/2014
DIENSTBARKEIT Duldung der Errichtung, Betrieb,
Instandhaltung, Erneuerung, Umbau der zur Übertragung
elektr Energie dienenden 20-kV-Leitung UW Webling -
Schwarzer Weg LKW Werkstätte, M2-791 sowie Fernmeldeanlagen
über Gst 98/3
gem Pkt 1 - 5 Vereinbarung 2014-02-25 für
STEWEAG-STEG GmbH (FN 196943y)
Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.
Grundbuch 01.04.2015 07:24:06

 

 

Commercial register

 

firm (style)

28      Fresenius Kabi Austria GmbH

legal form

1      Gesellschaft mit beschränkter Haftung

registered office

19      politischer Gemeinde Graz

business adress

19      Hafnerstr. 36
8055 Graz

capital

52      EUR 3.500.000

reference date annual accounts

1      31. Dezember

annual accounts

83      zum 31.12.2014 eingereicht am 24.08.2015

power of representation

19      Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen
vertreten.
Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäfts-
führer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige
Vertretungsbefugnis erteilen.
1   Gesellschaftsvertrag  vom 04.12.1969                                001
1   Verschmelzungsvertrag  vom 09.05.1985                               002
1   Generalversammlungsbeschluss  vom 09.05.1985                        003
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
SANQUISAN-MEDIZINAL-Gesell-
schaft m.b.H. (HRB 1851 LG Linz)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Linz.
1   Der Gesellschaftsvertrag wurde mehrfach geändert, zuletzt           004
mit Beschluss der Generalversammlung  vom 10.06.1988
18   Verschmelzungsvertrag  vom 25.06.1997                               007
18   Generalversammlungsbeschluss  vom 25.06.1997                        008
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Frika, Pharmazeutische Fabrik
Gesellschaft m.b.H.
(FN 106142 t)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Wien.
18   Verschmelzungsvertrag  vom 25.06.1997                               009
18   Generalversammlungsbeschluss  vom 25.06.1997                        010
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Leopold Pharma Gesellschaft m.b.H.
(FN 47648 x)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Graz.
28   Generalversammlungsbeschluss  vom 11.02.1999                        012
Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
30   Generalversammlungsbeschluss  vom 23.03.1999                        013
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 Abs 1
48   Verschmelzungsvertrag  vom 14.07.2003                               014
48   Generalversammlungsbeschluss  vom 22.07.2003                        015
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Calea Austria Healthcare GmbH
(FN 198501 p)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Linz.
52   Gesellschaftsvertrag mit Generalversammlungsbeschluss               016
vom 21.07.2004
gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.
Änderung des Gesellschaftsvertrages im § 7
52   Generalversammlungsbeschluss  vom 21.07.2004                        017
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 229.722,46.
Änderung des Gesellschaftsvertrages im § 4.
53   Verschmelzungsvertrag  vom 13.07.2004                               018
53   Generalversammlungsbeschluss  vom 21.07.2004                        019
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Laevosan-Pharma-GmbH
(FN 82201 i)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Linz.

 

Proxy

 

BQ   Dr. Johann Schlögl, geb. 29.09.1968
60        vertritt seit 05.05.2006 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
BR   Mag. Thomas Dekum, geb. 27.04.1973
62        vertritt seit 23.07.2007 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
BU   Mag. (FH) Andrej Mieth, geb. 03.02.1972
69        vertritt seit 01.01.2011 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
BW   Mag. Heinz-Peter Riesner, geb. 26.08.1968
72        vertritt seit 21.06.2012 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
BX   Gundolf Sabathiel, geb. 12.02.1963
74        vertritt seit 01.01.2013 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
CB   Dr. Jörg Heinrich, geb. 20.11.1970
77        vertritt seit 01.06.2013 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen

 

Supervisory Board

 

BN   Dr. Michael Schönhofen, geb. 28.01.1961
58        Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
BT   Dr. Carolin Kröner, geb. 06.04.1979
67        Mitglied
BV   Stanislav Jerinic, geb. 15.05.1961
71        Mitglied
BY   Mats Christer Henriksson, geb. 12.04.1967
75        Vorsitzende/r
BZ   Johann Schwarz, geb. 12.02.1957
75        Mitglied

 

MANAGING DIRECTOR

 

BE   Dr. Oskar Haszonits, geb. 19.10.1961
43        vertritt seit 01.07.2002 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
CA   Christoph Wilhelm Funke, geb. 06.03.1968
76        vertritt seit 01.03.2013 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen

 

Shareholder

 

BF   Fresenius Kabi Deutschland GmbH
54        ....................  EUR 3.495.450
54        ...............................................  EUR 3.495.450
BM   Fresenius HemoCare Beteiligungs GmbH
54        ........................  EUR 4.550
54        ...................................................  EUR 4.550
-------------------------------------------------------
Summen:           EUR 3.500.000              EUR 3.500.000

 

GENERAL TABLE

 

Landesgericht Linz
1 Ersterfassung abgeschlossen am 09.02.1994  Geschäftsfall 911 Fr    56/94 h
Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
18 eingetragen am 16.09.1997                  Geschäftsfall  12 Fr  3816/97 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.06.1997
eingetragen am 16.09.1997                  Geschäftsfall  12 Fr  3817/97 f
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.06.1997
Landesgericht für ZRS Graz
19 eingetragen am 04.10.1997                  Geschäftsfall  27 Fr  5749/97 k
Antrag auf Sitzverlegung  eingelangt am 18.09.1997
28 eingetragen am 24.03.1999                  Geschäftsfall  27 Fr  3157/99 t
Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.03.1999
30 eingetragen am 15.07.1999                  Geschäftsfall  27 Fr  4428/99 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.04.1999
38 eingetragen am 07.02.2001                  Geschäftsfall  27 Fr  1132/01 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 01.02.2001
43 eingetragen am 24.07.2002                  Geschäftsfall  27 Fr  8214/02 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.07.2002
48 eingetragen am 13.08.2003                  Geschäftsfall  27 Fr  9682/03 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.07.2003
50 eingetragen am 08.01.2004                  Geschäftsfall  27 Fr 16089/03 m
Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.12.2003
52 eingetragen am 17.09.2004                  Geschäftsfall  47 Fr   572/04 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.07.2004
53 eingetragen am 21.09.2004                  Geschäftsfall  47 Fr   574/04 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.07.2004
54 eingetragen am 30.09.2004                  Geschäftsfall  47 Fr   576/04 f
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.07.2004
56 eingetragen am 17.11.2004                  Geschäftsfall  47 Fr  2881/04 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 15.11.2004
58 eingetragen am 17.08.2005                  Geschäftsfall  47 Fr  4573/05 t
Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.08.2005
60 eingetragen am 18.05.2006                  Geschäftsfall  47 Fr  3316/06 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.05.2006
62 eingetragen am 04.08.2007                  Geschäftsfall  47 Fr  2092/07 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.07.2007
67 eingetragen am 01.09.2010                  Geschäftsfall  47 Fr  3081/10 t
Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.08.2010
69 eingetragen am 27.01.2011                  Geschäftsfall  47 Fr     8/11 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.01.2011
71 eingetragen am 30.05.2012                  Geschäftsfall  47 Fr  5270/12 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.05.2012
72 eingetragen am 17.07.2012                  Geschäftsfall  47 Fr  5899/12 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.06.2012
74 eingetragen am 26.01.2013                  Geschäftsfall  47 Fr 10757/12 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.12.2012
75 eingetragen am 26.01.2013                  Geschäftsfall  47 Fr    50/13 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.01.2013
76 eingetragen am 22.03.2013                  Geschäftsfall  47 Fr  1283/13 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.03.2013
77 eingetragen am 13.06.2013                  Geschäftsfall  47 Fr  2456/13 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 06.06.2013
82 eingetragen am 08.07.2015                  Geschäftsfall  47 Fr  2068/15 x
Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.07.2015
83 eingetragen am 06.10.2015
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 24.08.2015

 

 

Historical development

 

Year of incorporation

1947

Date of registration

1969-12-30

 

 

Change of company name

 

from

to

company name

 

1999-03-25

Fresenius Pharma Austria GmbH

1999-03-25

 

Fresenius Kabi Austria GmbH

 

 

Change in share capital

 

from

to

asset

 

 

2004-09-17

ATS

45.000.000,00

2004-09-17

 

EUR

3.500.000,00

 

 

Former executives

 

from

to

position

name

1997-06-25

1998-01-27

manager

Dr. Hans Jahnel

 

1998-01-27

manager

Erwin Tumeltshamer

 

2002-07-24

manager

Mag.rer.soc.oec. Horst Koch

1997-06-25

2002-10-19

manager

Mag.pharm. Karin Schaupp

2001-02-07

2002-07-24

joint signing clerk

Oskar Haszonits

1998-01-27

2001-08-03

chairman of the supervisory board

Dr. Hans Jahnel

1999-07-15

2001-08-03

member of the supervisory board

Christer Mats Henriksson

2004-11-17

2005-08-17

member of the supervisory board

Dr. Michael Schönhofen

 

1997-07-04

joint signing clerk

Ing. Johann Teichmann

 

1998-01-27

joint signing clerk

Dr. Hermann Markut

 

2000-10-11

joint signing clerk

Dipl-Ing. Gerold Lorenz

1999-03-24

2003-05-31

joint signing clerk

Dr. Gerhard Greier

 

1999-07-15

member of the supervisory board

Dr. Gerhard Greier

1997-06-25

2006-05-18

joint signing clerk

Edwin Rant

 

1997-07-04

member of the supervisory board

Mag.rer.soc.oec Axel Clodi

1999-07-15

1999-11-30

member of the supervisory board

Paul Critchlow

1999-07-15

1999-12-24

member of the supervisory board

Heinz Ernetzl

1998-01-27

1999-12-24

member of the supervisory board

Heinz Henrici

1999-11-30

2001-08-03

member of the supervisory board

Marc Crouton

1999-07-07

2001-11-10

member of the supervisory board

Gertraud Schörgenhumer

2004-11-17

2010-09-01

member of the supervisory board

Dr. Ulf Markus Schneider

2001-11-10

2002-07-31

employee's representative on the supervisory board

Heimo Messerschmidt

2008-07-03

2015-05-05

member of the supervisory board

Manfred Michael Köhler

1997-10-25

2013-03-22

manager

Dr. Rudolf Dax

 

1997-09-16

joint signing clerk

Mag. Bernhard Lotz

1997-06-25

1998-01-27

joint signing clerk

Dr. Herwig Prieler

1997-06-25

1998-01-27

joint signing clerk

Dkfm. Martin Ludwig Weber

 

2001-02-07

joint signing clerk

Heinz Tindl

1997-10-04

2001-08-03

deputy chairman of the supervisory board

Dr. Matthias Schmidt

1997-05-06

1998-01-27

chairman of the supervisory board

Dr. Burghard Weidler

1997-05-06

1999-11-30

member of the supervisory board

Friedrich Meyer

1998-01-27

1999-11-30

member of the supervisory board

Dr. Burghard Weidler

2003-08-13

2005-04-16

joint signing clerk

Dr. Younous Elalamy

1998-02-24

2013-08-09

joint signing clerk

Dipl-Ing. Karl Heinz Höfler

1998-02-24

1999-12-24

member of the supervisory board

Helmut Kirschner

1990-02-09

1997-05-06

chairman of the supervisory board

Dkfm. Herbert Gschwandtner

2001-08-03

2013-01-26

chairman of the supervisory board

Dipl-Ing. Rainer Baule

2001-08-03

2002-07-31

deputy chairman of the supervisory board

Dkfm. Harald Pinger

2002-07-31

2005-08-17

deputy chairman of the supervisory board

Dkfm. Norbert Koll

 

1997-07-04

member of the supervisory board

Dkfm. Irene Hascha

1997-10-04

1999-07-15

member of the supervisory board

Brigitte Richter

 

2001-11-10

member of the supervisory board

Wilhelm Lauss

2001-11-10

2003-05-31

member of the supervisory board

Dr. Bruno Penz

2003-08-13

2013-01-26

member of the supervisory board

Dr. Bruno Penz

1999-11-30

2004-11-17

member of the supervisory board

Dr. Gerd Edgar Krick

2005-08-17

2008-07-03

member of the supervisory board

Dipl-Ing. Klaus Lothar Walter Mokros

1999-12-24

2012-05-30

member of the supervisory board

Heimo Messerschmidt

 

 

Former shareholders

 

from

to

position

name

birth date

 

1997-03-11

partner

Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft

 

 

1997-03-11

partner

AGRANA Stärke-Gesellschaft m.b.H.

 

1993-03-03

1997-03-11

partner

Bernd Adensamer

1956-07-10

1993-03-03

1997-03-11

partner

Dr. Christian Adensamer

1950-12-19

 

1997-03-11

partner

Egbert Adensamer

1913-01-08

1993-03-03

1997-03-11

partner

Dipl-Ing. Helmut Adensamer

1948-12-04

1993-03-03

1997-03-11

partner

Dr. Martin Adensamer

1954-01-19

 

1997-03-11

partner

Dr. Friedrich Breyer

1939-01-30

1993-03-03

1997-03-11

partner

Mag.rer.soc.oec Axel Clodi

1959-05-09

 

1997-03-11

partner

Elisabeth Fuchshuber

1937-01-30

1993-03-03

1997-03-11

partner

Dkfm. Irene Hascha

1947-07-17

 

1997-03-11

partner

Dr. Herbert Kuhlmann

1916-05-01

1993-03-03

1997-03-11

partner

Dr. Sabine Putze

1959-04-24

 

1997-03-11

partner

Mag. Claudia Riha

1954-04-11

 

1997-03-11

partner

Dr.med. Bernhard Schwaighofer

1957-11-27

 

1997-03-11

partner

Dipl-Ing.Mag. Elisabeth Schwaighofer

1923-06-21

 

1997-03-11

partner

DDr. Gerbert Schwaighofer

1952-12-07

 

1997-03-11

partner

Alfred von Sick

1925-02-27

1994-02-09

1997-07-04

partner

Dr. Arnold Richter

1929-01-15

1994-02-09

1997-07-04

partner

Brigitte Richter

1937-07-07

1994-02-09

1997-07-04

partner

Lukas Richter

1966-02-28

1994-02-09

1997-07-04

partner

Dipl-Ing. Peter Otto Richter

1961-08-07

1994-02-09

1997-07-04

partner

Dr. Thomas Richter

1959-01-22

1999-11-30

2001-03-03

partner

Fresenius Kabi Aktiengesell- schaft

 

1997-07-04

2004-09-17

partner

Laevosan-Pharma-GmbH

 

 

 

Former shareholdings

 

from

to

company name

1994-03-03

1997-07-02

Laevosan-Pharma-GmbH

 

1997-09-16

Frika, Pharmazeutische Fabrik Gesellschaft m.b.H.

2001-12-18

2003-08-13

Calea Austria Healthcare GmbH

 

 

Mergers

 

On

position

name

2004-10-14

merged with

Laevosan-Pharma-GmbH

2003-08-20

merged with

Calea Austria Healthcare GmbH

 

 

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.66.11

UK Pound

1

Rs.100.51

Euro

1

Rs.70.39

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

RAS

 

 

Report Prepared by :

ANK

 


 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.