MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

343633

Report Date :

07.10.2015

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

ROSENDAHL NEXTROM GMBH

 

 

Registered Office :

Schachen 57,  A-8212 Pischelsdorf

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

30.06.2014

 

 

Date of Incorporation :

17.12.1987

 

 

Legal Form :

Limited Liability Company

 

 

Line of Business :

  • Manufacture of plastics and rubber machinery
  • Manufacture of metal forming machinery

 

 

No. of Employee :

300

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory

 

 

Payment Behaviour :

No complaints 

 

 

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31, 2015

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2014)

Current Rating

(31.03.2015)

Austria

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 

AUSTRIA - ECONOMIC OVERVIEW

 

Austria, with its well-developed market economy, skilled labor force, and high standard of living, is closely tied to other EU economies, especially Germany's. Its economy features a large service sector, a relatively sound industrial sector, and a small, but highly developed agricultural sector. Economic growth was anemic at less than 0.5% in 2013 and 2014, and growth in 2015 is not expected to exceed 0.5%. Austria’s 5.6% unemployment rate, while low by European standards, is at an historic high for Austria. Without extensive vocational training programs and generous early retirement, the unemployment rate would be even higher. Public finances have not stabilized even after a 2012 austerity package of expenditure cuts and new revenues. On the contrary, in 2014, the government created a “bad bank” for the troubled nationalized “Hypo Alpe Adria” bank, pushing the budget deficit up by 0.9% of GDP to 2.4% and public debt to 84.5% of the GDP. Although Austria's fiscal position compares favorably with other euro-zone countries, it faces several external risks, such as Austrian banks' continued exposure to Central and Eastern Europe, repercussions from the Hypo Alpe Adria bank collapse, political and economic uncertainties caused by the European sovereign debt crisis, the current crisis in Russia/Ukraine, the recent appreciation of the Swiss Franc, and political developments in Hungary.

 

Source : CIA

Company name and address

 

ROSENDAHL NEXTROM GMBH

 

Schachen 57,  A-8212 Pischelsdorf

 

Phone:

(0043) 3113 5100

Fax:

(0043) 3113 5100 - 59

E-mail:

office@rosendahlaustria.com

Internet:

http://www.rosendahlaustria.com

 

 

Activities

 

ÖNACE 28960 50% Manufacture of plastics and rubber machinery

ÖNACE 28410 50% Manufacture of metal forming machinery

 

 

Financial data

 

Financial details can also be entered during the period, irrespective of the balance sheet date.

 

total turnover (total sales)

2014

EUR

57.050.000,00

(approx.)

total turnover (total sales)

2013

EUR

55.443.825,01

(exact)

total turnover (total sales)

2012

EUR

63.833.660,91

(exact)

total turnover (total sales)

2011

EUR

62.443.770,96

(exact)

total turnover (total sales)

2010

EUR

66.606.145,94

(exact)

 

total investments

2013

EUR

3.956.539,98

(exact)

 

total company vehicles

2015

 

40

(approx.)

 

total employees

2015

 

300

(approx.)

apprentices

2015

 

10

(approx.)

 

 

General company information

 

Company name

Rosendahl Nextrom GmbH

Year of incorporation

1987

Type of company

Manufacturing

Legal form

limited liability company since 1987-12-17

Companies house number

FN 74318 t Graz  since 1987-12-17

Import

European Union

2015

Export

world-wide

2015

ARA-number

3376

VAT number

ATU 19111805

number - Austrian National Bank

506370

Last balance sheet:

2014

Banking connection

Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges.

BLZ 20815

main bank connection

BKS Bank AG

BLZ 17000

secondary banking connection

RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG

BLZ 32000

secondary banking connection

 

 

Locations

 

operational

A-8212 Pischelsdorf, Schachen 57

registered office

operational

A-8212 Pischelsdorf, Schachen 57

registered headquarters, owned property

 

0043 3113 5100

office@rosendahlaustria.com

former

A-2345 Brunn Gebirge, Industriestraße B 15

registered headquarters

former

A-8212 Pischelsdorf, Schachen 57

factory

 

 

Private data

 

Surname

Date of birth

Address

Executive positions

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Ing. Siegfried Altmann

1966-07-15

A-8223 Stubenberg

Zeil 203

manager

0

Gerhard Jakopic

1965-09-05

A-8076 Vasoldsberg

Ferbersdorf 18

manager

0

Ing. Josef Altmayr

1969-05-24

A-8271 Bad Waltersdorf

Wagerberg 163

joint signing clerk

0

Alain Jean- Pierre Giraud

1965-04-15

CH-1030 Bussigny

Route de Sullens 8

joint signing clerk

0

Timo Uolevi Id

1964-04-07

FI-01450 Vantaa

Majavatie 12

joint signing clerk

0

Mag. Richard Jonach

1975-02-02

A-8071 Hausmannstätten

Hangweg 21

joint signing clerk

0

Ing. Johann Jäkel

1962-09-04

A-8273 Ebersdorf

Ebersdorf 273

joint signing clerk

0

Mag. Meinrad Leitner

1959-03-15

A-8312 Ottendorf Rittschein

Ottendorf an der Rittschein 236

joint signing clerk

0

Mag. Werner Zierler

1959-07-30

A-8160 Weiz

Göttelsberg 97

joint signing clerk

2

Georg Knill

1973-01-02

A-8181 St. Ruprecht Raab

Feldgasse 105

chairman of the supervisory board

5

Mag. Christian Knill

1970-01-24

A-8160 Weiz

Eisengasse 24

deputy chairman of the supervisory board

7

Mag. Robert Assl-Pildner-Steinburg

1974-02-19

A-8010 Graz

Geidorfgürtel 28

member of the supervisory board

7

Ernst Hackl

1956-06-28

A-7540 Güssing

Moschendorf 25

member of the supervisory board

0

Manfred Pribek

1964-06-02

A-8212 Pischelsdorf

Rohrbach 20

member of the supervisory board

0

Dipl-Ing. Peter Rötzer

 

A-8212 Pischelsdorf

Schachen 57(c/o)

head of purchasing

0

Gerhard Jakopic

 

A-8212 Pischelsdorf

Schachen 57(c/o)

head of marketing

0

Manfred Gussmagg

 

A-8212 Pischelsdorf

Schachen 57 (c/o)

head of EDP

0

 

 

related companies

 

Company name

Address

Shareholdings in %

Since

Commercial register no.

Shares in this company are held by:

CK Vermögensverwaltungs GmbH

A-8160 Weiz

Eisengasse 25

50 %

2014-11-06

FN 378842 x

GK Betriebs GmbH

A-8181 St. Ruprecht Raab

Feldgasse 105

50 %

2014-11-06

FN 378345 s

 

 

 

 

Affiliated companies and further participations:

Knill Energy Holding GmbH

A-8160 Weiz

Eisengasse 25

 

 

FN 65602 z

 

 

 

Balance Sheet (absolute) all amounts in EUR

 

 

2014-06-30

Goodwill

68.564,41

Franchises, patents, licences, trademarks and similar rights and advantages

1.021.281,25

Sum intangible assets

1.089.845,66

 

Land and leasehold rights with buildings thereon including building on land owned by third parties

3.692.762,55

Other operating and business equipment

902.150,90

Technical plants and machines

1.269.046,00

Advanced payments and constructions in progress

1.871.839,10

Sum tangible assets

7.735.798,55

 

Shares on related firms

1.823.226,99

Other financial assets, values and securities of fixed assets

1.010.154,83

Sum financial assets

2.833.381,82

 

Sum fixed assets

11.659.026,03

 

Raw-, auxiliary materials and supplies

2.842.379,21

Unfinished products

5.117.683,56

Finished products

200.803,88

Advanced payments

1.073.677,49

Received advanced payments for orders

-2.182.584,85

Sum stock

7.051.959,29

 

Claims from delivered goods and performed services

7.499.494,81

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

876.905,87

Other claims and assets

1.658.834,13

Sum claims

10.035.234,81

 

Cash on hand, cheques and bank deposits

2.892.085,64

Sum cash and bank

2.892.085,64

 

Sum current assets

19.979.279,74

 

Deferred charges

124.904,65

Sum deferred charges

124.904,65

Assets

31.763.210,42

 

Subscribed/declared capital

1.500.000,00

Not committed capital reserves

600.000,00

Legal reserves

150.000,00

Balance sheet profit/balance sheet loss

6.687.093,61

Thereof profit/loss carried forward

4.878.671,00

Sum equity capital

8.937.093,61

 

Other reserves before taxes

403.565,86

Sum reserves before taxes

403.565,86

 

Reserves for severance pays

3.557.004,00

Other reserves

5.455.002,54

Sum reserves

9.012.006,54

 

Liabilities against credit institutes

5.669.241,57

Received advanced payments for orders

2.108.887,03

Liabilities from delivered goods and performed services

3.091.498,21

Liabilities against related firms

289.393,88

Other liabilities

2.251.523,72

Sum liabilities

13.410.544,41

 

Liabilities and shareholders'equity

31.763.210,42

Balance sheet sum

31.763.210,42

 

 

 

P / L Account (absolute) all amounts in EUR

 

 

2014-06-30

Gross sales

55.443.825,01

Increase or decrease in finished and unfinished goods and in service claims

602.162,77

Other manufacturing costs capitalized

631.421,66

Total turnover or gross profit

56.677.409,44

 

Profits from retirement of fixed assets, except financial assets

10.083,33

Income from dissolution of reserves

405.430,00

Other operating profits

2.080.779,57

Other operating profits totally

2.496.292,90

 

Costs for obtained services

-1.612.423,44

Material costs

-24.409.932,44

Costs for obtained services totally

-26.022.355,88

 

Wages

-3.756.993,16

Salaries

-11.703.341,91

Costs for severance pays

-616.376,96

Legal fringe benefits and other payments depending on salaries

-4.094.368,17

Other social fringe benefits

-51.913,41

Personnel expenses totally

-20.222.993,61

 

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation

-1.416.734,47

Depreciation tangible assets / intangible assets totally

-1.416.734,47

 

Other operating costs

-9.535.288,49

Total costs

-9.535.288,49

 

Operating result totally

1.976.329,89

 

Income from other securities and loans of financial assets

28.416,03

Interest income, securties income and similar income

189.691,11

Interest and similar disbursements

-121.313,14

Financial profits totally

96.794,00

 

Results from usual business activity totally

2.073.123,89

 

Taxes on income and profits

-279.072,79

Taxes on income and profits totally

-279.072,79

 

Annual surplus/annual deficit totally

1.794.051,10

 

Dissolution reserves before taxes

14.371,51

Reserves movements totally

14.371,51

 

Annual profit/annual loss totally

1.808.422,61

 

Profit and loss carried forward from previous year

4.878.671,00

Transfer of profits totally

4.878.671,00

 

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account

6.687.093,61

 

 

 

Key ratios

 

 

2014

Cashflow II

3.210.785,57

Debt amortisation period in years

5,42

Bank indebtedness

17,84

Equity capital share in %

31,49

Social capital share

11,19

Fixed assets coverage

110,62

Net profit ratio

3,65

Capital turnover

1,78

Return on investment in %

6,90

Cashflow in % of operating performance

5,66

Cashflow I

3.489.858,36

Gross productivity

2,80

Net productivity

1,51

Operating performance

56.677.409,44

Inventories in % of operating performance

12,44

Gross profit

30.655.053,56

 

 

Land Register

 

Last check                   

2015-01-14

 

Entry number

Cadastral community

Journal number

107

Schachen                             ST 68147

7763/2014

 

Section A – type of property:

GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
160       GST-Fläche             11571
Bauf.(10)               2917
Sonst(50)               8654  Schachen 57
162/1     GST-Fläche             17278
Bauf.(10)               7760
Wald(10)                 479
Sonst(50)               9039  Schachen 57
Schachen 58
166/2     GST-Fläche              5953
Wald(10)                3105
Sonst(50)               2848
GESAMTFLAECHE                    34802
Legende:
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude)
Sonst(50): Sonstige (Betriebsflächen)
Wald(10): Wald (Wälder)
2  a gelöscht

Section B – ownership structure:

1 ANTEIL: 1/1
Rosendahl Maschinen GmbH (FN 74318t)
ADR: Schachen 57   8212
b 2322/1999 Kaufvertrag 1999-06-24 Eigentumsrecht

Section C – encumbrances:

2  a 2969/2004 Pfandurkunde 2004-10-29
PFANDRECHT                              Höchstbetrag EUR 1.617.000,--
für Steiermärkische Bank und Sparkassen
Aktiengesellschaft
3  a 3826/2010 Pfandurkunde 2010-12-17
PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 400.000,--
für Steiermärkische Bank und Sparkassen
Aktiengesellschaft (FN 34274 d)
4  a 7763/2014 Pfandurkunde 2014-10-31
PFANDRECHT                              Höchstbetrag EUR 3.000.000,--
für Steiermärkische Bank und Sparkassen
Aktiengesellschaft (FN 34274d)
b 7763/2014 Simultanhaftung mit EZ 39
Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS
Vor dem 01.07.2014 war diese Einlage im Bezirksgericht Gleisdorf
Grundbuch 14.01.2015 14:45:25

 

 

Commercial register

 

firm (style)

48      Rosendahl Nextrom GmbH

legal form

1      Gesellschaft mit beschränkter Haftung

registered office

6      Pischelsdorf in der Steiermark, politische Gemeinde
Pischelsdorf am Kulm

business adress

6      Schachen 57
8212 Pischelsdorf

capital

28      EUR 1.500.000

reference date annual accounts

6      30. Juni

annual accounts

52      zum 30.06.2014 eingereicht am 05.12.2014

power of representation

54      Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen
bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam
oder durch eine/n von ihnen gemeinsam mit einer/einem
Prokuristin/Prokuristen vertreten.
Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere
Geschäftsführer/innen bestellt sind, einzelnen von
ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen.
1   Gesellschaftsvertrag  vom 17.12.1987                                 001
1   Der Gesellschaftsvertrag wurde mehrfach geändert, zuletzt           002
mit Beschluss der Generalversammlung  vom 23.02.1989
Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt Erstens.
1   Verschmelzungsvertrag  vom 09.06.1992                               003
1   Generalversammlungsbeschluss  vom 09.06.1992                        004
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Gepla Holding Gesellschaft m.b.H. und
"Rosendahl" Maschinen
Gesellschaft m.b.H.
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
6   Generalversammlungsbeschluss  vom 28.04.1997                        005
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Punkten Erstens
und Viertens.
14   Gesellschaftsvertrag mit Generalversammlungsbeschluss               007
vom 07.06.2000
gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.
14   Generalversammlungsbeschluss  vom 14.06.2000                        008
Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt "6".
28   Generalversammlungsbeschluss  vom 09.11.2006                        009
Kapitalerhöhung um EUR 750.000,--.
Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt 3.
39   Generalversammlungsbeschluss  vom 19.11.2010                        010
Spaltung zur Aufnahme eines Vermögensteiles der
Knill Liegenschafts GmbH
(FN 36641 i)
und zwar
des Betriebes BACK-TECH
gemäß Spaltungs- und Übernahmsvertrag vom 5.10.2010
48   Generalversammlungsbeschluss  vom 02.07.2014                        013
Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt I.
50   Verschmelzungsvertrag  vom 23.10.2014                               014
50   Generalversammlungsbeschluss  vom 23.10.2014                        015
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Knill Technology Holding GmbH
(FN 67135 d)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Weiz.
54   Generalversammlungsbeschluss  vom 22.12.2014                        017
Neufassung des Gesellschaftsvertrages
54   Generalversammlungsbeschluss  vom 06.02.2015                        018
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Punkt 9.

 

proxy

P   Ing. Josef Altmayr, geb. 24.05.1969
48        vertritt seit 02.07.2014 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
S   Mag. Werner Zierler, geb. 30.07.1959
48        vertritt seit 02.07.2014 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
W   Mag. Meinrad Leitner, geb. 15.03.1959
44        vertritt seit 18.07.2012 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
X   Ing. Johann Jäkel, geb. 04.09.1962
44        vertritt seit 18.07.2012 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
Y   Mag. Richard Jonach, geb. 02.02.1975
44        vertritt seit 18.07.2012 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
AC   Alain Jean-Pierre Giraud, geb. 15.04.1965
49        vertritt seit 26.08.2014 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
AD   Timo Uolevi Id, geb. 07.04.1964
49        vertritt seit 26.08.2014 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen

 

supervisory board

M   Georg Knill, geb. 02.01.1973
44        Vorsitzende/r
U   Manfred Pribek, geb. 02.06.1964
44        Mitglied
V   Ernst Hackl, geb. 28.06.1956
44        Mitglied
AA   Mag. Christian Knill, geb. 24.01.1970
48        Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
AB   Mag. Robert Assl-Pildner-Steinburg, geb. 19.02.1974
48        Mitglied

 

managing director

O   Gerhard Jakopic, geb. 05.09.1965
34        vertritt seit 17.07.2008 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
T   Ing. Siegfried Altmann, geb. 15.07.1966
48        vertritt seit 02.07.2014 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen

 

shareholder

AE   CK Vermögensverwaltungs GmbH
50        ......................  EUR 750.000
50        .................................................  EUR 750.000
AF   GK Betriebs GmbH
50        ......................  EUR 750.000
50        .................................................  EUR 750.000
-------------------------------------------------------
Summen:           EUR 1.500.000              EUR 1.500.000

 

general table

Handelsgericht Wien
1 Ersterfassung abgeschlossen am 19.01.1994  Geschäftsfall 904 Fr   213/94 k
Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
Landesgericht für ZRS Graz
6 eingetragen am 26.06.1997                  Geschäftsfall  27 Fr  3200/97 m
Antrag auf Sitzverlegung  eingelangt am 23.05.1997
13 eingetragen am 30.06.2000                  Geschäftsfall  27 Fr  4240/00 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.05.2000
14 eingetragen am 05.07.2000                  Geschäftsfall  27 Fr  5237/00 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.06.2000
19 eingetragen am 24.09.2002                  Geschäftsfall  27 Fr 11005/02 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.09.2002
21 eingetragen am 31.05.2003                  Geschäftsfall  27 Fr  6885/03 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.05.2003
28 eingetragen am 06.02.2007                  Geschäftsfall  47 Fr  6153/06 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.11.2006
34 eingetragen am 08.08.2008                  Geschäftsfall  47 Fr  3221/08 f
Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.07.2008
39 eingetragen am 17.03.2011                  Geschäftsfall  47 Fr  5183/10 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.12.2010
41 eingetragen am 11.05.2011                  Geschäftsfall  47 Fr   614/11 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.02.2011
44 eingetragen am 01.09.2012                  Geschäftsfall  47 Fr  7144/12 i
Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.07.2012
48 eingetragen am 10.07.2014                  Geschäftsfall  47 Fr  2661/14 i
Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.07.2014
49 eingetragen am 03.09.2014                  Geschäftsfall  47 Fr  3514/14 p
Antrag auf Änderung  eingelangt am 27.08.2014
50 eingetragen am 06.11.2014                  Geschäftsfall  47 Fr  5660/14 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.10.2014
52 eingetragen am 19.12.2014                  Geschäftsfall  47 Fr  6190/14 z
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 05.12.2014
54 eingetragen am 18.03.2015                  Geschäftsfall  47 Fr   683/15 i
amtswegige Berichtigung

 

 

 

Historical development

 

Year of incorporation

1987

Date of registration

1987-12-17

 

 

Change of company name

 

from

to

company name

 

2014-07-10

Rosendahl Maschinen GmbH

2014-07-10

 

Rosendahl Nextrom GmbH

 

 

Change in share capital

 

from

to

asset

 

 

2000-07-05

ATS

500.000,00

2000-07-05

2007-02-06

EUR

750.000,00

2007-02-06

 

EUR

1.500.000,00

 

 

Former executives

 

from

to

position

name

 

1997-06-26

manager

Dipl-Ing. Bernd Klein

1997-06-26

2000-06-30

manager

Ing.Mag. Günter Kleinrath

2000-06-30

2005-06-16

manager

Georg Knill

2001-03-02

2008-08-08

manager

Ing. Siegfried Altmann

2008-08-08

2014-07-10

manager

Ing. Josef Altmayr

2011-03-17

2012-08-30

manager

Ing. Siegfried Altmann

2011-03-17

2012-08-30

manager

Mag. Werner Zierler

1998-06-11

2001-03-02

joint signing clerk

Ing. Siegfried Altmann

2003-05-31

2008-08-08

joint signing clerk

Ing. Josef Altmayr

2002-09-24

2008-08-08

joint signing clerk

Gerhard Jakopic

 

2014-07-10

deputy chairman of the supervisory board

Ing. Siegfried Altmann

 

2014-07-10

member of the supervisory board

Mag. Werner Zierler

2000-10-19

2006-10-03

manager

Dipl-Ing. Johann Werl

2007-10-16

2009-12-27

manager

Ing. Siegfried Tieber

2011-03-17

2011-04-09

manager

Ing. Josef Altmayr

1998-06-11

1998-10-17

joint signing clerk

Dipl-Ing. Sven Wolf

1997-11-08

2000-06-30

joint signing clerk

Mag. Arnold Tanzmayr

1997-06-26

1997-11-08

joint signing clerk

Dipl-Ing. Rudolf Pretzenbacher

 

2013-09-12

joint signing clerk

Dipl-Ing. Johann Lomsek

1997-06-26

1998-06-11

joint signing clerk

Ing. Alvin Rottmann

2008-04-21

2010-08-25

joint signing clerk

MBA. Maria Kober

1997-06-26

2007-10-16

joint signing clerk

Erich Tobisch

 

 

Former shareholders

 

from

to

position

name

birth date

1996-11-13

1997-06-26

partner

kabelmetal electro Gesellschaft m.b.H.

 

1996-11-13

1997-06-26

partner

Frisch Kabel- und Verseilmaschinenbau GmbH

 

1997-06-26

1999-06-12

partner

Gunther Knill

1941-05-01

1997-06-26

2014-11-06

partner

Knill Technology Holding GmbH

 

 

 

Former shareholdings

 

from

to

company name

 

1992-06-09

Gepla Holding Gesellschaft m.b.H.

 

1992-08-17

"Rosendahl" Maschinen Gesellschaft m.b.H.

 

 

Mergers

 

On

position

name

2014-11-06

merged with

Knill Technology Holding GmbH

2001-03-28

merged with

"Rosendahl" Maschinen Gesellschaft m.b.H.

 

 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.65.39

UK Pound

1

Rs.99.05

Euro

1

Rs.73.19

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

DIV

 

 

Report Prepared by :

ASH

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.