MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

344592

Report Date :

17.10.2015

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA

 

 

Registered Office :

Av Emile Et Claude Puzenat, 71140 Bourbon Lancy

 

 

Country :

France

 

 

Date of Incorporation :

May 1989

 

 

Com. Reg. No.:

350 693 586

 

 

Legal Form :

Public Limited Company with Board of Directors

 

 

Line of Business :

Subject is manufacture of motor vehicles

 

 

No. of Employee :

1000 to 1999

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

B

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

Small

 

Status :

Moderate

 

 

Payment Behaviour :

Unknown

 

 

Litigation :

Clear

 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31, 2015

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2014)

Current Rating

(31.03.2015)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 

FRANCE - ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With more than 84 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that mitigate economic inequality. France's real GDP increased by 0.4% in 2014. The unemployment rate (including overseas territories) increased from 7.8% in 2008 to 10.4% in the fourth quarter of 2014. Youth unemployment in metropolitan France decreased from a high of 25.4% in the fourth quarter of 2012 to 24.3% in the fourth quarter of 2014. Lower-than-expected growth and high spending have strained France's public finances. The budget deficit rose sharply from 3.3% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 4% of GDP in 2014, while France's public debt rose from 68% of GDP to more than 95% in 2014, and may hit 100% by 2016. Elected on a conventionally leftist platform, President Francois HOLLANDE surprised and angered many supporters with a January 2014 speech announcing a sharp change in his economic policy, recasting himself as a liberalizing reformer. The government's budget for 2014 shifted the balance of fiscal consolidation from taxes to a total of $24 billion in spending cuts. In December 2014, HOLLANDE announced additional reforms, including a plan to extend commercial business hours, liberalize professional services, and sell off $6.2-12.4 billion in state owned assets. France’s tax burden remains well above the EU average and income tax cuts over the past decade are being partly reversed, particularly for higher earners. The top rate of income tax is 41%. The government is allowing a 75% payroll tax on salaries over $1.24 million to lapse.

 

Source : CIA

 

Company name

 

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA

 

 

Establishment Details

 

SIRET

350 693 586 00025

Name

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA

Acronym

-

Trade name

-

Status

Economically active

Postal Address

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA
AV EMILE ET CLAUDE PUZENAT
71140 BOURBON LANCY

Share Capital

73,444,960 Euros

Telephone

03 85 89 40 00

Activity (APE)

Manufacture of motor vehicles (2910Z)

RCS Registration

RCS Nevers B 350 693 586

Formation Date

04/1989

EUR VAT Number

FR49350693586

Deregistration Date

-

Last account Date

31/12/2014

Court Registry Number

19 8 9B00130

Incorporiation Date

05/1989

Registration Court

Nevers (58)

Fax

03 85 89 40 46

Nationality

France

 

Legal form

Public limited company with board of directors

Currency

Euros

 

 

Establishment Details

 

Type of Establishment

Secondary Establishment

Production Role

-

APE/NAF Code

2910Z

Activity

Manufacture of motor vehicles

Formation Date

01/2006

Reason for Formation

Contribution

Closure Date

-

Reason for Closure

-

Reactivation Date

-

Seasonality

-

Activity Nature

-

Activity Location

-

Trading Address

AVENUE EMILE ET CLAUDE PUZENAT 
71140 BOURBON LANCY

Department

Saône-et-Loire (71)

Location Surface

-

District

3

City

BOURBON LANCY

Status

Economically active

Business Pages FT®

FABRICATION DE MOTEURS THERMIQUES

Region

Bourgogne

Area

03

Size of Urban Area

-

 

 

Other Establishment(s)

 

Regionality

Legal unit with all establishments in same area

Mono-activity status

Legal unit having all establishments with the same main activity

Branches

4 branch entities in this company

 

 

Company Name

Company Type

APE/NAF Code

Activity

City

Post Code

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA

Head Office

2910Z

Manufacture of motor vehicles

GARCHIZY

58600

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA

Branch

285D

General mechanic

CHASSIEU

69680

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA

Branch

2910Z

Manufacture of motor vehicles

SAINT PRIEST

69800

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA

Branch

2910Z

Manufacture of motor vehicles

BOURBON LANCY

71140

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA

Branch

2910Z

Manufacture of motor vehicles

BOURBON LANCY

71140

 

 

Workforces

 

Workforce at address

Workforce unknown

Company workforce

1 000 to 1 999 employees

 

 

Status history

 

No Status History

Recent publications in Gazettes

 

Publication date

Gazette Name

Description

24/06/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

2126 - 350 693 586 RCS Nevers. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA. Forme : Société anonyme. Administration : Président, Directeur général, Administrateur : ALFARANO Vito Directeur général délégué : GRILLO Leonardo Administrateur : MOSCHENI Guido Administrateur : PISATURO Michele Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS). Activité : 
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

05/05/2015

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

5606 - 350693586 RCS. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SAForme : Société anonyme. Adresse : rue Pierre Timbaud 58600 Garchizy.Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2014.

12/08/2014

Bodacc B

Modification et mutation diverse

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

1959 - 350 693 586 RCS Nevers. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA. Forme : Société anonyme. Administration : Président, Directeur général, Administrateur : ALFARANO Vito Directeur général délégué : GRILLO Leonardo Administrateur : MOSCHENI Guido Administrateur : PISATURO Michèle Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS). Activité : 
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

30/07/2014

JAL

Appointment of the social representative

Echo charitois (L )


Date de décision : 26/06/2014
Société faisant l'objet d'une nomination : 350693586 - FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA, 5 RUE PIERRE TIMBAUD, BP 49, 58600 GARCHIZY 
Nominé : Monsieur Michele PISOTURO, 86039 TERMOLI CAMPOBASSO
En la fonction de : Administrateur

30/07/2014

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Echo charitois (L )


Date de décision : 26/06/2014
La société 350693586 - FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA, 5 RUE PIERRE TIMBAUD, BP 49, 58600 GARCHIZY 
Fait l'objet du départ de Madame Luisa FENOGLIO, Via Lambruschini 1, 10143, TORINO

30/04/2014

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

6375 - 350693586 RCS. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SAForme : Société anonyme. Adresse : rue Pierre Timbaud 58600 Garchizy.Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2013.

20/02/2014

Bodacc B

Modification et mutation diverse

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

920 - 350 693 586 RCS Nevers. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA. Forme : Société anonyme. Administration : Président, Directeur général, Administrateur : ALFARANO Vito Directeur général délégué : GRILLO Leonardo Administrateur : MOSCHENI Guido Administrateur : FENOGLIO Luisa Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS). Activité : 
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

30/01/2014

JAL

Appointment of the social representative

Echo charitois (L )


Date de décision : 14/01/2014
Société faisant l'objet d'une nomination : 350693586 - FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA, 5 RUE PIERRE TIMBAUD, BP 49, 58600 GARCHIZY 
Nominé : Monsieur Leonardo GRILLO, CINISELLO BALSAMO

30/01/2014

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Echo charitois (L )


Date de décision : 14/01/2014
La société 350693586 - FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA, 5 RUE PIERRE TIMBAUD, BP 49, 58600 GARCHIZY 
Fait l'objet du départ de Monsieur Giovanni BRUNETTI, DON L. MINZONI N.23, CORTE FRANCA BS

12/01/2014

Bodacc B

Modification et mutation diverse

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

1095 - 350 693 586 RCS Nevers. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA. Forme : Société anonyme. Administration : Président, Directeur général, Administrateur : ALFARANO Vito Directeur général délégué : BRUNETTI Giovanni Administrateur : MOSCHENI Guido Administrateur : FENOGLIO Luisa Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS). Activité : 
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

19/12/2013

JAL

Appointment of the social representative

Echo charitois (L )


Date de décision : 23/10/2013
Société faisant l'objet d'une nomination : 350693586 - FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA, 5 RUE PIERRE TIMBAUD, BP 49, 58600 GARCHIZY 
Nominé : Monsieur Luisa FENOGLIO, 10143 TORINO
En la fonction de : Administrateur

19/12/2013

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Echo charitois (L )


Date de décision : 23/10/2013
La société 350693586 - FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA, 5 RUE PIERRE TIMBAUD, BP 49, 58600 GARCHIZY 
Fait l'objet du départ de Monsieur Vittorio ALFARANO, via Enrico Toti 14, 72015, FASANO

10/06/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

6975 - 350693586 RCS. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SAForme : Société anonyme. Adresse : rue Pierre Timbaud 58600 Garchizy.Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2012.

09/05/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

7642 - 350693586 RCS. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SAForme : Société anonyme. Adresse : rue Pierre Timbaud 58600 Garchizy.Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011.

05/02/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

962 - 350 693 586 RCS Nevers. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA. Forme : Société anonyme. Administration : Président directeur général et administrateur : ALFARANO Vito Directeur général délégué : BRUNETTI Giovanni Administrateur : NOTARI Vittorio Administrateur : MOSCHENI Guido Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX. Activité : 
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

26/01/2012

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Echo charitois (L )


Date de décision : 11/01/2012
La société 350693586 - FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA, 5 RUE PIERRE TIMBAUD, BP 49, 58600 GARCHIZY 
Fait l'objet du départ de Monsieur Luigi SABATO

26/01/2012

JAL

Appointment of the social representative

Echo charitois (L )


Date de décision : 11/01/2012
Société faisant l'objet d'une nomination : 350693586 - FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA, 5 RUE PIERRE TIMBAUD, BP 49, 58600 GARCHIZY 
Nominé : Monsieur Giovanni BRUNETTI, CORTE FRANCA BS

28/07/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

549 - 350 693 586 RCS Nevers. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA. Forme : Société anonyme. Administration : Président directeur général et administrateur : ALFARANO Vito Directeur général délégué : SABATO Luigi Administrateur : NOTARI Vittorio Administrateur : MOSCHENI Guido Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG Commissaire aux comptes suppléant : BEAS Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX. Activité : 
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

09/06/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

1088 - 350 693 586 RCS Nevers. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA. Forme : Société anonyme. Administration : Président directeur général et administrateur : ALFARANO Vito Directeur général délégué : SABATO Luigi Administrateur : NOTARI Vittorio Administrateur : MOSCHENI Guido Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Activité : 
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

31/05/2011

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

8165 - 350693586 RCS. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SAForme : Société anonyme. Adresse : rue Pierre Timbaud 58600 Garchizy.Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2010.

02/05/2011

JAL

Appointment of the social representative

02/05/2011

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Centre Officielles (La Montagne, Le Populaire du Centre, Le journal du Centre, l'Eveil, Le Journal, L'Eveil de la Haute Loire)


Date de décision : 10/03/2011
La société 350693586 - FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA, 5 RUE PIERRE TIMBAUD, BP 49, 58600 GARCHIZY 
Fait l'objet du départ de Date d'effet : 10/03/2011

26/10/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

533 - 350 693 586 RCS Nevers. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA. Forme : Société anonyme. Administration : Président directeur général : DI BUONO Nicola Directeur général délégué : SABATO Luigi Administrateur : NOTARI Vittorio Administrateur : LUISE Giovanni Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. 
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

26/05/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

6407 - 350693586 RCS. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SAForme : Société anonyme. Adresse : rue Pierre Timbaud 58600 Garchizy.Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

04/04/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

320 - 350 693 586 RCS Nevers. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA. Forme : Société anonyme. Administration : Président directeur général : DI BUONO Nicola Directeur général délégué : VENDANGE Christian, Luc Administrateur : NOTARI Vittorio Administrateur : LUISE Giovanni Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. 
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

18/03/2010

JAL

Appointment of the social representative

L'ECHO CHARITOIS


Société faisant objet d'une nomination : 350693586 - FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA, 5 RUE PIERRE TIMBAUD, BP 49, 58600 GARCHIZY 
Nominé : Monsieur Giovanni LUISE
En la fonction de : Administrateur

18/03/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

L'ECHO CHARITOIS


Date de décision : 10/02/2010
La société 350693586 - FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA, 5 RUE PIERRE TIMBAUD, BP 49, 58600 GARCHIZY 
Fait l'objet du départ de Monsieur Fabrizio SAL VATICO 

08/09/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

388 - 350 693 586 RCS Nevers. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA. Forme : Société anonyme. Administration : Président : DI BUONO Nicola Directeur général délégué : VENDANGE Christian Luc Administrateur : NOTARI Vittorio Administrateur : SALVATICO Fabrizio Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. 
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

17/06/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

4876 - 350693586 RCS. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SAForme : Société anonyme. Adresse : rue Pierre Timbaud 58600 Garchizy.Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

24/12/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

1301 - 350 693 586 RCS Nevers. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA. Forme : Société anonyme. Administration : Président directeur général : GRILLO Leonardo. Directeur général délégué : PICCIONI Mario. Administrateur : NOTARI Vittorio. Administrateur : SALVATICO Fabrizio. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. 
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

12/07/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

58 - NIEVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

4436 - 350693586 RCS. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SAForme : Société anonyme. Adresse : rue Pierre Timbaud 58600 Garchizy.Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

23/10/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

2298 - RCS Nevers B 350 693 586. RC 89-B 130. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : rue Jean-Pierre-Timbaud,, 58600 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président directeur général : GRILLO (Leonardo) (Nom d'usage : GRILLO). Directeur général délégué : MINIACI (Damiano) (Nom d'usage : MINIACI). Administrateurs : NOTARI (Vittorio) (Nom d'usage : NOTARI) SALVATICO (Fabrizio) (Nom d'usage : SALVATICO). Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Date d'effet : 11 juillet 2007.

04/10/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

6074 - 350 693 586. RCS Nevers FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA. Forme: Société anonyme. Adresse du siège social: rue Pierre Timbaud 58600 Garchizy. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

03/08/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

847 - RCS Nevers B 350 693 586. RC 89-B 130. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : rue Jean-Pierre-Timbaud,, 58600 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président directeur général : GRILLO (Leonardo) (Nom d'usage : GRILLO). Directeur général délégué : MINIACI (Damiano) (Nom d'usage : MINIACI). Administrateurs : CHOPIN (Jean-François) (Nom d'usage : CHOPIN) NOTARI (Vittorio) (Nom d'usage : NOTARI). Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Date d'effet : 15 novembre 2006.

13/07/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

3358 - RCS Nevers B 350 693 586. RC 89-B 130. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA. Forme: S.A. Adresse du siège social: rue Pierre Timbaud,58600 Garchizy. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

31/05/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

0978 - RCS Nevers B 350 693 586. RC 89-B 130. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : rue Jean-Pierre-Timbaud,, 58600 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président directeur général : GRILLO (Leonardo) (Nom d'usage : GRILLO). Directeur général délégué : MINIACI (Damiano) (Nom d'usage : MINIACI). Administrateurs : CHOPIN (Jean-François) (Nom d'usage : CHOPIN) MEDICI (Gianfranco) (Nom d'usage : MEDICI). Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Date d'effet : 16 février 2006.

09/04/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1424 - RCS Nevers B 350 693 586. RC 89-B 130. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE S.A. Forme : S.A. Capital : 73 444 960 euros. Adresse du siège social : rue Jean-Pierre-Timbaud,, 58600 Commentaires : modification survenue sur la dénomination et le capital (augmentation). Date d'effet : 1er janvier 2006.

09/11/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1388 - RCS Nevers B 350 693 586. RC 89-B 130. EUROMOTEURS S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : rue Jean-Pierre-Timbaud,, 58600 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président directeur général : GRILLO (Leonardo) (Nom d'usage : GRILLO). Directeur général délégué : MINIACI (Damiano) (Nom d'usage : MINIACI). Administrateurs : CHOPIN (Jean-François) (Nom d'usage : CHOPIN) KASAK (Frédéric) (Nom d'usage : KASAK) CHECCHIN (Fabio) (Nom d'usage : CHECCHIN) CUONZO (Domenico) (Nom d'usage : CUONZO). Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Date d'effet : 21 juillet 2005.

30/10/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

3815 - RCS Nevers B 350 693 586. RC 89-B 130. EUROMOTEURS S.A.. Forme: S.A. Adresse du siège social: rue Pierre Timbaud,58600 Garchizy. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

09/08/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

997 - RCS Nevers B 350 693 586. RC 89-B 130. EUROMOTEURS S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : rue Jean-Pierre-Timbaud,, 58600 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président directeur général : CHAUVEAU (Claude) (Nom d'usage : CHAUVEAU). Directeur général et membre du directoire : MINIACI (Damiano) (Nom d'usage : MINIACI). Administrateurs : CHOPIN (Jean-François) (Nom d'usage : CHOPIN) KASAK (Frédéric) (Nom d'usage : KASAK) CHECCHIN (Fabio) (Nom d'usage : CHECCHIN) SCHIPILLITI (Gianluigi) (Nom d'usage : SCHIPILLITI). Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Date d'effet : 10 mars 2005.

09/08/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

998 - RCS Nevers B 350 693 586. RC 89-B 130. EUROMOTEURS S.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : rue Jean-Pierre-Timbaud,, 58600 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président directeur général : CHAUVEAU (Claude) (Nom d'usage : CHAUVEAU). Directeur général et membre du directoire : MINIACI (Damiano) (Nom d'usage : MINIACI). Administrateurs : CHOPIN (Jean-François) (Nom d'usage : CHOPIN) KASAK (Frédéric) (Nom d'usage : KASAK) CHECCHIN (Fabio) (Nom d'usage : CHECCHIN) SCHIPILLITI (Gianluigi) (Nom d'usage : SCHIPILLITI). Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Date d'effet : 4 mai 2005.

03/08/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nevers B 350693586 RC 89-B 130 EUROMOTEURS. Forme : S.A. Capital : 2 098 560 euros. Adresse du siège social : rue Jean-Pierre-Timbaud, 58600 Garchizy. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation). Date d'effet : 26 mai 2004.

25/03/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nevers B 350693586 RC 89-B 130 EUROMOTEURS. Forme : S.A. Adresse du siège social : rue Jean-Pierre-Timbaud, 58600 Garchizy. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président directeur général : CHAUVEAU (Claude) ( Nom d' usage : CHAUVEAU). Directeur général délégué et administrateur : MICHAUD ( Christophe) ( Nom d'usage : MICHAUD). Administrateurs : CHOPIN (Jean-François) ( Nom d'usage : CHOPIN) CUONZO ( Domenico) ( Nom d'usage : CUONZO) KASAK (Frédéric) ( Nom d'usage : KASAK) CHECCHIN (Fabio) ( Nom d'usage : CHECCHIN). Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Date d'effet : 29 octobre 2003.

19/12/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nevers B 350693586 RC 89-B 130 EUROMOTEURS. Forme : S.A. Adresse du siège social : rue Jean-Pierre-Timbaud, 58600 Garchizy. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président directeur général : CHAUVEAU (Claude) ( Nom d' usage : CHAUVEAU). Directeur général délégué et administrateur : MICHAUD ( Christophe) ( Nom d'usage : MICHAUD). Administrateurs : CHOPIN (Jean-François) ( Nom d'usage : CHOPIN) COPINOT ( Jean-Louis) ( Nom d'usage : COPINOT) CUONZO (Domenico) ( Nom d'usage : CUONZO) KASAK (Frédéric) ( Nom d' usage : KASAK). Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Date d'effet : 30 avril 2003.

12/03/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nevers B 350693586 RC 89-B 130 EUROMOTEURS. Forme : S.A. Capital : 915 000 euros. Adresse du siège social : rue Jean- Pierre-Timbaud, 58600 Garchizy. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : P.-D.G. CHOPIN (Jean-François) ( Nom d'usage : CHOPIN). Administrateurs : COPINOT ( Jean-Louis) ( Nom d'usage : COPINOT) CUONZO (Domenico) ( Nom d'usage : CUONZO) KASAK (Frédéric). Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Date d'effet : 2 octobre 2002.

24/09/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nevers B 350693586 RC 89-B 130 EUROMOTEURS. Forme : S.A. Capital : 915 000 euros. Adresse du siège social : rue Jean- Pierre-Timbaud, 58600 Garchizy. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d'administration : CHOPIN (Jean-François) ( Nom d'usage : CHOPIN). Administrateurs : COPINOT ( Jean-Louis) ( Nom d'usage : COPINOT) CUONZO (Domenico) ( Nom d'usage : CUONZO) KASAK (Frédéric). Commissaire aux comptes titulaire : STE BARBIER FRINAULT ET AUTRES. Commissaire aux comptes suppléant : JOUANNE (Pierre) ( Nom d'usage : JOUANNE). Date d'effet : 23 avril 2002.

12/02/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nevers B 350693586 RC 89-B 130 EUROMOTEURS S.A. Forme : S.A. Capital : 915 000 euros. Adresse du siège social : rue Jean-Pierre-Timbaud, 58600 Garchizy. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation). Date d'effet : 23 octobre 2001.

16/01/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nevers B 350693586 RC 89-B 130 EUROMOTEURS. Forme : S.A. Capital : 6 000 000 de F. Adresse du siège social : rue Pierre-Timbaud, 58600 Garchizy. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d'administration : CHOPIN (Jean-François) ( Nom d'usage : CHOPIN). Administrateurs : COPINOT ( Jean-Louis) ( Nom d'usage : COPINOT) DELOGER (Gilles) ( Nom d'usage : DELOGER) CUONZO (Domenico) ( Nom d' usage : CUONZO). Commissaire aux comptes titulaire : STE BARBIER FRINAULT ET AUTRES. Commissaire aux comptes suppléant : JOUANNE (Pierre) ( Nom d'usage : JOUANNE). Date d'effet : 3 octobre 2001.

07/12/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nevers B 350693586 RC 89-B 130 EUROMOTEURS. Forme : S.A. Capital : 6 000 000 de F. Adresse du siège social : rue Pierre-Timbaud, Garchizy, 58600 Fourchambault. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : président du conseil d'administration : CHOPIN (Jean-François) ( Nom d'usage : CHOPIN). Administrateurs : PIQUET ( Gérard) ( Nom d'usage : PIQUET) COPINOT (Jean-Louis) ( Nom d'usage : COPINOT) DELOGER (Gilles) ( Nom d' usage : DELOGER) CUONZO (Domenico) ( Nom d'usage : CUONZO). Commissaire aux comptes titulaire : STE BARBIER FRINAULT ET AUTRES. Commissaire aux comptes suppléant : JOUANNE (Pierre) ( Nom d'usage : JOUANNE). Date d'effet : 25 octobre 2000.

23/07/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nevers B 350693586 RC 89-B 130 EUROMOTEURS. Forme : S.A. Capital : 6 000 000 de F. Adresse du siège social : rue Pierre-Timbaud, Garchizy, 58600 Fourchambault. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : président du conseil d'administration : VILLA (Ferruccio, Paolino) ( Nom d' usage : VILLA). Administrateurs : PIQUET (Gérard) ( Nom d'usage : PIQUET) MARELLO (Remo) ( Nom d'usage : MARELLO) COPINOT (Jean-Louis) ( Nom d'usage : COPINOT) DELOGER (Gilles) ( Nom d' usage : DELOGER). Commissaire aux comptes titulaire : STE BARBIER FRINAULT ET AUTRES. Commissaire aux comptes suppléant : JOUANNE (Pierre) ( Nom d'usage : JOUANNE). Date d'effet : 17 mai 2000.

05/04/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nevers B 350693586 RC 89-B 130 EUROMOTEURS. Forme : S.A. Adresse du siège social : rue Pierre-Timbaud, Garchizy, 58600 Fourchambault. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : président du conseil d'administration : VILLA (Ferruccio, Paolino) ( Nom d' usage : VILLA). Administrateurs : PIQUET (Gérard) ( Nom d'usage : PIQUET) MARELLO (Remo) ( Nom d'usage : MARELLO) COPINOT (Jean-Louis) ( Nom d'usage : COPINOT) DELOGER (Gilles) ( Nom d' usage : DELOGER). Commissaire aux comptes titulaire : COOPERS ET LYBRAND AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : GUFFLET (Gilles) ( Nom d' usage : GUFFLET). Date d'effet : 23 février 2000.

21/07/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nevers B 350693586 RC 89-B 130 EUROMOTEURS. Forme : S.A. Adresse du siège social : rue Pierre-Timbaud, Garchizy, 58600 Fourchambault. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : administrateurs : PIQUET (Gérard) ( Nom d'usage : PIQUET) MARELLO (Remo) ( Nom d'usage : MARELLO) COPINOT (Jean- Louis) ( Nom d'usage : COPINOT) DELOGER (Gilles) ( Nom d'usage : DELOGER). Commissaire aux comptes titulaire : COOPERS ET LYBRAND AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : GUFFLET (Gilles) ( Nom d'usage : GUFFLET). Président et administrateur : BRUNO (Pietro) ( Nom d'usage : BRUNO). Date d'effet : 31 mai 1999.

07/11/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nevers B 350 693 586 RC 89-B 130 EUROMOTEURS. Forme : S.A. Capital : 6 000 000 de F (fixe). Adresse du siège social : rue Pierre-Timbauld, Garchizy 58600 Fourchambault. Administration : ancien administrateur : PETRICOLA (Donato) nouvel administrateur : COPINOT (Jean- Louis) ancien commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE DE FRANCE, représentée par : M. YVES MARTIN nouveau commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE COOPERS ET LYBRAND AUDIT ancien commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE FIDULOR nouveau commissaire aux comptes suppléant : GUFFLET (Gilles). Date d'effet : 20 mai 1996.

09/03/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nevers B 350 693 586 RC 89-B 130 EUROMOTEURS. Forme : S.A. Capital : 6 000 000 de F. Adresse du siège social : rue Pierre-Timbauld, Garchizy 58600 Fourchambault. Administration : nomination en qualité de président et administrateur : PIETRO (Bruno), en remplacement de BUSCHINO (Guy), qui reste administrateur. Anciens administrateurs : MARELLO (Rémo) et LOUIS (Daniel). Nouvel administrateur : CONCIA (Giancarlo). Date d'effet : 21 novembre 1995.

20/01/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Nevers B 350693586 RC 89-B 130 S.E.L.E. FRANCE. Forme : S.A. Capital : 6 000 000 F (fixe). Adresse : rue Pierre-Timbauld, Garchizy, 58600 Fourchambault Nouvelle situation du siège social dénomination: EUROMOTEURS. Date d'effet : 30 aout 1995.

29/11/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nevers B 350 693 586 RC 89-B 130 S. E.L.E. FRANCE. Forme : S.A. Capital : 6 000 000 de F (fixe). Adresse du siège social : rue Pierre-Timbauld, Garchizy 58600 Fourchambault. Administration : ancien président-directeur général et administrateur : MOEHLING (Jozef) nouveau président-directeur général et administrateur : BUSCHINO (Guy) anciens administrateurs : BROWN (Richard), WHITING (Paul), WILSON (Robert) nouveaux administrateurs : PIQUET ( Gérard), MARELLO (Rémo), PETRICOLA ( Donato), LOUIS (Daniel). Date d'effet : 30 juin 1995.

 

 

Establishment events history

 

Date

Description

11/12/2007

Update of phone numbers

 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.64.97

UK Pound

1

Rs.100.55

Euro

1

Rs.73.99

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

DIV

 

 

Report Prepared by :

ASH

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.