MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

346397

Report Date :

24.10.2015

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

SPGPRINTS AUSTRIA GMBH

 

 

Registered Office :

Kufsteinerstraße 4 A-6336 Langkampfen

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

31.12.2014

 

 

Date of Incorporation :

1971

 

 

Legal Form :

Limited Liability Company

 

 

Line of Business :

Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production.

 

 

No. of Employee :

102 (Approx.)

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory

 

 

Payment Behaviour :

No complaints

 

 

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31, 2015

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2014)

Current Rating

(31.03.2015)

Austria

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 

 

AUSTRIA ECONOMIC OVERVIEW

 

Austria, with its well-developed market economy, skilled labor force, and high standard of living, is closely tied to other EU economies, especially Germany's. Its economy features a large service sector, a relatively sound industrial sector, and a small, but highly developed agricultural sector. Economic growth was anemic at less than 0.5% in 2013 and 2014, and growth in 2015 is not expected to exceed 0.5%. Austria's 5.6% unemployment rate, while low by European standards, is at an historic high for Austria. Without extensive vocational training programs and generous early retirement, the unemployment rate would be even higher. Public finances have not stabilized even after a 2012 austerity package of expenditure cuts and new revenues. On the contrary, in 2014, the government created a "bad bank" for the troubled nationalized "Hypo Alpe Adria" bank, pushing the budget deficit up by 0.9% of GDP to 2.4% and public debt to 84.5% of the GDP. Although Austria's fiscal position compares favorably with other euro-zone countries, it faces several external risks, such as Austrian banks' continued exposure to Central and Eastern Europe, repercussions from the Hypo Alpe Adria bank collapse, political and economic uncertainties caused by the European sovereign debt crisis, the current crisis in Russia/Ukraine, the recent appreciation of the Swiss Franc, and political developments in Hungary.

 

Source : CIA

 

Company name and address

 

SPGPRINTS AUSTRIA GMBH

Kufsteinerstraße 4

A-6336 Langkampfen

 

Phone:

(0043) 5372 6993

Fax:

(0043) 5372 6993 - 54

E-mail:

austria@spgprints.com

Internet:

http://www.spgprints.com

 

 

Activities

 

ÖNACE 28940 100% Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production

 

 

Financial data

 

Financial details can also be entered during the period, irrespective of the balance sheet date.

 

total turnover (total sales)

2014

EUR

22.000.000,00

(approx.)

total turnover (total sales)

2013

EUR

20.124.000,00

(approx.)

total turnover (total sales)

2012

EUR

17.723.000,00

(approx.)

total turnover (total sales)

2011

EUR

17.779.000,00

(approx.)

total turnover (total sales)

2010

EUR

15.537.000,00

(approx.)

 

total investments

2014

EUR

698.912,75

(exact)

 

total company vehicles

2015

 

10

(approx.)

 

total employees

2015

 

102

(approx.)

white collar workers

2015

 

88

(approx.)

blue collar workers

2015

 

14

(approx.)

 

 

General company information

 

Company name

SPGPrints Austria GmbH

Year of incorporation

1971

Type of company

Manufacturing

Legal form

limited liability company since 1993-12-10

Companies house number

FN 38678 f Innsbruck  since 1971-05-03

Export

world-wide

2015

VAT number

ATU 32274801

number - Austrian National Bank

187933

Last balance sheet:

2014

Banking connection

UniCredit Bank Austria AG

BLZ 12000

main bank connection

 

 

Locations

 

operational

A-6336 Langkampfen, Kufsteiner Straße 4

registered office

operational

A-6336 Langkampfen, Kufsteinerstraße 4, (umben.v.Unterlangkampfen 461)

registered headquarters, owned property

 

0043 5372 6993

austria@spgprints.com

former

A-6336 Langkampfen, Schaftenau, Unterlangkampfen

registered office

former

A-6336 Langkampfen, Unterlangkampfen 461

registered headquarters

 

 

Private data

 

Surname

Date of birth

Address

Executive positions

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Arnoldus Bouwmeester

1976-02-10

NL-5463CB Veghel

Dr. Schaepmanlaan 2

manager

1

Ing. Klaus Kruckenhauser

1964-12-27

A-6336 Langkampfen

Kufsteinerstraße 4(c/o)

joint signing clerk

0

Ing.Dr. Richard Schuster

1970-10-25

A-6600 Reutte

Schoberstadl 22

joint signing clerk

0

 

 

related companies

 

Company name

Address

Shareholdings in %

Since

Commercial register no.

Shares in this company are held by:

Stork Prints B.V.

NL-5831AT Boxmeer

Raamstraat 3

99,9 %

2007-05-16

 

STK Nederland B.V.

NL-1412 Naarden

Amersfoortsestraatweg 7

0,1 %

2004-05-01

32053605

 

 

 

 

Affiliated companies and further participations:

SPGPrints Beteiligungs GmbH

A-1010 Wien

Plankengasse 7

 

 

FN 78775 x

 

 

 

Balance Sheet (absolute) all amounts in EUR

 

 

2014-12-31

Intangible assets

189.118,00

Sum intangible assets

189.118,00

 

Land and leasehold rights with buildings thereon including building on land owned by third parties

1.992.637,28

Other operating and business equipment

649.070,28

Technical plants and machines

687.150,00

Advanced payments and constructions in progress

50.643,00

Sum tangible assets

3.379.500,56

 

Financial assets

103.677,82

Sum financial assets

103.677,82

 

Sum fixed assets

3.672.296,38

 

Stocks

2.465.697,28

Sum stock

2.465.697,28

 

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

1.444.678,01

Other claims and assets

3.228.252,89

Sum claims

4.672.930,90

 

Cash on hand, cheques and bank deposits

1.042.538,91

Sum cash and bank

1.042.538,91

 

Sum current assets

8.181.167,09

 

Deferred charges

60.778,42

Sum deferred charges

60.778,42

Assets

11.914.241,89

 

Subscribed/declared capital

73.000,00

Capital reserves

900.000,00

Profit reserves

7.300,00

Balance sheet profit/balance sheet loss

2.223.123,44

Thereof profit/loss carried forward

374,08

Sum equity capital

3.203.423,44

 

Reserves for severance pays

1.674.000,00

Other reserves

1.718.110,00

Sum reserves

3.392.110,00

 

Liabilities against credit institutes

2.300.010,00

Liabilities against related firms

229.747,69

Other liabilities

2.341.560,24

Sum liabilities

4.871.317,93

 

Deferred income

447.390,52

Sum deferred income

447.390,52

 

Liabilities and shareholders'equity

11.914.241,89

Contingent liabilities

89.867,18

Balance sheet sum

11.914.241,89

 

 

 

P / L Account (absolute) all amounts in EUR

 

 

2014-12-31

Gross profit

13.889.678,14

Total turnover or gross profit

13.889.678,14

 

Income from dissolution of reserves

392.308,00

Other operating profits

442.270,32

Other operating profits totally

834.578,32

 

Wages

-416.066,01

Salaries

-5.389.990,37

Costs for severance pays

-218.587,36

Legal fringe benefits and other payments depending on salaries

-1.562.632,98

Other social fringe benefits

-56.704,49

Personnel expenses totally

-7.643.981,21

 

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation

-903.129,35

Depreciation tangible assets / intangible assets totally

-903.129,35

 

Other operating costs

-3.614.783,68

Other taxes

-26.195,29

Total costs

-3.640.978,97

 

Operating result totally

2.536.166,93

 

Profits from the retirement of and investment in financial assets  and securities of current assets

2.596,83

Interest income, securties income and similar income

185.774,99

Interest and similar disbursements

-23.384,20

Financial profits totally

164.987,62

 

Results from usual business activity totally

2.701.154,55

 

Taxes on income and profits

-478.405,19

Taxes on income and profits totally

-478.405,19

 

Annual surplus/annual deficit totally

2.222.749,36

 

Annual profit/annual loss totally

2.222.749,36

 

Profit and loss carried forward from previous year

374,08

Transfer of profits totally

374,08

 

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account

2.223.123,44

 

 

 

Key ratios

 

 

2014

Cashflow II

3.125.878,71

Debt amortisation period in years

2,31

Bank indebtedness

19,30

Equity capital share in %

26,88

Social capital share

14,05

Fixed assets coverage

132,81

Net profit ratio

0,00

Capital turnover

0,00

Return on investment in %

22,86

Cashflow in % of operating performance

0,00

Cashflow I

3.604.283,90

Gross productivity

0,00

Net productivity

0,00

Operating performance

0,00

Inventories in % of operating performance

0,00

Gross profit

13.889.678,14

 

 

Land Register

 

Last check

2015-08-19

 

Entry number

Cadastral community

Journal number

1163

Langkampfen                          T 83009

2755/2014

 

Section A – type of property:

GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
759/4   G GST-Fläche        *    12284
Bauf.(10)               7174
Sonst(50)               5110  Kufsteiner Straße 8
Kufsteiner Straße 6
Kufsteiner Straße 4
Legende:
G: Grundstück im Grenzkataster
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude)
Sonst(50): Sonstige (Betriebsflächen)
1  a 2555/1990 Eröffnung der Einlage für Gst 759/4 aus EZ 137
2  a 528/2006 Kaufvertrag 2005-09-08 Zuschreibung Teilfläche(n) Gst 759/7
hins 295 m2 aus EZ 137

Section B – ownership structure:

1 ANTEIL: 1/1
Stork Prints Austria GmbH
ADR: Kufsteiner Str. 4, Langkampfen   6336
c 2281/1994 Verschmelzungsvertrag 1993-11-23 und Urkunde 1994-05-16
Eigentumsrecht
d 2169/2004 Namensänderung

Section C – encumbrances:

2  a 1901/1985
DIENSTBARKEIT der Führung, Benützung und Erhaltung eines
unterirdisch verlegten Hochspannungskabels auf Gst 759/4
gem Pkt 1 2 Dienstbarkeitsvertrag 1985-01-31 für Tiroler
Wasserkraftwerke AG
b 2555/1990 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus
EZ 137
3  a 1642/1987
DIENSTBARKEIT der Führung, Benützung und Erhaltung eines
unterirdisch verlegten Hochspannungskabels auf Gst 759/4
gem Abschnitt 1. und 2. des Dienstbarkeitsvertrages
1987-02-17 für Tiroler Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft
b 2555/1990 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus
EZ 137
4  a 2555/1990
DIENSTBARKEIT der Führung und Erhaltung von Ver- und
Entsorgungsleitungen auf Gst 759/4 gem Kaufvertrag
1990-02-28 für EZ 137
8  a 1771/1995
DIENSTBARKEIT der Errichtung, Benützung und Erhaltung einer
Transformatorstation auf Gst 759/4 gemäß Pkt I. a)
Dienstbarkeitsbestellungsvertrag 1994-12-13 für Tiroler
Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft
9  a 1771/1995
DIENSTBARKEIT des Gehens und Fahrens auf Gst 759/4 gemäß
Pkt I. b) Dienstbarkeitsbestellungsvertrag 1994-12-13 für
Tiroler Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft
10  a 544/1999
DIENSTBARKEIT der unterirdischen Verlegung, Benützung und
Erhaltung eines Kabels zur Übertragung von Nachrichten in
Gst 759/4 gemäß Pkt I. Dienstbarkeitsbestellungsvertrag
1999-01-22 für TIWAG-Tiroler Wasserkraftwerke
Aktiengesellschaft
12  a 1771/1995 624/1997
DIENSTBARKEIT des Gehens und Fahrens auf Gst 759/4 (hins
295 m2 lt. Plan TZ 528/2006) gemäß Pkt I. b)
Dienstbarkeitsbestellungsvertrag 1994-12-13 für Tiroler
Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft
b 528/2006 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ
137
13  a 4710/1998 gleichzeitig mit 4708/1998
DIENSTBARKEIT der unterirdischen Verlegung, Benützung und
Erhaltung eines Kabels zur Übertragung von Nachrichten in
Gst 759/4 (hins 295 m2 lt. Plan TZ 528/2006) gemäß Pkt I.
Dienstbarkeitsbestellungsvertrag 1998-10-23 für
TIWAG-Tiroler Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft
b 528/2006 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ
137
14  a 23456/2012
DIENSTBARKEIT der unterirdischen Verlegung, Benützung und
Erhaltung von Starkstromkabeln sowie von Kabeln zur
Übertragung von Nachrichten gem Pkt I.
Dienstbarkeitsbestellungsvertrag 2012-12-03 auf Gst 759/4
für TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG (FN 44133b)
15  a 2755/2014
DIENSTBARKEIT der unterirdischen Verlegung, Benützung und
Erhaltung von Starkstromkabeln sowie von Kabeln zur
Übertragung von Nachrichten in Gst 759/4 gem Punkt I.
Dienstbarkeitsbestellungsvertrages vom 12. 6. 2014 für
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG (FN 44133b)
Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.
Grundbuch 19.08.2015 18:15:15

 

 

Commercial register

 

firm (style)

45      SPGPrints Austria GmbH

legal form

27      Gesellschaft mit beschränkter Haftung

registered office

5      politischer Gemeinde Langkampfen

business adress

23      Kufsteiner Straße 4
6336 Langkampfen

capital

18      EUR 73.000

reference date annual accounts

11      31. Dezember

annual accounts

47      zum 31.12.2014 eingereicht am 23.09.2015

power of representation

27      Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten.
2   Generalversammlungsbeschluss sowie Verschmelzungsvertrag je         003
vom 22.11.1993
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
STK-Leasing Gesellschaft m.b.H.
(FN 54678 i)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Unterlangkampfen.
4   Generalversammlungsbeschluss mit Neufassung der Satzung             005
vom 23.11.1993
Umwandlung der
Schablonentechnik Kufstein
Gesellschaft m.b.H.
(FN 38678 f)
in eine Aktiengesellschaft gemäß §§ 245 ff AktG.
7   Generalversammlungsbeschluss samt Verschmelzungsvertrag je          006
vom 17.11.1994
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Screens Lasertechnologie GmbH
(FN 69886 z)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Langkampfen.
11   Hauptversammlungsbeschluss  vom 12.06.1996                          007
Änderung der Satzung in den §§ 11, 14 und 15.
18   Satzung mit Hauptversammlungsbeschluss  vom 08.06.2000              008
gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 300,-- auf
EUR 73.000,--. Änderung der Satzung in den §§ 2 und 4.
24   Hauptversammlungsbeschluss  vom 02.07.2003                          009
Änderung der Satzung im § 1.
27   Hauptversammlungsbeschluss  vom 02.04.2004                          010
Umwandlung der
Stork Prints Austria AG
(FN 38678 f)
in eine GmbH gemäß §§ 239 ff AktG.
Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
33   Generalversammlungsbeschluss  vom 15.11.2007                        011
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8.
45   Generalversammlungsbeschluss  vom 01.10.2013                        012
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.

 

Proxy

 

W   Ing. Dr. Richard Schuster, geb. 25.10.1970
37        vertritt seit 12.03.2009 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
X   Ing. Klaus Kruckenhauser, geb. 27.12.1964
39        vertritt seit 25.08.2010 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen

 

Managing Director

 

Y   Arnoldus Bouwmeester, geb. 10.02.1976
42        vertritt seit 16.09.2011 selbständig

 

Shareholder

 

S   STK Nederland B.V.
27        .........................    EUR 73
27        ....................................................    EUR 73
U   Stork Prints B.V.
32        .....................    EUR 72.927
32        ................................................    EUR 72.927
------------------------------------------------------
Summen:            EUR 73.000                 EUR 73.000

General Table

 

Landesgericht Innsbruck
1 Ersterfassung abgeschlossen am 20.07.1993  Geschäftsfall 917 Fr   258/93 z
Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
2 eingetragen am 01.12.1993                  Geschäftsfall  19 Fr  4362/93 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.11.1993
4 eingetragen am 10.12.1993                  Geschäftsfall  19 Fr  4448/93 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.11.1993
5 eingetragen am 22.12.1993                  Geschäftsfall  19 Fr  4878/93 s
Berichtigung - Antrag  eingelangt am 17.12.1993
7 eingetragen am 07.12.1994                  Geschäftsfall  19 Fr  5248/94 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.11.1994
11 eingetragen am 26.09.1996                  Geschäftsfall  50 Fr  4695/96 a
Antrag auf Änderung  eingelangt am 10.09.1996
18 eingetragen am 16.09.2000                  Geschäftsfall  61 Fr  2765/00 x
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.08.2000
23 eingetragen am 11.03.2003                  Geschäftsfall  62 Fr   553/03 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.03.2003
24 eingetragen am 10.07.2003                  Geschäftsfall  62 Fr  1281/03 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.07.2003
27 eingetragen am 01.05.2004                  Geschäftsfall  62 Fr   788/04 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.04.2004
32 eingetragen am 16.05.2007                  Geschäftsfall  62 Fr   676/07 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.04.2007
33 eingetragen am 23.11.2007                  Geschäftsfall  62 Fr  2196/07 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.11.2007
37 eingetragen am 25.03.2009                  Geschäftsfall  62 Fr   622/09 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.03.2009
39 eingetragen am 04.09.2010                  Geschäftsfall  62 Fr  1895/10 m
Antrag auf Änderung  eingelangt am 27.08.2010
42 eingetragen am 10.12.2011                  Geschäftsfall  62 Fr  4536/11 f
Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.11.2011
45 eingetragen am 29.10.2013                  Geschäftsfall  62 Fr  4175/13 t
Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.10.2013
47 eingetragen am 01.10.2015
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 23.09.2015

 

 

Historical development

 

Year of incorporation

1971

Date of registration

1971-05-03

 

 

Change of company name

 

from

to

company name

 

2003-07-10

Schablonentechnik Kufstein Aktiengesellschaft

2003-07-10

2004-05-01

Stork Prints Austria AG

2004-05-01

2013-10-29

Stork Prints Austria GmbH

2013-10-29

 

SPGPrints Austria GmbH

 

 

Change of legal form

 

from

to

company name

 

2004-05-01

joint stock company

2004-05-01

 

limited liability company

 

 

Change in share capital

 

from

to

asset

 

 

2000-09-18

ATS

1.000.000,00

2000-09-18

 

EUR

73.000,00

 

 

Former executives

 

from

to

position

name

2002-01-24

2004-04-15

member of the supervisory board

Dirk Wim Joustra

 

2004-05-01

member of the supervisory board

Dr. Andreas Foglar Deinhardstein

1993-12-10

2004-05-01

employee's representative on the supervisory board

Helmut Bodner

2004-04-15

2004-05-01

chairman of the supervisory board

Dirk Wim Joustra

 

2004-05-01

employee's representative on the supervisory board

Ernst Kapfinger

2004-05-01

2011-12-10

manager

Stefan Rückl

2003-02-19

2004-05-01

joint signing clerk

Stefan Rückl

2007-05-16

2008-11-25

joint signing clerk

Rolph Houterman

1998-06-19

1999-02-23

member of the executive board

Antonius Martinus Proos

 

1999-07-30

chairman of the supervisory board

Gerardus Adrianus Christiaanse

1993-12-10

1998-10-02

deputy chairman of the supervisory board

Jhr. Henrick van Lannep

1998-10-02

2004-05-01

deputy chairman of the supervisory board

Alfred van Efferen

 

1998-10-02

member of the supervisory board

Alfred van Efferen

 

2004-06-17

joint signing clerk

Mag. Thilo Werzinger

1998-06-19

1999-02-23

chairman of the executive board

Siegfried Rückl

 

1998-06-19

member of the executive board

Siegfried Rückl

1999-02-23

2004-05-01

member of the executive board

Siegfried Rückl

 

2010-09-04

joint signing clerk

Ewald Pollhammer

1999-07-30

2004-04-15

chairman of the supervisory board

Arvid Manneke

1998-10-02

2001-10-02

member of the supervisory board

Hans Albert Dirk van den Boogaard

 

 

Former shareholders

 

from

to

position

name

2004-05-01

2004-10-05

partner

Stork Laser Technology B.V.

2004-10-05

2007-05-16

partner

Stork N.V.

 

2004-05-01

shareholder

Stork Laser Technology B.V.

 

 

Former shareholdings

 

from

to

company name

 

1993-12-01

STK-Leasing Gesellschaft m.b.H.

1993-09-16

1999-11-12

STK Industrieanlagenleasing Gesellschaft m.b.H.

 

 

 

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.64.88

UK Pound

1

Rs.99.89

Euro

1

Rs.72.06

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

TRI

 

 

Report Prepared by :

ANK

 


 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.