MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

347438

Report Date :

28.10.2015

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

ARKEMA FRANCE

 

 

Registered Office :

420 Rue Estienne D Orves 92700 Colombes

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2014

 

 

Date of Incorporation :

January 1980

 

 

Legal Form :

Public limited company with board of directors

 

 

Line of Business :

Manufacture of other organic basic chemicals.

 

 

No. of Employee :

5 000+ employees

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory

 

 

Payment Behaviour :

Slow but correct

 

 

Litigation :

Clear

 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31, 2015

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2014)

Current Rating

(31.03.2015)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 


 

FRANCE ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With more than 84 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that mitigate economic inequality. France's real GDP increased by 0.4% in 2014. The unemployment rate (including overseas territories) increased from 7.8% in 2008 to 10.4% in the fourth quarter of 2014. Youth unemployment in metropolitan France decreased from a high of 25.4% in the fourth quarter of 2012 to 24.3% in the fourth quarter of 2014. Lower-than-expected growth and high spending have strained France's public finances. The budget deficit rose sharply from 3.3% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 4% of GDP in 2014, while France's public debt rose from 68% of GDP to more than 95% in 2014, and may hit 100% by 2016. Elected on a conventionally leftist platform, President Francois HOLLANDE surprised and angered many supporters with a January 2014 speech announcing a sharp change in his economic policy, recasting himself as a liberalizing reformer. The government's budget for 2014 shifted the balance of fiscal consolidation from taxes to a total of $24 billion in spending cuts. In December 2014, HOLLANDE announced additional reforms, including a plan to extend commercial business hours, liberalize professional services, and sell off $6.2-12.4 billion in state owned assets. France’s tax burden remains well above the EU average and income tax cuts over the past decade are being partly reversed, particularly for higher earners. The top rate of income tax is 41%. The government is allowing a 75% payroll tax on salaries over $1.24 million to lapse.

 

Source : CIA

 

 

Company name and summary

 

Name

ARKEMA FRANCE

Acronym

-

Trade name

-

Status

Economically active

Postal Address

ARKEMA FRANCE
420 RUE ESTIENNE D ORVES
92700 COLOMBES

Share Capital

270,035,923 Euros

Telephone

01 49 00 80 80

Activity (APE)

Manufacture of other organic basic chemicals (2014Z)

RCS Registration

RCS Nanterre B 319 632 790

Formation Date

01/1980

EUR VAT Number

FR32319632790

Deregistration Date

-

Last account Date

31/12/2014

Court Registry Number

19 8 1B00332

Incorporiation Date

02/1957

Registration Court

Nanterre (92)

Fax

-

Nationality

France

Legal form

Public limited company with board of directors

Currency

Euros

 

 

Key Financials

 

Year to date

Turnover

Gross operating surplus

Shareholder's equity

Net result

Employees

31/12/2014

2,585,000,000 €

0.46% Turnover

193,000,000 €

5,000,000 €

5 000+ employees

31/12/2013

2,695,000,000 €

1.67% Turnover

209,000,000 €

-26,000,000 €

5055 employees

31/12/2012

3,240,000,000 €

-2.01% Turnover

206,000,000 €

-100,000,000 €

5 000+ employees

 

 

Trends

 

Profitability

Liquidity

Net Worth

 

 

Directors

 

Current Directors

12

 

 

Ultimate Holding Company

 

Name

Country

Company Number

ARKEMA

445074685

Affiliation links.

95 companies in the international Group Structure from 11 countries.

 

 

Judgment and Preferential

 

Judgment

No judgement

Preferential Right

Last Preferential 14/10/2015

 

 

Establishment Details

 

Type of Establishment

Head Office

Production Role

-

APE/NAF Code

7010Z

Activity

Activities of head offices

Formation Date

06/2007

Reason for Formation

Formation

Closure Date

-

Reason for Closure

-

Reactivation Date

-

Seasonality

-

Activity Nature

-

Activity Location

-

Trading Address

420 RUE ESTIENNE D ORVES
92700 COLOMBES

Department

Hauts-de-Seine (92)

Location Surface

-

District

2

City

COLOMBES

Status

Economically active

Business Pages FT®

PRODUITS CHIMIQUES (FABRICATION, GROS)

Region

Ile-de-France

Area

92

Size of Urban Area

Paris conglomeration

 

 

Ultimate Parent(s)

 

1 ultimate parent company/companies for this company

Company Name

Activity (APE)

APE/NAF Code

City

Post Code

ARKEMA

Activities of head offices

6420Z

COLOMBES

92700

 

 

Other Establishment(s)

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas but no one grouping more than 50% of workforce

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which one activity grouping from 50 to 80% of workforce

Branches

59 branch entities in this company

 

 

Company Name

Company Type

APE/NAF Code

Activity

City

Post Code

ARKEMA FRANCE

Head Office

2014Z

Manufacture of other organic basic chemicals

COLOMBES

92700

ARKEMA FRANCE

Branch

2014Z

Manufacture of other organic basic chemicals

MARSEILLE 8

13008

ARKEMA FRANCE

Branch

2014Z

Manufacture of other organic basic chemicals

PORT DE BOUC

13110

ARKEMA FRANCE

Branch

2014Z

Manufacture of other organic basic chemicals

MARTIGUES

13117

ARKEMA FRANCE

Branch

2014Z

Manufacture of other organic basic chemicals

BERRE L'ETANG

13130

 

 

Workforces

 

Workforce at address

500 to 999 employees

Company workforce

5 000+ employees

 

 

Commentary

 

The comments are ordered according to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative for another or can change depending on its value. This is a purely statistical decision.

 

The shareholder's equity is 193,000,000 €

The creditor days are 49

The liabilities are 3,509,000,000 €

The net current assets are 2,633,000,000 €

The net turnover is 2,585,000,000 €

The risk provisions are 387,000,000 €

The total assets are 4,810,000,000 €

Low risk workforce size

The company has 14 directors

Industry code with low risk rating

Department code with low risk rating

The ratio total assets to total liabilities is 1.23

The stock to turnover ratio is 13.42

The pre-tax profit is -14,000,000 €

The sales to current assets ratio is 0.98

The return on total assets employed is 0

The increase in the gearing percentage over the last two accounting periods is 23 %

Social Security or Tresor Preferential Right detected

 

 

Industry comparison

 

Activity (APE)

Manufacture of other organic basic chemicals (2014Z)

Industry average credit rating

47

Industry average credit limit

234,360

 

 

Collective procedures

 

No judgment information for the company

 

 

Preferential rights details and history

 

SUMMARY OF PREFERENTIAL RIGHTS

 

Company monitored since

14/09/2007

Status of Monitoring

This company is under monitoring with at least one active preferential right

Number of active preferential rights

1

Total amount

3,772,931 EUR

Due remaining amount

3,772,931 EUR

 

 

TAX OFFICE PREFERENTIAL RIGHTS

 

Number of preferential rights

1

Total amount

3,772,931 EUR

Due remaining amount

3,772,931 EUR

Date of last preferential right

14/10/2015

 

 

ACTIVE

 

Registration number

Registration date

Date of the planned end

Creditor

Amount of the debt

Due remaining amount

41500946

14/10/2015

14/10/2019

DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

3,772,931 EUR

3,772,931 EUR

Court

Nanterre

Creditor

DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
8 RUE COURTOIS 93505, PANTIN CEDEX

Debtor

ARKEMA FRANCE
420 RUE ESTIENNE DORVES 92700 COLOMBES, FR

 

 

HISTORICAL

 

Registration number

Registration date

Date of the planned end

Creditor

Amount of the debt

Due remaining amount

41100541

25/05/2011

19/07/2011

DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

432,238 EUR

-

Reason for closure

Crossed Off

Court

Nanterre

Creditor

DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
8 RUE COURTOIS 93505, PANTIN CEDEX

Debtor

ARKEMA FRANCE
420 RUE Estienne d Orves 92700 COLOMBES, FR

41300089

29/01/2013

11/02/2013

SERVICE DES IMPOTS DE PANTIN

908,213 EUR

-

Reason for closure

Crossed Off

Court

Nanterre

Creditor

SERVICE DES IMPOTS DE PANTIN
8 RUE COURTOIS 93505, PANTIN CEDEX

Debtor

ARKEMA FRANCE
420 RUE Estienne d Orves 92700 COLOMBES, FR

 

 

GROUP DATA

 

Ultimate parent company

ARKEMA

Direct parent

ARKEMA - 99.99 %

Group – Number of companies

125

Linkages – Number of companies

95

Number of countries

11

 

 

Name

SIREN

Parts

Last account published

1

ARKEMA

445074685

-

31/12/2013

2

BOSTIK HOLDING SA

445074461

Majority

31/12/2014

3

BOSTIK SA

332110097

100 %

31/12/2014

4

BOSTIK BRASIL ADESIVOS LTDA

-

99.30 %

-

BOSTIK MEXICANA SA DE CV

-

99.90 %

-

BOSTIK FINDLEY (CHINA) CO. LTD

-

100 %

-

BOSTIK BELUX S.A.-N.V. NV

401171808

99.90 %

31/12/2014

BOSTIK NEDERLAND B.V.

20041764

100 %

31/12/2013

BOSTIK ESPAGNE

-

97.19 %

-

BOSTIK FINDLEY SERVICIOS SA DE CV

-

99.90 %

-

BOSTIK FINDLEY DIS TICARET

-

99.90 %

-

SOCIÉTÉ MAROCAINE DES COLLES

-

97 %

-

BOSTIK, INC

-

100 %

-

BOSTIK INDUSTRIES LIMITED

IE015670

100 %

31/12/2013

BOSTIK UNIPESSOAL LDA

-

100 %

-

BOSTIK LIMITED

00068328

100 %

31/12/2014

BOSTIK AB SWEDEN

-

100 %

-

2

ARKEMA AMERIQUES SAS

451658470

99.46 %

31/12/2014

3

ARKEMA CANADA INC.

-

100 %

-

3

ARKEMA DELAWARE INC

-

100 %

-

4

ARKEMA INC

-

100 %

-

5

AMERICAN ACRYL LP

-

50 %

-

AMERICAN ACRYL NA LLC

-

50 %

-

ODOR-TECH LLC

-

100 %

-

NEWSPAR

-

50 %

-

ARKEMA QUIMICA LTDA

-

100 %

-

ARKEMA MEXICO S.A DE C.V

-

100 %

-

MAURIENNE EXPANSION

353043946

3.13 %

31/12/2014

2

ARKEMA ASIE SAS

418681029

59.40 %

31/12/2014

3

ARKEMA K.K.

-

100 %

-

4

ARKEMA YOSHITOMI LTD

-

49 %

-

4

SARTOMER ASIA LTD

-

100 %

-

5

SARTOMER GUANGZHOU CHEMICAL CO LTD

-

100 %

-

3

ARKEMA CHINA INVESTMENT CO LTD

-

100 %

-

4

ARKEMA HYDROGEN PEROXIDE CO LTD SHANGHAI

-

66.70 %

-

ARKEMA CHANGSHU FLUOROCHEMICAL CO., LTD

-

50.80 %

-

CHANGSHU HAIKE CHEMICALS CO LTD

-

49 %

-

ARKEMA CHANGSHU CHEMICALS CO LTD

-

100 %

-

ARKEMA SHANGHAI DISTRIBUTION CO. LTD

-

100 %

-

SHANGHAI ARKEMA GAOYUAN CHEMICALS CO LTD

-

100 %

-

CHANGSHU RESICHINA ENGINEERING POLYMERS CO LTD

-

100 %

-

ARKEMA DAIKIN ADVANCED FLUOROCHEMICALS CO LTD

-

10 %

-

SUZHOU HIPRO POLYMERS CO LTD

-

10 %

-

HEBEI CASDA BIOMATERIALS CO LTD

-

10 %

-

ARKEMA CO LTD

-

100 %

-

ARKEMA CHANGSHU FLUOROCHEMICAL CO., LTD

-

49.20 %

-

DAIKIN ARKEMA REFRIGERANTS ASIA LTD

-

40 %

-

ARKEMA DAIKIN ADVANCED FLUOROCHEMICALS CO LTD

-

50 %

-

SUZHOU HIPRO POLYMERS CO LTD

-

90 %

-

HEBEI CASDA BIOMATERIALS CO LTD

-

90 %

-

NOBLE SYNTHETICS PRIVATE LIMITED

-

100 %

-

2

ARKEMA EUROPE

429608342

34.32 %

31/12/2014

3

ARKEMA B.V.

33133916

100 %

-

4

ARKEMA HOLLAND HOLDING B.V.

33220762

100 %

31/12/2007

ARKEMA GMBH

HRB 29373

80 %

31/12/2014

ARKEMA COATINGS RESINS LTD

-

100 %

-

ARKEMA QUIMICA

117595

99.92 %

31/12/2012

ARKEMA S.R.L.

MI1393516

100 %

31/12/2013

ARKEMA FINANCE NEDERLAND B.V.

27157026

100 %

31/12/2007

2

ARKEMA FRANCE

319632790

99.99 %

31/12/2014

3

ARKEMA AMERIQUES SAS

451658470

0.54 %

31/12/2014

4

ARKEMA CANADA INC.

-

100 %

-

4

ARKEMA DELAWARE INC

-

100 %

-

5

ARKEMA INC

-

100 %

-

6

AMERICAN ACRYL LP

-

50 %

-

AMERICAN ACRYL NA LLC

-

50 %

-

ODOR-TECH LLC

-

100 %

-

NEWSPAR

-

50 %

-

ARKEMA QUIMICA LTDA

-

100 %

-

ARKEMA MEXICO S.A DE C.V

-

100 %

-

MAQUILADORA GENERAL DE MATAMOROS SA DE CV

-

100 %

-

ARKEMA ROTTERDAM B.V.

24183071

100 %

31/12/2013

ARKEMA PEROXIDES INDIA PRIVATE LTD

-

100 %

-

VETEK SA

-

60 %

-

3

SOCIETE COATEX

971509070

100 %

31/12/2014

4

COATEX NETHERLANDS B.V.

20106984

100 %

31/12/2014

COATEX INC

-

100 %

-

COATEX KOREA

-

100 %

-

COATEX CENTRAL EASTERN EUROPE SRO

-

100 %

-

COATEX ASIA PACIFIC INC

-

100 %

-

CHANGSHU COATEX ADDITIVES CO. LTD

-

100 %

-

3

ARKEMA ASIE SAS

418681029

40.60 %

31/12/2014

4

ARKEMA K.K.

-

100 %

-

5

ARKEMA YOSHITOMI LTD

-

49 %

-

5

SARTOMER ASIA LTD

-

100 %

-

6

SARTOMER GUANGZHOU CHEMICAL CO LTD

-

100 %

-

4

ARKEMA CHINA INVESTMENT CO LTD

-

100 %

-

5

ARKEMA HYDROGEN PEROXIDE CO LTD SHANGHAI

-

66.70 %

-

ARKEMA CHANGSHU FLUOROCHEMICAL CO., LTD

-

50.80 %

-

CHANGSHU HAIKE CHEMICALS CO LTD

-

49 %

-

ARKEMA CHANGSHU CHEMICALS CO LTD

-

100 %

-

ARKEMA SHANGHAI DISTRIBUTION CO. LTD

-

100 %

-

SHANGHAI ARKEMA GAOYUAN CHEMICALS CO LTD

-

100 %

-

CHANGSHU RESICHINA ENGINEERING POLYMERS CO LTD

-

100 %

-

ARKEMA DAIKIN ADVANCED FLUOROCHEMICALS CO LTD

-

10 %

-

SUZHOU HIPRO POLYMERS CO LTD

-

10 %

-

HEBEI CASDA BIOMATERIALS CO LTD

-

10 %

-

ARKEMA CO LTD

-

100 %

-

ARKEMA CHANGSHU FLUOROCHEMICAL CO., LTD

-

49.20 %

-

DAIKIN ARKEMA REFRIGERANTS ASIA LTD

-

40 %

-

ARKEMA DAIKIN ADVANCED FLUOROCHEMICALS CO LTD

-

50 %

-

SUZHOU HIPRO POLYMERS CO LTD

-

90 %

-

HEBEI CASDA BIOMATERIALS CO LTD

-

90 %

-

NOBLE SYNTHETICS PRIVATE LIMITED

-

100 %

-

MLPC INTERNATIONAL

986120186

100 %

31/12/2014

3

ALTUGLAS INTERNATIONAL SAS

388432171

100 %

31/12/2014

4

SUNCLEAR SRL

-

100 %

-

3

ARKEMA EUROPE

429608342

65.68 %

31/12/2014

4

ARKEMA B.V.

33133916

100 %

-

5

ARKEMA HOLLAND HOLDING B.V.

33220762

100 %

31/12/2007

ARKEMA GMBH

HRB 29373

80 %

31/12/2014

ARKEMA COATINGS RESINS LTD

-

100 %

-

ARKEMA QUIMICA

117595

99.92 %

31/12/2012

ARKEMA S.R.L.

MI1393516

100 %

31/12/2013

ARKEMA GMBH

HRB 29373

20 %

31/12/2014

SCI AGRICOLE PARAPON

428343826

98 %

-

ARKEMA

-

100 %

-

SOC ALSACIENNE ET LORRAINE DE SONDAGES

758801013

30.24 %

31/12/2013

OXOCHIMIE

662048883

50 %

31/12/2014

SOC ETUDE REALISAT FINANCIERES

712057165

100 %

31/12/2014

SOCIETE DES FLUIDES DIELECTRIQUES

552149353

50 %

31/12/2014

3

CECA SA

775728025

100 %

31/12/2014

4

FEBEX SA

9865

96.77 %

-

CECA ITALIANA S.R.L.

MI1302745

100 %

31/12/2013

WINKELMANN MINERARIA SRL

-

100 %

-

CECA BELGIUM

-

100 %

-

ARKEMA PTY LTD

-

100 %

-

SUNCLEAR

330338013

99.92 %

31/12/2014

SEKI ARKEMA

-

51 %

-

ARKEMA ENERGIE

493446603

100 %

31/12/2014

PIEZOTECH S.A.

391321122

100 %

31/12/2014

CECALC

530705953

100 %

31/12/2014

ADHESIFS ET COMPOSITES POLYMERS

447761636

60 %

31/12/2014

SUNCLEAR

330338013

0.07 %

31/12/2014

EXELTIUM

490299989

9.96 %

31/12/2014

ALTUGLAS INTERNATIONAL MEXICO

-

100 %

-

ARKEMA HOLDINGS LTD.

01470171

100 %

31/12/2009

ARKEMA PTE LTD

-

100 %

-

ARKEMA INSURANCE LIMITED

IE420011

100 %

31/12/2014

ARKEMA SP ZOO

-

100 %

-

DELAWARE CHEMICALS CORP

-

100 %

-

MICHELET FINANCE INC

-

100 %

-

OZARK MAHONING CO

-

100 %

-

SUNCLEAR SA ESPANA

-

99.92 %

-

RESIL BELGIUM NV

877366285

100 %

31/12/2014

TURKISH PRODUCTS INC

-

100 %

-

VIKING CHEMICAL, INC

-

100 %

-

FOSFANIL SA

-

96.58 %

-

ALTUGLAS INTERNATIONAL DENMARK AS

-

100 %

-

ARKEMA MAGYARORSZAG KFT

-

100 %

-

ARKEMA SDN BHD

-

100 %

-

2

ARKEMA AFRIQUE

493446645

100 %

31/12/2014

3

ARKEMA RESINS (PTY) LTD

-

100 %

-

ELEMICA INC

-

5.20 %

-

ARKEMA PEKK INC

-

100 %

-

ARKEMA GAS ODORANTS LLC

-

100 %

-

RESINOPLAST NORTH AMERICA SRL DE CV

-

100 %

-

ARKEMA SRO

-

100 %

-

ARKEMA VE KIMYA SANAYI VE TICARET

-

100 %

-

IMPEL MICROCHIP LTD

-

15.08 %

-

MEGLAS SRL

-

33 %

-

ARKEMA INTERNATIONAL SA

5079041

100 %

-

EXELTIUM 2

529589467

12.05 %

31/12/2014

COATEX LATIN AMERICA INDUSTRIA ET COMERCIO LTD

-

100 %

-

IHSEDU AGROCHEM PRIVATE LTD

-

24.90 %

-

ARKEMA CHEMICALS INDIA PRIVATE LTD

-

100 %

-

ARKEMA COATINGS RESINS MALAYSIA SDN BHD

-

100 %

-

ARKEMA COATINGS RESINS SAU

-

99.92 %

-

ARKEMA INSURANCE LIMITED

IE420011

100 %

31/12/2014

ARKEMA MEXICO SERVICIOS SA DE CV

-

100 %

-

ARKEMA SPAR NL LIMITED PARTNERSHIP

-

100 %

-

HARVEYS COMPOSITES SOUTH AFRICA

-

100 %

-

CJ BIO MALAYSIA SDN BHD

-

14 %

-

ARKEMA THIOCHEMICALS SDN BHD

-

86 %

-

SARTOMER SHANGAI DISTRIBUTION COMPANY LIMITED

-

100 %

-

SARTOMER USA LLC

-

100 %

-

OXIDO S.R.L.

RM713038

Majority

31/12/2014

 

 

Linkages

 

Company Name

Siren

Last Account Published

Turnover

NIPPON SHOKUBAI

-

31/03/2015

3,214,510,500 €

TOTAL SA

542051180

31/12/2014

13,092,427,000 €

TOTAL HOLDINGS UK LIMITED

01722136

31/12/2014

0 £

ELF PETROLEUM UK LIMITED

01290174

31/12/2014

0 £

TOTAL DOWNSTREAM UK PLC

00223114

31/12/2014

0 £

TOTAL LINDSEY OIL REFINERY LIMITED

00564599

31/12/2014

4,389,914,000 £

ARKEMA B.V.

24270059

31/12/2013

102,859,000 €

E. F. OIL AND GAS LIMITED

03430228

31/12/2014

379,050,000 £

TOTAL UPSTREAM UK LIMITED

02413951

31/12/2014

0 £

TOTAL MIDSTREAM HOLDINGS UK LIMITED

02600099

31/12/2014

0 £

TOTAL GAS & POWER LIMITED

02172239

31/12/2014

11,588,184,000 £

TOTAL AFRICA SA

401144498

31/12/2014

0 €

BOSTIK SA

332110097

31/12/2014

319,865,000 €

BOSTIK SA

332110097

31/12/2014

319,865,000 €

TOTAL HOLDINGS EUROPE

428292197

31/12/2014

0 €

TOTAL UK LIMITED

00553535

31/12/2014

761,000,000 £

HUTCHINSON

542051826

31/12/2010

109,960,405 €

TOTAL GAS MARKETING LIMITED

02641991

31/12/2001

0 £

CECA BELGIUM SA

460850166

31/12/2014

17,188,158 €

TOTAL LUBRIFIANTS

552006454

31/12/2014

1,958,363,291 €

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE

692004807

31/12/2013

216,348,537 €

SOVEREIGN CHEMICALS LIMITED

03281228

31/12/2014

10,909,000 £

ALTUMAX EUROPE SAS

413065574

31/12/2010

0 €

ARKEMA COATINGS RESINS LIMITED

07609424

31/12/2014

0 £

ELF EXPLORATION UK LIMITED

00810743

31/12/2014

972,000 £

ATOTECH UK LIMITED

01315374

31/12/2014

6,410,000 £

TOTAL E&P UK LIMITED

00811900

31/12/2014

854,817,000 £

TOTAL BITUMEN UK LIMITED

00105979

31/12/2014

1,971,000 £

TOTAL GAS & POWER SERVICES LIMITED

02461545

31/12/2014

500,000 £

SUNCLEAR S.R.L.

MI1337657

31/12/2013

12,338,179 €

TOTAL PETROCHEMICALS UK LIMITED

05186102

31/12/2014

2,379,000 £

BOSTIK HOLDING B.V.

18027015

31/12/2013

-

BOSTIK B.V.

33216332

31/12/2013

24,786,000 €

TOTAL (AFRICA) LIMITED

00546167

31/12/2014

0 £

TOTAL FINANCE CORPORATE SERVICES LIMITED

08742010

31/12/2014

31,270,000 £

PAN INSURANCE LIMITED

IE501034

31/12/2014

8,314,069 €

HUTCHINSON HOLDINGS UK LIMITED

03440589

31/12/2014

0 £

ATOTECH B.V.

30128915

31/12/2013

-

BARRY WRIGHT (U.K.) LIMITED

02018962

31/12/2014

-

ARKEMA LTD.

00868680

31/12/2014

4,416,757 £

HUTCHINSON (U.K.) LIMITED

00126931

31/12/2014

1,628,000 £

STOP-CHOC LIMITED

01286216

31/12/2014

18,529,716 £

DUBAI MARINE AREAS LIMITED

00535541

31/12/2014

17,520 £

TOTAL PENSION COMPANY UK LIMITED

01518500

31/12/2014

11,052,000 £

CRUDE OIL TERMINALS (HUMBER) LIMITED

00554458

31/12/2014

45,098 £

SHETLAND LAND LEASE LIMITED

07224751

31/12/2014

460,000 £

AS24 FUEL CARD LTD

01895419

31/12/2014

26,331,144 £

TOTALFINAELF GAS LIMITED

03249437

31/12/2001

0 £

PAMARGAN PRODUCTS LIMITED

01597523

31/12/2014

11,565,739 £

ASSOCIATED PETROLEUM TERMINALS (IMMINGHAM) LIMITED

00564394

31/12/2014

13,186,000 £

MACHEN LAND LIMITED

08772718

31/12/2014

0 £

TOTAL NEW ENERGIES LIMITED

02466611

31/12/2014

0 £

AS24 IRELAND LIMITED

IE300812

31/12/2013

-

LAYBOND PRODUCTS LIMITED

00076920

31/12/2014

-

ELF OIL UK PROPERTIES LIMITED

00262147

31/12/2014

-

EVODE LIMITED

00265896

31/12/2014

-

TOTAL MILFORD HAVEN REFINERY LIMITED

00285103

30/06/2014

-

ELF LUB MARINE UK LTD

00375065

31/12/2014

-

BARRY CONTROLS LIMITED

00486600

31/12/2014

-

WARWICKSHIRE OIL STORAGE LIMITED

00691923

31/12/2014

5,800,000 £

FINA PETROLEUM DEVELOPMENT LIMITED

00740632

31/12/2014

-

FINA EXPLORATION LIMITED

00808167

31/12/2014

-

HUMBER OIL TERMINALS TRUSTEE LIMITED

00874993

31/12/2014

23,125,000 £

HERTFORDSHIRE OIL STORAGE LIMITED

00964902

31/12/2014

616,000 £

CALEDONIA NORTH SEA LIMITED

01153507

30/11/2008

-

ELF OIL UK AVIATION LIMITED

01560989

31/12/2014

-

ELF HYDROCARBONS LIMITED

02600097

31/12/2014

-

LJF (UK) LIMITED

02796513

30/06/2014

-

TOTAL GAS CONTRACTS LIMITED

03157676

31/12/2014

150,000 £

TOTAL UK FINANCE LIMITED

03988955

31/12/2014

0 £

THE LAYBOND GROUP LIMITED

04026996

31/12/2014

-

TOTAL PENSION TRUSTEE UK LIMITED

04370265

30/06/2014

-

WETHERBY BUILDING PRODUCTS LIMITED

05247368

31/12/2014

-

SEALOCRETE (HOLDINGS) LIMITED

05750569

31/12/2014

-

TOTAL GAS & POWER CHARTERING LIMITED

06710451

31/12/2014

102,481,000 £

TOTAL MARINE IRELAND LIMITED

IE085711

31/12/2013

-

TOTAL E&P EUROPE AND CENTRAL ASIA LIMITED

09499606

-

-

ARKEMA S.A.

09973677

-

-

ALTUMAX DEUTSCHLAND GMBH

HRB 7404

-

-

ALPHACAN OMNIPLAST GMBH

HRB 1182

-

-

ARKEMA GMBH, NIEDERLASSUNG KIRCHHEIMBOLANDEN

HRB 11862

-

-

ARKEMA CHEMICALS INC

-

-

0 $

BARRY WRIGHT CORP

-

-

20,000,000 $

ARKEMA RESEARCH CENTER

-

-

0 $

ARKEMA INC

-

-

0 $

ALTUGLAS INTERNATIONAL

-

-

294,000 $

ARKEMA INC

-

-

0 $

ELF ATOCHEM N A

-

-

0 $

ARKEMA SA

-

-

-

AS24 FRANCE SA

-

-

-

AS24 SA

-

-

-

BOSTIK S.A.

-

-

-

COATEX S.A.S.

-

-

-

MIMOSA SAS

-

-

-

TENESOL SA

-

-

-

 

 

Director(s)

 

Name

M. DELABORDE MICHEL

Manager position

Managing director, Administrator

Date of birth

14/08/1956

Place of birth

SENLIS

Type

Individual

Name at birth

Name

M. LE HENAFF THIERRY

Manager position

Chairman of the Board, Administrator

Date of birth

04/05/1963

Place of birth

SAVIGNY SUR ORGE

Type

Individual

Name at birth

 

Name

M. LEMONNIER THIERRY

Manager position

Delegated managing director

Date of birth

06/11/1953

Place of birth

MONTREUIL

Type

Individual

Name at birth

Name

M. SCHULLER MARC

Manager position

Delegated managing director

Date of birth

11/12/1960

Place of birth

METZ

Type

Individual

Name at birth

 

Name

M. GIDON YVES

Manager position

Administrator

Date of birth

10/02/1952

Place of birth

CLERMONT FERRAND

Type

Individual

Name at birth

Name

M. BOYER BERNARD

 

Manager position

Administrator

Date of birth

17/09/1960

 

Place of birth

BONNETABLE

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

 

Name

M. BENOIT-CATTIN LUC

 

Manager position

Administrator

Date of birth

03/12/1963

 

Place of birth

PARIS

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

Name

M. PINATEL BERNARD

Manager position

Delegated managing director

Date of birth

05/06/1962

Place of birth

LA ROCHELLE

Type

Individual

Name at birth

 

 

Statutory Auditor

 

Name

KPMG AUDIT

Name of representative

Manager position

Statutory auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

Name

ERNST & YOUNG AUDIT

Name of representative

Manager position

Statutory auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

Name

AUDITEX

Name of representative

Manager position

Deputy auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

Name

KPMG AUDIT IS

Name of representative

Manager position

Deputy auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

 

Previous Directors

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

Chairman of the Board

M. LE HENAFF THIERRY

04/05/1963 - SAVIGNY SUR ORGE

Managing director

M. DELABORDE MICHEL

14/08/1956 - SENLIS

Managing director

M. PINATEL BERNARD

05/06/1962 - LA ROCHELLE

Delegated managing director

M. CHANOINE PIERRE

10/05/1949 - WORMS(ALLEMAGNE)

Administrator

M. CHANOINE PIERRE

10/05/1949 - WORMS ALLEMAGNE

Administrator

M. CHANOINE PIERRE

10/05/1949 - WORMS(ALLEMAGNE)

Administrator

M. CHANOINE PIERRE

10/05/1949 - WORMS(ALLEMAGNE)

Administrator

M. DELABORDE MICHEL

14/08/1956 - SENLIS

Administrator

M. LE HENAFF THIERRY

04/05/1963 - SAVIGNY SUR ORGE

Administrator

M. LEMONNIER THIERRY

06/11/1953 - MONTREUIL

Administrator

M. LEMONNIER THIERRY

06/11/1953 - MONTREUIL

Administrator

M. SCHULLER MARC

11/12/1960 - METZ

Administrator

M. SCHULLER MARC

11/12/1960 - METZ

Administrator

M. TAKKEN OTTO

-

Administrator

M. TAKKEN OTTO

30/04/1951 - VEENENDAAL(PAYS-BAS)

Administrator

M. TAKKEN OTTO

30/04/1951 - VEENENDAAL PAYS BAS

Administrator

M. TAKKEN OTTO

30/04/1951 - VEENENDAAL(PAYS-BAS)

Delegated managing director

M. PINATEL BERNARD

05/06/1962 - LA ROCHELLE

 

 

Status history

 

No Status History

 

 

Recent publications in Gazettes

 

Publication date

Gazette Name

Description

17/06/2015

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

17322 - 319632790 RCS. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2014.

23/04/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1544 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 06 Septembre 2001 Président du conseil d'administration Administrateur : LE HENAFF Thierry modification le 26 Août 2008 Directeur général Administrateur : DELABORDE Michel modification le 14 Juin 2006 Directeur général délégué : LEMONNIER Thierry modification le 01 Décembre 2014 Directeur général délégué : SCHULLER Marc modification le 01 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 14 Juin 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 14 Juin 2006 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 02 Juillet 2010 Administrateur représentant les salariés : GIDON Yves en fonction le 01 Décembre 2014 Administrateur : BOYER Bernard en fonction le 01 Décembre 2014 Administrateur : BENOIT-CATTIN Luc en fonction le 01 Décembre 2014 Directeur général : PINATEL Bernard en fonction le 15 Avril 2015. Activité : .
Adresse du siège social : 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Commentaires : Modification de représentant. Modification de l'adresse du siège.

12/03/2015

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 02/03/2015
La société 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, 92700 COLOMBES
Fait l'objet du départ de Monsieur Pierre CHANOINE

12/03/2015

JAL

Appointment of the social representative

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 02/03/2015
Société faisant l'objet d'une nomination : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, 92700 COLOMBES
Nominé : Monsieur Bernard Pinatel, 75116 PARIS 16

09/12/2014

Bodacc B

Modification et mutation diverse

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2176 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 06 Septembre 2001 Président du conseil d'administration Administrateur : LE HENAFF Thierry modification le 26 Août 2008 Directeur général Administrateur : DELABORDE Michel modification le 14 Juin 2006 Directeur général délégué : LEMONNIER Thierry modification le 01 Décembre 2014 Directeur général délégué : SCHULLER Marc modification le 01 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 14 Juin 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 14 Juin 2006 Directeur général délégué : CHANOINE Pierre modification le 01 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 02 Juillet 2010 Administrateur représentant les salariés : GIDON Yves en fonction le 01 Décembre 2014 Administrateur : BOYER Bernard en fonction le 01 Décembre 2014 Administrateur : BENOIT-CATTIN Luc en fonction le 01 Décembre 2014. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant.

04/11/2014

JAL

Appointment of the social representative

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 24/10/2014
Société faisant l'objet d'une nomination : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, 92700 COLOMBES
Nominé : Monsieur Yves Gidon, 69540 IRIGNY
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Monsieur Bernard Boyer, 92200 NEUILLY SUR SEINE
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Monsieur Luc Benoît Cattin, 75017 PARIS 17
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Monsieur Pierre Chanoine
Nominé : Monsieur Thierry Lemonnier
Nominé : Monsieur Marc Schuller

04/11/2014

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 24/10/2014
La société 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, 92700 COLOMBES
Fait l'objet du départ de Monsieur Thierry Lemonnier,
De Monsieur Marc Schuller,
De Monsieur Pierre Chanoine

20/06/2014

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

10536 - 319632790 RCS. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves 92700 Colombes. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2013.

22/07/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

13777 - 319632790 RCS. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves 92700 Colombes. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2012.

18/01/2013

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

694 - . MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY. Forme : Société de droit étranger. Adresse : Chiyoda-Ku 2-5-2 Marunouchi 00000 Tokyo 100-8324
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 80000 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : un élément du fonds de commerce compose d'un portefeuille clientèle. complément de la rubrique capital de l'acquéreur : 41 970 000 000 000 yen. Adresse : 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. 319 632 790 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/12/2012. Publication légale : Les Petites Affiches du 07/01/2013. Oppositions : ARKEMA FRANCE 420 RUE D ESTIENNE D ORVES 92700 COLOMBES pour la validité et pour la correspondance. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

07/01/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Seller

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 22/11/2012
Cédant : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, 92700 COLOMBES
Cessionnaire : MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY,, 2-5 2 Marunouchi, Chiyoda-ku, 100-8324 TOKYO
Prix de vente : 80000 €
Date d’effet : 01/12/2012

28/12/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1729 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 270035923 EUR. Activité : .
Commentaires : Modification du capital.

18/12/2012

JAL

Modification of the share capital

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 07/11/2012
La société : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, 92700 COLOMBES a subi une diminution de son capital social désormais de 270 035 923 €
Date d'effet : 07/11/2012

22/11/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1657 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 06 Septembre 2001 Président du conseil d'administration et administrateur : LE HENAFF Thierry modification le 26 Août 2008 Directeur général et administrateur : DELABORDE Michel modification le 14 Juin 2006 Administrateur : LEMONNIER Thierry en fonction le 28 Mars 2006 Administrateur : SCHULLER Marc en fonction le 28 Mars 2006 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 14 Juin 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 14 Juin 2006 Administrateur : CHANOINE Pierre en fonction le 25 Mars 2008 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 02 Juillet 2010. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant.

23/10/2012

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 19/10/2012
La société 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, 92700 COLOMBES
Fait l'objet du départ de Monsieur Takken Otto

14/10/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1263 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 274845346.04 EUR. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 79076945 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : avenant en date du 20 juillet 2012 d'un acte du 1er juillet 2011 relatif à la cession parue au Bodacc le 28/09/2012 - N°188a - aux termes dudit avenant, il a été procédé à l'ajustement du prix des différents éléments composant le prix d'acquisition, celui-ci s'élève ainsi à : 79 076 945 euros au lieu de 76 386 469 euros. Adresse : 16-32 rue Henri Régnault, - la Défense 6 -, 92400 Courbevoie.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 20/07/2012. Publication légale : La Loi du 07/09/2012. Oppositions : Société CRAY VALLEY SA - 16-32 rue Henri Régnault - La Défense 6 - 92400 Courbevoie pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

05/10/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

62 - PAS-DE-CALAIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS

291 - Réctificatif.
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : . Date de parution : 23 septembre 2012. Numéro d’annonce : 502. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant.
319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 274845346.04 EUR. Adresse : 420 rue Estienne d'orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 79076945 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Un fonds de commere de développement production et commercialisation de resine photoréticulable et des résines de revetement. Adresse : route d'Arras Drocourt, 62320 Rouvroy.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : la voix du nord du 11/09/2012. Oppositions : à ROUVROY Route d'arras drocourt pour la validité et au siège de la société CRAY VALLEY SA situé 16-32 rue Henri Regnault LA DEFENSE 6, 92400 COURBEVOIE pour la correspondance. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

29/09/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

60 - OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE

442 - 319 632 790 RCS Compiegne. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 79076945 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : avenant en date du 20 juillet 2012 d'un acte du 1er juillet 2011 relatif à la cession parue au Bodacc le 27 juillet 2011 N° 144 a - aux termes dudit avenant, il a été procédé à l'ajustement du prix des différents éléments composants le prix d'acquisition, celui-ci s'élève ainsi à : 79 076 945 euros au lieu de 76 386 469 euros;. Adresse : Zone Artisanale de Villers Saint-Paul, 60870 Villers-Saint-Paul.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : Le Parisien du 11/09/2012. Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance CRAY VALLAY SA 16-32 Rue Henri Regnault La Défense 6 92400 COURBEVOIE. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

28/09/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

580 - Réctificatif.
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : . Date de parution : 27 juillet 2011. Numéro d’annonce : 1635. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant.
319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 274845346.04 EUR. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 79 076 945 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : le fonds de commerce relatif a l'activité de développement, production et commercialisation de résines Photoreticulables et des résines de revêtement. Adresse : 16-32 rue Henri Regbault, la Défense 6, 92400 Courbevoie.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : La Loi du 15/07/2011. Oppositions : STE CRAY VALLEY SA A L ATTENTION DU DIRECTEUR GENERAL SITUE 16-32 RUE HENRI REGNAULT LA DEFENSE 6 - 92400 COURBEVOIE pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

23/09/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

62 - PAS-DE-CALAIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS

502 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 274845346.04 EUR. Adresse : 420 rue Estienne d'orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 79076945 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Un fonds de commere de développement production et commercialisation de resine photoréticulable et des résines de revetement. Adresse : route d'Arras Drocourt, 62320 Rouvroy.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : la voix du nord du 11/09/2012. Oppositions : à ROUVROY Route d'arras drocourt. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

19/09/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

60 - OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE

316 - 319 632 790 RCS Compiegne. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 79076945 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : avenant en date du 20 juillet 2012, d'un acte du 1er juillet 2011 relatif à la cession, Paur au Bodacc le 27 juillet 2011 N° 144 a aux termes dudit avenant, il a été procédé à l'ajustement du prix des différents éléments composant le prix d'acquisition. celui-ci s'élève ainsi à : 79 076 945 euros au lieu de 76 386 469 euros. Adresse : rue Taffanel, 60550 Verneuil-en-Halatte.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : Le Parisien du 11/09/2012. Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance CRAY VALLEY SA 16-32 Rue Henri Regnault La Défense 6 92400 COURBEVOIE. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

11/09/2012

JAL

Activity or goodwill cession

Voix du Nord (La)/édition CALAIS


Date de décision : 20/07/2011
Cédant : 340869353 - CRAY VALLEY SA, 16 RUE HENRI REGNAULT, LA DEFENSE 6 - 16 A 32, 92400 COURBEVOIE
Cessionnaire : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Prix de vente : 79076945 €

11/09/2012

JAL

Activity or goodwill cession

Parisien (Le)/Edition de l'Oise


Date de décision : 20/07/2012
Cédant : 340869353 - CRAY VALLEY SA, 16 RUE HENRI REGNAULT, LA DEFENSE 6 - 16 A 32, 92400 COURBEVOIE
Cessionnaire : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Prix de vente : 79076945 €

06/09/2012

JAL

Activity or goodwill cession

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 20/07/2012
Cédant : 340869353 - CRAY VALLEY SA, 16 RUE HENRI REGNAULT, LA DEFENSE 6 - 16 A 32, 92400 COURBEVOIE
Cessionnaire : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Prix de vente : 79076945 €
Date d’effet : 20/07/2012

29/08/2012

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

30 - GARD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

132 - 538 695 040 RCS Lyon. KEM ONE. Forme : Société par Actions Simplifiée. Adresse : 210 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon.
Origine du fonds : Apport partiel d'actif 1 EUR. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Exploitation d'un giseent de sel et transports de la saumure, production de sel. Adresse : Parrapon, 30600 Vauvert.
Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. 319 632 790 RCS Nîmes.
Date de commencement de l’activité : 02/07/2012. Publication légale : Medialex 35 Avenue des Peupliers 35515 CESSON-SEVIGNE du 25/07/2012. Déclarations des créances : Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

05/07/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

12952 - 319632790 RCS. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves 92700 Colombes. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011.

23/05/2012

JAL

Continuation of activity in spite of stockholders' equity become lower in the middle of the share capital

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 16/05/2012
Poursuite d'activité malgré des fonds propres devenus inférieurs à la moitié du capital social de la société 319632790 -  ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Date d'effet : 16/05/2012

18/10/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

62 - PAS-DE-CALAIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS

903 - Réctificatif.
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : . Date de parution : 7 octobre 2011. Numéro d’annonce : 524. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant.
319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 76386469 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Fabrication et distillation de goudrons, développement, production et commercialisation des résines de revêtemets. Adresse : 121 route de Lille, 62218 Loison-sous-Lens.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : la voix du nord du 16/07/2011. Oppositions : au siège de la société CRAY VALLEY SA 16-32 rue Henry Régnault la défense 6, 92400 COURBEVOIE et pour la validité au lieu d'exploitation à ROUVROY Route d'Arras Drocourt. Descriptif : Montant du capital social de la soci¿t¿ ARKEMA FRANCE : 274 845 346.04 EUROS. Modification survenue sur l'activit¿. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

07/10/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

62 - PAS-DE-CALAIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS

524 - Réctificatif.
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : . Date de parution : 14 septembre 2011. Numéro d’annonce : 543. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant.
319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 76386269 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Fabrication et distillation de goudrons, développement, production et commercialistion des résines de revêtemetns. Adresse : 121 route de Lille, 62218 Loison-sous-Lens.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : la voix du nord du 16/07/2011. Oppositions : au siège de la société CRAY VALLEY SA 16-32 rue Henry Régnault la défense 6 92400 COURBEVOIE et pour la validité au lieu d exploitation à ROUVROY Route d'Arras Drocourt MERCI DE COMPLETER LE CAPITAL SOCIAL DE LA STE ARKEMA FRANCE SOIT / 274 845 346.04 EUROS. Descriptif : Modification survenue sur l'activit¿. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

14/09/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

62 - PAS-DE-CALAIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS

543 - Réctificatif.
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : . Date de parution : 2 août 2011. Numéro d’annonce : 720. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant.
319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 76386269 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Fabrication et distillation de goudrons, développement, production et commercialistion des résines de revêtemetns. Adresse : 121 route de Lille, 62218 Loison-sous-Lens.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : la voix du nord du 16/07/2011. Oppositions : au siège de la société CRAY VALLEY SA 16-32 rue Henry Régnault la défense 6 92400 COURBEVOIE et pour la validité au lieu d exploitation à ROUVROY Route d'Arras Drocourt. Descriptif : Modification survenue sur l'activit¿. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

02/08/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

62 - PAS-DE-CALAIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS

720 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Etablissement secondaire précédemment exploité en location-gérance acquis par apport au montant évalué à 7279029677 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Fabrication et distillation de goudrons . Développement production et commercialisation des résines de revêtements. Adresse : 121 route de Lille, 62218 Loison-sous-Lens. Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 76386269 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Fabrication et distillation de goudrons, développement, production et commercialistion des résines de revêtemetns. Adresse : 121 route de Lille, 62218 Loison-sous-Lens.
Précédent propriétaire : NORSOLOR. 301 459 525 RCS Arras. Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 31/07/1990. Publication légale : Publicateur légal du 03/08/1990. Oppositions : pas d'oppositions. Descriptif : Modification survenue sur l'activit¿. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

27/07/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

60 - OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE

844 - 319 632 790 RCS Compiegne. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 76386469 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : recherche et développement dans le domaine des résines Photoréticulables et des résines de revêtement. Adresse : rue Jacques Taffanel, 60550 Verneuil-en-Halatte.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : Le Parisien du 16/07/2011. Oppositions : ARKEMA FRANCE ZA de Villers St Paul BP 13 60870 VILLERS ST PAUL pour la validité et pour la correspondance CRAY VALLEY SA La Défense 6 16-32 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

27/07/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1635 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 274845346.04 EUR. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 76386469 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : le fonds de commerce relatif a l'activité de développement, production et commercialisation de résines Photoreticulables et des résines de revêtement. Adresse : 16-32 rue Henri Regbault, la Défense 6, 92400 Courbevoie.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY SA. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : La Loi du 15/07/2011. Oppositions : STE CRAY VALLEY SA A L ATTENTION DU DIRECTEUR GENERAL SITUE 16-32 RUE HENRI REGNAULT LA DEFENSE 6 - 92400 COURBEVOIE pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

27/07/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

60 - OISE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE

845 - 319 632 790 RCS Compiegne. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 76386469 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : développement, production et commercialisation des résines Photoréticulables et des résines de revêtement. Adresse : Zone Artisanale de Villers Saint-Paul, Bp 13, 60870 Villers Saint-Paul.
Précédent propriétaire : CRAY VALLEY. 340 869 353 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2011. Publication légale : Le Parisien du 16/07/2011. Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance CRAY VALLEY La Défense 6 16-32 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

16/07/2011

JAL

Activity or goodwill cession

Parisien (Le)/Edition de l'Oise


Date de décision : 01/07/2011
Cédant : 340869353 - CRAY VALLEY SA, 16 RUE HENRI REGNAULT, LA DEFENSE 6 - 16 A 32, 92400 COURBEVOIE
Cessionnaire : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Prix de vente : 34090200 €
Date d’effet : 01/07/2011

16/07/2011

JAL

Activity or goodwill cession

Voix du Nord (La)/édition CALAIS


Date de décision : 01/07/2011
Cédant : 340869353 - CRAY VALLEY SA, 16 RUE HENRI REGNAULT, LA DEFENSE 6 - 16 A 32, 92400 COURBEVOIE
Cessionnaire : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Prix de vente : 76386469 €
Date d’effet : 01/07/2011

15/07/2011

JAL

Activity or goodwill cession

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 01/07/2011
Cédant : 340869353 - CRAY VALLEY SA, 16 RUE HENRI REGNAULT, LA DEFENSE 6 - 16 A 32, 92400 COURBEVOIE
Cessionnaire : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Prix de vente : 76386469 €
Date d’effet : 01/07/2011

31/07/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1196 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 274845346.04 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

16/07/2010

JAL

Modification of the share capital

LES PETITES AFFICHES


Date de décision : 28/06/2010
La société : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES a subi une augmentation de son capital social désormais de 274 845 300 €

13/07/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2801 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 06 Septembre 2001 Président du conseil d'administration et administrateur : LE HENAFF Thierry modification le 26 Août 2008 Directeur général et administrateur : DELABORDE Michel modification le 14 Juin 2006 Administrateur : LEMONNIER Thierry en fonction le 28 Mars 2006 Administrateur : SCHULLER Marc en fonction le 28 Mars 2006 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 14 Juin 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 14 Juin 2006 Administrateur : TAKKEN Otto en fonction le 12 Décembre 2006 Administrateur : CHANOINE Pierre en fonction le 25 Mars 2008 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 02 Juillet 2010.
Commentaires : Modification de représentant.

09/07/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

8816 - 319632790 RCS. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves 92700 Colombes. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

23/06/2010

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1463 - . BASF SE (SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DROIT ALLEMAND À CAPITAL VARIABLE). Forme : Société de droit étranger. Capital : 1175652728.32 EUR. Adresse : Carl - Bosch - Strasse 38, 99999 .
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : commercialisation d'acide méthacrylique. Adresse : 420 rue Estienne d' Orves, 92700 Colombes.
Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. 319 632 790 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : La Loi du 04/02/2010. Oppositions : Au fonds vendu et au siège du cessionnaire pour la correspondance pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 100000 Euros. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

26/03/2010

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

1527 - . EVONIK RÖHM GMBH. Forme : Société de droit étranger. Capital : 52300000 EUR. Adresse : Kirschenallée 00000 64293 Darmstadt
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : commercialisation de Monomères d'Esthers Métacryliques de spécialités. Adresse : 420 rue d'Estienne d Orves, 92700 Colombes.
Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. 319 632 790 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : Le Parisien du 08/02/2010. Oppositions : ARKEMA FRANCE AU 420 RUE D ESTIENNE D ORVES 92700 COLOMBES pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 1700000 Euros. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

08/02/2010

JAL

Activity or goodwill cession

92


Date de décision : 04/02/2010
Cédant : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Cessionnaire : EVONIK ROHM GMBH,
Prix de vente : 1700000 €

04/02/2010

JAL

Activity or goodwill cession

LES PETITES AFFICHES


Date de décision : 02/02/2010
Cédant : 319632790 - ARKEMA FRANCE, 420 RUE ESTIENNE D ORVES, /8, 92700 COLOMBES
Cessionnaire : BASF SE, CARL BOSCH STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN
Prix de vente : 100000 €

02/08/2009

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

865 - . EW LIMITED PRIVATE LIMITED COMPANY. Forme : Société de droit étranger. Adresse : C/o Internationals Management Édith Cavell Street Limited - les Cascades Building - 00000 Port Louis
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : commercialisation de chlorure d'aluminium. Adresse : 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. 319 632 790 RCS Nanterre.
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : Gazette du palais du 23/07/2009. Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 200000 Euros. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

19/07/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

9398 - 319632790 RCS. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves 92700 Colombes. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

30/06/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

7881 - 319632790 RCS. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 420 rue Estienne d'Orves 92700 Colombes. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

29/05/2008

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

2119 - . SUMITOMO SEIKA EUROPE S. A. N. V. Forme : Société de droit étranger. Capital : 4000000 EUR. Adresse : 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : un élément de fonds de commerce relatif à l'activité de production et de commercialisation de différents super-absorbants acryliques. Adresse : 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes.
Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. 319 632 790 RCS Nanterre.
Publication légale : Journal spécial des sociétés françaises du 15/05/2008. Oppositions : Au Mandataire FIDAL - ME JOSSET ET HARIRI - 14 BD DU GENERAL LECLERC - 92527 NEUILLY SUR SEINE CEDEX pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 5000000 Euros. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

23/03/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

92 - HAUTS-DE-SEINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

3704 - 319 632 790 RCS Nanterre. ARKEMA FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 06 Septembre 2001. Commissaire aux comptes suppléant : BOUCHET Alain en fonction le 06 Septembre 2001. Président du conseil d'administration et administrateur : LE HENAFF Thierry modification le 14 Juin 2006. Directeur général et administrateur : DELABORDE Michel modification le 14 Juin 2006. Administrateur : LEMONNIER Thierry en fonction le 28 Mars 2006. Administrateur : SCHULLER Marc en fonction le 28 Mars 2006. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 14 Juin 2006. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 14 Juin 2006. Administrateur : TAKKEN Otto en fonction le 12 Décembre 2006. Administrateur : CHANOINE Pierre en fonction le 25 Mars 2008.
Commentaires : Modification de représentant.

29/11/2007

Bodacc A

Vente et cession

507 - RCS Lyon B 349 305 318. RC 07-B 5775. KEMIRA CHIMIE. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : route de Mothern Port du Rhin, 67630 Lauterbourg. Etablissement secondaire - Activité : fabrication de co-agulant pour le traitement de l'eau. Adresse : rue Henri Moisan, 69491 Pierre-Benite. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 496 000 euros . Date de début d'activité : 31 octobre 2007. Précédent propriétaire : RCS 319 632 790. ARKEMA FRANCE. Publication légale : Petites Affiches Lyonnaises du 19 novembre 2007 . Oppositions : à l'attention de Monsieur Denis Fromage, Directeur d'Usine Arkema France rue Henri Moisan 69491 Pierre-Benite.

25/11/2007

Bodacc A

Vente et cession

966 - RCS B 349 305 318. RC AP-B 42109. KEMIRA CHIMIE S.A.S. Forme : S.A.S. Capital : 5 700 000 euros. Adresse du siège social : route de Mothern, 67630 Lauterbourg. Etablissement principal - Activité : conception, fabrication, vente et livraisons d'appareils de traitement de l'eau. Adresse : 420 rue d'Estienne-d'Orves, 92700 Colombes. Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 496 000 euros. Date d'effet : 31 octobre 2007. Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. RCS 319 632 790. Publication légale : Le Publicateur légal du 12 novembre 2007. Oppositions : Arkema France, 420 rue d'Estienne-d'Orves, 92700 Colombes, pour la validité et Cabinet Carreras, Barsikian, Robertson et Associés, 32 avenue Raymond-Poincaré, 75116 Paris, pour la correspondance.

18/09/2007

Bodacc A

Vente et cession

2047 - RCS non encore inscrit. RC AP-B 42014. CAFFARO CHIMICA. Forme : société de droit étranger. Capital : 20 010 000 euros. Etablissement principal - Activité : activité de chlorite de sodium. Adresse : 420 rue d'Estiennes-d'Orves, 92700 Colombes. Cession de la propriété et de l'ensemble des droits et des intérêts, dépendant de l'établissement principal, acquis par achat au prix stipulé de 2 500 000 euros, à l'exclusion du bail commercial. Date d'effet : 7 août 2007. Précédent propriétaire : ARKEMA FRANCE. RCS 319 632 790. Publication légale : La Gazette du Palais du 1er septembre 2007. Oppositions : au fonds, pour la validité et la correspondance.

25/07/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

2306 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA FRANCE. Forme : S.A. Adresse du siège social : 420 rue Estienne-d'Orves,, 92700 Commentaires : modification survenue sur l'adresse du siège social et l'adresse de l'établissement principal. Etablissement principal - Adresse : 420 rue Estienne-d'Orves, 92700

10/07/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

8117 - 319 632 790. RCS Nanterre ARKEMA FRANCE. Forme: Société anonyme. Adresse du siège social: 4/8 Cours Michelet 92800 Puteaux. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

26/12/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

2895 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA FRANCE. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : PERNOT (Philippe). Nomination d'un administrateur : TAKKEN (Otto).

11/08/2006

Bodacc A

Vente et cession

1717 - RCS non encore inscrit. RC AP-B 41427. FACT-FUTURE ADVANCED COMPOSITES & TECHNOLOGY. Forme : société de droit étranger. Capital : 82 200 euros. Etablissement principal - Activité : fabrication et commercialisation de produits de base thermoplastiques renforcés de fibres longues distribués tant en France, qu'en Allemagne ou qu'au Portugal sous la marque > Pryltex < . Adresse : La Défense 10, 4-8 cours Michelet, 92800 Puteaux. Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 600 000 euros. Date d'effet : 6 juillet 2006. Précédent propriétaire : ARKEMA (France). RCS 319 632 790. Publication légale : Les Petites affiches du 26 juillet 2006. Oppositions : au fonds vendu pour la validité et la correspondance.

11/07/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1569 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA FRANCE. Forme : S.A. Capital : 68 685 704,12 euros. Commentaires : modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation) et l'administration. Administration : modification du président du conseil d'administration et administrateur : LE HENAFF (Thierry). Modification d'un directeur général et administrateur : DELABORDE (Michel). Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT. Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.

20/06/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

2002 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA. Forme: S.A. Adresse du siège social: 4/8, cours Michelet,92800 Puteaux. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

23/04/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

2776 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateurs partants : CASTAIGNE (Robert) LAFONT (Françoise) (Nom d'usage : LEROY) HOWAT (Ian). Nomination d'administrateurs : PERNOT (Philippe) GOEBEL (Philippe) LEMONNIER (Thierry) SCHULLER (Marc).

16/12/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1679 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA. Forme : S.A. Capital : 27 125 346,60 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (diminution).

24/08/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

5185 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA. Forme: S.A. Adresse du siège social: 4/8, cours Michelet,92800 Puteaux. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

06/01/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1776 - RCS Nanterre B 319 632 790. RC 81-B 332. ARKEMA. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'administrateurs : HOWAT (Ian) DELABORDE (Michel).

01/12/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nanterre B 319632790 RC 81-B 332 ARKEMA. Forme : S.A. Capital : 520 868 934, 51 euros. Activité : fabrication et vente de produits chimiques ou plastiques. Adresse du siège social : 48 cours Michelet, 92800 Puteaux. Commentaires : modification survenue sur le capital ( augmentation). Apport des sociétés BOSTIK HOLDINGS S.A. (ex-DAJA 33),. RCS Nanterre 445 074 461 et TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE S.A.,. RCS Nanterre 428 891 113. Date d'effet : 22 octobre 2004.

25/01/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nanterre B 319632790 RC 81-B 332 ATOFINA. Forme : S.A. Capital : 501 240 321 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration. Administration : nomination du commissaire aux comptes titulaire : CABINET BARBIER FRINAULT ET AUTRES. Nomination du commissaire aux comptes suppléant : LEGER (Michel).

18/05/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

*. RCS Nanterre B 319 632 790 RC 81-B 332 ATOFINA. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur la dénomination.

29/08/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nanterre B 319632790 RC 81-B 332 ELF ATOCHEM S.A. Forme : S.A. Capital : 494 868 500 euros. Adresse du siège social : 4-8 cours Michelet, 92800 Puteaux. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation). Fusion- absorption de la CIE FINANCIERE ATOCHEM, de la STE FINIRIS , de la STE MEDITERRANEENNE DU BROME et de la STE OXYSYNTHESE. Date d'effet : 30 juin 1999.

06/09/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nanterre B 319 632 790 RC 81-B 332 ELF ATOCHEM S.A. Forme : S.A. Capital : 3 246 123 500 F. Adresse du siège social : 4-8 cours Michelet 92800 Puteaux. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation). Apport pur et simple par la STE ELF AQUITAINE EXPLORATION PRODUCTION FRANCE (LACTAME ET THIOCHIMIE),. RCS Nanterre B 409 160 132. Date d'effet : 31 juillet 1998.

02/10/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Nanterre B 319 632 790 RC RC 81-B 332 ELF ATOCHEM S.A. Forme : S.A. Capital : 3 156 750 500 F. Administration : président du conseil d'administration : PUECHAL (Jacques) Administrateurs : DIDIER (François) RUTMAN (Gilbert) ISOARD (Frédéric) CASTILLON (Pierre) DE WISSOCQ (François) POLGE DE COMBERT (Bernard) WEYMULLER ( Stanislas) DESBIENDRAS (Daniel) ARTHAUD (Jean-Pierre). Commissaire aux comptes titulaire : ERNST AND YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : BAHON (Yves). Commentaires : modification survenue sur le capital et l'administration.

 

 

Company events history

 

Date

Description

14/10/2015

New Filling of Tax Office preferential right

08/10/2015

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

17/06/2015

Bodacc C : Deposit accounts notice

16/06/2015

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

02/06/2015

Amendment

02/06/2015

Updated articles of association

23/04/2015

Bodacc B: Various editing or changing

15/04/2015

Changes to the Board of Directors

15/04/2015

Minutes of Board meeting

12/03/2015

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

02/03/2015

Legal Gazette: Appointment of the social representative

31/12/2014

New accounts available

09/12/2014

Bodacc B: Various editing or changing

06/12/2014

Update of participations in other companies

06/12/2014

Disengagement in other companies

06/12/2014

New subsidiarie(s) detected

01/12/2014

Minutes of Board meeting

01/12/2014

Changes to the Board of Directors

08/11/2014

Disengagement in other companies

04/11/2014

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

24/10/2014

Legal Gazette: Appointment of the social representative

20/06/2014

Bodacc C : Deposit accounts notice

19/06/2014

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

05/06/2014

Updated articles of association

05/06/2014

Amendment

31/12/2013

New accounts available

31/08/2013

Invalid balance sheet

02/08/2013

Update of participations in other companies

02/08/2013

New subsidiarie(s) detected

22/07/2013

Bodacc C : Deposit accounts notice

07/06/2013

Disengagement in other companies

05/04/2013

Disengagement in other companies

29/01/2013

Unfiling of a Tax Office preferential right

29/01/2013

New Filling of Tax Office preferential right

18/01/2013

Bodacc A : Sale and transfer

31/12/2012

New accounts available

28/12/2012

Bodacc B: Various editing or changing

19/12/2012

Updated articles of association

19/12/2012

Reconstitution of net assets

19/12/2012

Minutes of general meeting of shareholders

19/12/2012

Capital increase

22/11/2012

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Seller

22/11/2012

Bodacc B: Various editing or changing

14/11/2012

Amendment

14/11/2012

Changes to the Board of Directors

07/11/2012

Legal Gazette: Modification of the share capital

07/11/2012

Other modification of Establishment

23/10/2012

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

14/10/2012

Bodacc A : Sale and transfer

06/10/2012

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

05/10/2012

Bodacc A : Sale and transfer

29/09/2012

Bodacc A : Sale and transfer

28/09/2012

Bodacc A : Sale and transfer

23/09/2012

Bodacc A : Sale and transfer

19/09/2012

Bodacc A : Sale and transfer

29/08/2012

Bodacc A : Sale and transfer

25/07/2012

Partial contribution

25/07/2012

Minutes of general meeting of shareholders

25/07/2012

Declaration of conformity

20/07/2012

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

05/07/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

11/06/2012

Amendment

11/06/2012

Continuation of business despite loss of equity

01/06/2012

Disengagement in other companies

01/06/2012

Partial contribution

16/05/2012

Legal Gazette: Continuation of activity

04/05/2012

Payment incident closed

03/02/2012

Disengagement in other companies

31/12/2011

New accounts available

18/10/2011

Bodacc A : Sale and transfer

07/10/2011

Bodacc A : Sale and transfer

14/09/2011

Bodacc A : Sale and transfer

02/09/2011

Update of participations in other companies

02/09/2011

Disengagement in other companies

02/09/2011

New subsidiarie(s) detected

02/08/2011

Bodacc A : Sale and transfer

27/07/2011

Bodacc A : Sale and transfer

20/07/2011

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

18/07/2011

Bodacc C : Deposit accounts notice

08/07/2011

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

01/07/2011

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

25/05/2011

Unfiling of a Tax Office preferential right

25/05/2011

New Filling of Tax Office preferential right

31/12/2010

New accounts available

29/11/2010

Payment incident closed

23/08/2010

Payment incident closed

13/08/2010

Update of participations in other companies

13/08/2010

Disengagement in other companies

13/08/2010

New participations in other companies

13/08/2010

New subsidiarie(s) detected

02/08/2010

Payment incident closed

31/07/2010

Bodacc B: Various editing or changing

21/07/2010

Payment incident detected

21/07/2010

Fund deposit certificate

21/07/2010

Capital increase

21/07/2010

Amendment

21/07/2010

Updated articles of association

13/07/2010

Bodacc B: Various editing or changing

09/07/2010

Update of participations in other companies

09/07/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

01/07/2010

New auditor

01/07/2010

Amendment

28/06/2010

Other modification of Establishment

28/06/2010

Legal Gazette: Modification of the share capital

23/06/2010

Bodacc A : Sale and transfer

21/06/2010

Payment incident detected

01/06/2010

Payment incident closed

26/03/2010

Bodacc A : Sale and transfer

08/02/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

04/02/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

26/01/2010

Payment incident detected

13/01/2010

Payment incident closed

08/01/2010

Payment incident closed

31/12/2009

New accounts available

16/10/2009

Payment incident closed

02/10/2009

Payment incident detected

31/08/2009

Payment incident detected

02/08/2009

Bodacc A : Sale and transfer

28/07/2009

Minutes of general meeting of shareholders

28/07/2009

Amendment

28/07/2009

Private document

28/07/2009

Updated articles of association

28/07/2009

Updated articles of association

19/07/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

17/07/2009

Payment incident closed

26/06/2009

Payment incident closed

09/06/2009

Payment incident detected

19/03/2009

Payment incident detected

31/12/2008

New accounts available

15/10/2008

Payment incident closed

29/07/2008

Payment incident detected

30/06/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

29/05/2008

New Bodacc A ads detected

29/05/2008

Bodacc A : Sale and transfer

25/03/2008

Private document

25/03/2008

Minutes of Board meeting

25/03/2008

Changes to the Board of Directors

25/03/2008

Changes to the Board of Directors

25/03/2008

Appointment/resignation of company officers

25/03/2008

Amendment

25/03/2008

Minutes of Board meeting

23/03/2008

Bodacc B: Various editing or changing

23/03/2008

New Bodacc B ads detected

31/12/2007

New accounts available

14/09/2007

Collection of preferential rights activated for this company

04/07/2007

Private document

04/07/2007

Updated articles of association

04/07/2007

Updated articles of association

04/07/2007

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

04/07/2007

Minutes of general meeting of shareholders

04/07/2007

Minutes of general meeting of shareholders

04/07/2007

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

25/06/2007

Minutes of general meeting of shareholders

25/06/2007

Updated articles of association

25/06/2007

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

15/06/2007

Modification to Establishment Address or Identifier

31/12/2006

New accounts available

12/12/2006

Appointment/resignation of company officers

12/12/2006

Changes to the Board of Directors

12/12/2006

Changes to the Board of Directors

12/12/2006

Minutes of Board meeting

12/12/2006

Minutes of Board meeting

12/12/2006

Private document

12/12/2006

Amendment

14/06/2006

Changes to the Board of Directors

14/06/2006

Capital reduction

14/06/2006

Capital increase

14/06/2006

Audit or Management Report

14/06/2006

Appointment/resignation of company officers

14/06/2006

Amendment

14/06/2006

Minutes of Board meeting

14/06/2006

Updated articles of association

14/06/2006

Private document

14/06/2006

New company name

14/06/2006

New chairman (CEO, CoB)

14/06/2006

New auditor

14/06/2006

Minutes of general meeting of shareholders

18/05/2006

Amendment

18/05/2006

Office copy

18/04/2006

Modification to Establishment Address or Identifier

28/03/2006

Appointment/resignation of company officers

28/03/2006

Changes to the Board of Directors

28/03/2006

Minutes of general meeting of shareholders

28/03/2006

Private document

28/03/2006

Updated articles of association

31/12/2005

New accounts available

01/12/2005

Audit or Management Report

01/12/2005

Capital reduction

01/12/2005

Minutes of general meeting of shareholders

01/12/2005

Private document

01/12/2005

Updated articles of association

22/11/2005

Audit or Management Report

22/11/2005

Private document

31/12/2004

New accounts available

17/12/2004

Appointment/resignation of company officers

17/12/2004

Audit or Management Report

17/12/2004

Changes to the Board of Directors

17/12/2004

Minutes of general meeting of shareholders

17/12/2004

Private document

15/11/2004

Amendment

15/11/2004

Audit or Management Report

15/11/2004

Declaration of conformity

15/11/2004

Fund deposit certificate

15/11/2004

Minutes of Board meeting

15/11/2004

Private document

15/11/2004

Reconstitution of net assets

15/11/2004

Updated articles of association

22/10/2004

Minutes of Board meeting

22/10/2004

Updated articles of association

22/10/2004

New company name

22/10/2004

Minutes of general meeting of shareholders

22/10/2004

Appointment/resignation of company officers

22/10/2004

Amendment

21/10/2004

New chairman (CEO, CoB)

21/10/2004

New company name

21/10/2004

Updated articles of association

21/10/2004

Minutes of general meeting of shareholders

21/10/2004

Minutes of Board meeting

21/10/2004

Changes to the Board of Directors

21/10/2004

Appointment/resignation of company officers

21/10/2004

Private document

01/10/2004

Capital increase

01/10/2004

Capital reduction

01/10/2004

Private document

01/10/2004

Minutes of general meeting of shareholders

21/09/2004

Audit or Management Report

25/08/2004

Private document

25/08/2004

Amendment

25/08/2004

Spin-off

25/08/2004

Partial contribution

16/04/2004

Updated articles of association

16/04/2004

Audit or Management Report

16/04/2004

Minutes of general meeting of shareholders

16/04/2004

Private document

31/12/2003

New accounts available

12/12/2003

Appointment/resignation of company officers

12/12/2003

Changes to the Board of Directors

12/12/2003

Private document

28/08/2003

Minutes of Board meeting

28/08/2003

Audit or Management Report

28/08/2003

Amendment

28/08/2003

Changes to the Board of Directors

28/08/2003

Updated articles of association

28/08/2003

Private document

28/08/2003

Minutes of general meeting of shareholders

14/09/2002

Amendment

14/09/2002

Appointment/resignation of company officers

14/09/2002

Changes to the Board of Directors

14/09/2002

Minutes of Board meeting

14/09/2002

New auditor

14/09/2002

Private document

14/09/2002

Updated articles of association

14/09/2002

Minutes of general meeting of shareholders

04/06/2002

Minutes of Board meeting

04/06/2002

Changes to the Board of Directors

04/06/2002

Appointment/resignation of company officers

04/06/2002

Amendment

04/06/2002

Private document

29/11/2001

Updated articles of association

29/11/2001

Private document

29/11/2001

Amendment

06/09/2001

Appointment/resignation of company officers

06/09/2001

Private document

06/09/2001

New auditor

06/09/2001

Minutes of general meeting of shareholders

04/07/2001

Private document

04/07/2001

Amendment

04/07/2001

Appointment/resignation of company officers

04/07/2001

Changes to the Board of Directors

04/07/2001

Minutes of Board meeting

04/07/2001

New chairman (CEO, CoB)

11/01/2001

Appointment/resignation of company officers

11/01/2001

Audit or Management Report

11/01/2001

Capital increase

11/01/2001

Minutes of general meeting of shareholders

11/01/2001

Private document

11/01/2001

Updated articles of association

11/01/2001

New auditor

05/12/2000

Audit or Management Report

05/12/2000

Private document

17/08/2000

Amendment

17/08/2000

Application and court order

17/08/2000

Appointment/resignation of company officers

02/05/2000

Audit or Management Report

02/05/2000

Changes to the Board of Directors

02/05/2000

Minutes of general meeting of shareholders

02/05/2000

New company name

02/05/2000

Private document

02/05/2000

Updated articles of association

14/04/2000

Changes to the Board of Directors

14/04/2000

Appointment/resignation of company officers

14/04/2000

Amendment

14/04/2000

Minutes of Board meeting

14/04/2000

New chairman (CEO, CoB)

14/04/2000

Private document

11/10/1999

Changes to the Board of Directors

11/10/1999

Minutes of Board meeting

11/10/1999

Amendment

11/10/1999

Private document

11/10/1999

Appointment/resignation of company officers

16/08/1999

Updated articles of association

16/08/1999

Private document

16/08/1999

Minutes of general meeting of shareholders

16/08/1999

Declaration of conformity

16/08/1999

Conversion of equity to euro

16/08/1999

Capital increase

16/08/1999

Merger

22/06/1999

Audit or Management Report

22/06/1999

Private document

28/05/1999

Private document

28/05/1999

Planned merger

10/03/1999

Application and court order

10/03/1999

Appointment/resignation of company officers

10/03/1999

Amendment

09/12/1998

Audit or Management Report

09/12/1998

Private document

02/12/1998

Private document

02/12/1998

Planned merger

18/11/1998

Appointment/resignation of company officers

18/11/1998

Application and court order

18/11/1998

Amendment

17/11/1998

Planned merger

17/11/1998

Private document

20/10/1998

Minutes of Board meeting

20/10/1998

Changes to the Board of Directors

20/10/1998

Appointment/resignation of company officers

20/10/1998

Amendment

20/10/1998

Private document

24/08/1998

Capital increase

24/08/1998

Minutes of general meeting of shareholders

24/08/1998

Planned merger

24/08/1998

Private document

24/08/1998

Updated articles of association

23/07/1998

Audit or Management Report

23/07/1998

Private document

19/05/1998

Application and court order

19/05/1998

Appointment/resignation of company officers

19/05/1998

Amendment

29/07/1997

Appointment/resignation of company officers

29/07/1997

Minutes of general meeting of shareholders

29/07/1997

New auditor

29/07/1997

Private document

18/09/1996

Fund deposit certificate

18/09/1996

Capital increase

18/09/1996

Amendment

18/09/1996

Minutes of Board meeting

18/09/1996

Updated articles of association

18/09/1996

Private document

18/09/1996

Minutes of general meeting of shareholders

04/08/1995

Amendment

04/08/1995

Minutes of general meeting of shareholders

14/09/1994

Changes to the Board of Directors

14/09/1994

Minutes of Board meeting

14/09/1994

Appointment/resignation of company officers

14/09/1994

Amendment

14/09/1994

Minutes of general meeting of shareholders

22/03/1994

Minutes of general meeting of shareholders

22/03/1994

Declaration of conformity

22/03/1994

Amendment

22/03/1994

Updated articles of association

16/09/1993

Amendment

16/09/1993

Capital increase

16/09/1993

Declaration of conformity

16/09/1993

Minutes of Board meeting

16/09/1993

Minutes of general meeting of shareholders

16/09/1993

Updated articles of association

16/09/1993

Fund deposit certificate

16/04/1993

Minutes of Board meeting

16/04/1993

Changes to the Board of Directors

16/04/1993

Amendment

16/04/1993

Appointment/resignation of company officers

10/02/1992

Minutes of general meeting of shareholders

10/02/1992

Merger

10/02/1992

Amendment

10/02/1992

New company name

10/02/1992

Updated articles of association

10/02/1992

Private document

 

 

Synthesized Accounts

 

Annual Accounts

 

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2012

Account period (month)

12

12

12

Account Type

Normal

Normal

Normal

Date of capture

15/06/2015

18/06/2014

11/09/2015

Activity Code

2014Z

2014Z

2014Z

Employees

0

5055

0

 

 

Active account

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

2,174,000,000

6.0 %

2,051,000,000

10.6 %

1,855,000,000

2,679,000

81049.7 %

Intangible assets

120,000,000

13.2 %

106,000,000

21.8 %

87,000,000

15,000

799900.0 %

Tangible assets

698,000,000

-2.4 %

715,000,000

16.3 %

615,000,000

1,051,466

66283.5 %

Financial assets

1,354,000,000

10.1 %

1,230,000,000

6.7 %

1,153,000,000

6,959

19456718.5 %

Net current assets

2,633,000,000

57.8 %

1,669,000,000

-6.3 %

1,781,000,000

3,242,633

81099.4 %

Stocks

347,000,000

-4.9 %

365,000,000

-4.5 %

382,000,000

632,462

54765.0 %

Advanced payments

43,000,000

-12.2 %

49,000,000

-29.0 %

69,000,000

0

0%

Receivables

1,198,000,000

22.9 %

975,000,000

-13.1 %

1,122,000,000

1,424,678

83989.2 %

Securities and cash

1,045,000,000

273.2 %

280,000,000

34.6 %

208,000,000

164,263

636074.9 %

Prepaid expenses

-

-

-

-

-

620

-

Accounts of regularization

2,000,000

-89.5 %

19,000,000

11.8 %

17,000,000

0

0%

Total Assets

4,810,000,000

28.6 %

3,739,000,000

2.4 %

3,653,000,000

7,194,655

66755.2 %

 

 

Passive Account

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Shareholders' equity

193,000,000

-7.7 %

209,000,000

1.5 %

206,000,000

1,403,096

13655.3 %

Share capital

270,000,000

0%

270,000,000

0%

270,000,000

477,136

56487.6 %

Other capital resources

700,000,000

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

387,000,000

-16.6 %

464,000,000

7.9 %

430,000,000

50,213

770616.7 %

Liabilities

3,509,000,000

14.6 %

3,062,000,000

1.4 %

3,020,000,000

2,304,550

152164.0 %

Financial liabilities

2,971,000,000

18.7 %

2,504,000,000

5.1 %

2,382,000,000

225,183

1319271.4 %

Advanced payments received

3,000,000

-40.0 %

5,000,000

-28.6 %

7,000,000

0

0%

Trade account payables

347,000,000

3.3 %

336,000,000

-12.3 %

383,000,000

487,847

71028.9 %

Tax and social liabilities

124,000,000

-12.7 %

142,000,000

5.2 %

135,000,000

289,730

42698.5 %

Other debts and fixed assets liabilities

78,000,000

6.8 %

73,000,000

-32.4 %

108,000,000

88,965

87574.9 %

Account regularization

2,000,000

0%

2,000,000

-71.4 %

7,000,000

0

0%

Total liabilities

4,805,000,000

28.6 %

3,735,000,000

2.1 %

3,658,000,000

7,194,654

66685.7 %

 

 

Results

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Sales of Goods

2,774,000,000

-4.6 %

2,909,000,000

-16.4 %

3,479,000,000

5,572,280

49682.1 %

Net turnover

2,585,000,000

-4.1 %

2,695,000,000

-16.8 %

3,240,000,000

5,549,957

46476.9 %

of which net export turnover

0

0%

0

0%

0

23,445

0%

Operating charges

2,795,000,000

-2.7 %

2,874,000,000

-20.6 %

3,620,000,000

5,087,069

54843.2 %

Operating profit/loss

-25,000,000

-171.4 %

35,000,000

124.8 %

-141,000,000

130,534

-19252.1 %

Financial income

187,000,000

36.5 %

137,000,000

15.1 %

119,000,000

5,060

3695552.2 %

Financial charges

198,000,000

178.9 %

71,000,000

-11.3 %

80,000,000

11,489

1723287.6 %

Financial profit/loss

-11,000,000

-116.7 %

66,000,000

73.7 %

38,000,000

-2,090

-526215.8 %

Pretax net operating income

-35,000,000

-134.7 %

101,000,000

199.0 %

-102,000,000

99,261

-35360.6 %

Extraordinary income

200,000,000

-29.3 %

283,000,000

-72.0 %

1,009,000,000

16,655

1200740.6 %

Extraordinary charges

179,000,000

-58.7 %

433,000,000

-57.7 %

1,023,000,000

12,330

1451643.7 %

Extraordinary profit/loss

21,000,000

114.0 %

-150,000,000

-971.4 %

-14,000,000

0

0%

Net result

5,000,000

119.2 %

-26,000,000

74.0 %

-100,000,000

124,305

3922.4 %

 

 

Accounts – Active

 

Normal Account

 

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2012

Months

12

12

12

 

 

Grand Total - Active Accounts (I to VI)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Grand Total (I to VI)

Net

4,810,000,000

28.6 %

3,739,000,000

2.4 %

3,653,000,000

Gross

CO

7,303,000,000

16.7 %

6,257,000,000

3.0 %

6,077,000,000

Amortisation

1A

2,496,000,000

-0.9 %

2,518,000,000

3.9 %

2,424,000,000

 

 

Non declared distributed capital (I)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

Gross

AA

0

0%

0

0%

0

 

 

Active fixed asset (II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total Active fixed asset (II)

Net

2,174,000,000

6.0 %

2,051,000,000

10.6 %

1,855,000,000

Gross

BJ

4,628,000,000

5.4 %

4,392,000,000

4.3 %

4,210,000,000

Amortisation

BK

2,453,000,000

4.8 %

2,341,000,000

-0.6 %

2,355,000,000

 

 

Intangible fixed assets

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R&D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CQ

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

88,000,000

44.3 %

61,000,000

96.8 %

31,000,000

Gross

AF

238,000,000

17.2 %

203,000,000

3.6 %

196,000,000

Amortisation

AG

150,000,000

5.6 %

142,000,000

-13.9 %

165,000,000

Goodwill

Net

0

0%

1,000,000

0%

1,000,000

Gross

AH

25,000,000

0%

25,000,000

0%

25,000,000

Amortisation

AI

26,000,000

8.3 %

24,000,000

0%

24,000,000

Other intangible fixed assets

Net

32,000,000

-27.3 %

44,000,000

69.2 %

26,000,000

Gross

AJ

32,000,000

-30.4 %

46,000,000

39.4 %

33,000,000

Amortisation

AK

0

0%

2,000,000

-71.4 %

7,000,000

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

29,000,000

Gross

AL

0

0%

0

0%

29,000,000

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible asset

Net

120,000,000

13.2 %

106,000,000

21.8 %

87,000,000

 

 

Tangilble fixed assets

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Lands

Net

21,000,000

0%

21,000,000

0%

21,000,000

Gross

AN

33,000,000

3.1 %

32,000,000

0%

32,000,000

Amortisation

AO

12,000,000

9.1 %

11,000,000

0%

11,000,000

Buildings

Net

118,000,000

16.8 %

101,000,000

21.7 %

83,000,000

Gross

AP

540,000,000

6.3 %

508,000,000

4.5 %

486,000,000

Amortisation

AQ

422,000,000

3.7 %

407,000,000

1.0 %

403,000,000

Plant

Net

492,000,000

21.8 %

404,000,000

7.7 %

375,000,000

Gross

AR

2,156,000,000

8.0 %

1,997,000,000

3.4 %

1,932,000,000

Amortisation

AS

1,664,000,000

4.5 %

1,593,000,000

2.3 %

1,557,000,000

Other tangible fixed assets

Net

7,000,000

-12.5 %

8,000,000

166.7 %

3,000,000

Gross

AT

43,000,000

4.9 %

41,000,000

-18.0 %

50,000,000

Amortisation

AU

36,000,000

9.1 %

33,000,000

-29.8 %

47,000,000

Fixed assets in construction

Net

60,000,000

-66.9 %

181,000,000

36.1 %

133,000,000

Gross

AV

60,000,000

-66.9 %

181,000,000

33.1 %

136,000,000

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

3,000,000

Advances and payments on account

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AX

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

Sub Total Tangible asset

Net

698,000,000

-2.4 %

715,000,000

16.3 %

615,000,000

 

 

Financial assets

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

846,000,000

1.1 %

837,000,000

-2.6 %

859,000,000

Gross

CU

989,000,000

2.4 %

966,000,000

-2.7 %

993,000,000

Amortisation

CV

142,000,000

10.1 %

129,000,000

-3.7 %

134,000,000

Inter-company receivables

Net

278,000,000

46.3 %

190,000,000

-5.5 %

201,000,000

Gross

BB

278,000,000

46.3 %

190,000,000

-5.5 %

201,000,000

Amortisation

BC

0

0%

0

0%

0

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

Loans

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BF

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BG

0

0%

0

0%

0

Other financial assets

Net

230,000,000

13.3 %

203,000,000

118.3 %

93,000,000

Gross

BH

234,000,000

15.3 %

203,000,000

109.3 %

97,000,000

Amortisation

BI

3,000,000

0%

3,000,000

-25.0 %

4,000,000

Sub Total Financial assets

Net

1,354,000,000

10.1 %

1,230,000,000

6.7 %

1,153,000,000

 

 

Current Assets (III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total Current Assets

Net

2,633,000,000

57.8 %

1,669,000,000

-6.3 %

1,781,000,000

Gross

CJ

2,676,000,000

45.0 %

1,846,000,000

-0.2 %

1,850,000,000

Amortisation

CK

43,000,000

-75.7 %

177,000,000

156.5 %

69,000,000

 

 

Stocks

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Raw materials

Net

86,000,000

-3.4 %

89,000,000

-11.9 %

101,000,000

Gross

BL

105,000,000

-0.9 %

106,000,000

-10.9 %

119,000,000

Amortisation

BM

19,000,000

11.8 %

17,000,000

-5.6 %

18,000,000

Work in progress (goods)

Net

16,000,000

6.7 %

15,000,000

-6.3 %

16,000,000

Gross

BN

16,000,000

6.7 %

15,000,000

-6.3 %

16,000,000

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

245,000,000

0%

0

0%

265,000,000

Gross

BR

260,000,000

0%

0

0%

303,000,000

Amortisation

BS

15,000,000

0%

0

0%

38,000,000

Goods for resale

Net

0

0%

261,000,000

0%

0

Gross

BT

0

0%

299,000,000

0%

0

Amortisation

BU

0

0%

38,000,000

0%

0

Sub Total Stocks

Net

347,000,000

-4.9 %

365,000,000

-4.5 %

382,000,000

 

 

Advance payments to suppliers

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Advance payments to suppliers

Net

43,000,000

-12.2 %

49,000,000

-29.0 %

69,000,000

Gross

BV

43,000,000

-12.2 %

49,000,000

-29.0 %

69,000,000

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0

 

 

Debtors

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Trade accounts receivable

Net

1,190,000,000

206.7 %

388,000,000

-26.2 %

526,000,000

Gross

BX

1,196,000,000

166.4 %

449,000,000

-16.4 %

537,000,000

Amortisation

BY

6,000,000

-90.2 %

61,000,000

454.5 %

11,000,000

Other debtors

Net

0

0%

579,000,000

-1.5 %

588,000,000

Gross

BZ

0

0%

640,000,000

8.5 %

590,000,000

Amortisation

CA

0

0%

61,000,000

2950.0 %

2,000,000

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

Sub Total debtors

Net

1,190,000,000

23.1 %

967,000,000

-13.2 %

1,114,000,000

 

 

Divers

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Investment securities

Net

1,039,000,000

275.1 %

277,000,000

34.5 %

206,000,000

Gross

CD

1,039,000,000

275.1 %

277,000,000

34.5 %

206,000,000

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

6,000,000

100.0 %

3,000,000

50.0 %

2,000,000

Gross

CF

6,000,000

100.0 %

3,000,000

50.0 %

2,000,000

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

Sub Total Divers

Net

1,045,000,000

273.2 %

280,000,000

34.6 %

208,000,000

 

 

Prepaid expenses

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Prepaid expenses

Net

8,000,000

0%

8,000,000

0%

8,000,000

Gross

CH

8,000,000

0%

8,000,000

0%

8,000,000

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

 

Equalization accounts (IV to VI)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Expenses of loan issue to be spread

CW3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Currency differential gain

CN3

2,000,000

-89.5 %

19,000,000

11.8 %

17,000,000

Gross

2,000,000

-89.5 %

19,000,000

11.8 %

17,000,000

 

 

References

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

 

Accounts – Passive

 

Grand Total - Passive Accounts (I to V)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Grand Total (I to V)

EE

4,805,000,000

28.6 %

3,735,000,000

2.1 %

3,658,000,000

 

 

Shareholder Equity (I)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total shareholders' equity (Total I)

DL

193,000,000

-7.7 %

209,000,000

1.5 %

206,000,000

Equity and shareholders' equity

DA

270,000,000

0%

270,000,000

0%

270,000,000

Issue and merger premiums

DB

0

0%

0

0%

0

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

Legal reserve

DD

6,000,000

0%

6,000,000

-14.3 %

7,000,000

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

Other reserves

DG

0

0%

0

0%

0

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

0%

0

0%

0

Profits or losses brought forward

DH

-127,000,000

-27.0 %

-100,000,000

0%

0

Profit or loss for the period

DI

5,000,000

119.2 %

-26,000,000

74.0 %

-100,000,000

Investment grants

DJ

35,000,000

2.9 %

34,000,000

100.0 %

17,000,000

Special tax-allowable reserves

DK

2,000,000

-92.0 %

25,000,000

108.3 %

12,000,000

 

 

Other capital resources (II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total other capital resources (Total II)

DO

700,000,000

0%

0

0%

0

Income from participating securities

DM

700,000,000

0%

0

0%

0

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

 

 

Provisions for risks and charges (III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

387,000,000

-16.6 %

464,000,000

7.9 %

430,000,000

Risk provisions

DP

322,000,000

-18.9 %

397,000,000

57.5 %

252,000,000

Reserves for charges

DQ

64,000,000

-4.5 %

67,000,000

-62.4 %

178,000,000

 

 

Liabilities (IV)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total Liabilities (Total IV)

EC

3,509,000,000

14.6 %

3,062,000,000

1.4 %

3,020,000,000

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

Bank loans and liabilities

DU

125,000,000

7.8 %

116,000,000

-19.4 %

144,000,000

Sundry loans and financial liabilities

DV

2,846,000,000

19.2 %

2,388,000,000

6.7 %

2,238,000,000

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

Advance payments received for current orders

DW

3,000,000

-40.0 %

5,000,000

-28.6 %

7,000,000

Trade accounts payables

DX

347,000,000

3.3 %

336,000,000

-12.3 %

383,000,000

Tax and social security liabilities

DY

124,000,000

-12.7 %

142,000,000

5.2 %

135,000,000

Fixed asset liabilities

DZ

39,000,000

-31.6 %

57,000,000

29.5 %

44,000,000

Other debts

EA

19,000,000

18.8 %

16,000,000

-74.2 %

62,000,000

 

 

Translation loss (V)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Translation loss (Total V)

ED

20,000,000

0%

0

0%

2,000,000

 

 

Equalization accounts

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Deferred income

EB

2,000,000

0%

2,000,000

-71.4 %

7,000,000

 

 

References

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

 

 

Result account

 

1 - Operating result (I-II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Operating result (Total I-II)

GG

-25,000,000

-171.4 %

35,000,000

124.8 %

-141,000,000

 

 

2 - Financial result (V-VI)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Financial result (Total V-VI)

GV

-11,000,000

-116.7 %

66,000,000

73.7 %

38,000,000

 

 

3 - Pre-tax net operating income result (I to VI)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

-35,000,000

-134.7 %

101,000,000

199.0 %

-102,000,000

 

 

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

21,000,000

114.0 %

-150,000,000

-971.4 %

-14,000,000

 

 

Profit or loss

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Profit or loss

HN

5,000,000

119.2 %

-26,000,000

74.0 %

-100,000,000

 

 

Total Income (I+III+V+VII)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total Income (Total I+III+V+VII)

HL

3,161,000,000

-5.0 %

3,329,000,000

-27.7 %

4,607,000,000

 

 

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

3,152,000,000

-6.1 %

3,357,000,000

-28.7 %

4,706,000,000

 

 

Operating income (I)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total operating income (Total I)

FR

2,774,000,000

-4.6 %

2,909,000,000

-16.4 %

3,479,000,000

 

 

Operating income (details)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sale of goods for resale

FC

2,309,000,000

-5.7 %

2,448,000,000

0%

0

France

FA

2,309,000,000

-5.7 %

2,448,000,000

0%

0

Export

FB

0

0%

0

0%

0

Sale of goods produced

FF

0

0%

0

0%

2,922,000,000

France

FD

0

0%

0

0%

2,923,000,000

Export

FE

0

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

276,000,000

11.7 %

247,000,000

-22.3 %

318,000,000

France

FG

276,000,000

11.7 %

247,000,000

-22.3 %

318,000,000

Export

FH

0

0%

0

0%

0

Net turnover

FL

2,585,000,000

-4.1 %

2,695,000,000

-16.8 %

3,240,000,000

France

FJ

2,585,000,000

-4.1 %

2,695,000,000

-16.8 %

3,241,000,000

Export

FK

0

0%

0

0%

0

Stocked production

FM

-32,000,000

-966.7 %

-3,000,000

-109.4 %

32,000,000

Self-constructed assets

FN

12,000,000

-42.9 %

21,000,000

16.7 %

18,000,000

Operating grants

FO

7,000,000

16.7 %

6,000,000

-14.3 %

7,000,000

Release of reserves and provisions

FP

152,000,000

2.0 %

149,000,000

-2.6 %

153,000,000

Other income

FQ

49,000,000

19.5 %

41,000,000

41.4 %

29,000,000

 

 

Operating charges (II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total operating charges (Total II)

GF

2,795,000,000

-2.7 %

2,874,000,000

-20.6 %

3,620,000,000

 

 

Exploitation charges

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Purchase of goods for resale

FS

0

0%

0

0%

531,000,000

Change in stocks of goods for resale

FT

0

0%

0

0%

0

Purchase of raw materials

FU

1,474,000,000

-8.6 %

1,613,000,000

8.5 %

1,487,000,000

Change in stocks of raw materials

FV

7,000,000

-50.0 %

14,000,000

450.0 %

-4,000,000

Other external purchases and charges

FW

635,000,000

7.3 %

592,000,000

-28.3 %

826,000,000

Tax, duty and similar payments

FX

36,000,000

-21.7 %

46,000,000

-23.3 %

60,000,000

Payroll

FY

260,000,000

1.6 %

256,000,000

-11.7 %

290,000,000

Social security costs

FZ

148,000,000

-3.3 %

153,000,000

-11.0 %

172,000,000

 

 

Depreciation

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Depreciation of fixed assets

GA

129,000,000

12.2 %

115,000,000

-12.2 %

131,000,000

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

0

Depreciation/amortisation of current assets

GC

43,000,000

-6.5 %

46,000,000

-25.8 %

62,000,000

Provisions for risks and charges

GD

55,000,000

77.4 %

31,000,000

-44.6 %

56,000,000

 

 

Other charges

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Other charges

GE

8,000,000

0%

8,000,000

-11.1 %

9,000,000

 

 

Operating charges (III-IV)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

 

 

Financial income (V)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total financial income (Total V)

GP

187,000,000

36.5 %

137,000,000

15.1 %

119,000,000

Share financial income

GJ

72,000,000

-36.8 %

114,000,000

26.7 %

90,000,000

Other investment income & capitalised receivables

GK

0

0%

0

0%

0

Other interest and similar income

GL

3,000,000

0%

3,000,000

0%

3,000,000

Released provisions and transferred charges

GM

23,000,000

1050.0 %

2,000,000

-83.3 %

12,000,000

Exchange gains

GN

88,000,000

363.2 %

19,000,000

35.7 %

14,000,000

Net income from disposal of investment securities

GO

1,000,000

0%

1,000,000

0%

0

 

 

Financial charge (VI)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total financial charge (Total VI)

GU

198,000,000

178.9 %

71,000,000

-11.3 %

80,000,000

Financial reserves and provisions

GQ

25,000,000

56.3 %

16,000,000

6.7 %

15,000,000

Interest and similar charges

GR

54,000,000

14.9 %

47,000,000

4.4 %

45,000,000

Exchange losses

GS

119,000,000

1387.5 %

8,000,000

-60.0 %

20,000,000

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

 

 

Extraordinary income (VII)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total extraordinary income (Total VII)

HD

200,000,000

-29.3 %

283,000,000

-72.0 %

1,009,000,000

Extraordinary operating income

HA

1,000,000

-93.3 %

15,000,000

50.0 %

10,000,000

Extraordinary income from capital transactions

HB

5,000,000

-94.7 %

94,000,000

-62.7 %

252,000,000

Released provisions and transferred charges

HC

194,000,000

11.5 %

174,000,000

-76.6 %

745,000,000

 

 

Extraordinary charges (VIII)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

179,000,000

-58.7 %

433,000,000

-57.7 %

1,023,000,000

Extraordinary operating charges

HE

50,000,000

2.0 %

49,000,000

-83.0 %

288,000,000

Extraordinary charges from capital transactions

HF

111,000,000

170.7 %

41,000,000

-93.6 %

637,000,000

Extraordinary reserves and provisions

HG

17,000,000

-95.0 %

343,000,000

250.0 %

98,000,000

 

 

Employee profit sharing (IX)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

0

0%

0

0%

0

 

 

Tax on profits (X)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Tax on profits (Total X)

HK

-19,000,000

9.5 %

-21,000,000

-23.5 %

-17,000,000

 

 

References

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

Of which transferred charges

A1

0

0%

0

0%

0

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

 

 

Other incomes tax return forms

 

Fixed Assets

 

Grand Total Fixed Assets (I to IV)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

OK2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

OL

0

0%

0

0%

0

 

 

Research and development Charge (Total I)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

CO1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

CO2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

DO

0

0%

0

0%

0

 

 

Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value at begin of period

KD

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

LV2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

LW

0

0%

0

0%

0

 

 

Tangible fixed assets (Total III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value at begin of period

LN

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NG2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

NH

0

0%

0

0%

0

 

 

Financial assets (Total IV)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value at begin of period

LQ

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NJ2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

NK

0

0%

0

0%

0

 

 

Reserve for depreciation

 

Situation and movement of reserve for depreciation - Grand total (I-II-III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Reserve for depreciation value at begin of period

ON

0

0%

0

0%

0

Increases

OP

0

0%

0

0%

0

Decreasess

OQ

0

0%

0

0%

0

Reserve for depreciation value at the end of period

OR

0

0%

0

0%

0

 

 

Research and development charge (Total I)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0

 

 

Other intangible assets (Total II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

0

0%

0

0%

0

Increases

PF

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PG

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

PH

0

0%

0

0%

0

 

 

Total fixed assets amotisation (Total III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

0

0%

0

0%

0

Increases

QV

0

0%

0

0%

0

Decreases

QW

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

QX

0

0%

0

0%

0

 

 

Movements during period affecting charge allocated over several period

 

Deferred charges and debt issuance costs

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0

 

 

Premium refund of obligations

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Net value at begin of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

 

 

Provisions included in balance sheet

 

Grand Total (I-II-III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Value at begining of period

7C

0

0%

0

0%

0

Increases

UB

0

0%

0

0%

0

Decreases

UC

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

UD

0

0%

0

0%

0

 

 

Includes Total allocations

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Operating

UE

0

0%

0

0%

0

Financial

UG

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UJ

0

0%

0

0%

0

 

 

Includes Total Withdrawal

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Operating

UF

0

0%

0

0%

0

Financial

UH

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UK

0

0%

0

0%

0

 

 

Total regulated provisions (Total I)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Value at begining of period

3Z

0

0%

0

0%

0

Increases

TS

0

0%

0

0%

0

Decreases

TT

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

TU

0

0%

0

0%

0

 

 

Total risk and charge provisions (Total II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Value at begining of period

5Z

0

0%

0

0%

0

Increases

TV

0

0%

0

0%

0

Decreases

TW

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

TX

0

0%

0

0%

0

 

 

Total Provision for depreciation (Total III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Value at begining of period

7B

0

0%

0

0%

0

Increases

TY

0

0%

0

0%

0

Decreases

TZ

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

UA

0

0%

0

0%

0

 

 

State deadlines claims and debts at the end of period

 

State claims

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value

VT

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VU

0

0%

0

0%

0

More than one year

VV

0

0%

0

0%

0

 

 

State of loans

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Claims related to holdings (gross)

UL

0

0%

0

0%

0

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

0%

0

0%

0

Loans (gross)

UP

0

0%

0

0%

0

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

0

0%

0

Other financial assets (gross)

UT

0

0%

0

0%

0

Other financial assets (1 year at most)

UV

0

0%

0

0%

0

 

 

Receivables statement of assets

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Customers doubtful or disputed

VA

0

0%

0

0%

0

Other claims customer

UX

0

0%

0

0%

0

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts

UY

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

0

0%

0

Income taxes

VM

0

0%

0

0%

0

Value added tax

VB

0

0%

0

0%

0

Other taxes and payments assimilated

VN

0

0%

0

0%

0

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

0

0%

0

Group and Associates

VC

0

0%

0

0%

0

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

0

0%

0

0%

0

 

 

Prepaid

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Prepaid

VS

0

0%

0

0%

0

 

 

State Debt

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total debt (gross)

VY

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

VZ4

0

0%

0

0%

0

 

 

Details

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VG2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VH2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8A2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8A3

0

0%

0

0%

0

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8B2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8B3

0

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8C2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8D2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (Gross)

VW1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VW2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VQ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8J2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VI2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

V14

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8K2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8L2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0

 

References

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Loans made during the period

VJ

0

0%

0

0%

0

Debt repaid during the period

VK

0

0%

0

0%

0

 

 

Table allocation results and other information

 

Dividends distributed

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0

 

 

Commitments

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0

 

 

Other charges Externes

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0

 

 

Taxes and Fees

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0

 

 

VAT

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0

 

 

Average number of employees

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Average number of employees

YP

0

0%

5,055

0%

0

 

 

Groups and Shareholders

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Groups and Shareholders

ZR

0

-

-

-

0

 

 

Ratios

 

Structure and Liquidity

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Fixed Asset Financing

1.45

15.1 %

1.26

-1.6 %

1.28

1.33

9.0 %

Global Debt

489 days

19.6 %

409 days

21.7 %

336 days

114 days

328.9 %

Working Capital Fund overall net

289 days

92.7 %

150 days

16.3 %

129 days

93 days

210.8 %

Financial independence

6.50 %

-22.2 %

8.35 %

-3.5 %

8.65 %

358.91 %

-98.2 %

Solvability

18.58 %

231.8 %

5.60 %

-0.5 %

5.63 %

54.31 %

-65.8 %

Capacity debt futures

-

-

-

-

-

2,705.66 %

-

Coverage of current assets by net working capital overall

56.05 %

5.3 %

53.24 %

-6.3 %

56.79 %

51.66 %

8.5 %

General Liquidity

-

-

-

-

-

0.71

-

Restricted Liquidity

-

-

-

-

-

1.38

-

 

 

Management or rotation

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Need background in operating working capital

146 days

32.7 %

110 days

5.8 %

104 days

50 days

192.0 %

Treasury

146 days

294.6 %

37 days

60.9 %

23 days

6 days

2333.3 %

Inventory turnover of goods

-

-

-

-

0 days

0 days

-

Average length of credit granted to customers

167 days

178.3 %

60 days

0%

60 days

54 days

209.3 %

Average length of credit obtained suppliers

59 days

7.3 %

55 days

12.2 %

49 days

60 days

-1.7 %

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

26 days

8.3 %

24 days

-17.2 %

29 days

68 days

-61.8 %

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

-

-

-

-

-

143 days

-

Rotation tangible assets

-

-

-

-

-

137.07 %

-

 

 

Profitability of the business

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Margin trading

89.32 %

-1.7 %

90.83 %

654.2 %

-16.39 %

0.00 %

0%

Profitability of the business

0.46 %

-72.5 %

1.67 %

183.1 %

-2.01 %

8.24 %

-94.4 %

Net profit

0.19 %

119.8 %

-0.96 %

68.9 %

-3.09 %

3.89 %

-95.1 %

Growth rate of turnover (excluding VAT)

-4.08 %

75.7 %

-16.82 %

-39.8 %

-12.03 %

2.67 %

-252.8 %

Rates integration

17.37 %

-5.2 %

18.33 %

32.0 %

13.89 %

33.17 %

-47.6 %

Rate leasing furniture

0.00 %

0%

0.00 %

0%

0.00 %

0.00 %

0%

Work Factor

90.87 %

9.8 %

82.79 %

-19.4 %

102.67 %

56.55 %

60.7 %

Weight interests

7.66 %

191.3 %

2.63 %

6.5 %

2.47 %

0.30 %

2453.3 %

 

 

Return on capital

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Cash flow from the overall profitability

10.91 %

-25.6 %

14.66 %

-10.2 %

16.33 %

7.65 %

42.6 %

Rates of economic profitability

0.00 %

0%

2.00 %

166.7 %

-3.00 %

13.00 %

0%

Financial profitability

893,000,000.00 %

327.3 %

209,000,000.00 %

1.5 %

206,000,000.00 %

1,321,951.00 %

67451.7 %

Return on investment

5.25 %

216.3 %

1.66 %

315.6 %

-0.77 %

7.53 %

-30.3 %

 

 

Management intermediate balances

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Turnover

2,585,000,000

-4.1 %

2,695,000,000

-16.8 %

3,240,000,000

5,549,957

46476.9 %

 

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Sales of goods

2,309,000,000

-5.7 %

2,448,000,000

0%

0

-

- Purchase of goods

0

0%

0

0%

531,000,000

-

+/- Stock of goods variation

0

0%

0

0%

0

-

Trading margin

2,309,000,000 €

-5.7 %

2,448,000,000 €

561.0 %

-531,000,000 €

0 €

0%

89.32 % CA

-1.7 %

90.83 % CA

654.2 %

-16.39 % CA

0.00 % CA

0%

 

 

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Sale of goods produced

276,000,000

11.7 %

247,000,000

-92.4 %

3,240,000,000

-

+/- Stocked production

-32,000,000

-966.7 %

-3,000,000

-109.4 %

32,000,000

-

+ Self-constructed assets

12,000,000

-42.9 %

21,000,000

16.7 %

18,000,000

-

Period production

256,000,000 €

-3.4 %

265,000,000 €

-91.9 %

3,290,000,000 €

3,374,405 €

7486.5 %

9.90 % CA

0.7 %

9.83 % CA

-90.3 %

101.54 % CA

99.76 % CA

-90.1 %

 

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Trading margin

2,309,000,000

-5.7 %

2,448,000,000

561.0 %

-531,000,000

0

0%

+ Period Production

256,000,000

-3.4 %

265,000,000

-91.9 %

3,290,000,000

3,374,405

7486.5 %

- Purchase of raw materials

1,474,000,000

-8.6 %

1,613,000,000

8.5 %

1,487,000,000

-

+/- Change in stocks of raw materiels

7,000,000

-50.0 %

14,000,000

450.0 %

-4,000,000

-

- Other external purchases and charges

635,000,000

7.3 %

592,000,000

-28.3 %

826,000,000

-

Added value

449,000,000 €

-9.1 %

494,000,000 €

9.8 %

450,000,000 €

1,178,555 €

37997.5 %

17.37 % CA

-5.2 %

18.33 % CA

32.0 %

13.89 % CA

33.17 % CA

-47.6 %

 

 

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Added value

449,000,000 €

-9.1 %

494,000,000 €

9.8 %

450,000,000 €

1,178,555 €

37997.5 %

+ Operating grants

7,000,000

16.7 %

6,000,000

-14.3 %

7,000,000

-

- Tax, duty and similar payments

36,000,000

-21.7 %

46,000,000

-23.3 %

60,000,000

-

- Personal charges

408,000,000

-0.2 %

409,000,000

-11.5 %

462,000,000

-

Gross operating surplus

12,000,000 €

-73.3 %

45,000,000 €

169.2 %

-65,000,000 €

257,185 €

4565.9 %

0.46 % CA

-72.5 %

1.67 % CA

183.1 %

-2.01 % CA

8.24 % CA

-94.4 %

 

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Gross operating surplus

12,000,000 €

-73.3 %

45,000,000 €

169.2 %

-65,000,000 €

257,185 €

4565.9 %

+ Release of reserves and provisions

152,000,000

2.0 %

149,000,000

-2.6 %

153,000,000

-

+ Other operating income

49,000,000

19.5 %

41,000,000

41.4 %

29,000,000

-

- Depreciation/ Amortisation

227,000,000

18.2 %

192,000,000

-22.9 %

249,000,000

-

- Other charges

8,000,000

0%

8,000,000

-11.1 %

9,000,000

-

Operating result

-22,000,000 €

-162.9 %

35,000,000 €

124.8 %

-141,000,000 €

130,537 €

-16953.5 %

-0.85 % CA

-165.4 %

1.30 % CA

129.9 %

-4.35 % CA

3.39 % CA

-125.1 %

 

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Operating result

-22,000,000 €

-162.9 %

35,000,000 €

124.8 %

-141,000,000 €

130,537 €

-16953.5 %

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

-

+ Financial income

187,000,000

36.5 %

137,000,000

15.1 %

119,000,000

-

- Financial charges

198,000,000

178.9 %

71,000,000

-11.3 %

80,000,000

-

Pre-tax result

-33,000,000 €

-132.7 %

101,000,000 €

199.0 %

-102,000,000 €

99,262 €

-33345.4 %

-1.28 % CA

-134.1 %

3.75 % CA

219.0 %

-3.15 % CA

3.35 % CA

-138.2 %

 

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Extraordinary income

200,000,000

-29.3 %

283,000,000

-72.0 %

1,009,000,000

16,655

1200740.6 %

- Extraordinary charges

179,000,000

-58.7 %

433,000,000

-57.7 %

1,023,000,000

-

Extraordinary result

21,000,000 €

114.0 %

-150,000,000 €

-971.4 %

-14,000,000 €

0 €

0%

0.81 % CA

114.5 %

-5.57 % CA

-1195.3 %

-0.43 % CA

0.00 % CA

0%

 

 

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sector Median 2014

Pre-tax result

-33,000,000 €

-132.7 %

101,000,000 €

199.0 %

-102,000,000 €

99,262 €

-33345.4 %

Extraordinary result

21,000,000 €

114.0 %

-150,000,000 €

-971.4 %

-14,000,000 €

0 €

0%

- Employee profit sharing

0

0%

0

0%

0

-

- Tax on profits

-19,000,000

9.5 %

-21,000,000

-23.5 %

-17,000,000

-

Net result

7,000,000 €

125.0 %

-28,000,000 €

71.7 %

-99,000,000 €

147,139 €

4657.4 %

0.27 % CA

126.0 %

-1.04 % CA

66.0 %

-3.06 % CA

3.93 % CA

-93.1 %

 

 

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.64.96

UK Pound

1

Rs.99.73

Euro

1

Rs.71.84

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

KAR

 

 

Report Prepared by :

ANK

 


 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

 

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.