|
Report No. : |
338701 |
|
Report Date : |
14.09.2015 |
IDENTIFICATION DETAILS
|
Name : |
VEOLIA
PROPRETE |
|
|
|
|
Registered Office : |
Cgea Onyx, 5 Rue Pleyel, 93200 Saint Denis |
|
|
|
|
Country : |
France |
|
|
|
|
Date of Incorporation : |
December 1957 |
|
|
|
|
Com. Reg. No.: |
572 221 034 |
|
|
|
|
Legal Form : |
Simplified Joint Stock Company with Single Associate |
|
|
|
|
Line of Business : |
|
|
|
|
|
No. of Employee : |
1 000 to 1 999 |
RATING & COMMENTS
|
MIRA’s Rating : |
B |
|
RATING |
STATUS |
PROPOSED CREDIT LINE |
|
|
26-40 |
B |
Capability to overcome financial difficulties seems comparatively
below average. |
Small |
|
Status : |
Moderate |
|
|
|
|
Payment Behaviour : |
Unknown |
|
|
|
|
Litigation : |
Clear |
NOTES :
Any query related to this report can be made
on e-mail : infodept@mirainform.com
while quoting report number, name and date.
ECGC Country Risk Classification List – March 31, 2015
|
Country Name |
Previous Rating (31.12.2014) |
Current Rating (31.03.2015) |
|
France |
A1 |
A1 |
|
Risk Category |
ECGC
Classification |
|
Insignificant |
A1 |
|
Low |
A2 |
|
Moderate |
B1 |
|
High |
B2 |
|
Very High |
C1 |
|
Restricted |
C2 |
|
Off-credit |
D |
FRANCE - ECONOMIC OVERVIEW
The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With more than 84 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that mitigate economic inequality. France's real GDP increased by 0.4% in 2014. The unemployment rate (including overseas territories) increased from 7.8% in 2008 to 10.4% in the fourth quarter of 2014. Youth unemployment in metropolitan France decreased from a high of 25.4% in the fourth quarter of 2012 to 24.3% in the fourth quarter of 2014. Lower-than-expected growth and high spending have strained France's public finances. The budget deficit rose sharply from 3.3% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 4% of GDP in 2014, while France's public debt rose from 68% of GDP to more than 95% in 2014, and may hit 100% by 2016. Elected on a conventionally leftist platform, President Francois HOLLANDE surprised and angered many supporters with a January 2014 speech announcing a sharp change in his economic policy, recasting himself as a liberalizing reformer. The government's budget for 2014 shifted the balance of fiscal consolidation from taxes to a total of $24 billion in spending cuts. In December 2014, HOLLANDE announced additional reforms, including a plan to extend commercial business hours, liberalize professional services, and sell off $6.2-12.4 billion in state owned assets. France’s tax burden remains well above the EU average and income tax cuts over the past decade are being partly reversed, particularly for higher earners. The top rate of income tax is 41%. The government is allowing a 75% payroll tax on salaries over $1.24 million to lapse.
|
Source
: CIA |
VEOLIA PROPRETE
|
SIRET
|
572
221 034 01180 |
||
|
Name
|
VEOLIA
PROPRETE |
||
|
Acronym
|
CGEA
|
||
|
Trade
name |
-
|
||
|
Status
|
Economically
active |
||
|
Postal
Address |
VEOLIA
PROPRETE |
||
|
Share
Capital |
143,473,440
Euros |
||
|
Incorporiation
Date |
12/1957
|
||
|
Activity
(APE) |
Recovery of sorted materials (3832Z) |
RCS
Registration |
RCS
Nanterre B 572 221 034 |
|
Formation
Date |
-
|
EUR
VAT Number |
FR85572221034
|
|
Deregistration
Date |
-
|
Last
account Date |
31/12/2013
|
|
Court
Registry Number |
19
8 0B03901 |
Telephone
|
-
|
|
Registration
Court |
Nanterre
(92) |
Fax
|
-
|
|
Nationality
|
France
|
|
|
|
Legal
form |
Simplified
Joint Stock Company with Single Associate |
||
|
Currency
|
Euros
|
||
|
Type
of Establishment |
Secondary
Establishment |
Production
Role |
- |
|
APE/NAF
Code |
4677Z |
Activity |
Wholesale
(business to business) waste and scrap |
|
Formation
Date |
10/2010 |
Reason
for Formation |
Formation |
|
Closure
Date |
- |
Reason
for Closure |
- |
|
Reactivation
Date |
- |
Seasonality |
- |
|
Activity
Nature |
- |
Activity
Location |
N/R |
|
Trading
Address |
5
RUE PLEYEL |
Department |
- |
|
Location
Surface |
- |
District |
- |
|
City |
SAINT
DENIS |
Status |
Economically
active |
|
Business
Pages FT® |
- |
Region |
Ile-de-France |
|
Area |
- |
||
|
Size
of Urban Area |
- |
|
Regionality |
Legal
unit with multiple establishments in many areas having at least 50% of
workforce in same area |
|
Mono-activity
status |
Legal
unit with multiple establishments having main activities in many divisions,
which one activity grouping from 80 to 99% of workforce |
|
Branches |
43
branch entities in this company |
|
Company
Name |
Company
Type |
APE/NAF
Code |
Activity |
City |
Post
Code |
|
VEOLIA
PROPRETE |
Head
Office |
3832Z |
Recovery
of sorted materials |
NANTERRE |
92000 |
|
VEOLIA
PROPRETE |
Branch |
3832Z |
Recovery
of sorted materials |
ARGENCES |
14370 |
|
VEOLIA
PROPRETE |
Branch |
3832Z |
Recovery
of sorted materials |
AMFREVILLE |
14860 |
|
VEOLIA
PROPRETE |
Branch |
3832Z |
Recovery
of sorted materials |
AUBEVOYE |
27940 |
|
VEOLIA
PROPRETE |
Branch |
3832Z |
Recovery
of sorted materials |
LEVES |
28300 |
|
Workforce
at address |
Workforce
unknown |
Company
workforce |
1
000 to 1 999 employees |
Status
history
|
No
Status History |
|
Publication
date |
Gazette
Name |
Description
|
|
|
04/11/2014
|
Bodacc
C |
Comptes
annuels et rapports |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 18075
- 572221034 RCS. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société par actions
simplifiée. Adresse : 163-169 avenue Georges Clémenceau 92000
Nanterre. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice
clos le : 31/12/2013. |
|||
|
11/08/2013
|
Bodacc
B |
Modification
et mutation diverse |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 2305
- 572 221 034 RCS Nanterre. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société
par actions simplifiée. Administration : Commissaire aux comptes
titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 02 Août 2013
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 02 Août 2013
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 11 Septembre
2007 Président : BERTREAU François modification le 02 Août 2013 Commissaire
aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 04 Juin 2013. Activité
: . |
|||
|
30/07/2013
|
JAL
|
Resignation
/ Revocation of the social representative |
|
|
Affiches
parisiennes (Les)
|
|||
|
30/07/2013
|
JAL
|
Appointment
of the social representative |
|
|
Affiches
parisiennes (Les)
|
|||
|
22/07/2013
|
Bodacc
C |
Comptes
annuels et rapports |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 15167
- 572221034 RCS. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société par actions
simplifiée. Adresse : 163-169 avenue Georges Clémenceau 92000
Nanterre. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice
clos le : 31/12/2012. |
|||
|
13/06/2013
|
Bodacc
B |
Modification
et mutation diverse |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 2537
- 572 221 034 RCS Nanterre. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société
par actions simplifiée. Administration : Commissaire aux comptes
titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 11 Septembre 2007
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Septembre 2007
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 11 Septembre
2007 Président : LE CONTE Jérôme, Marie, Didier modification le 07 Novembre
2012 Directeur général : BERTREAU François en fonction le 04 Juin 2013
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 04 Juin
2013. Activité : . |
|||
|
25/05/2013
|
JAL
|
Resignation
/ Revocation of the social representative |
|
|
Affiches
parisiennes (Les)
|
|||
|
25/05/2013
|
JAL
|
Appointment
of the social representative |
|
|
Affiches
parisiennes (Les)
|
|||
|
16/11/2012
|
Bodacc
B |
Modification
et mutation diverse |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 1252
- 572 221 034 RCS Nanterre. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société
par actions simplifiée. Administration : Commissaire aux comptes
titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 11 Septembre 2007
Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François en fonction le 11
Septembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11
Septembre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le
11 Septembre 2007 Président : LE CONTE Jérôme, Marie, Didier modification le
07 Novembre 2012. Activité : . |
|||
|
09/11/2012
|
Bodacc
B |
Modification
et mutation diverse |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 2160
- 572 221 034 RCS Nanterre. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société
anonyme. Administration : Président d'honneur et administrateur :
ROUER Bernard modification le 01 Décembre 2011 Administrateur : GIRARDOT
Paul, Louis modification le 25 Novembre 2011 Administrateur : BURFIN Armand
en fonction le 02 Janvier 2001 Administrateur : KUCH Gustave en fonction le
21 Septembre 2002 Administrateur : BITTERLICH Joachim en fonction le 19
Novembre 2003 Président du conseil d'administration et administrateur :
FREROT Antoine modification le 31 Octobre 2012 Commissaire aux comptes
titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 11 Septembre 2007
Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François en fonction le 11
Septembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11
Septembre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le
11 Septembre 2007 Administrateur : BLONDEAU Jean en fonction le 11 Février
2009 Administrateur : HERREWYN Jean Michel en fonction le 21 Juillet 2011
Administrateur : RIOLACCI Pierre Francois en fonction le 21 Juillet 2011
Directeur général et administrateur : LE CONTE Jérôme, Marie, Didier
modification le 07 Décembre 2011. Activité : . |
|||
|
01/11/2012
|
JAL
|
Appointment
of the social representative |
|
|
Affiches
parisiennes (Les)
|
|||
|
30/10/2012
|
JAL
|
Appointment
of the social representative |
|
|
Affiches
parisiennes (Les)
|
|||
|
30/10/2012
|
JAL
|
Resignation
/ Revocation of the social representative |
|
|
Affiches
parisiennes (Les)
|
|||
|
19/08/2012
|
Bodacc
B |
Modification
et mutation diverse |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 1104
- 572 221 034 RCS Nanterre. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société
anonyme. Administration : Président d'honneur et administrateur :
ROUER Bernard modification le 01 Décembre 2011 Administrateur : GIRARDOT
Paul, Louis modification le 25 Novembre 2011 Administrateur : BURFIN Armand
en fonction le 02 Janvier 2001 Président du conseil d'administration et
administrateur : GASQUET Denis Claude Marcellin modification le 24 Octobre
2011 Administrateur : KUCH Gustave en fonction le 21 Septembre 2002
Administrateur : BITTERLICH Joachim en fonction le 19 Novembre 2003
Administrateur : FREROT Antoine modification le 24 Octobre 2011 Commissaire
aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 11
Septembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François en
fonction le 11 Septembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en
fonction le 11 Septembre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A
en fonction le 11 Septembre 2007 Administrateur : BLONDEAU Jean en fonction
le 11 Février 2009 Administrateur : HERREWYN Jean Michel en fonction le 21
Juillet 2011 Administrateur : RIOLACCI Pierre Francois en fonction le 21
Juillet 2011 Directeur général et administrateur : LE CONTE Jérôme, Marie,
Didier modification le 07 Décembre 2011. Activité : . |
|||
|
07/08/2012
|
JAL
|
Resignation
/ Revocation of the social representative |
|
|
Affiches
parisiennes (Les)
|
|||
|
26/07/2012
|
Bodacc
C |
Comptes
annuels et rapports |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 13652
- 572221034 RCS. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société anonyme. Adresse
: 163-169 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre. Commentaires :
Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011. |
|||
|
26/06/2012
|
Bodacc
B |
Modification
et mutation diverse |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 1911
- 572 221 034 RCS Nanterre. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société
anonyme. Administration : Administrateur : TURION Jean-Claude
modification le 09 Août 2001 Président d'honneur et administrateur : ROUER
Bernard modification le 01 Décembre 2011 Administrateur : GIRARDOT Paul,
Louis modification le 25 Novembre 2011 Administrateur : BURFIN Armand en
fonction le 02 Janvier 2001 Président du conseil d'administration et
administrateur : GASQUET Denis Claude Marcellin modification le 24 Octobre
2011 Administrateur : KUCH Gustave en fonction le 21 Septembre 2002
Administrateur : BITTERLICH Joachim en fonction le 19 Novembre 2003
Administrateur : FREROT Antoine modification le 24 Octobre 2011 Commissaire aux
comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 11 Septembre
2007 Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François en fonction le 11
Septembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11
Septembre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le
11 Septembre 2007 Administrateur : BLONDEAU Jean en fonction le 11 Février
2009 Administrateur : HERREWYN Jean Michel en fonction le 21 Juillet 2011
Administrateur : RIOLACCI Pierre Francois en fonction le 21 Juillet 2011
Directeur général et administrateur : LE CONTE Jérôme, Marie, Didier
modification le 07 Décembre 2011. Activité : . |
|||
|
14/06/2012
|
JAL
|
Resignation
/ Revocation of the social representative |
|
|
Affiches
parisiennes (Les)
|
|||
|
13/03/2012
|
Bodacc
B |
Modification
et mutation diverse |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 2102
- 572 221 034 RCS Nanterre. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société
anonyme. Administration : Administrateur : PROGLIO Henri modification le
25 Novembre 2011 Administrateur : TURION Jean-Claude modification le 09 Août
2001 Président d'honneur et administrateur : ROUER Bernard modification le 01
Décembre 2011 Administrateur : GIRARDOT Paul, Louis modification le 25
Novembre 2011 Administrateur : BURFIN Armand en fonction le 02 Janvier 2001
Président du conseil d'administration et administrateur : GASQUET Denis
Claude Marcellin modification le 24 Octobre 2011 Administrateur : KUCH
Gustave en fonction le 21 Septembre 2002 Administrateur : BITTERLICH Joachim
en fonction le 19 Novembre 2003 Administrateur : FREROT Antoine modification
le 24 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et
Autres en fonction le 11 Septembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant :
CAUBRIERE François en fonction le 11 Septembre 2007 Commissaire aux comptes
suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Septembre 2007 Commissaire aux comptes
titulaire : KPMG S. A en fonction le 11 Septembre 2007 Administrateur :
BLONDEAU Jean en fonction le 11 Février 2009 Administrateur : HERREWYN Jean
Michel en fonction le 21 Juillet 2011 Administrateur : RIOLACCI Pierre
Francois en fonction le 21 Juillet 2011 Directeur général et administrateur :
LE CONTE Jérôme, Marie, Didier modification le 07 Décembre 2011
Administrateur : ORSINI Olivier en fonction le 05 Mars 2012. Activité : .
|
|||
|
01/03/2012
|
JAL
|
Resignation
/ Revocation of the social representative |
|
|
Affiches
parisiennes (Les)
|
|||
|
01/03/2012
|
JAL
|
Appointment
of the social representative |
|
|
Affiches
parisiennes (Les)
|
|||
|
25/11/2011
|
Bodacc
C |
Comptes
annuels et rapports |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 12167
- 572221034 RCS. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société anonyme. Adresse
: 163-169 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre. Commentaires :
Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2010. |
|||
|
31/10/2011
|
Bodacc
B |
Modification
et mutation diverse |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 1763
- 572 221 034 RCS Nanterre. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société
anonyme. Administration : Administrateur : PROGLIO HENRI modification
le 19 Avril 2011 Administrateur : TURION Jean-Claude modification le 09 Août
2001 Président d'honneur et administrateur : ROUER BERNARD Administrateur :
GIRARDOT PAUL LOUIS Administrateur : BURFIN Armand en fonction le 02 Janvier
2001 Président du conseil d'administration et administrateur : GASQUET Denis
Claude Marcellin modification le 24 Octobre 2011 Administrateur : KUCH
Gustave en fonction le 21 Septembre 2002 Administrateur : BITTERLICH Joachim
en fonction le 19 Novembre 2003 Administrateur : BARBAROUX Olivier en
fonction le 05 Juillet 2004 Administrateur : FREROT Antoine modification le
24 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et
Autres en fonction le 11 Septembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant :
CAUBRIERE François en fonction le 11 Septembre 2007 Commissaire aux comptes
suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Septembre 2007 Commissaire aux comptes
titulaire : KPMG S. A en fonction le 11 Septembre 2007 Administrateur :
BLONDEAU Jean en fonction le 11 Février 2009 Administrateur : HERREWYN Jean
Michel en fonction le 21 Juillet 2011 Administrateur : RIOLACCI Pierre
Francois en fonction le 21 Juillet 2011 Directeur général et administrateur :
LECONTE Jérome, Marie, Didier en fonction le 24 Octobre 2011. Activité : .
|
|||
|
20/10/2011
|
JAL
|
Resignation
/ Revocation of the social representative |
|
|
Affiches
parisiennes (Les)
|
|||
|
20/10/2011
|
JAL
|
Appointment
of the social representative |
|
|
Affiches
parisiennes (Les)
|
|||
|
27/07/2011
|
Bodacc
B |
Modification
et mutation diverse |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 4061
- 572 221 034 RCS Nanterre. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société
anonyme. Administration : Administrateur : PROGLIO HENRI modification
le 19 Avril 2011 Administrateur : TURION Jean-Claude modification le 09 Août
2001 Président d'honneur et administrateur : ROUER BERNARD Administrateur :
GIRARDOT PAUL LOUIS Administrateur : BURFIN Armand en fonction le 02 Janvier
2001 Directeur général et administrateur : GASQUET Denis Claude Marcellin
modification le 12 Janvier 2010 Administrateur : KUCH Gustave en fonction le 21
Septembre 2002 Administrateur : BITTERLICH Joachim en fonction le 19 Novembre
2003 Administrateur : BARBAROUX Olivier en fonction le 05 Juillet 2004
Président du conseil d'administration et administrateur : FREROT Antoine
modification le 19 Avril 2011 Administrateur : DU PELOUX Cyrille en fonction
le 02 Août 2007 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et
Autres en fonction le 11 Septembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant :
CAUBRIERE François en fonction le 11 Septembre 2007 Commissaire aux comptes
suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Septembre 2007 Commissaire aux comptes
titulaire : KPMG S. A en fonction le 11 Septembre 2007 Administrateur :
BLONDEAU Jean en fonction le 11 Février 2009 Administrateur : HERREWYN Jean
Michel en fonction le 21 Juillet 2011 Administrateur : RIOLACCI Pierre
Francois en fonction le 21 Juillet 2011. Activité : . |
|||
|
19/07/2011
|
JAL
|
Appointment
of the social representative |
|
|
Affiches
parisiennes (Les)
|
|||
|
29/04/2011
|
Bodacc
B |
Modification
et mutation diverse |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 1615
- 572 221 034 RCS Nanterre. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société
anonyme. Administration : Administrateur : PROGLIO HENRI modification
le 19 Avril 2011 Administrateur : TURION Jean-Claude modification le 09 Août
2001 Président d'honneur et administrateur : ROUER BERNARD Administrateur :
GIRARDOT PAUL LOUIS Administrateur : BURFIN Armand en fonction le 02 Janvier
2001 Directeur général et administrateur : GASQUET Denis Claude Marcellin
modification le 12 Janvier 2010 Administrateur : KUCH Gustave en fonction le
21 Septembre 2002 Administrateur : BITTERLICH Joachim en fonction le 19
Novembre 2003 Administrateur : BARBAROUX Olivier en fonction le 05 Juillet
2004 Président du conseil d'administration et administrateur : FREROT Antoine
modification le 19 Avril 2011 Administrateur : DU PELOUX Cyrille en fonction
le 02 Août 2007 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et
Autres en fonction le 11 Septembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant :
CAUBRIERE François en fonction le 11 Septembre 2007 Commissaire aux comptes
suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Septembre 2007 Commissaire aux comptes
titulaire : KPMG S. A en fonction le 11 Septembre 2007 Administrateur :
BLONDEAU Jean en fonction le 11 Février 2009. Activité : . |
|||
|
16/04/2011
|
JAL
|
Appointment
of the social representative |
|
|
Affiches
parisiennes (Les)
|
|||
|
25/08/2010
|
Bodacc
C |
Comptes
annuels et rapports |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 8596
- 572221034 RCS. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société anonyme. Adresse
: 163-169 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre. Commentaires :
Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009. |
|||
|
25/08/2010
|
Bodacc
C |
Comptes
annuels, consolidés et rapports |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 8597
- 572221034 RCS. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société anonyme. Adresse
: 163-169 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre. Commentaires :
Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009. |
|||
|
19/03/2010
|
Bodacc
B |
Modification
et mutation diverse |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 1601
- 572 221 034 RCS Nanterre. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société
anonyme. Administration : Président du conseil d'administration :
PROGLIO HENRI Administrateur : TURION Jean-Claude modification le 09 Août
2001 Président d'honneur et administrateur : ROUER BERNARD Administrateur :
GIRARDOT PAUL LOUIS Administrateur : BURFIN Armand en fonction le 02 Janvier
2001 Directeur général et administrateur : GASQUET Denis Claude Marcellin
modification le 12 Janvier 2010 Administrateur : KUCH Gustave en fonction le
21 Septembre 2002 Administrateur : BITTERLICH Joachim en fonction le 19
Novembre 2003 Administrateur : BARBAROUX Olivier en fonction le 05 Juillet
2004 Administrateur : FREROT Antoine en fonction le 05 Juillet 2004 Administrateur
: DU PELOUX Cyrille en fonction le 02 Août 2007 Commissaire aux comptes
titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 11 Septembre 2007
Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François en fonction le 11
Septembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11
Septembre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le
11 Septembre 2007 Administrateur : BLONDEAU Jean en fonction le 11 Février
2009. |
|||
|
08/03/2010
|
JAL
|
Resignation
/ Revocation of the social representative |
|
|
AFFICHES
PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES
|
|||
|
17/01/2010
|
Bodacc
B |
Modification
et mutation diverse |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 4600
- 572 221 034 RCS Nanterre. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société anonyme.
Enseigne : CGEA ONYX - ONYX- VEOLIA PROPRETE FRANCE RECYCLING- VPFR. |
|||
|
30/09/2009
|
JAL
|
Proposed
merger |
|
|
AFFICHES
PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES
|
|||
|
30/09/2009
|
JAL
|
Proposed
merger |
|
|
AFFICHES
PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES
|
|||
|
12/08/2009
|
Bodacc
C |
Comptes
annuels et rapports |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 10258
- 572221034 RCS. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société anonyme. Adresse
: 163-169 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre. Commentaires :
Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008. |
|||
|
12/08/2009
|
Bodacc
C |
Comptes
annuels, consolidés et rapports |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 10259
- 572221034 RCS. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société anonyme. Adresse
: 163-169 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre. Commentaires :
Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008. |
|||
|
14/05/2009
|
Bodacc
B |
Modification
et mutation diverse |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 5302
- 572 221 034 RCS Nanterre. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société
anonyme. Administration : Président du conseil d'administration : PROGLIO
HENRI. Administrateur : TURION Jean-Claude modification le 09 Août 2001.
Président d'honneur et administrateur : ROUER BERNARD. Administrateur :
GIRARDOT PAUL LOUIS. Administrateur : BURFIN Armand en fonction le 02 Janvier
2001. Directeur général et administrateur : GASQUET Denis Claude Marcellin
modification le 30 Décembre 2005. Administrateur : KUCH Gustave en fonction
le 21 Septembre 2002. Administrateur : BITTERLICH Joachim en fonction le 19
Novembre 2003. Administrateur : BARBAROUX Olivier en fonction le 05 Juillet
2004. Administrateur : FREROT Antoine en fonction le 05 Juillet 2004.
Administrateur : DU PELOUX Cyrille en fonction le 02 Août 2007. Commissaire
aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 11
Septembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François en
fonction le 11 Septembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en
fonction le 11 Septembre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A
en fonction le 11 Septembre 2007. Administrateur : BLONDEAU Jean en fonction
le 11 Février 2009. Administrateur : PIQUEMAL Thomas en fonction le 05 Mai
2009. |
|||
|
26/02/2009
|
Bodacc
B |
Modification
et mutation diverse |
|
|
92 - HAUTS-DE-SEINE GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NANTERRE 2225 - 572 221 034
RCS Nanterre. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société anonyme. Administration
: Président du conseil d'administration : PROGLIO HENRI. Administrateur :
TURION Jean-Claude modification le 09 Août 2001. Président d'honneur et
administrateur : ROUER BERNARD. Administrateur : GIRARDOT PAUL LOUIS.
Administrateur : BURFIN Armand en fonction le 02 Janvier 2001. Directeur
général et administrateur : GASQUET Denis Claude Marcellin modification le 30
Décembre 2005. Administrateur : CONTAMINE Jerome en fonction le 11 Octobre
2001. Administrateur : KUCH Gustave en fonction le 21 Septembre 2002.
Administrateur : BITTERLICH Joachim en fonction le 19 Novembre 2003. Administrateur
: BARBAROUX Olivier en fonction le 05 Juillet 2004. Administrateur : FREROT
Antoine en fonction le 05 Juillet 2004. Administrateur : DU PELOUX Cyrille en
fonction le 02 Août 2007. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST &
YOUNG et Autres en fonction le 11 Septembre 2007. Commissaire aux comptes
suppléant : CAUBRIERE François en fonction le 11 Septembre 2007. Commissaire
aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Septembre 2007. Commissaire
aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 11 Septembre 2007.
Administrateur : BLONDEAU Jean en fonction le 11 Février 2009. Activité : transport
public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le
transport routier de marchandises avec conducteurs. toutes opérations de collecte
d'enlèvement de déchets dangereux et non dangereux. toutes opérations de
traitement desdits déchets. toutes activités accompagnant ou facilitant les
opérations précitées. conception classement construction réalisation
financement et exploitation de centres de déchets. études et recherches et
exploitation de sites propres. obtention achat exploitation et vente de tous
brevets d'invention licences de marques de fabrique se rattachant à
l'activité. études et exécution de tous projets et travaux pour le compte de
collectivités publiques d'industriels et de particuliers. |
|||
|
26/12/2008
|
Bodacc
A |
Vente
et cession : Vendeur |
|
|
74
- HAUTE-SAVOIE GREFFE
DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS 1409
- 487 709 867 RCS Saint-Denis. VEOLIA PROPRETE LA REUNION. Forme : S.A.S.
Capital : 37000 EUR. Adresse : 89 rue Henri Cornu, Cambaie,
97460 Saint-Paul. |
|||
|
08/07/2008
|
Bodacc
C |
Comptes
annuels et rapports |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 9136
- 572221034 RCS. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société anonyme. Adresse
: 163-169 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre. Commentaires :
Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007. |
|||
|
08/07/2008
|
Bodacc
C |
Comptes
consolidés et rapports |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 9137
- 572221034 RCS. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société anonyme. Adresse
: 163-169 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre. Commentaires :
Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007. |
|||
|
27/03/2008
|
Bodacc
B |
Modification
et mutation diverse |
|
|
92
- HAUTS-DE-SEINE GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 3731
- 572 221 034 RCS Nanterre. VEOLIA PROPRETE. Forme : Société
anonyme. Enseigne : CGEA ONYX - ONYX. Capital : 143473440 EUR. |
|||
|
12/10/2007
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
2526
- RCS Nanterre B 572 221 034. RC 80-B 3901. VEOLIA PROPRETE. Forme : S.A. Commentaires
: modification survenue sur l'administration. Administration : commissaire
aux comptes titulaire partant : SALUSTRO REYDEL. Commissaire aux comptes
suppléant partant : HUBERT LUNEAU. Commissaire aux comptes titulaire partant
: BARBIER FRINAULT & Cie. Commissaire aux comptes suppléant partant :
PETIET (Maxime). Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : ERNST
& YOUNG ET AUTRES. Nomination de commissaires aux comptes suppléants :
CAUBRIERE (François) AUDITEX. Nomination d'un commissaire aux comptes
titulaire : K.P.M.G. S.A. |
|||
|
13/09/2007
|
Bodacc
C |
Avis
de dépôt des comptes |
|
|
6323
- 572 221 034. RCS Nanterre VEOLIA PROPRETE. Forme: Société anonyme. Adresse du
siège social: 163-169 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre. Comptes
annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006. |
|||
|
13/09/2007
|
Bodacc
C |
Avis
de dépôt des comptes |
|
|
6324
- 572 221 034. RCS Nanterre VEOLIA PROPRETE. Forme: Société anonyme. Adresse
du siège social: 163-169 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre. Comptes
consolidés et rapport de l'exercice clos le: 31 décembre 2006. |
|||
|
09/09/2007
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
1464
- RCS Nanterre B 572 221 034. RC 80-B 3901. VEOLIA PROPRETE. Forme : S.A.
Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration :
nomination d'un administrateur : DU PELOUX (Cyrille). |
|||
|
04/09/2007
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
2069
- RCS Nanterre B 572 221 034. RC 80-B 3901. VEOLIA PROPRETE. Forme : S.A.
Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration :
administrateur partant : SCHMIDT (Daniel). |
|||
|
31/05/2007
|
Bodacc
A |
Vente
et cession |
|
|
1207
- RCS B 086 880 036. RC 06-B 167. SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE
COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES. Sigle : SOCCOIM. Forme : S.A.S.
Activité : collecte, tri et traitement de déchets. Adresse du siège social :
Z.A. des Pierrelets, 45380 Chaingy. Etablissement secondaire - Adresse : 8
rue des Chênes, 53940 Saint-Berthevin. Fonds secondaire d'enlèvement et de
traitement des ordures ménagères de la Mayenne 53 exploité sis Z.A. La
Remaizière, 61790 Saint-Pierre-du-Regard et immédiatement transféré à
l'adresse du nouvel établissement secondaire acquis par achat au prix stipulé
de 387 000 euros. Commentaires : modification survenue sur l'adresse du fonds
secondaire anciennement : 9 rue des Chênes, 53940 Berthevin nouvellement : 8
rue des Chênes, 53940 Berthevin. Date de début d'activité : 1er décembre
2005. Date d'effet : 1er janvier 2007. Précédent propriétaire : SOCIETE
VEOLIA PROPRETE. RCS Nanterre 572 221 034. Publication légale : Ouest France
du 30 janvier 2007. Oppositions : VEOLIA PROPRETE, 10 rue de la Cotonnerie,
Chemin-Vert, 14000 Caen pour la correspondance et à l'établissement
secondaire de SOCCOIM sis 8 rue des Chênes, 53940 Berthevin, pour la
validité. |
|||
|
30/08/2006
|
Bodacc
C |
Avis
de dépôt des comptes |
|
|
5355
- RCS Nanterre B 572 221 034. RC 80-B 3901. VEOLIA PROPRETE. Forme: S.A.
Adresse du siège social: 163-169, avenue Georges Clemenceau,92000 Nanterre. Comptes
annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005. |
|||
|
30/08/2006
|
Bodacc
C |
Avis
de dépôt des comptes |
|
|
5356
- RCS Nanterre B 572 221 034. RC 80-B 3901. VEOLIA PROPRETE. Forme: S.A. Adresse
du siège social: 163-169, avenue Georges Clemenceau,92000 Nanterre. Comptes
consolidés et rapport de l'exercice clos le: 31 décembre 2005. |
|||
|
24/01/2006
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
1760
- RCS Nanterre B 572 221 034. RC 80-B 3901. VEOLIA PROPRETE. Forme : S.A.
Capital : 137 014 000 euros. Commentaires : modification survenue sur le
capital (augmentation). |
|||
|
28/12/2005
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
941
- RCS Nanterre B 572 221 034. RC 80-B 3901. VEOLIA PROPRETE. Forme : S.A.
Commentaires : modification survenue sur la dénomination et le nom
commercial. Etablissement principal - Nom commercial : CGEA Onyx Onyx.
Adresse : 163-169 avenue Georges-Clemenceau, 92000 |
|||
|
23/09/2005
|
Bodacc
C |
Avis
de dépôt des comptes |
|
|
5163
- RCS Nanterre B 572 221 034. RC 80-B 3901. ONYX. Forme: S.A. Adresse du
siège social: 163-169, avenue Georges Clemenceau,92000 Nanterre. Comptes annuels
et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004. |
|||
|
23/09/2005
|
Bodacc
C |
Avis
de dépôt des comptes |
|
|
5164
- RCS Nanterre B 572 221 034. RC 80-B 3901. ONYX. Forme: S.A. Adresse du siège
social: 163-169, avenue Georges Clemenceau,92000 Nanterre. Comptes consolidés
et rapport de l'exercice clos le: 31 décembre 2004. |
|||
|
28/07/2004
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572221034 RC 80-B 3901 ONYX. Forme : S.A Nom commercial: CGEA
Onyx. Commentaires : modification survenue sur la dénomination, le nom
commercial et l'administration. Administration : nomination d'
administrateurs : BARBAROUX (Olivier) FREROT (Antoine). |
|||
|
28/07/2004
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572221034 RC 80-B 3901 ONYX. Forme : S.A Nom commercial: CGEA
Onyx. Commentaires : modification survenue sur l'administration.
Administration : administrateur partant : GONTARD (Bertrand). |
|||
|
30/11/2003
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572221034 RC 80-B 3901 C. G.E.A. ONYX. Forme : S.A. Commentaires :
modification survenue sur l' administration. Administration : nomination d'un
administrateur : BITTERLICH (Joachim). |
|||
|
28/01/2003
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572221034 RC 80-B 3901 C. G.E.A. ONYX. Forme : S.A. Commentaires :
modification survenue sur l' administration. Administration : administrateurs
partants : MESSIER ( Jean-Marie) HANNEZO (Guillaume) LICOYS (Eric). |
|||
|
04/10/2002
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572221034 RC 80-B 3901 C. G.E.A. ONYX. Forme : S.A. Commentaires :
modification survenue sur l' administration. Administration : nomination d'un
administrateur : KUCH ( Gustave). |
|||
|
16/05/2002
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572221034 RC 80-B 3901 C. G.E.A. ONYX. Forme : S.A. Capital : 148
969 408 euros. Activité : toutes opérations de collecte, d'enlèvement de déchets
dangereux et non toutes opérations de traitement desdits déchets. Toutes
activités accompagnant ou facilitant les opérations précitées. Conception,
classement, construction, réalisation, financement et exploitation de centres
de déchets. Etudes, recherches et exploitation de sites propres. Obtention,
achat, exploitation et vente de tous brevets d'invention, de licences et de
marques de fabrique se rattachant à l'activité. Etudes, exécution de tous
projets et de travaux pour le compte de collectivités publiques,
d'industriels et de particuliers. Commentaires : modification survenue sur le
capital ( augmentation) et l'activité. |
|||
|
25/10/2001
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572221034 RC 80-B 3901 C. G.E.A. ONYX. Forme : S.A. Capital : 111
819 168 euros. Adresse du siège social : 163- 169 avenue Georges-Clemenceau,
92000 Nanterre. Commentaires : achat à la STE OUEST PROPRETE S.A. de sa
branche d' activité de contrats de marchés d'un fonds de commerce de déchets industriels
exploitée dans le département de la Manche. Date d'effet : 1 e r juin 2001. |
|||
|
24/10/2001
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572221034 RC 80-B 3901 C. G.E.A. ONYX. Forme : S.A. Commentaires :
modification survenue sur l' administration. Administration : modification du
directeur général et administrateur : GASQUET (Denis, Claude, Marcellin).
Administrateurs partants : OLLIVIER (Jean-Yves) LIFFORT DE BUFFEVENT
(Bertrand). Nomination d' administrateurs : CONTAMINE (Jérome) GONTARD
(Bertrand). Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE TOUCHE
TOHMATSU B.M.A. Nomination du commissaire aux comptes titulaire : BARBIER
FRINAULT ET COMPAGNIE. Commissaire aux comptes suppléant partant : CONVERT
(Jacques). Nomination du commissaire aux comptes suppléant : PETIET (Maxime).
|
|||
|
24/10/2001
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572221034 RC 80-B 3901 C. G.E.A. ONYX. Forme : S.A. Commentaires :
modification survenue sur l' administration. Administration : administrateur
partant : DAUBERLIEU ( Bertrand). |
|||
|
28/09/2001
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572221034 RC 80-B 3901 C. G.E.A. ONYX. Forme : S.A. Capital : 111
819 792 euros. Adresse du siège social : 163- 169 avenue Georges-Clemenceau,
92000 Nanterre. Commentaires : modification survenue sur le capital
(augmentation). Fusion-absorption des sociétés ONYX RECYCLAGE,. RCS Bobigny B
552 106 650 S.C.I. LES CAMPAGNETTES et S.C.I. LE VERT GALANT. Date d'effet :
29 décembre 2000. |
|||
|
26/08/2001
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572221034 RC 80-B 3901 C. G.E.A. ONYX. Forme : S.A. Capital : 111
819 168 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital
(augmentation). |
|||
|
26/08/2001
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572221034 RC 80-B 3901 C. G.E.A. ONYX. Forme : S.A. Commentaires :
modification survenue sur l' administration. Administration : nomination du
directeur général : GASQUET (Denis, Claude, Marcellin). Modification d'un
administrateur : TURION (Jean-Claude). |
|||
|
26/08/2001
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572221034 RC 80-B 3901 C. G.E.A. ONYX. Forme : S.A. Commentaires :
modification survenue sur la dénomination. |
|||
|
17/01/2001
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572221034 RC 80-B 3901 COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES
AUTOMOBILE-C.G.E.A. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur
l'administration. Administration : administrateur partant : CANS (Claude).
Nomination d'un administrateur : BURFIN (Armand). |
|||
|
15/12/2000
|
Bodacc
A |
Création
d'établissement |
|
|
RCS
Nanterre B 572221034 A dater du: 20 novembre 2000 C.G.E.A.-COMPAGNIE GENERALE
D'ENTREPRISES AUTOMOBILES. Forme : S.A. Capital : 105 064 768 euros. Adresse
du siège social : 169 avenue Georges-Clemenceau, 92000 Nanterre Etablissement
principal: Activité : collecte de déchets ménagers exploité dans les
départements de La Manche et du Calvados. Adresse : Le Promettant, 14490 La
Bazoque Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 380 000
F. Date d'effet : 1er juillet 2000. Précédent propriétaire : HUREL
Jean-Pierre ,conjoint BRIARD ( Evelyne). RCS Bayeux A 321059909 RC 85-A 145
Publication légale: Ouest-France du 13 juillet 2000 et rectificatif du 22
novembre 2000. Oppositions : au fonds pour la validité. |
|||
|
27/10/2000
|
Bodacc
A |
Création
d'établissement |
|
|
RCS
Nanterre B 572221034 COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES-C.G. E.A.
Forme : S.A. Capital : 105 064 768 euros. Activité : collecte de déchets
ménagers. Adresse du siège social : 169 avenue Georges-Clemenceau, 92000
Nanterre Exploitation d'un fonds de collecte de dechets dans le département
de la Manche acquise par achat au prix stipulé de 380 000 F. Date d'effet :
1er juillet 2000. Précédent propriétaire : HUREL Jean-Pierre ,conjoint BRIARD
( Evelyne). RCS Bayeux A 321059909 Publication légale: Ouest-France édition
de la Manche du 13 juillet 2000. Oppositions : C.G.E.A. Onyx Direction Agence
Régionale, Z.I. du Chemin Vert, 9 rue de la Cotonnière, 14052 Caen Cedex o le
domicile a été élu à cet effet. |
|||
|
28/11/1999
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572221034 RC 80-B 3901 COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES
AUTOMOBILE-C.G.E.A. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur
l'administration. Administration : administrateur partant : TARDIEU (Jean-
Pierre). |
|||
|
09/11/1999
|
Bodacc
A |
Création
d'établissement |
|
|
572
221 034. RCS Nanterre. COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES. Forme :
S.A. Capital : 105 064 768 euros. Adresse du siège social : 163-169 avenue
Georges-Clemenceau, 92000 Nanterre Fonds principal acquis par achat, au prix
stipulé de 584 000 F Etablissement principal: Activité : collecte de déchets
ménagers. Adresse : 14860 Amfreville. Date d'effet : 1er juillet 1999
Précédente propriétaire- exploitante SCOMDEC S.A.R.L. 400 928 123. RCS Caen.
Publication légale: Ouest-France édition Calvados du 27 septembre 1999.
Oppositions : à la C.G.E. A., direction de l'Agence Régionale de Normandie,
7-9 rue de la Cotonnière, 14000 Caen. |
|||
|
22/08/1999
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572221034 RC 80-B 3901 COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES
AUTOMOBILE-C.G.E.A. Forme : S.A. Capital : 105 064 768 euros. Commentaires :
modification survenue sur le capital ( augmentation). |
|||
|
18/05/1999
|
Bodacc
A |
Création
d'établissement |
|
|
410
303 085. RCS Nanterre. GEVAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : 169
avenue Georges-Clemenceau, 92000 Nanterre Fonds complémentaire acquis par
apport partiel d'actif, au montant global évalué à 39 512 035,03 F. Commentaires
: la S.A. C.G.E.A. devient propriétaire par suite d'apport partiel d'actif de
ladite branche par la société SOGEA Etablissement Complémentaire. Activité :
usine de compactage , traitement d'ordures ménagères et mise en balles.
Adresse : 267 rue J.A.-Gabriel, zone industrielle Lann-Sevelin, 56850 Caudan.
Date d'effet : 1er avril 1997 Précédente propriétaire S.A. C.G.E.A. - CIE
GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES. RCS Nanterre B 572 221 034 Publication
légale: L'Informateur judiciaire du 25 avril 1997 déclaration de créances: au
greffe du tribunal de commerce de Lorient. |
|||
|
11/09/1998
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
*. RCS Nanterre B 572 221 034 RC RC 80-B 3901 COMPAGNIE GENERALE D'
ENTREPRISES AUTOMOBILE C.G.E.A. Forme : S. A. Administration : suppression :
administrateur : COUPLAN (Jean-Pierre). Commentaires : modification survenue
sur l'administration. |
|||
|
26/07/1998
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572 221 034 RC 80-B 3901 COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES
AUTOMOBILE-C.G.E.A. Forme : S.A. Capital : 656 654 800 F. Commentaires :
modification survenue sur le capital ( augmentation) et l'administration.
Administration : modification du commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE
TOUCHE TOHMATSU-B.M.A. |
|||
|
17/05/1998
|
Bodacc
A |
Création
d'établissement |
|
|
RCS
Nanterre B 572 221 034 A dater du: 10 avril 1998 RC 78-B 79 COMPAGNIE GENERALE
D'ENTREPRISES AUTOMOBILES. Sigle : C.G.E.A. Forme : S.A. Adresse du siège
social : 163-169 rue Georges- Clemenceau, 92000 Nanterre Fonds principal
acquis par cession, au prix stipulé de 1 000 000 de F Etablissement
principal: Activité : collecte de déchets ménagers. Adresse : route
nationale, Missy 14210 Evrecy. Date d'effet : 1er avril 1998. Précédent
propriétaire : SUPPER Hubert. RCS Caen A 693 810 897 RC 69-A 89 Publication
légale: Ouest-France du 9 avril 1998. Oppositions : à la C.G.E.A., Direction
de l'Agence Régionale, 9 rue La Cotonnière, à Caen (14000). |
|||
|
25/04/1998
|
Bodacc
A |
Création
d'établissement |
|
|
RCS
Nanterre B 410 303 085 GEVAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : 169 avenue
Georges-Clemenceau, 92000 Nanterre Fonds secondaire acquis par apport partiel
d'actif au montant net évalué à 39 512 035,03 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC
Lorient 97-B 254. Activité : incinération d'ordures ménagères. Adresse :
Kerneve, Plouharnel 56340 Carnac. Date d'effet : 1er janvier 1997 Précédente
propriétaire S.A. COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES - C. G.E.A.
RCS Nanterre B 572 221 034 Publication légale: Ouest France du 8 aout 1997
déclaration de créances: au greffe du tribunal de commerce de Lorient. |
|||
|
27/03/1998
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
*. RCS Nanterre B 572 221 034 RC RC 80-B 3901 COMPAGNIE GENERALE D'
ENTREPRISES AUTOMOBILE C.G.E.A. Forme : S. A. Capital : 484 981 000 F. Administration
: nomination en qualité d'administrateurs HANNEZO (Guillaume) LICOYS (Eric).
Commentaires : modification survenue sur l'administration et le capital (
augmentation). |
|||
|
23/10/1997
|
Bodacc
A |
Création
d'établissement |
|
|
RCS.
RCS B 383 607 090 RC RC 97-B 4368 C. G.E.A. TRANSPORT. Forme : S.A. Capital :
340 500 000 F. Adresse du siège social : 163-169, avenue Georges-Clemenceau
92000 Nanterre ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Adresse : 40, rue des Guilleraies
92000 Nanterre. Activité : transport Etablissement secondaire acquis par
apport au montant évalué à 361 834 470 F. Date d'effet : 30 juin 1997.
Précédent propriétaire : : COMPAGNIE GENERALE D' ENTREPRISES AUTOMOBILE
C.G.E.A. RCS RCS B 572 221 034 Publication légale: Journal Spécial des Sociétés
Françaises du 21 juin 1997 déclaration de créances: au greffe du tribunal de
commerce de Nanterre. |
|||
|
23/09/1997
|
Bodacc
A |
Création
d'établissement |
|
|
RCS
*. RCS Nanterre B 572 221 034 RC RC 80-B 3901 COMPAGNIE GENERALE D' ENTREPRISES
AUTOMOBILE - C.G.E.A. Forme : S.A. Capital : 436 807 000 F. Adresse du siège
social : 163-169, avenue Georges- Clemenceau 92000 Nanterre Etablissement
principal: Activité : étude et entreprise de toutes affaires de transports,
location de véhicules automobiles de transports routiers et de marchandises,
services touristiques par autocars, services réguliers de voyageurs, service
de transports publics de marchandises, voirie, commissionnaire de transport,
enlèvement d'ordures et déchets. Adresse : 163-169, avenue Georges-Clemenceau
92000 Nanterre Etablissement secondaire acquis par apport au montant évalué à
55 413 311 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE immatriculé au. RCS : Nanterre. Adresse
: 222, avenue Aristide-Briand 92220 Bagneux. Activité : enlèvement des
ordures, collecte et évacuation d' ordures ménagères, transports publics
routiers de marchandises. Date d'effet : 30 juin 1997. Précédent propriétaire
: : COMPAGNIE DE TRANSPORT ET DE SERVICES PUBLICS. RCS RCS B 572 212 464
Publication légale: La Loi du 23 juin 1997 déclaration de créances: au greffe
du tribunal de commerce de Nanterre. |
|||
|
20/09/1997
|
Bodacc
A |
Création
d'établissement |
|
|
RCS
B 572 221 034 RC 87-B 13858 COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES-C.G.E.A.
Forme : S.A. Capital : . Adresse du siège social : 163-169 avenue
Georges-Clemenceau 92000 Nanterre Etablissement principal: Activité : toutes
opérations concernant l' exploitation d'automobiles et plus spécialement le
transport industriel achat, vente et location de voitures automobiles de
toutes marques. Adresse : 34-40 route Noisy 93230 Romainville ETABLISSEMENT
SECONDAIRE. Activité : enlèvement d'ordures, collecte et évacuation d'ordures
ménagères transport public routier de marchandises. Adresse : 1 quai de Seine
93400 Saint-Ouen Etablissement secondaire acquis par apport au montant évalué
à 195 124 687 F Date de début d' activité: 1er mai 1942. Date d'effet : 30
juin 1997. Précédent propriétaire : COMPAGNIE DE TRANSPORT ET DE SERVICES
PUBLICS Publication légale: La Loi du 23 juin 1997 déclaration de créances:
au tribunal de commerce de Bobigny. |
|||
|
04/07/1997
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572 221 034 RC 80-B 3901 COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES
AUTOMOBILE-C.G.E.A. Forme : S.A. Capital : 436 807 000 F. Commentaires :
modification survenue sur le capital ( augmentation). |
|||
|
06/04/1997
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572 221 034 RC 80-B 3901 COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES
AUTOMOBILE-C.G.E.A. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur
l'administration. Administration : suppression du directeur général et administrateur
: LE DORE (Yann-Marie). Modification du commissaire aux comptes titulaire :
SALUSTRO REYDEL. Modification du commissaire aux comptes suppléant : LUNEAU
(Hubert). |
|||
|
06/10/1996
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572 221 034 RC 80-B 3901 COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES
AUTOMOBILE C.G.E.A. Forme : S.A. Capital : 413 908 500 F. Administration :
président d'honneur et administrateur : ROUER ( Bernard). Président du
conseil d' administration : PROGLIO (Henri). Directeurs généraux et
administrateurs : LE DORE (Yann-Marie) COUPLAN (Jean- Pierre).
Administrateurs : CANS (Claude) TARDIEU (Jean-Pierre) SCHMIDT (Daniel) TURION
(Jean-Claude) OLLIVIER (Jean- Yves) GIRARDOT (Paul, Louis) LIFFORT DE
BUFFEVENT (Bertrand) DAUBERLIEU (Bertrand) MESSIER (Jean- Marie).
Commissaires aux comptes titulaires : SALUSTRO REYDEL CABINET BERNARD
MONTAGNE ANDRE AMIC ET ASSOCIES. Commissaires aux comptes suppléants : LUNEAU
(Hubert) CONVERT (Jacques). Commentaires : modification survenue sur le
capital et l'administration. |
|||
|
23/06/1996
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572 221 034 RC 80-B 3901 COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILE-C.G.E.A.
Forme : S.A. Capital : 410 545 500 F. Commentaires : modification survenue
sur le capital. |
|||
|
02/06/1996
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
Nanterre B 572 221 034 RC 80-B 3901 COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES
AUTOMOBILES-C.G.E.A. Forme : S.A. Capital : 410 465 500 F. Commentaires :
modification survenue sur le capital. |
|||
|
10/05/1996
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS.
RCS B 303 775 175 RC RC 94-B 610 TRANSEVRY. Forme : S.A. Capital : 2 766 500
F. Adresse du siège social : 5, rue du Canal-Prolongé, Z.A.C. de la Marinière
91070 Bondoufle Branche d'activité de transport de voyageurs sur le réseau
Tice reçue en location-gérance du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2010 sans
tacite reconduction Propriétaire : COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES
AUTOMOBILES C.G.E.A. RCS RCS B 572 221 034. |
|||
|
23/04/1996
|
Bodacc
A |
Création
d'établissement |
|
|
RCS
Nanterre B 572 221 034 RC 78-B 79 COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES
AUTOMOBILES - C.G.E.A. Forme : S.A. Adresse du siège social : 163-169 rue
Georges-Clemenceau, 92000 Nanterre Fonds principal acquis par cession, au
prix stipulé de 350 000 F Etablissement principal: Activité : collecte de
déchets industriels et de chantiers. Adresse : route de Caen, Feuguerolles-
Bully 14320 May-sur-Orne. Date d'effet : 16 novembre 1995 Précédente
propriétaire L.B.R. S.A.R.L. Publication légale: Ouest-France du 14 mars
1996. Oppositions : au siège de la société C.G.E.A., zone industrielle du
Chemin Vert, 9 rue de la Cotonnière à Caen (14). |
|||
|
27/12/1995
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
*. RCS Nanterre B 572 221 034 RC RC 80-B 3901 COMPAGNIE GENERALE D' ENTREPRISES
AUTOMOBILE - C.G.E.A. Forme : S.A. Administration : président d'honneur et
administrateur : ROUER (Bernard). Président du conseil d'administration :
PROGLIO (Henri) Directeur général et administrateur : LE DORE (Yann-Marie).
Directeur général non administrateur : COUPLAN (Jean-Pierre). Administrateurs
CANS (Claude) TARDIEU (Jean-Pierre) SCHMIDT (Daniel) TURION (Jean-Claude)
BOURGEOIS GAVARDIN (Jacques) OLLIVIER (Jean-Yves) GIRARDOT (Paul, Louis)
LIFFORT DE BUFFEVENT ( Bertrand) COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE DAUBERLIEU
(Bertrand) MESSIER (Jean-Marie). Commissaires aux comptes titulaires :
SALUSTRO REYDEL CABINET BERNARD MONTAGNE ANDRE AMIC ET ASSOCIES. Commissaires
aux comptes suppléants : LUNEAU (Hubert) CONVERT (Jacques). Commentaires :
modification survenue sur l' administration. |
|||
|
26/10/1995
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
*. RCS Nanterre B 572 221 034 RC RC 80-B 3901 COMPAGNIE GENERALE D' ENTREPRISES
AUTOMOBILE - C.G.E.A. Forme : S.A. Administration : président d'honneur et
administrateur : ROUER (Bernard). Président du conseil d'administration :
PROGLIO (Henri) Directeur général et administrateur : LE DORE (Yann-Marie).
Directeur général non administrateur : COUPLAN (Jean-Pierre). Administrateurs
CANS (Claude) TARDIEU (Jean-Pierre) SCHMIDT (Daniel) TURION (Jean-Claude)
BOURGEOIS GAVARDIN (Jacques) OLLIVIER (Jean-Yves) GIRARDOT (Paul, Louis)
LIFFORT DE BUFFEVENT ( Bertrand) COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE DAUBERLIEU
(Bertrand) MESSIER (Jean-Marie). Commissaires aux comptes titulaires :
SALUSTRO REYDEL CABINET BERNARD MONTAGNE ANDRE AMIC ET ASSOCIES. Commissaires
aux comptes suppléants : LUNEAU (Hubert) CONVERT (Jacques). Commentaires :
modification survenue sur l' administration. |
|||
|
17/10/1995
|
Bodacc
A |
Création
d'établissement |
|
|
RCS
Nanterre B 572 221 034 COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES. Sigle : C.G.E.A.
Forme : S.A. Capital : 410 358 000 F. Adresse du siège social : 169 avenue
Georges-Clemenceau 92000 Nanterre ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité :
transport public de personnes sur la ligne < Tigery - Saint-Germain-
les-Corbeil - Saint-Pierre-du-Perray >. Adresse : gara de Lieusaint-Moissy
77127 Lieussaint Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de
2 500 000 F. Date d'effet : 5 juillet 1995. Précédent propriétaire : LES CARS
SOEUR. RCS Corbeil-Essonnes B 314 438 557 Publication légale: Le Moniteur de
Seine-et-Marne du 15 juillet 1995. Oppositions : Etude de Mes Bertrand et
Letellier, 5 rue Waldeck-Rousseau, 91100 Corbeil-Essonnes pour la
corresponance et pour la validité au 355 avenue Blaise-Pascal, 77550 Moissy-
Cramayel. |
|||
|
21/09/1995
|
Bodacc
B |
Modifications
et mutations diverses |
|
|
RCS
*. RCS Nanterre B 572 221 034 RC RC 80-B 3901 COMPAGNIE GENERALE D'
ENTREPRISES AUTOMOBILE - C.G.E.A. Forme : S.A. Capital : 410 358 000 F. Commentaires
: modification survenue sur le capital. |
|||
|
13/08/1995
|
Bodacc
A |
Création
d'établissement |
|
|
RCS
B 572 221 034 COMPAGNIE GENERALE D' ENTREPRISES AUTOMOBILES. Forme : S.A.
Capital : . Adresse du siège social : 169 avenue Georges-Clemenceau 92000
Nanterre Etablissement principal: Activité : exploitation de la ligne Tigery
- Saint-Germain-les-Corbeil - Saint-Pierre-du-Perray-Gare de Lieusaint
Moissy. Adresse : Tegery, Saint- Germain-les-Corbeil 91000 Saint-Pierre-
du-Perray Ligne de transport, dépendant de l'établissement principal, acquise
par cession au prix stipulé de 2 500 000 F. Date d'effet : 5 juillet 1995.
Précédent propriétaire : LES CARS SOEUR. RCS B 314 438 557 Publication
légale: La Semaine de l'Ile-de-France du 13 juillet 1995. Oppositions : Etude
D. Bertrand et R. Letellier, 5 rue Waldeck- Rousseau, 91100 Corbeil-Essonnes.
|
|||
|
Date |
Description |
|
19/10/2010 |
Formation
of Establishment |
FOREIGN EXCHANGE RATES
|
Currency |
Unit
|
Indian Rupees |
|
US Dollar |
1 |
Rs.66.39 |
|
|
1 |
Rs.102.59 |
|
Euro |
1 |
Rs.74.90 |
INFORMATION DETAILS
|
Analysis Done by
: |
TRI |
|
|
|
|
Report Prepared
by : |
ASH |
RATING EXPLANATIONS
|
RATING |
STATUS |
PROPOSED CREDIT LINE |
|
|
>86 |
Aaa |
Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability
for timely payment of interest and principal sums |
Unlimited |
|
71-85 |
Aa |
Possesses adequate working capital. No caution needed for credit
transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest
and principal sums |
Large |
|
56-70 |
A |
Financial & operational base are regarded healthy. General
unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for
payment of interest and principal sums |
Fairly Large |
|
41-55 |
Ba |
Overall operation is considered normal. Capable to meet normal
commitments. |
Satisfactory |
|
26-40 |
B |
Capability to overcome financial difficulties seems comparatively
below average. |
Small |
|
11-25 |
Ca |
Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums
in default or expected to be in default upon maturity |
Limited with
full security |
|
<10 |
C |
Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised |
Credit not
recommended |
|
-- |
NB |
New Business |
-- |
This score serves as a reference to assess
SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is
calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major
sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as
indicated through %) are as follows:
Financial
condition (40%) Ownership
background (20%) Payment
record (10%)
Credit history
(10%) Market trend (10%) Operational size
(10%)
This report is issued at your request without any
risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL)
or its officials.