MIPL-Logo

3decades

 

MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

489044

Report Date :

01.02.2018

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

COOPERATIVE U ENSEIGNE

 

 

Formerly Known As :

SYSTEME U CENTRALE NATIONALE

 

 

Registered Office :

Tertiaire Silic Batiment Montreal 20 Rue D Arcueil 94150 Rungis

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2016

 

 

Date of Incorporation :

November, 1986

 

 

Com. Reg. No.:

RCS Creteil B 304 602 956

 

 

Legal Form :

Cooperative public limited company with board of directors

 

 

Line of Business :

Subject is engaged in Non-Food Purchasing Centers.

 

 

No. of Employees :

823

 

 

RATING & COMMENTS

(Mira Inform has adopted New Rating mechanism w.e.f. 23rd January 2017)

 

MIRA’s Rating :

A+

 

Credit Rating

Explanation

Rating Comments

A+

Low Risk

Business dealings permissible with low risk of default

 

Status :

Excellent

 

 

Payment Behaviour :

Regular

 

 

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List

 

Country Name

Previous Rating

(30.06.2017)

Current Rating

(30.09.2017)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low Risk

 

A2

Moderately Low Risk

 

B1

Moderate Risk

 

B2

Moderately High Risk

 

C1

High Risk

 

C2

Very High Risk

 

D

 


 

FRANCE - ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. France is the most visited country in the world with 83 million foreign tourists in 2016, including 530,000 visitors for the 2016 Euro Cup. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that mitigate economic inequality.

 

France's real GDP grew by 1.6% in 2017, up from 1.2% the year before. The unemployment rate (including overseas territories) increased from 7.8% in 2008 to 10.2% in 2015, before falling to 9.5% in 2017. Youth unemployment in metropolitan France decreased from 24.6% in the fourth quarter of 2014 to 24% in the fourth quarter of 2016.

 

France’s public finances have historically been strained by high spending and low growth. Despite measures to restore public finances, the budget deficit rose from 3.3% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009. In 2017, the budget deficit improved to 2.9% of GDP, bringing it in compliance with the EU-mandated 3% deficit target. Meanwhile, France's public debt rose from 89.5% of GDP in 2012 to 96.9% in 2017.

 

Since entering office in May 2017, President Emmanuel MACRON launched a series of economic reforms to improve competitiveness and boost economic growth. President MACRON campaigned on reforming France’s labor code and in late 2017 implemented a range of reforms to increase flexibility in the labor market by making it easier for firms to hire and fire and simplifying negotiations between employers and employees. In addition to labor reforms, President MACRON’s proposed 2018 budget cuts public spending, taxes, and social security contributions to spur private investment and increase purchasing power.

 

Source : CIA

 


Company name and address

 

SIRET

304 602 956 00142

Name

COOPERATIVE U ENSEIGNE

Acronym

-

Trade name

-

Status

Economically active

Postal Address

COOPERATIVE U ENSEIGNEU ENSEIGNE PARC TERTIAIRE SILIC BATIMENT MONTREAL 20 RUE D ARCUEIL 94150 RUNGIS FRANCE

Variable Share Capital

22,867 Euros

Telephone

01 45 15 95 00

Activity (APE)

Non-Food Purchasing Centers (4619A)

Formation Date

01/1900

Deregistration Date

-

Court Registry Number

19 8 6B00187

Registration Court

Creteil (94)

Nationality

France

RCS Registration

RCS Creteil B 304 602 956

EUR VAT Number

FR10304602956

Last account Date

31/12/2016

Incorporiation Date

11/1986

Fax

-

Legal form

cooperative public limited company with board of directors

Currency

Euros

 

 

Key Financials

 

YEAR TO DATE

TURNOVER

GROSS OPERATING SURPLUS

SHAREHOLDER'S EQUITY

NET RESULT

EMPLOYEES

31/12/2016

829,919,000 €

-1.33% Turnover

1,982,000 €

-7,483,000 €

823 employees

31/12/2015

779,327,000 €

1.05% Turnover

9,464,000 €

154,000 €

779 employees

31/12/2014

749,319,000 €

0.71% Turnover

9,310,000 €

650,000 €

755 employees

 

 

Directors

 

Current Directors

20

 

 

Ultimate Holding Company

 

Name

Country

Company Number

 

SYSTEME U CEN REG OUEST DIM SYST U OUEST

867800427

 

Affiliation links.

 

 

Judgment and Preferential

 

Judgment

No judgement

Preferential Right

No social security and tax office preferential right to date

 

Payment Details Summary

Payment Details Summary

Company DBT Industry DBT Region DBT3 Days 15 Days 21 Days DBT Trend15 Days 30 Days 45 Days 60 DaysInvoice due dates are exceeded by 3 days.

Establishment Details

 

Type of Establishment

Head Office

Production Role

-

APE/NAF Code

4617A

Activity

Central purchasing food

Formation Date

03/2012

Reason for Formation

Formation

Closure Date

-

Reason for Closure

-

Reactivation Date

-

Seasonality

-

Activity Nature

-

Activity Location

-

Trading Address

20 RUE D ARCUEIL 
94150 RUNGIS

Department

Val-de-Marne (94)

Location Surface

-

District

3

City

RUNGIS

Status

Economically active

Business Pages FT®

GROUPEMENTS D'ACHATS

Region

Ile-de-France

Area

19

Size of Urban Area

Paris conglomeration

 

 

Ultimate Parent(s)

 

2 ultimate parent company/companies for this company

Company Name

Activity (APE)

APE/NAF Code

City

Post Code

COOPERATIVE U ENSEIGNE

Non-Food Purchasing Centers

4619A

RUNGIS

94150

SYSTEME U CEN REG OUEST DIM SYST U OUEST

Central purchasing food

4617A

CARQUEFOU

44470

 

 

Other Establishment(s)

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas having at least 50% of workforce in same area

Mono-activity status

Legal unit having all establishments with the same main activity

Branches

17 branch entities in this company

 

Company Name

Company Type

APE/NAF Code

Activity

City

Post Code

COOPERATIVE U ENSEIGNE

Head Office

4619A


Non-Food Purchasing Centers

RUNGIS

94150

COOPERATIVE U ENSEIGNE

Branch

4619A

Non-Food Purchasing Centers

CARQUEFOU

44470

COOPERATIVE U ENSEIGNE

Branch

4619A

Non-Food Purchasing Centers

CARQUEFOU

44470

COOPERATIVE U ENSEIGNE

Branch

4619A

Non-Food Purchasing Centers

CRETEIL

94000

COOPERATIVE U ENSEIGNE

Branch

4619A

Non-Food Purchasing Centers

CRETEIL

94000

 

 

Workforces

 

Workforce at address

500 to 999 employees

Company workforce

500 to 999 employees

 

 

Workforce account

500 to 999 employees

 

 

31/12/2016

 

 

 

Commentary

 

The comments are ordered according to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative for another or can change depending on its value. This is a purely statistical decision.

 

The company has 22 directors

Industry code with low risk rating

The total assets are 893,843,000 €

The risk provisions are 88,288,000 €

The liabilities are 803,255,000 €

The net current assets are 871,114,000 €

The net turnover is 829,919,000 €

Low risk workforce size

Department code with low risk rating

The shareholder's equity is 1,982,000 €

The stock to turnover ratio is 11.96

The return on total assets employed is -1

The creditor days are 188.68

The sales to current assets ratio is 0.95

The pre-tax profit is -6,713,000 €

The ratio total assets to total liabilities is 1

The increase in the gearing percentage over the last two accounting periods is 764 %

 

 

Industry comparison

 

Activity (APE)

Non-Food Purchasing Centers (4619A)

Industry average credit rating

53

Industry average credit limit

135,379

 

 

Collective procedures

 

No judgment information for the company

 

 

Preferential rights details and history

 

Summary of preferential rights

 

Company monitored since

26/03/2009

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

 

Group Data

 

Ultimate parent company

COOPERATIVE U ENSEIGNE

Direct parent

-

Group – Number of companies

15

Linkages – Number of companies

-

Number of countries

-

Parent

SYSTEME U CEN REG OUEST DIM SYST U OUEST

Direct parent

SYSTEME U CEN REG OUEST DIM SYST U OUEST - 36.01 %

Group – Number of companies

10

Linkages – Number of companies

-

Number of countries

-

 

 

NAME

SIREN

PARTS

LAST ACCOUNT PUBLISHED

1

COOPERATIVE U ENSEIGNE

304602956

-

31/12/2016

2

U PARTNERS

489454819

100 %

31/12/2016

SOC CIVILE DE ST BRES

313925695

100 %

-

U GIE IRIS

532036399

15.45 %

31/12/2012

CASTEL'0

519035307

0.67 %

-

SCI DU 8 MAI

793732389

1 %

-

SCI EXPO ST BRES

341645414

100 %

-

ABDM

800805145

100 %

31/12/2016

ABDIS

800805244

100 %

31/12/2016

LGQDIS

800802738

100 %

31/12/2016

ECODDS

751139940

2 %

31/12/2015

2

DORNINVEST

915822084

99.99 %

31/12/2015

3

ALLONZIERDIS

799321328

99.75 %

31/12/2015

CHICHERYDIS

789813235

99.75 %

31/12/2015

KOENIGS DISTRIBUTION

800131195

99.75 %

31/12/2015

PARONDIS

789813201

99.75 %

31/12/2015

TIL CHATEL DISTRIBUTION

800134801

99.75 %

31/12/2015

TOULDIS

802304212

99.75 %

31/12/2015

VEZERONCE DISTRIBUTION

795145770

99.75 %

31/12/2015

 

 

Shareholders

 

Type of shareholders

Company: 36.01%Undefined: 63.99%CompanyUndefined

Shareholders

SYSTEME U CEN REG OUEST D...: 36.01%Undefined: 63.99%SYSTEME U CEN REG OUEST DIM SYST U OUESTUndefined

 

 

Linkages

 

No Linkages information available for the company.

 

 

Director(s)

 

Name

M. DIERICK SÉBASTIEN

Manager position

Administrator

Date of birth

08/05/1972

Place of birth

NEUILLY-SUR-SEINE

Type

Individual

Name at birth

Name

M. CARON STEPHANE

Manager position

Administrator

Date of birth

30/12/1961

Place of birth

DIEPPE (76)

Type

Individual

Name at birth

 

Name

M. GOURNAY DANIEL

Manager position

Administrator

Date of birth

11/01/1953

Place of birth

LISIEUX

Type

Individual

Name at birth

Name

M. PAPIN SERGE

Manager position

Administrator, Managing director, Chairman of the Board

Date of birth

01/08/1955

Place of birth

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Type

Individual

Name at birth

 

Name

M. BRINGER NICOLAS

Manager position

Administrator

Date of birth

09/11/1971

Place of birth

MENDE

Type

Individual

Name at birth

Name

M. GAGNEPAIN DAVID

Manager position

Administrator

Date of birth

14/04/1973

Place of birth

PONTARLIER

Type

Individual

Name at birth

 

Name

M. BEDROSSIAN-MARDIROSSIAN JEAN-PAUL

Manager position

Administrator

Date of birth

05/01/1970

Place of birth

BRIANÇON

Type

Individual

Name at birth

Name

M. DARRASSE GUILLAUME

Manager position

Delegated managing director

Date of birth

24/06/1963

Place of birth

PARIS 8

Type

Individual

Name at birth

 

Name

M. SCHELCHER DOMINIQUE

Manager position

Administrator

Date of birth

11/04/1971

Place of birth

COLMAR

Type

Individual

Name at birth

Name

M. AUBE DENIS

Manager position

Administrator

Date of birth

03/12/1962

Place of birth

DREUX

Type

Individual

Name at birth

 

Name

M. BESNARD STÉPHANE

Manager position

Administrator

Date of birth

30/04/1970

Place of birth

QUIMPER

Type

Individual

Name at birth

Name

M. PELLETIER LOÏC

Manager position

Administrator

Date of birth

15/08/1957

Place of birth

MEAUX

Type

Individual

Name at birth

 

Name

M. GRAZELIE ALBAN

Manager position

Administrator

Date of birth

09/04/1970

Place of birth

ANGERS

Type

Individual

Name at birth

Name

M. BOURASSIN BENOIT

Manager position

Administrator

Date of birth

19/04/1974

Place of birth

SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS

Type

Individual

Name at birth

 

Name

M. BOURBON MICHEL

Manager position

Administrator

Date of birth

28/10/1962

Place of birth

MOULINS

Type

Individual

Name at birth

Name

M. GRASS PHILIPPE

Manager position

Administrator

Date of birth

09/08/1963

Place of birth

STRASBOURG

Type

Individual

Name at birth

 

Name

M. EGONNEAU FRANCK

Manager position

Administrator

Date of birth

15/05/1968

Place of birth

MACHECOUL-SAINT-MÊME

Type

Individual

Name at birth

Name

M. LEBOUL JEEAN-YVES

Manager position

Administrator

Date of birth

10/08/1960

Place of birth

LE MANS

Type

Individual

Name at birth

 

Name

M. VOUTERS GRÉGORY

Manager position

Administrator

Date of birth

11/10/1973

Place of birth

HAUBOURDIN

Type

Individual

Name at birth

 

Statutory Auditor

 

Name

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Name of representative

Manager position

Statutory auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

 

Previous Directors

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

Chairman of the Board

M. PAPIN SERGE

01/08/1955 - ST GILLES CROIX DE VIE

Managing director

M. PAPIN SERGE

01/08/1955 - ST GILLES CROIX DE VIE

Delegated managing director

M. DARRASSE GUILLAUME

24/06/1963 - PARIS 8

Administrator

M. AUBE DENIS

03/12/1962 - DREUX

Administrator

M. BEDROSSIAN-MARDIROSSIAN JEAN-PAUL

05/01/1970 - BRIANCON

Administrator

M. BENHAMOU STÉPHANE

24/09/1956 - MILIANA(ALGERIE)

Administrator

M. BESNARD STÉPHANE

30/04/1970 - QUIMPER

Administrator

M. BESSUEILLE PATRICK

02/06/1951 - CAVAILLON

Administrator

M. BOLTZ THIERRY

-

Administrator

M. BOLTZ THIERRY

14/02/1968 - MULHOUSE

Administrator

M. BRINGER NICOLAS

09/11/1971 - MENDE

Administrator

M. BUR GERARD

-

Administrator

M. BUR GÉRARD

06/08/1952 - PARIS

Administrator

M. BUR GÉRARD

06/08/1952 - PARIS

Administrator

M. CARON STEPHANE

30/12/1961 - DIEPPE (76)

Administrator

M. COLLET GILLES

22/10/1960 - PLEGUIEN

Administrator

M. DIERICK SÉBASTIEN

08/05/1972 - NEUILLY SUR SEINE

Administrator

M. ELLUL MARC

16/08/1964 - PERPIGNAN

Administrator

M. GAGNEPAIN DAVID

14/04/1973 - PONTARLIER

Administrator

M. GOURNAY DANIEL

11/01/1953 - LISIEUX

Administrator

M. HADJADJ SERGE

-

Administrator

M. HIRSCHNER RICHARD

25/07/1961 - STRASBOURG

Administrator

M. HIRSCHNER RICHARD

25/07/1961 - STRASBOURG

Administrator

M. MANNEVILLE NICOLAS

30/11/1966 - DIEPPE

Administrator

M. MAUCOURT PATRICK

-

Administrator

M. MAUCOURT PATRICK

16/08/1963 - ANGERS

Administrator

M. MAUCOURT PATRICK

16/08/1963 - ANGERS

Administrator

Mme. MISKDJIAN INGRID

12/04/1968 - LYON

Administrator

Mme. MISKDJIAN INGRID

12/04/1968 - LYON

Administrator

M. PAPIN SERGE

01/08/1955 - ST GILLES CROIX DE VIE

 

 

Status history

 

No Status History

 

 

Recent publications in Gazettes

 

Publication date

Gazette Name

Description

20/09/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

1560 - 304 602 956 RCS Créteil. COOPERATIVE U ENSEIGNE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Capital variable: 22867.65 EUR. Activité : 
Commentaires : Modification du capital..

07/09/2017

JAL

Miscellaneous updates

Les Petites affiches - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 28/06/2017 
Entreprise :304602956 - SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, LE MOULIN BOISSEAU, BATIMENT A, 44470, CARQUEFOU 
Description :Prorogation de la durée de la sociét造

04/08/2017

JAL

Partial asset

L'Informateur judiciaire


Date de décision : 03/07/2017
Apporteur : 304602956 - SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, LE MOULIN BOISSEAU, BATIMENT A, 44470 CARQUEFOU

02/08/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

1424 - 304 602 956 RCS Créteil. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Administration : Administrateur : CARON STEPHANE ; Administrateur : GOURNAY Daniel modification le 30 Août 2000 ; Administrateur : PAPIN Serge en fonction le 30 Août 2000 ; Président du conseil d'administration Directeur général : PAPIN Serge modification le 21 Février 2005 ; Directeur général délégué : DARRASSE Guillaume modification le 05 Septembre 2006 ; Administrateur : MAUCOURT Patrick en fonction le 26 Septembre 2007 ; Administrateur : SCHELCHER Dominique en fonction le 24 Avril 2009 ; Administrateur : AUBE Denis en fonction le 17 Décembre 2009 ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 06 Juillet 2012 ; Administrateur : BESNARD Stéphane en fonction le 12 Novembre 2012 ; Administrateur : PELLETIER Loïc en fonction le 12 Novembre 2012 ; Administrateur : DIERICK Sébastien en fonction le 31 Juillet 2013 ; Administrateur : BRINGER Nicolas en fonction le 31 Juillet 2013 ; Administrateur : GAGNEPAIN David en fonction le 07 Août 2015 ; Administrateur : BEDROSSIAN-MARDIROSSIAN Jean-Paul en fonction le 31 Mai 2016 ; Administrateur : GRAZELIE Alban en fonction le 25 Avril 2017 ; Administrateur : BOURASSIN Benoit en fonction le 25 Avril 2017 ; Administrateur : BOURBON Michel en fonction le 25 Avril 2017 ; Administrateur : MANNEVILLE Nicolas en fonction le 25 Avril 2017 ; Administrateur : GRASS Philippe en fonction le 25 Avril 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Juillet 2017. Activité : 
Commentaires : Modification de représentant..

02/08/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

1446 - 304 602 956 RCS Créteil. COOPERATIVE U ENSEIGNE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Enseigne : U ENSEIGNE. Administration : Administrateur : CARON STEPHANE ; Administrateur : GOURNAY Daniel modification le 30 Août 2000 ; Administrateur : PAPIN Serge en fonction le 30 Août 2000 ; Président du conseil d'administration Directeur général : PAPIN Serge modification le 21 Février 2005 ; Directeur général délégué : DARRASSE Guillaume modification le 05 Septembre 2006 ; Administrateur : SCHELCHER Dominique en fonction le 24 Avril 2009 ; Administrateur : AUBE Denis en fonction le 17 Décembre 2009 ; Administrateur : BESNARD Stéphane en fonction le 12 Novembre 2012 ; Administrateur : PELLETIER Loïc en fonction le 12 Novembre 2012 ; Administrateur : DIERICK Sébastien en fonction le 31 Juillet 2013 ; Administrateur : BRINGER Nicolas en fonction le 31 Juillet 2013 ; Administrateur : GAGNEPAIN David en fonction le 07 Août 2015 ; Administrateur : BEDROSSIAN-MARDIROSSIAN Jean-Paul en fonction le 31 Mai 2016 ; Administrateur : GRAZELIE Alban en fonction le 25 Avril 2017 ; Administrateur : BOURASSIN Benoit en fonction le 25 Avril 2017 ; Administrateur : BOURBON Michel en fonction le 25 Avril 2017 ; Administrateur : GRASS Philippe en fonction le 25 Avril 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Juillet 2017 ; Administrateur : EGONNEAU Franck en fonction le 28 Juillet 2017 ; Administrateur : LEBOUL Jeean-Yves en fonction le 28 Juillet 2017 ; Administrateur : VOUTERS Grégory en fonction le 28 Juillet 2017. Activité : 
Commentaires : Modification de la dénomination. Modification du nom commercial. Modification de représentant..

02/08/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

1431 - 304 602 956 RCS Créteil. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Administration : Administrateur : CARON STEPHANE ; Administrateur : GOURNAY Daniel modification le 30 Août 2000 ; Administrateur : PAPIN Serge en fonction le 30 Août 2000 ; Président du conseil d'administration Directeur général : PAPIN Serge modification le 21 Février 2005 ; Directeur général délégué : DARRASSE Guillaume modification le 05 Septembre 2006 ; Administrateur : SCHELCHER Dominique en fonction le 24 Avril 2009 ; Administrateur : AUBE Denis en fonction le 17 Décembre 2009 ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 06 Juillet 2012 ; Administrateur : BESNARD Stéphane en fonction le 12 Novembre 2012 ; Administrateur : PELLETIER Loïc en fonction le 12 Novembre 2012 ; Administrateur : DIERICK Sébastien en fonction le 31 Juillet 2013 ; Administrateur : BRINGER Nicolas en fonction le 31 Juillet 2013 ; Administrateur : GAGNEPAIN David en fonction le 07 Août 2015 ; Administrateur : BEDROSSIAN-MARDIROSSIAN Jean-Paul en fonction le 31 Mai 2016 ; Administrateur : GRAZELIE Alban en fonction le 25 Avril 2017 ; Administrateur : BOURASSIN Benoit en fonction le 25 Avril 2017 ; Administrateur : BOURBON Michel en fonction le 25 Avril 2017 ; Administrateur : MANNEVILLE Nicolas en fonction le 25 Avril 2017 ; Administrateur : GRASS Philippe en fonction le 25 Avril 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Juillet 2017 ; Administrateur : EGONNEAU Franck en fonction le 28 Juillet 2017. Activité : 
Commentaires : Modification de représentant..

01/08/2017

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

11639 - 304602956 RCS. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Adresse : Parc Tertiaire Silic 20 Rue d'Arcueil - Bât. Montréal 94150 Rungis. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2016.

13/07/2017

JAL

Partial asset

Les Petites affiches - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 29/03/2017
Apporteur : 304602956 - SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, LE MOULIN BOISSEAU, BATIMENT A, 44470 CARQUEFOU

13/07/2017

JAL

Miscellaneous updates

Les Petites affiches - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 29/03/2017 
Entreprise :304602956 - SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, LE MOULIN BOISSEAU, BATIMENT A, 44470, CARQUEFOU 
Description :Nomination d'un administrateur€ 

07/07/2017

JAL

Partial asset

L'Informateur judiciaire


Date de décision : 20/06/2017
Apporteur : 304602956 - SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, LE MOULIN BOISSEAU, BATIMENT A, 44470 CARQUEFOU

28/04/2017

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

1717 - 304 602 956 RCS Créteil. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Capital : 22867.35 EUR. Adresse : Parc Tertiaire Silic, 20 Rue d'Arcueil - Bât. Montréal, 94150 Rungis. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Oppositions : Les créanciers des sociétés scindées pourront former opposition à cette scission dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-21 du Code de Commerce. Descriptif : AVIS DE PROJET DE SCISSION SYSTEME U CENTRALE NATIONALE Forme juridique Soci¿t¿ coop¿rative ¿ forme anonyme ¿ capital variable Au capital de 22867,35 EUR Si¿ge social Parc Tertiaire Silic 20 rue d'Arcueil - B¿t. Montr¿al 94150 RUNGIS N¿ RCS 304602956 RCS CRETEIL, est soci¿t¿ b¿n¿ficiaire. SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD Forme juridique Soci¿t¿ coop¿rative de commer¿ants d¿taillants ¿ forme anonyme Si¿ge social RTE de Jacou Le Parc Herm¿s 34747 VENDARGUES N¿ RCS 306020140 RCS MONTPELLIER, est soci¿t¿ apporteuse. L¿¿valuation de l¿actif et du passif dont la transmission ¿ la soci¿t¿ b¿n¿ficiaire est pr¿vue : Actif : 557600000 euros Passif : 423200000 euros Actif net apport¿ : 134400000 euros Rapport d'¿change des droits sociaux : R¿mun¿ration de l¿apport : La soci¿t¿ b¿n¿ficiaire SYSTEME U CENTRALE NATIONALE augmentera son capital social par ¿mission au profit de la soci¿t¿ apporteuse de 49.358 parts nouvelles de cat¿gorie C, d¿une valeur nominale de 0,153 euros. Prime d¿apport : 134.392.448,23 euros. Date du projet : 11/04/2017 Date du d¿p¿t : 21/04/2017, lieu du d¿p¿t : Greffe du Tribunal de Commerce de Cr¿teil pour la soci¿t¿ SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Date du d¿p¿t : 25/04/2017, lieu du d¿p¿t : Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier pour la soci¿t¿ SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD. Commentaires : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement).

27/04/2017

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

1306 - 304 602 956 RCS Créteil. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Capital : 22867.35 EUR. Adresse : Parc Tertiaire Silic, 20 Rue d'Arcueil - Bât. Montréal, 94150 Rungis. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Oppositions : Les créanciers des sociétés scindées pourront former opposition à cette scission dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-21 du Code de Commerce. Descriptif : AVIS DE PROJET DE SCISSION SYSTEME U CENTRALE NATIONALE Forme juridique Soci¿t¿ coop¿rative ¿ forme anonyme ¿ capital variable Au capital de 22867,35 EUR Si¿ge social Parc Tertiaire Silic 20 rue d'Arcueil - B¿t. Montr¿al 94150 RUNGIS N¿ RCS 304602956 RCS CRETEIL, est soci¿t¿ b¿n¿ficiaire. SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST Forme juridique Soci¿t¿ anonyme Au capital de 18500 EUR Si¿ge social 14 ave de la C¿te de N¿cre 14000 CAEN N¿ RCS 313042251 RCS CAEN, est soci¿t¿ apporteuse. L¿¿valuation de l¿actif et du passif dont la transmission ¿ la soci¿t¿ b¿n¿ficiaire est pr¿vue : Actif : 364800000 euros Passif : 271400000 euros Actif net apport¿ : 93500000 euros Rapport d'¿change des droits sociaux : R¿mun¿ration de l¿apport : La soci¿t¿ b¿n¿ficiaire SYSTEME U CENTRALE NATIONALE augmentera son capital social par ¿mission au profit de la soci¿t¿ apporteuse de 34.338 parts nouvelles de cat¿gorie C, d¿une valeur nominale de 0,153 euros. Prime d¿apport : 93.494.746,29 euros Date du projet : 12/04/2017 Date du d¿p¿t : 21/04/2017, lieu du d¿p¿t : Greffe du Tribunal de Commerce de Cr¿teil pour la soci¿t¿ SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Date du d¿p¿t : 24/04/2017, lieu du d¿p¿t : Greffe du Tribunal de Commerce de Caen pour la soci¿t¿ SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST. Commentaires : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement).

27/04/2017

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

1305 - 304 602 956 RCS Créteil. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Capital : 22867.35 EUR. Adresse : Parc Tertiaire Silic, 20 Rue d'Arcueil - Bât. Montréal, 94150 Rungis. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Oppositions : Les créanciers des sociétés scindées pourront former opposition à cette scission dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-21 du Code de Commerce. Descriptif : AVIS DE PROJET DE SCISSION SYSTEME U CENTRALE NATIONALE Forme juridique Soci¿t¿ coop¿rative ¿ forme anonyme ¿ capital variable Au capital de 22867,35 EUR Si¿ge social Parc Tertiaire Silic 20 rue d'Arcueil - B¿t. Montr¿al 94150 RUNGIS N¿ RCS 304602956 RCS CRETEIL, est soci¿t¿ b¿n¿ficiaire. SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST, DIMINUTIF SYSTEME U OUEST Forme juridique Soci¿t¿ coop¿rative ¿ forme anonyme ¿ capital variable Si¿ge social PL des Pl¿iades ZI Belle Etoile Antar¿s 44470 CARQUEFOU N¿ RCS 867800427 RCS NANTES, est soci¿t¿ apporteuse. L¿¿valuation de l¿actif et du passif dont la transmission ¿ la soci¿t¿ b¿n¿ficiaire est pr¿vue : Actif : 1264300000 euros Passif : 920300000 euros Actif net apport¿ : 344000000 euros Rapport d'¿change des droits sociaux : R¿mun¿ration de l¿apport : La soci¿t¿ b¿n¿ficiaire SYSTEME U CENTRALE NATIONALE augmentera son capital social par ¿mission au profit de la soci¿t¿ apporteuse de 126.333 parts nouvelles de cat¿gorie C, d¿une valeur nominale de 0,153 euros. Prime d¿apport : 343.980.671,05 euros Date du projet : 12/04/2017 Date du d¿p¿t : 21/04/2017, lieu du d¿p¿t : Greffe du Tribunal de Commerce de Cr¿teil pour la soci¿t¿ SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Date du d¿p¿t : 24/04/2017, lieu du d¿p¿t : Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes pour la soci¿t¿ SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST DIMINUTIF SYSTEME U OUEST. Commentaires : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement).

27/04/2017

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

1304 - 304 602 956 RCS Créteil. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Capital : 22867.35 EUR. Adresse : Parc Tertiaire Silic, 20 Rue d'Arcueil - Bât. Montréal, 94150 Rungis. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Oppositions : Les créanciers des sociétés scindées pourront former opposition à cette scission dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-21 du Code de Commerce. Descriptif : AVIS DE PROJET DE SCISSION SYSTEME U CENTRALE NATIONALE Forme juridique Soci¿t¿ coop¿rative ¿ forme anonyme ¿ capital variable Au capital de 22867,35 EUR Si¿ge social Parc Tertiaire Silic 20 rue d'Arcueil - B¿t. Montr¿al 94150 RUNGIS N¿ RCS 304602956 RCS CRETEIL, est soci¿t¿ b¿n¿ficiaire. SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST Forme juridique Soci¿t¿ coop¿rative ¿ forme anonyme ¿ capital variable Au capital de 16928000 EUR Si¿ge social 43 RUE Eugene Ducretet 68200 MULHOUSE N¿ RCS 946051018 RCS MULHOUSE (TI), est soci¿t¿ apporteuse. L¿¿valuation de l¿actif et du passif dont la transmission ¿ la soci¿t¿ b¿n¿ficiaire est pr¿vue : Actif : 594600000 euros Passif : 395700000 euros Actif net apport¿ : 198900000 euros Rapport d'¿change des droits sociaux : R¿mun¿ration de l¿apport : La soci¿t¿ b¿n¿ficiaire SYSTEME U CENTRALE NATIONALE augmentera son capital social par ¿mission au profit de la soci¿t¿ apporteuse de 73.046 parts nouvelles de cat¿gorie C, d¿une valeur nominale de 0,153 euros. Prime d¿apport : 198.888.823,96 euros. Date du projet : 12/04/2017 Date du d¿p¿t : 21/04/2017, lieu du d¿p¿t : Greffe du Tribunal de Commerce de Cr¿teil pour la soci¿t¿ SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Date du d¿p¿t : 24/04/2017, lieu du d¿p¿t : Greffe du Tribunal d'Instance de Mulhouse pour la soci¿t¿ SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST. Commentaires : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement).

29/03/2017

JAL

Miscellaneous updates

Les Petites affiches - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 25/05/2016 
Entreprise :304602956 - SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, LE MOULIN BOISSEAU, BATIMENT A, 44470, CARQUEFOU 
Description :Nomination d'un administrateur€ 

10/12/2016

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

12779 - 304602956 RCS. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Adresse : Parc Tertiaire Silic 20 Rue d'Arcueil - Bât. Montréal 94150 Rungis. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2015.

03/06/2016

Bodacc B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

3932 - 304 602 956 RCS Créteil. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BEFEC PRICE WATERHOUSE modification le 16 Mars 2006 Administrateur : CARON STEPHANE Administrateur : GOURNAY Daniel modification le 30 Août 2000 Administrateur : PROU Marc en fonction le 06 Octobre 1998 Administrateur : PAPIN Serge en fonction le 30 Août 2000 Président du conseil d'administration Directeur général : PAPIN Serge modification le 21 Février 2005 Directeur général délégué : DARRASSE Guillaume modification le 05 Septembre 2006 Administrateur : MAUCOURT Patrick en fonction le 26 Septembre 2007 Administrateur : SCHELCHER Dominique en fonction le 24 Avril 2009 Administrateur : BOLTZ Thierry en fonction le 24 Avril 2009 Administrateur : BENHAMOU Stéphane en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : AUBE Denis en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : COLLET Gilles en fonction le 17 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 06 Juillet 2012 Administrateur : VAPPEREAU Alain en fonction le 06 Juillet 2012 Administrateur : BESNARD Stéphane en fonction le 12 Novembre 2012 Administrateur : PELLETIER Loïc en fonction le 12 Novembre 2012 Administrateur : DIERICK Sébastien en fonction le 31 Juillet 2013 Administrateur : BRINGER Nicolas en fonction le 31 Juillet 2013 Administrateur : GAGNEPAIN David en fonction le 07 Août 2015 Administrateur : BEDROSSIAN-MARDIROSSIAN Jean-Paul en fonction le 31 Mai 2016. Activité : 
Commentaires : Modification de représentant..

19/05/2016

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Les Petites affiches - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 27/01/2016
La société 304602956 - SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, LE MOULIN BOISSEAU, BATIMENT A, 44470 CARQUEFOU 
Fait l'objet du départ de Ingrid MISKDJIAN

19/05/2016

JAL

Appointment of the social representative

Les Petites affiches - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 27/01/2016
Société faisant l'objet d'une nomination : 304602956 - SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, LE MOULIN BOISSEAU, BATIMENT A, 44470 CARQUEFOU 
Nominé : Monsieur Jean-Paul BEDROSSIAN, 38470 VINAY
En la fonction de : Administrateur

24/08/2015

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

12448 - 304602956 RCS. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Adresse : Parc Tertiaire Silic 20 Rue d'Arcueil - Bât. Montréal 94150 Rungis. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2014.

18/08/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

1308 - 304 602 956 RCS Créteil. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BEFEC PRICE WATERHOUSE modification le 16 Mars 2006 Administrateur : CARON STEPHANE Administrateur : GOURNAY Daniel modification le 30 Août 2000 Administrateur : PROU Marc en fonction le 06 Octobre 1998 Administrateur : PAPIN Serge en fonction le 30 Août 2000 Président du conseil d'administration Directeur général : PAPIN Serge modification le 21 Février 2005 Directeur général délégué : DARRASSE Guillaume modification le 05 Septembre 2006 Administrateur : MAUCOURT Patrick en fonction le 26 Septembre 2007 Administrateur : SCHELCHER Dominique en fonction le 24 Avril 2009 Administrateur : BOLTZ Thierry en fonction le 24 Avril 2009 Administrateur : MISKDJIAN Ingrid en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : HIRSCHNER Richard en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : BENHAMOU Stéphane en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : AUBE Denis en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : COLLET Gilles en fonction le 17 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 06 Juillet 2012 Administrateur : VAPPEREAU Alain en fonction le 06 Juillet 2012 Administrateur : BESNARD Stéphane en fonction le 12 Novembre 2012 Administrateur : PELLETIER Loïc en fonction le 12 Novembre 2012 Administrateur : DIERICK Sébastien en fonction le 31 Juillet 2013 Administrateur : BRINGER Nicolas en fonction le 31 Juillet 2013 Administrateur : GAGNEPAIN David en fonction le 07 Août 2015. Activité : 
Commentaires : Modification de représentant.

29/07/2015

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Gazette du palais (La)


Date de décision : 27/05/2015
La société 304602956 - SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, 20 RUE D ARCUEIL, PARC TERTIAIRE SILIC BATIMENT MONTREAL, 94150 RUNGIS 
Fait l'objet du départ de Monsieur Gérard THIBOUS

21/07/2014

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

15012 - 304602956 RCS. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Adresse : Parc Tertiaire Silic 20 Rue d'Arcueil - Bât. Montréal 94150 Rungis. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2013.

29/08/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

13702 - 304602956 RCS. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Adresse : Parc Tertiaire Silic 20 Rue d'Arcueil - Bât. Montréal 94150 Rungis. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2012.

08/08/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

1375 - 304 602 956 RCS Créteil. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BEFEC PRICE WATERHOUSE modification le 16 Mars 2006 Administrateur : CARON STEPHANE Administrateur : GOURNAY Daniel modification le 30 Août 2000 Administrateur : PROU Marc en fonction le 06 Octobre 1998 Administrateur : PAPIN Serge en fonction le 30 Août 2000 Président du conseil d'administration Directeur général : PAPIN Serge modification le 21 Février 2005 Directeur général délégué : DARRASSE Guillaume modification le 05 Septembre 2006 Administrateur : MAUCOURT Patrick en fonction le 26 Septembre 2007 Administrateur : SCHELCHER Dominique en fonction le 24 Avril 2009 Administrateur : BOLTZ Thierry en fonction le 24 Avril 2009 Administrateur : MISKDJIAN Ingrid en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : HIRSCHNER Richard en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : BENHAMOU Stéphane en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : AUBE Denis en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : COLLET Gilles en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : THIBOUS Gérard en fonction le 17 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 06 Juillet 2012 Administrateur : VAPPEREAU Alain en fonction le 06 Juillet 2012 Administrateur : BESNARD Stéphane en fonction le 12 Novembre 2012 Administrateur : PELLETIER Loïc en fonction le 12 Novembre 2012 Administrateur : DIERICK Sébastien en fonction le 31 Juillet 2013 Administrateur : BRINGER Nicolas en fonction le 31 Juillet 2013. Activité : 
Commentaires : Modification de représentant.

12/07/2013

JAL

Appointment of the social representative

Gazette du palais (La)


Date de décision : 29/05/2013
Société faisant l'objet d'une nomination : 304602956 - SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, 20 RUE D ARCUEIL, PARC TERTIAIRE SILIC BATIMENT MONTREAL, 94150 RUNGIS 
Nominé : Monsieur Sébastien DIERICK, 28130 HANCHES
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Monsieur Nicolas BRINGER, 34700 LODEVE
En la fonction de : Administrateur

12/07/2013

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Gazette du palais (La)


Date de décision : 29/05/2013
La société 304602956 - SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, 20 RUE D ARCUEIL, PARC TERTIAIRE SILIC BATIMENT MONTREAL, 94150 RUNGIS 
Fait l'objet du départ de Monsieur Gérard BUR, 
De Monsieur Marc ELLUL

20/11/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

1937 - 304 602 956 RCS Créteil. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BEFEC PRICE WATERHOUSE modification le 16 Mars 2006 Administrateur : CARON STEPHANE Administrateur : GOURNAY Daniel modification le 30 Août 2000 Administrateur : PROU Marc en fonction le 06 Octobre 1998 Administrateur : PAPIN Serge en fonction le 30 Août 2000 Président du conseil d'administration et directeur général : PAPIN Serge modification le 21 Février 2005 Directeur général délégué : DARRASSE Guillaume modification le 05 Septembre 2006 Administrateur : BUR Gérard en fonction le 26 Septembre 2007 Administrateur : MAUCOURT Patrick en fonction le 26 Septembre 2007 Administrateur : SCHELCHER Dominique en fonction le 24 Avril 2009 Administrateur : BOLTZ Thierry en fonction le 24 Avril 2009 Administrateur : MISKDJIAN Ingrid en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : HIRSCHNER Richard en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : BENHAMOU Stéphane en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : AUBE Denis en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : COLLET Gilles en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : THIBOUS Gérard en fonction le 17 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 06 Juillet 2012 Administrateur : VAPPEREAU Alain en fonction le 06 Juillet 2012 Administrateur : BESNARD Stéphane en fonction le 12 Novembre 2012 Administrateur : ELLUL Marc en fonction le 12 Novembre 2012 Administrateur : PELLETIER Loïc en fonction le 12 Novembre 2012. Activité : 
Commentaires : Modification de représentant.

21/09/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

1257 - 304 602 956 RCS Créteil. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Activité : 
Adresse du siège social : Parc Tertiaire Silic, 20 Rue d'Arcueil - Bât. Montréal, 94150 Rungis. 
Commentaires : Modification de l'adresse du siège.

07/09/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

9300 - 304602956 RCS. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Adresse : 72-92 avenue Robert Schuman Bât Quito Parc Tertiaire Silic 94150 Rungis. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011.

19/07/2012

JAL

Head Office Transfer

Gazette du palais (La)


Date de décision : 28/03/2012
Transfert du siège social de la société 304602956 -  SYSTEME U CENTRALE NATIONALE 
Adresse du nouveau siège : 20 RUE D ARCUEIL, 94150 RUNGIS
Ancienne localisation : 72 AV ROBERT SCHUMAN, BAT QUITO PARC TERTIAI SILIC /72-92, 94150 RUNGIS
Date d'effet : 01/09/2012

19/07/2012

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Gazette du palais (La)


Date de décision : 29/05/2012
La société 304602956 - SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, 72 AV ROBERT SCHUMAN, BAT QUITO PARC TERTIAI SILIC /72-92, 94150 RUNGIS 
Fait l'objet du départ de Monsieur Jean-Claude SOULARD, 
De Monsieur Yves PETITPAS, 
De Monsieur Patrick Bessueille

19/07/2012

JAL

Appointment of the social representative

Gazette du palais (La)


Date de décision : 29/05/2012
Société faisant l'objet d'une nomination : 304602956 - SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, 72 AV ROBERT SCHUMAN, BAT QUITO PARC TERTIAI SILIC /72-92, 94150 RUNGIS 
Nominé : Monsieur Stéphane BESNARD, 44260 SAVENAY
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Monsieur Loïc Pelletier, 17100 SAINTES
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Monsieur Marc ELLUL, 66500 PRADES
En la fonction de : Administrateur

15/07/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

1532 - 304 602 956 RCS Créteil. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BEFEC PRICE WATERHOUSE modification le 16 Mars 2006 Administrateur : CARON STEPHANE Administrateur : GOURNAY Daniel modification le 30 Août 2000 Administrateur : SOULARD Jean Claude en fonction le 02 Octobre 1997 Administrateur : PETITPAS Yves en fonction le 06 Octobre 1998 Administrateur : PROU Marc en fonction le 06 Octobre 1998 Administrateur : BESSUEILLE Patrick en fonction le 30 Août 2000 Administrateur : PAPIN Serge en fonction le 30 Août 2000 Président du conseil d'administration et directeur général : PAPIN Serge modification le 21 Février 2005 Directeur général délégué : DARRASSE Guillaume modification le 05 Septembre 2006 Administrateur : BUR Gérard en fonction le 26 Septembre 2007 Administrateur : MAUCOURT Patrick en fonction le 26 Septembre 2007 Administrateur : SCHELCHER Dominique en fonction le 24 Avril 2009 Administrateur : BOLTZ Thierry en fonction le 24 Avril 2009 Administrateur : MISKDJIAN Ingrid en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : HIRSCHNER Richard en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : BENHAMOU Stéphane en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : AUBE Denis en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : COLLET Gilles en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : THIBOUS Gérard en fonction le 17 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 06 Juillet 2012 Administrateur : VAPPEREAU Alain en fonction le 06 Juillet 2012. Activité : 
Commentaires : Modification de représentant.

23/06/2012

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Gazette du palais (La)


Date de décision : 25/05/2011
La société 304602956 - SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, 72 AV ROBERT SCHUMAN, BAT QUITO PARC TERTIAI SILIC /72-92, 94150 RUNGIS 
Fait l'objet du départ de Muriel DELPERIE, 
De Monsieur Pierre COLL

23/06/2012

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Gazette du palais (La)


Date de décision : 25/05/2011
La société 304602956 - SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, 72 AV ROBERT SCHUMAN, BAT QUITO PARC TERTIAI SILIC /72-92, 94150 RUNGIS 
Fait l'objet du départ de Muriel DELPERIE, 
De Monsieur Pierre COLL

23/06/2012

JAL

Appointment of the social representative

Gazette du palais (La)


Date de décision : 25/05/2011
Société faisant l'objet d'une nomination : 304602956 - SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, 72 AV ROBERT SCHUMAN, BAT QUITO PARC TERTIAI SILIC /72-92, 94150 RUNGIS 
Nominé : Monsieur Alain VAPPEREAU, 05200 EMBRUN
En la fonction de : Administrateur

23/06/2012

JAL

Appointment of the social representative

Gazette du palais (La)


Date de décision : 25/05/2011
Société faisant l'objet d'une nomination : 304602956 - SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, 72 AV ROBERT SCHUMAN, BAT QUITO PARC TERTIAI SILIC /72-92, 94150 RUNGIS 
Nominé : Monsieur Alain VAPPEREAU, 05200 EMBRUN
En la fonction de : Administrateur

30/01/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

13686 - 304602956 RCS. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société coopérative à forme anonyme à capital variable. Adresse : 72-92 avenue Robert Schuman Bât Quito Parc Tertiaire Silic 94150 Rungis. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2010.

28/12/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

13689 - 304602956 RCS. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société anonyme coopérative à conseil d'administration à capital variable. Adresse : 72-92 avenue Robert Schuman Bât Quito Parc Tertiaire Silic 94150 Rungis. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

31/12/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

2454 - 304 602 956 RCS Créteil. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société anonyme coopérative à capital variable. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BEFEC PRICE WATERHOUSE modification le 16 Mars 2006 Administrateur : CARON STEPHANE Administrateur : GOURNAY Daniel modification le 30 Août 2000 Administrateur : SOULARD Jean Claude en fonction le 02 Octobre 1997 Administrateur : PETITPAS Yves en fonction le 06 Octobre 1998 Administrateur : PROU Marc en fonction le 06 Octobre 1998 Administrateur : BESSUEILLE Patrick en fonction le 30 Août 2000 Administrateur : PAPIN Serge en fonction le 30 Août 2000 Administrateur : DELPERIE Muriel Thérèse en fonction le 29 Juillet 2003 Président du conseil d'administration et directeur général : PAPIN Serge modification le 21 Février 2005 Commissaire aux comptes suppléant : COLL Pierre modification le 16 Mars 2006 Directeur général délégué : DARRASSE Guillaume modification le 05 Septembre 2006 Administrateur : BUR Gérard en fonction le 26 Septembre 2007 Administrateur : MAUCOURT Patrick en fonction le 26 Septembre 2007 Administrateur : SCHELCHER Dominique en fonction le 24 Avril 2009 Administrateur : BOLTZ Thierry en fonction le 24 Avril 2009 Administrateur : MISKDJIAN Ingrid en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : HIRSCHNER Richard en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : BENHAMOU Stéphane en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : AUBE Denis en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : COLLET Gilles en fonction le 17 Décembre 2009 Administrateur : THIBOUS Gérard en fonction le 17 Décembre 2009. 
Commentaires : Modification de représentant.

12/08/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

11670 - 304602956 RCS. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société anonyme coopérative à capital variable. Adresse : 72-92 avenue Robert Schuman Bât Quito Parc Tertiaire Silic 94150 Rungis. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

06/05/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

1815 - 304 602 956 RCS Créteil. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société anonyme coopérative à capital variable. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BEFEC PRICE WATERHOUSE modification le 16 Mars 2006. Administrateur : FLANC MICHEL modification le 03 Septembre 1999. Administrateur : CARON STEPHANE. Administrateur : GOURNAY Daniel modification le 30 Août 2000. Administrateur : SOULARD Jean Claude en fonction le 02 Octobre 1997. Administrateur : PETITPAS Yves en fonction le 06 Octobre 1998. Administrateur : PROU Marc en fonction le 06 Octobre 1998. Administrateur : BESSUEILLE Patrick en fonction le 30 Août 2000. Administrateur : PAPIN Serge en fonction le 30 Août 2000. Administrateur : DELPERIE Muriel Thérèse en fonction le 29 Juillet 2003. Président du conseil d'administration et directeur général : PAPIN Serge modification le 21 Février 2005. Commissaire aux comptes suppléant : COLL Pierre modification le 16 Mars 2006. Directeur général délégué : DARRASSE Guillaume modification le 05 Septembre 2006. Administrateur : TISCHMACHER Georges en fonction le 26 Septembre 2007. Administrateur : BUR Gérard en fonction le 26 Septembre 2007. Administrateur : MAUCOURT Patrick en fonction le 26 Septembre 2007. Administrateur : SCHELCHER Dominique en fonction le 24 Avril 2009. Administrateur : BOLTZ Thierry en fonction le 24 Avril 2009. 
Commentaires : Modification de représentant.

29/10/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

5226 - 304 602 956 RCS Créteil. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société anonyme coopérative à capital variable. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BEFEC PRICE WATERHOUSE modification le 16 Mars 2006. Administrateur : FLANC MICHEL modification le 03 Septembre 1999. Administrateur : CARON STEPHANE. Administrateur : GOURNAY Daniel modification le 30 Août 2000. Administrateur : SOULARD Jean Claude en fonction le 02 Octobre 1997. Administrateur : PETITPAS Yves en fonction le 06 Octobre 1998. Administrateur : PROU Marc en fonction le 06 Octobre 1998. Administrateur : BESSUEILLE Patrick en fonction le 30 Août 2000. Administrateur : MOREAU Jacques en fonction le 30 Août 2000. Administrateur : PAPIN Serge en fonction le 30 Août 2000. Administrateur : DELPERIE Muriel Thérèse en fonction le 29 Juillet 2003. Administrateur : BOUTREUX Philippe en fonction le 29 Juillet 2003. Président du conseil d'administration et directeur général : PAPIN Serge modification le 21 Février 2005. Commissaire aux comptes suppléant : COLL Pierre modification le 16 Mars 2006. Directeur général délégué : DARRASSE Guillaume modification le 05 Septembre 2006. Administrateur : TISCHMACHER Georges en fonction le 26 Septembre 2007. Administrateur : HADJADJ Serge en fonction le 26 Septembre 2007. Administrateur : BUR Gérard en fonction le 26 Septembre 2007. Administrateur : MAUCOURT Patrick en fonction le 26 Septembre 2007. 
Commentaires : Modification de représentant.

29/10/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

5227 - 304 602 956 RCS Créteil. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société anonyme coopérative à capital variable. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BEFEC PRICE WATERHOUSE modification le 16 Mars 2006. Administrateur : FLANC MICHEL modification le 03 Septembre 1999. Administrateur : CARON STEPHANE. Administrateur : GOURNAY Daniel modification le 30 Août 2000. Administrateur : SOULARD Jean Claude en fonction le 02 Octobre 1997. Administrateur : PETITPAS Yves en fonction le 06 Octobre 1998. Administrateur : PROU Marc en fonction le 06 Octobre 1998. Administrateur : BESSUEILLE Patrick en fonction le 30 Août 2000. Administrateur : PAPIN Serge en fonction le 30 Août 2000. Administrateur : DELPERIE Muriel Thérèse en fonction le 29 Juillet 2003. Administrateur : BOUTREUX Philippe en fonction le 29 Juillet 2003. Président du conseil d'administration et directeur général : PAPIN Serge modification le 21 Février 2005. Commissaire aux comptes suppléant : COLL Pierre modification le 16 Mars 2006. Directeur général délégué : DARRASSE Guillaume modification le 05 Septembre 2006. Administrateur : TISCHMACHER Georges en fonction le 26 Septembre 2007. Administrateur : HADJADJ Serge en fonction le 26 Septembre 2007. Administrateur : BUR Gérard en fonction le 26 Septembre 2007. Administrateur : MAUCOURT Patrick en fonction le 26 Septembre 2007. 
Commentaires : Modification de représentant.

30/09/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

10298 - 304602956 RCS. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société anonyme coopérative à capital variable. Adresse : 72-92 avenue Robert Schuman Bât Quito Parc Tertiaire Silic, 94150 Rungis. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

20/02/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

94 - VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

3997 - 304 602 956 RCS Créteil. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : Société anonyme coopérative à capital variable. Enseigne : SUPER U - HYPER U - MARCHE U - MAGASINS U - U LES NOUVEAUX COMMERCANTS. Adresse de l’établissement principal : 72-92 avenue Robert Schuman - Bât. Quito, Parc Tertiaire Silic, 94150 Rungis. 
Commentaires : Modification de l'adresse de l'établissement.

21/10/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

4127 - RCS Créteil B 304 602 956. RC 86-B 187. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'administrateurs : TISCHMACHER (Georges) HADJADJ (Serge) BUR (Gérard) MAUCOURT (Patrick).

18/10/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

4154 - RCS Créteil B 304 602 956. RC 86-B 187. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : BAUDE (Gérard).

30/08/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

7624 - 304 602 956. RCS Créteil SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme: Société anonyme coopérative à capital variable. Adresse du siège social: 1 rue Thomas Edison 94000 Créteil. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

24/04/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1754 - RCS Créteil B 304 602 956. RC 86-B 187. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : TRAULLE (Jean, Luc).

05/04/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

2139 - RCS Créteil B 304 602 956. RC 86-B 187. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : LEROYER (Jean, Marcel, Marie, Joseph).

26/08/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

2897 - RCS Créteil B 304 602 956. RC 86-B 187. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme: S.A. coopérative à capital variable. Adresse du siège social: 1, rue Thomas Edison,94000 Creteil. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

25/08/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

4757 - RCS Créteil B 304 602 956. RC 86-B 187. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateurs partants : BARTHOLOME (Yves) MANDROYAN (Bruno). Nomination d'un directeur général délégué : DARRASSE (Guillaume).

17/09/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

3161 - RCS Créteil B 304 602 956. RC 86-B 187. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme: S.A. coopérative à capital variable. Adresse du siège social: 1, rue Thomas Edison,94000 Creteil. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

19/07/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

3141 - RCS Créteil B 304 602 956. RC 86-B 187. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable. Nom commercial : Super U Hyper U Marché U Magasins U U Les Nouveaux Commerçants. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : commissaire aux comptes suppléant partant : VIENNE (Dominique). Administrateur partant : BERTOUT (Gérard). Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : COLL (Pierre).

25/03/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

2156 - RCS Créteil B 304 602 956. RC 86-B 187. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable. Nom commercial : Super U Hyper U Marché U Magasins U U Les Nouveaux Commerçants. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification d'un administrateur : BARTHOLOME (Yves). Modification du président du conseil d'administration et directeur général : PAPIN (Serge).

03/03/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1427 - RCS Créteil B 304 602 956. RC 86-B 187. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable. Nom commercial : Super U Hyper U Marché U Magasins U U Les Nouveaux Commerçants. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : directeur général partant : GALLO (Michel). Nomination d'un directeur général : PAPIN (Serge).

03/08/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Créteil B 304602956 RC 86-B 187 SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable Nom commercial: Super U Hyper U Marché U Magasins U U Les Nouveaux Commerçants. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateurs partants : JAUNAIT (Jean, Claude) REBOURSEAU (Patrick). Nomination d' administrateurs : BERTOUT (Gérard) MANDROYAN (Bruno).

28/01/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Créteil B 304602956 RC 86-B 187 SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable Nom commercial: Super U Hyper U Marché U Magasins U U Les Nouveaux Commerçants. Adresse du siège social : 1 rue Thomas-Edison, 94000 Créteil. Commentaires : modification survenue sur l'adresse du siège social et l'adresse de l'établissement principal Etablissement principal: Adresse : 1 rue Thomas-Edison, 94000 Créteil.

08/08/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Créteil B 304602956 RC 86-B 187 SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable Nom commercial: Super U Hyper U Marché U Magasins U U Les Nouveaux Commerçants. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification d'un administrateur : JAUNAIT (Jean, Claude). Modification du président du conseil d' administration : BARTHOLOME (Yves). Administrateurs partants : HALM (Claude) BRINGER (Daniel, Célestin, Clément) TISCHMACHER (Georges). Nomination d' administrateurs : DELPERIE (Muriel, Thérèse) BOUTREUX (Philippe) REBOURSEAU (Patrick).

14/05/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Créteil B 304602956 RC 86-B 187 SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable Nom commercial: Super U Hyper U Marché U Magasins U U Les Nouveaux Commerçants. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification du président du conseil d'administration : JAUNAIT (Jean, Claude). Modification d' un directeur général délégué : GALLO ( Michel).

27/08/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Créteil B 304602956 RC 86-B 187 SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable Nom commercial: Super U Hyper U Marché U Magasins U U Les Nouveaux Commerçants. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification du président du conseil d'administration et directeur général : JAUNAIT (Jean, Claude). Vice-président partant : DI SCALA (Christian). Modification d'un directeur général délégué non administrateur : GALLO (Michel). Administrateur partant : JAMET ( Philippe, Jean, Albert).

05/09/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Créteil B 304602956 RC 86-B 187 SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable Nom commercial: Super U Hyper U Marché U Magasins U U Les Nouveaux Commerçants. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateurs partants : GINOUVES (Bernard) BEYNEL ( Francis).

23/08/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Créteil B 304602956 RC 86-B 187 SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable Nom commercial: Super U Hyper U Marché U Magasins U U Les Nouveaux Commerçants. Commentaires : modification survenue sur le nom commercial.

14/09/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Créteil B 304602956 RC 86-B 187 SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : DUMEL (Bernard) . Modification d'un administrateur : GOURNAY (Daniel). Administrateur partant : BONGIOVANNI (Antoine, Georges, Dominique). Nomination d' administrateurs : BESSUEILLE (Patrick) MOREAU (Jacques) PAPIN (Serge) TISCHMACHER (Georges).

19/09/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Créteil B 304602956 RC 86-B 187 SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification du P.-D.G. : JAUNAIT (Jean, Claude). Administrateur partant : DIAZ ( Barthélémy, René). Nomination d' administrateurs : HALM (Claude) BRINGER (Daniel, Célestin, Clément) LEROYER (Jean, Marcel, Marie, Joseph) JAMET (Philippe, Jean, Albert) BONGIOVANNI (Antoine, Georges, Dominique). Modification d' administrateurs : TRAULLE (Jean, Luc) BEYNEL (Francis) FLANC (Michel) BARTHOLOME (Yves) BAUDE (Gérard). Modification du commissaire aux comptes titulaire : CABINET BEFEC-PRICE WATERHOUSE. Nomination du commissaire aux comptes suppléant : VIENNE ( Dominique). Commissaire aux comptes suppléant partant : SCACCHI (Pierre).

18/04/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Créteil B 304 602 956 RC 86-B 187 SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification du vice-président : DI SCALA (Christian). Nomination du directeur général non administrateur : GALLO (Michel).

25/10/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Créteil B 304 602 956 RC 86-B 187 SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateurs partants : PAPIN (Serge) BILLAUDOT (Luc). Nomination d' administrateurs : PETITPAS (Yves) PROU (Marc).

17/10/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Créteil B 304 602 956 RC RC 86-B 187 SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable. Administration : suppression : administrateur : DIERICK (Daniel). Nomination en qualité d'administrateurs GOURNAY (Daniel) SOULARD (Jean- Claude). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

03/11/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Créteil B 304 602 956 RC RC 86-B 187 SYSTEME U. CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable. Administration : président- directeur général : JAUNAIT (Jean- Claude) Directeur général et administrateur : DI SCALA (Christian). Administrateurs : TRAULLE (Jean-Luc) DIAZ (Barthélémy, René) GINOUVES ( Bernard) PAPIN (Serge) BEYNEL ( Francis) BILLAUDOT (Luc) FLANC ( Michel) DIERICK (Daniel) BARRE ( Jean-Louis) BARTHOLOME (Yves) BAUDE (Gérard) CARON (Stéphane) DUMEL (Bernard). Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PETITEAU SCACCHI E. ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : SCACCHI (Pierre). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

23/04/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Créteil B 304 602 956 RC RC 86-B 187 SYSTEME U. CENTRALE NATIONALE. Forme : S.A. coopérative à capital variable. Administration : président- directeur général : JAUNAIT (Jean- Claude) Directeur général et administrateur : DI SCALA (Christian). Administrateurs : TRAULLE (Jean-Luc) DIAZ (Barthélémy,René) GINOUVES ( Bernard) PAPIN (Serge) AURIAU ( Jean-Louis) BEYNEL (Francis) BILLAUDOT (Luc) FLANC (Michel) DIERICK (Daniel). Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PETITEAU SCACCHI ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : SCACCHI (Pierre). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

 

 

Company events history

 

Date

Description

05/01/2018

New subsidiarie(s) detected

03/11/2017

New participations in other companies

20/09/2017

Bodacc B: Various editing or changing

07/09/2017

Legal Gazette: Miscellaneous updates

02/08/2017

Bodacc B: Various editing or changing

01/08/2017

Bodacc C : Deposit accounts notice

28/07/2017

Amendment

28/07/2017

Changes to the Board of Directors

28/07/2017

Declaration of conformity

28/07/2017

Minutes of general meeting of shareholders

28/07/2017

New auditor

28/07/2017

Updated articles of association

28/07/2017

New company name

19/07/2017

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

13/07/2017

Legal Gazette: Miscellaneous updates

03/07/2017

Legal Gazette: Partial asset

30/06/2017

Update of Company Name

20/06/2017

Legal Gazette: Partial asset

28/04/2017

Bodacc A : Sale and transfer

27/04/2017

Bodacc A : Sale and transfer

25/04/2017

Amendment

25/04/2017

Changes to the Board of Directors

29/03/2017

Legal Gazette: Miscellaneous updates

29/03/2017

Legal Gazette: Partial asset

14/03/2017

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

31/12/2016

New accounts available

10/12/2016

Bodacc C : Deposit accounts notice

05/12/2016

Invalid balance sheet

03/12/2016

Invalid balance sheet

02/09/2016

Application and court order

03/06/2016

Bodacc B: Various editing or changing

31/05/2016

Amendment

31/05/2016

Changes to the Board of Directors

19/05/2016

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

07/05/2016

New participations in other companies

27/01/2016

Legal Gazette: Appointment of the social representative

31/12/2015

New accounts available

29/12/2015

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

06/11/2015

New participations in other companies

06/11/2015

New subsidiarie(s) detected

24/08/2015

Bodacc C : Deposit accounts notice

22/08/2015

Invalid balance sheet

18/08/2015

Bodacc B: Various editing or changing

07/08/2015

Minutes of general meeting of shareholders

07/08/2015

Changes to the Board of Directors

07/08/2015

Updated articles of association

29/07/2015

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

01/05/2015

New ultimate parent

24/03/2015

Application and court order

31/12/2014

New accounts available

21/07/2014

Bodacc C : Deposit accounts notice

02/07/2014

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

31/12/2013

New accounts available

28/12/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

30/08/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

29/08/2013

Bodacc C : Deposit accounts notice

08/08/2013

Bodacc B: Various editing or changing

31/07/2013

Amendment

31/07/2013

Changes to the Board of Directors

12/07/2013

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

29/05/2013

Legal Gazette: Appointment of the social representative

11/05/2013

Invalid balance sheet

31/12/2012

New accounts available

20/11/2012

Bodacc B: Various editing or changing

12/11/2012

Changes to the Board of Directors

12/11/2012

Amendment

21/09/2012

Bodacc B: Various editing or changing

13/09/2012

Amendment

13/09/2012

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

13/09/2012

Updated articles of association

07/09/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

19/07/2012

Legal Gazette: Head Office Transfer

19/07/2012

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

15/07/2012

Bodacc B: Various editing or changing

06/07/2012

New auditor

06/07/2012

Changes to the Board of Directors

06/07/2012

Amendment

23/06/2012

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

29/05/2012

Legal Gazette: Appointment of the social representative

28/03/2012

Transfer of Establishment

28/03/2012

Update of Company Head Office Identifier

30/01/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

31/12/2011

New accounts available

25/05/2011

Legal Gazette: Appointment of the social representative

28/12/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

22/02/2010

New subsidiarie(s) detected

22/02/2010

New ultimate parent

22/02/2010

New parent detected

31/12/2009

Bodacc B: Various editing or changing

31/12/2009

New accounts available

17/12/2009

Changes to the Board of Directors

17/12/2009

Amendment

08/12/2009

Payment incident closed

12/08/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

06/05/2009

Bodacc B: Various editing or changing

24/04/2009

Minutes of Board meeting

24/04/2009

Changes to the Board of Directors

24/04/2009

Changes to the Board of Directors

24/04/2009

Appointment/resignation of company officers

24/04/2009

Amendment

24/04/2009

Private document

26/03/2009

Collection of preferential rights activated for this company

31/12/2008

New accounts available

29/10/2008

New Bodacc B ads detected

29/10/2008

Bodacc B: Various editing or changing

20/10/2008

Appointment/resignation of company officers

20/10/2008

Private document

20/10/2008

Minutes of Board meeting

20/10/2008

Changes to the Board of Directors

20/10/2008

Changes to the Board of Directors

20/10/2008

Amendment

30/09/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

15/09/2008

Payment incident closed

01/08/2008

Payment incident detected

20/02/2008

New Bodacc B ads detected

20/02/2008

Bodacc B: Various editing or changing

31/12/2007

New accounts available

09/11/2007

Minutes of Board meeting

09/11/2007

Private document

09/11/2007

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

09/11/2007

Updated articles of association

09/11/2007

Updated articles of association

09/11/2007

Amendment

09/11/2007

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

26/09/2007

Appointment/resignation of company officers

26/09/2007

Changes to the Board of Directors

26/09/2007

Changes to the Board of Directors

26/09/2007

Minutes of general meeting of shareholders

26/09/2007

Minutes of general meeting of shareholders

26/09/2007

Private document

18/09/2007

Changes to the Board of Directors

18/09/2007

Changes to the Board of Directors

18/09/2007

Minutes of Board meeting

18/09/2007

Private document

18/09/2007

Amendment

18/09/2007

Appointment/resignation of company officers

30/03/2007

Changes to the Board of Directors

30/03/2007

Minutes of Board meeting

30/03/2007

Amendment

30/03/2007

Appointment/resignation of company officers

30/03/2007

Changes to the Board of Directors

30/03/2007

Private document

14/03/2007

Private document

14/03/2007

Changes to the Board of Directors

14/03/2007

Changes to the Board of Directors

14/03/2007

Appointment/resignation of company officers

14/03/2007

Amendment

14/03/2007

Minutes of Board meeting

31/12/2006

New accounts available

02/08/2006

Private document

02/08/2006

Minutes of general meeting of shareholders

02/08/2006

Minutes of Board meeting

02/08/2006

Changes to the Board of Directors

02/08/2006

Appointment/resignation of company officers

02/08/2006

Amendment

31/12/2005

New accounts available

29/06/2005

Updated articles of association

29/06/2005

Minutes of general meeting of shareholders

29/06/2005

New auditor

23/06/2005

Updated articles of association

23/06/2005

Private document

23/06/2005

Appointment/resignation of company officers

23/06/2005

Minutes of general meeting of shareholders

23/06/2005

Changes to the Board of Directors

21/02/2005

New chairman (CEO, CoB)

21/02/2005

Minutes of Board meeting

21/02/2005

Changes to the Board of Directors

21/02/2005

Appointment/resignation of company officers

21/02/2005

Amendment

21/02/2005

Private document

04/02/2005

Amendment

04/02/2005

Changes to the Board of Directors

04/02/2005

Minutes of Board meeting

04/02/2005

Private document

04/02/2005

Appointment/resignation of company officers

31/12/2004

New accounts available

15/07/2004

Changes to the Board of Directors

15/07/2004

Minutes of general meeting of shareholders

15/07/2004

Private document

15/07/2004

Updated articles of association

15/07/2004

Appointment/resignation of company officers

16/01/2004

Amendment

16/01/2004

Minutes of Board meeting

16/01/2004

Private document

16/01/2004

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

16/01/2004

Updated articles of association

31/12/2003

New accounts available

29/07/2003

Private document

29/07/2003

New chairman (CEO, CoB)

29/07/2003

Minutes of general meeting of shareholders

29/07/2003

Changes to the Board of Directors

29/07/2003

Appointment/resignation of company officers

29/07/2003

Amendment

29/07/2003

Minutes of Board meeting

25/04/2003

Minutes of Board meeting

25/04/2003

Changes to the Board of Directors

25/04/2003

Private document

25/04/2003

Appointment/resignation of company officers

25/04/2003

Amendment

12/08/2002

Amendment

12/08/2002

Appointment/resignation of company officers

12/08/2002

Changes to the Board of Directors

12/08/2002

Minutes of Board meeting

12/08/2002

Minutes of general meeting of shareholders

12/08/2002

Updated articles of association

12/08/2002

Private document

21/08/2001

Capital increase

21/08/2001

Changes to the Board of Directors

21/08/2001

Conversion of equity to euro

21/08/2001

Private document

21/08/2001

Updated articles of association

21/08/2001

Minutes of general meeting of shareholders

21/03/2001

Changes to the Board of Directors

21/03/2001

Minutes of general meeting of shareholders

21/03/2001

Private document

21/03/2001

Appointment/resignation of company officers

21/03/2001

Updated articles of association

29/08/2000

Appointment/resignation of company officers

29/08/2000

Changes to the Board of Directors

29/08/2000

Minutes of general meeting of shareholders

29/08/2000

Private document

02/09/1999

Changes to the Board of Directors

02/09/1999

Appointment/resignation of company officers

02/09/1999

Private document

02/09/1999

New auditor

02/09/1999

Minutes of general meeting of shareholders

31/03/1999

Appointment/resignation of company officers

31/03/1999

Changes to the Board of Directors

31/03/1999

Minutes of Board meeting

31/03/1999

Private document

31/03/1999

Amendment

05/10/1998

Minutes of general meeting of shareholders

05/10/1998

Changes to the Board of Directors

05/10/1998

Appointment/resignation of company officers

05/10/1998

Private document

01/10/1997

Private document

01/10/1997

Minutes of general meeting of shareholders

01/10/1997

Appointment/resignation of company officers

01/10/1997

Changes to the Board of Directors

12/08/1996

Minutes of general meeting of shareholders

12/08/1996

Change to corporate purpose

12/08/1996

Amendment

12/08/1996

Updated articles of association

16/10/1995

Updated articles of association

16/10/1995

Appointment/resignation of company officers

16/10/1995

Changes to the Board of Directors

16/10/1995

Amendment

16/10/1995

Minutes of general meeting of shareholders

04/04/1995

Appointment/resignation of company officers

04/04/1995

Changes to the Board of Directors

04/04/1995

Minutes of general meeting of shareholders

04/04/1995

Amendment

22/08/1994

Amendment

22/08/1994

Minutes of Board meeting

03/08/1992

Minutes of general meeting of shareholders

03/08/1992

Changes to the Board of Directors

03/08/1992

Appointment/resignation of company officers

03/08/1992

Amendment

 

 

Establishment events history

 

Date

Description

10/09/2017

Update of phone numbers

30/06/2017

Update of Establishment Address

30/06/2017

Modification of Head office

26/03/2017

Update of phone numbers

01/08/2014

Modification of Head office

23/02/2014

Update of phone numbers

28/03/2012

Formation of Head office (after transfer)

 

 

Synthesized Accounts

 

Annual Accounts

 

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Account period (month)

12

12

12

Account Type

Normal

Normal

Normal

Date of capture

17/07/2017

13/03/2017

28/12/2015

Activity Code

4619A

4619A

4619A

Employees

823

779

755

 

 

 

 

Active account

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

SECTOR MEDIAN 2016

Capital not called

0

0%

1,000

-66.7%

3,000

0

0%

Total fixed assets

22,274,000

-1.8%

22,691,000

1.3%

22,396,000

37,777

58861.8%

 Intangible assets

5,232,000

14.6%

4,565,000

14.4%

3,989,000

95

5507268.4%

 Tangible assets

11,799,000

-8.3%

12,871,000

-9.5%

14,229,000

8,552

137867.7%

 Financial assets

5,243,000

-0.2%

5,254,000

25.8%

4,178,000

4,000

130975.0%

Net current assets

871,114,000

18.9%

732,403,000

3.0%

711,066,000

845,165

102970.3%

 Stocks

99,258,000

9.1%

90,947,000

10.5%

82,284,000

0

0%

 Advanced payments

0

0%

0

0%

0

0

0%

 Receivables

713,862,000

19.9%

595,188,000

-4.9%

625,861,000

444,746

160410.0%

 Securities and cash

57,994,000

25.3%

46,268,000

1484.0%

2,921,000

81,575

70992.9%

 Prepaid expenses

-

-

-

-

-

0

-

Accounts of regularization

454,000

57.1%

289,000

-22.3%

372,000

0

0%

Total Assets

893,843,000

18.3%

755,383,000

2.9%

733,837,000

959,884

93019.9%

 

 

Passive Account

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

SECTOR MEDIAN 2016

Shareholders' equity

1,982,000

-79.1%

9,464,000

1.7%

9,310,000

241,846

719.5%

Share capital

87,000

1.2%

86,000

0%

86,000

50,000

74.0%

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

88,288,000

938.8%

8,499,000

28.9%

6,593,000

0

0%

Liabilities

803,255,000

8.9%

737,289,000

2.7%

717,823,000

517,571

155097.1%

 Financial liabilities

90,181,000

0%

90,181,000

24.4%

72,492,000

22,891

393858.3%

 Advanced payments received

0

0%

0

0%

0

0

0%

 Trade account payables

429,001,000

11.5%

384,666,000

0.8%

381,595,000

166,918

256913.0%

 Tax and social liabilities

49,878,000

-13.9%

57,898,000

9.7%

52,795,000

102,464

48578.8%

 Other debts and fixed assets liabilities

232,254,000

13.5%

204,676,000

-3.0%

211,052,000

21,712

1069603.4%

Account regularization

2,259,000

0%

0

0%

0

0

0%

Total liabilities

893,843,000

18.3%

755,384,000

2.9%

733,837,000

959,884

93019.9%

 

 

Results

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

SECTOR MEDIAN 2016

Sales of Goods

856,557,000

8.8%

787,106,000

4.3%

755,008,000

1,118,309

76493.9%

Net turnover

829,919,000

6.5%

779,327,000

4.0%

749,319,000

1,002,882

82653.4%

 of which net export turnover

0

0%

0

0%

0

0

0%

Operating charges

856,526,000

9.2%

784,640,000

3.7%

756,469,000

1,144,230

74756.1%

Operating profit/loss

31,000

-98.7%

2,466,000

268.8%

-1,461,000

20,131

54.0%

Financial income

1,605,000

-35.5%

2,489,000

54.3%

1,613,000

748

214472.2%

Financial charges

1,496,000

-53.0%

3,183,000

393.5%

645,000

428

349432.7%

Financial profit/loss

109,000

115.7%

-694,000

-171.7%

968,000

0

0%

Pretax net operating income

140,000

-92.1%

1,772,000

459.4%

-493,000

23,511

495.5%

Extraordinary income

76,898,000

22517.1%

340,000

359.5%

74,000

115

66867726.1%

Extraordinary charges

83,751,000

30466.1%

274,000

-40.8%

463,000

750

11166700.0%

Extraordinary profit/loss

-6,853,000

-10483.3%

66,000

117.0%

-389,000

0

0%

Net result

-7,483,000

-4959.1%

154,000

-76.3%

650,000

23,636

-31759.3%

 

 

Accounts – Active

 

Normal Account

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Months

12

12

12

 

Grand Total - Active Accounts (I to VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Grand Total (I to VI)

Net

893,843,000

18.3%

755,383,000

2.9%

733,837,000

Gross

CO

917,347,000

18.8%

772,123,000

3.0%

749,604,000

Amortisation

1A

23,504,000

40.4%

16,740,000

6.2%

15,767,000

 

 

Non declared distributed capital (I)

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

1,000

-66.7%

3,000

Gross

AA

1,000

0%

1,000

-66.7%

3,000

 

 

Active fixed asset (II)

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total Active fixed asset (II)

Net

22,274,000

-1.8%

22,691,000

1.3%

22,396,000

Gross

BJ

35,718,000

4.4%

34,198,000

7.2%

31,913,000

Amortisation

BK

13,444,000

16.8%

11,507,000

20.9%

9,517,000

 

 

Intangible fixed assets

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R&D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CQ

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

3,027,000

9.9%

2,754,000

0%

0

Gross

AF

6,187,000

13.7%

5,442,000

0%

0

Amortisation

AG

3,160,000

17.6%

2,688,000

0%

0

Goodwill

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AH

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AI

0

0%

0

0%

0

Other intangible fixed assets

Net

98,000

21.0%

81,000

-98.0%

3,989,000

Gross

AJ

1,776,000

3.1%

1,722,000

-77.7%

7,714,000

Amortisation

AK

1,678,000

2.3%

1,641,000

-55.9%

3,725,000

Pre-payments and downpayments

Net

2,107,000

21.8%

1,730,000

0%

0

Gross

AL

2,107,000

21.8%

1,730,000

0%

0

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible asset

Net

5,232,000

14.6%

4,565,000

14.4%

3,989,000

 

 

Tangible fixed assets

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Lands

Net

625,000

0%

625,000

0%

625,000

Gross

AN

625,000

0%

625,000

0%

625,000

Amortisation

AO

0

0%

0

0%

0

Buildings

Net

5,477,000

-9.4%

6,048,000

-8.6%

6,620,000

Gross

AP

9,664,000

0%

9,664,000

0%

9,664,000

Amortisation

AQ

4,187,000

15.8%

3,616,000

18.8%

3,044,000

Plant

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AR

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AS

0

0%

0

0%

0

Other tangible fixed assets

Net

5,697,000

-8.1%

6,198,000

-11.3%

6,984,000

Gross

AT

10,110,000

3.6%

9,760,000

0.3%

9,732,000

Amortisation

AU

4,413,000

23.9%

3,562,000

29.6%

2,748,000

Fixed assets in construction

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AV

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AX

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

Sub Total Tangible asset

Net

11,799,000

-8.3%

12,871,000

-9.5%

14,229,000

 

 

Financial assets

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

3,799,000

-0.1%

3,804,000

77.3%

2,146,000

Gross

CU

3,805,000

0.0%

3,804,000

77.3%

2,146,000

Amortisation

CV

6,000

0%

0

0%

0

Inter-company receivables

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BC

0

0%

0

0%

0

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

Loans

Net

0

0%

0

0%

827,000

Gross

BF

0

0%

0

0%

827,000

Amortisation

BG

0

0%

0

0%

0

Other financial assets

Net

1,444,000

-0.4%

1,450,000

20.3%

1,205,000

Gross

BH

1,444,000

-0.4%

1,450,000

20.3%

1,205,000

Amortisation

BI

0

0%

0

0%

0

Sub Total Financial assets

Net

5,243,000

-0.2%

5,254,000

25.8%

4,178,000

 

 

Current Assets (III)

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total Current Assets

Net

871,114,000

18.9%

732,403,000

3.0%

711,066,000

Gross

CJ

881,174,000

19.5%

737,636,000

2.8%

717,316,000

Amortisation

CK

10,060,000

92.2%

5,233,000

-16.3%

6,250,000

 

 

Stocks

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Raw materials

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BL

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BM

0

0%

0

0%

0

Work in progress (goods)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BN

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BR

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BS

0

0%

0

0%

0

Goods for resale

Net

99,258,000

9.1%

90,947,000

10.5%

82,284,000

Gross

BT

102,267,000

9.4%

93,467,000

6.0%

88,216,000

Amortisation

BU

3,009,000

19.4%

2,520,000

-57.5%

5,932,000

Sub Total Stocks

Net

99,258,000

9.1%

90,947,000

10.5%

82,284,000

 

 

Advance payments to suppliers

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Advance payments to suppliers

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BV

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0

 

 

Debtors

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Trade accounts receivable

Net

184,082,000

0.7%

182,879,000

0.4%

182,060,000

Gross

BX

184,333,000

-0.7%

185,592,000

1.8%

182,378,000

Amortisation

BY

251,000

-90.7%

2,713,000

753.1%

318,000

Other debtors

Net

524,669,000

28.1%

409,733,000

-7.0%

440,420,000

Gross

BZ

531,469,000

29.7%

409,733,000

-7.0%

440,420,000

Amortisation

CA

6,800,000

0%

0

0%

0

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

Sub Total debtors

Net

708,751,000

19.6%

592,612,000

-4.8%

622,480,000

 

 

Divers

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Investment securities

Net

10,000,000

-21.3%

12,713,000

0%

0

Gross

CD

10,000,000

-21.3%

12,713,000

0%

0

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

47,994,000

43.0%

33,555,000

1048.8%

2,921,000

Gross

CF

47,994,000

43.0%

33,555,000

1048.8%

2,921,000

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

Sub Total Divers

Net

57,994,000

25.3%

46,268,000

1484.0%

2,921,000

 

 

Prepaid expenses

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Prepaid expenses

Net

5,111,000

98.4%

2,576,000

-23.8%

3,381,000

Gross

CH

5,111,000

98.4%

2,576,000

-23.8%

3,381,000

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

 

Equalization accounts (IV to VI)

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Expenses of loan issue to be spread

CW3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Currency differential gain

CN3

454,000

57.1%

289,000

-22.3%

372,000

Gross

454,000

57.1%

289,000

-22.3%

372,000

References

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

 

Accounts – Passive

 

Grand Total - Passive Accounts (I to V)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Grand Total (I to V)

EE

893,843,000

18.3%

755,384,000

2.9%

733,837,000

 

 

Shareholder Equity (I)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total shareholders' equity (Total I)

DL

1,982,000

-79.1%

9,464,000

1.7%

9,310,000

Equity and shareholders' equity

DA

87,000

1.2%

86,000

0%

86,000

Issue and merger premiums

DB

0

0%

0

0%

0

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

Legal reserve

DD

11,000

0%

11,000

0%

11,000

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

Other reserves

DG

4,844,000

0%

4,844,000

0%

4,844,000

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

0%

0

0%

0

Profits or losses brought forward

DH

4,523,000

3.5%

4,369,000

17.5%

3,719,000

Profit or loss for the period

DI

-7,483,000

-4959.1%

154,000

-76.3%

650,000

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

Special tax-allowable reserves

DK

0

0%

0

0%

0

Other capital resources (II)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

Provisions for risks and charges (III)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

88,288,000

938.8%

8,499,000

28.9%

6,593,000

Risk provisions

DP

82,478,000

2267.3%

3,484,000

42.1%

2,452,000

Reserves for charges

DQ

5,810,000

15.9%

5,015,000

21.1%

4,141,000

Liabilities (IV)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total Liabilities (Total IV)

EC

803,255,000

8.9%

737,289,000

2.7%

717,823,000

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

Bank loans and liabilities

DU

90,181,000

0%

90,181,000

0%

0

Sundry loans and financial liabilities

DV

0

0%

0

0%

72,492,000

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

Advance payments received for current orders

DW

0

0%

0

0%

0

Trade accounts payables

DX

429,001,000

11.5%

384,666,000

0.8%

381,595,000

Tax and social security liabilities

DY

49,878,000

-13.9%

57,898,000

9.7%

52,795,000

Fixed asset liabilities

DZ

286,000

110.3%

136,000

183.3%

48,000

Other debts

EA

231,650,000

13.3%

204,408,000

-3.1%

210,893,000

Translation loss (V)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Translation loss (Total V)

ED

318,000

140.9%

132,000

18.9%

111,000

Equalization accounts

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Deferred income

EB

2,259,000

0%

0

0%

0

References

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

Result account

1 - Operating result (I-II)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Operating result (Total I-II)

GG

31,000

-98.7%

2,466,000

268.8%

-1,461,000

2 - Financial result (V-VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Financial result (Total V-VI)

GV

109,000

115.7%

-694,000

-171.7%

968,000

3 - Pre-tax net operating income result (I to VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

140,000

-92.1%

1,772,000

459.4%

-493,000

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

-6,853,000

-10483.3%

66,000

117.0%

-389,000

Profit or loss

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Profit or loss

HN

-7,483,000

-4959.1%

154,000

-76.3%

650,000

Total Income (I+III+V+VII)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total Income (Total I+III+V+VII)

HL

935,060,000

18.4%

789,935,000

4.4%

756,695,000

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

942,543,000

19.3%

789,776,000

4.5%

756,042,000

Operating income (I)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total operating income (Total I)

FR

856,557,000

8.8%

787,106,000

4.3%

755,008,000

Operating income (details)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Sale of goods for resale

FC

573,460,000

6.9%

536,202,000

3.9%

516,023,000

France

FA

573,460,000

6.9%

536,202,000

3.9%

516,023,000

Export

FB

0

0%

0

0%

0

Sale of goods produced

FF

0

0%

34,427,000

0%

0

France

FD

0

0%

34,427,000

0%

0

Export

FE

0

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

256,459,000

22.9%

208,698,000

-10.5%

233,296,000

France

FG

256,459,000

22.9%

208,698,000

-10.5%

233,296,000

Export

FH

0

0%

0

0%

0

Net turnover

FL

829,919,000

6.5%

779,327,000

4.0%

749,319,000

France

FJ

829,919,000

6.5%

779,327,000

4.0%

749,319,000

Export

FK

0

0%

0

0%

0

Stocked production

FM

0

0%

0

0%

0

Self-constructed assets

FN

0

0%

0

0%

0

Operating grants

FO

0

0%

0

0%

0

Release of reserves and provisions

FP

6,295,000

-7.6%

6,810,000

20.5%

5,653,000

Other income

FQ

20,339,000

1999.0%

969,000

2591.7%

36,000

Operating charges (II)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total operating charges (Total II)

GF

856,526,000

9.2%

784,640,000

3.7%

756,469,000

Exploitation charges

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Purchase of goods for resale

FS

596,717,000

8.9%

548,011,000

3.1%

531,452,000

Change in stocks of goods for resale

FT

-8,800,000

-67.6%

-5,250,000

32.6%

-7,792,000

Purchase of raw materials

FU

0

0%

0

0%

0

Change in stocks of raw materials

FV

0

0%

0

0%

0

Other external purchases and charges

FW

184,289,000

12.7%

163,549,000

4.6%

156,413,000

Tax, duty and similar payments

FX

5,788,000

-4.4%

6,052,000

8.8%

5,561,000

Payroll

FY

41,120,000

5.8%

38,862,000

1.2%

38,407,000

Social security costs

FZ

21,879,000

9.8%

19,921,000

-0.2%

19,968,000

Depreciation

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Depreciation of fixed assets

GA

2,469,000

9.9%

2,247,000

-11.2%

2,530,000

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

0

Depreciation/amortisation of current assets

GC

3,260,000

-36.3%

5,114,000

-22.3%

6,581,000

Provisions for risks and charges

GD

3,491,000

26.6%

2,758,000

6314.0%

43,000

Other charges

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Other charges

GE

6,313,000

87.0%

3,376,000

2.1%

3,306,000

Operating charges (III-IV)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

Financial income (V)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total financial income (Total V)

GP

1,605,000

-35.5%

2,489,000

54.3%

1,613,000

Share financial income

GJ

0

0%

0

0%

0

Other investment income & capitalised receivables

GK

0

0%

30,000

0%

0

Other interest and similar income

GL

1,307,000

-18.4%

1,602,000

70.4%

940,000

Released provisions and transferred charges

GM

289,000

-22.1%

371,000

24.9%

297,000

Exchange gains

GN

0

0%

461,000

22.6%

376,000

Net income from disposal of investment securities

GO

9,000

-64.0%

25,000

0%

0

Financial charge (VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total financial charge (Total VI)

GU

1,496,000

-53.0%

3,183,000

393.5%

645,000

Financial reserves and provisions

GQ

542,000

87.5%

289,000

-22.1%

371,000

Interest and similar charges

GR

954,000

7.3%

889,000

438.8%

165,000

Exchange losses

GS

0

0%

2,005,000

1739.4%

109,000

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

Extraordinary income (VII)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total extraordinary income (Total VII)

HD

76,898,000

22517.1%

340,000

359.5%

74,000

Extraordinary operating income

HA

76,898,000

512553.3%

15,000

-75.4%

61,000

Extraordinary income from capital transactions

HB

0

0%

10,000

-23.1%

13,000

Released provisions and transferred charges

HC

0

0%

315,000

0%

0

Extraordinary charges (VIII)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

83,751,000

30466.1%

274,000

-40.8%

463,000

Extraordinary operating charges

HE

75,000

-72.6%

274,000

83.9%

149,000

Extraordinary charges from capital transactions

HF

5,000

0%

5,000

0%

0

Extraordinary reserves and provisions

HG

83,671,000

0%

0

0%

314,000

Employee profit sharing (IX)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

0

0%

682,000

0%

0

Tax on profits (X)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Tax on profits (Total X)

HK

770,000

-22.8%

997,000

165.0%

-1,535,000

References

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

Of which transferred charges

A1

0

0%

0

0%

0

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

Other incomes tax return forms

Fixed Assets

Grand Total Fixed Assets (I to IV)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

OK2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

OL

0

0%

0

0%

0

Research and development Charge (Total I)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

CO1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

CO2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

DO

0

0%

0

0%

0

Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Gross value at begin of period

KD

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

LV2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

LW

0

0%

0

0%

0

Tangible fixed assets (Total III)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Gross value at begin of period

LN

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NG2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

NH

0

0%

0

0%

0

Financial assets (Total IV)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Gross value at begin of period

LQ

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NJ2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

NK

0

0%

0

0%

0

 

 

Reserve for depreciation

 

Situation and movement of reserve for depreciation - Grand total (I-II-III)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Reserve for depreciation value at begin of period

ON

0

0%

0

0%

0

Increases

OP

0

0%

0

0%

0

Decreasess

OQ

0

0%

0

0%

0

Reserve for depreciation value at the end of period

OR

0

0%

0

0%

0

Research and development charge (Total I)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0

Other intangible assets (Total II)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

0

0%

0

0%

0

Increases

PF

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PG

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

PH

0

0%

0

0%

0

Total fixed assets amotisation (Total III)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

0

0%

0

0%

0

Increases

QV

0

0%

0

0%

0

Decreases

QW

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

QX

0

0%

0

0%

0

Movements during period affecting charge allocated over several period

Deferred charges and debt issuance costs

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0

Premium refund of obligations

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Net value at begin of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

Provisions included in balance sheet

Grand Total (I-II-III)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Value at begining of period

7C

0

0%

0

0%

0

Increases

UB

0

0%

0

0%

0

Decreases

UC

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

UD

0

0%

0

0%

0

Includes Total allocations

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Operating

UE

0

0%

0

0%

0

Financial

UG

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UJ

0

0%

0

0%

0

Includes Total Withdrawal

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Operating

UF

0

0%

0

0%

0

Financial

UH

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UK

0

0%

0

0%

0

Total regulated provisions (Total I)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Value at begining of period

3Z

0

0%

0

0%

0

Increases

TS

0

0%

0

0%

0

Decreases

TT

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

TU

0

0%

0

0%

0

Total risk and charge provisions (Total II)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Value at begining of period

5Z

0

0%

0

0%

0

Increases

TV

0

0%

0

0%

0

Decreases

TW

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

TX

0

0%

0

0%

0

Total Provision for depreciation (Total III)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Value at begining of period

7B

0

0%

0

0%

0

Increases

TY

0

0%

0

0%

0

Decreases

TZ

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

UA

0

0%

0

0%

0

State deadlines claims and debts at the end of period

State claims

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Gross value

VT

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VU

0

0%

0

0%

0

More than one year

VV

0

0%

0

0%

0

State of loans

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Claims related to holdings (gross)

UL

0

0%

0

0%

0

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

0%

0

0%

0

Loans (gross)

UP

0

0%

0

0%

0

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

0

0%

0

Other financial assets (gross)

UT

0

0%

0

0%

0

Other financial assets (1 year at most)

UV

0

0%

0

0%

0

Receivables statement of assets

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Customers doubtful or disputed

VA

0

0%

0

0%

0

Other claims customer

UX

0

0%

0

0%

0

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts

UY

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

0

0%

0

Income taxes

VM

0

0%

0

0%

0

Value added tax

VB

0

0%

0

0%

0

Other taxes and payments assimilated

VN

0

0%

0

0%

0

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

0

0%

0

Group and Associates

VC

0

0%

0

0%

0

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

0

0%

0

0%

0

Prepaid

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Prepaid

VS

0

0%

0

0%

0

State Debt

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total debt (gross)

VY

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

VZ4

0

0%

0

0%

0

Details

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VG2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VH2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8A2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8A3

0

0%

0

0%

0

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8B2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8B3

0

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8C2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8D2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (Gross)

VW1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VW2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VQ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8J2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VI2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

V14

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8K2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8L2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0

References

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Loans made during the period

VJ

0

0%

0

0%

0

Debt repaid during the period

VK

0

0%

0

0%

0

Table allocation results and other information

Dividends distributed

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0

Commitments

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0

Other charges Externes

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0

Taxes and Fees

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0

VAT

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0

Average number of employees

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Average number of employees

YP

823

5.6%

779

3.2%

755

Groups and Shareholders

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Groups and Shareholders

ZR

0

-

-

-

-

Ratios

Synthetic financial performance indicators

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Score

Situation

Score

Situation

Score

Situation

HideAFDCC 2

-

-

-

-

-

-

Description

The AFDCC 2 score uses sectors of activity and company sizes for companies with a turnover of 150 000 to 75 million euros. This calculation allows a classification of the companies in three levels:

-

Healthy: the higher the score value is, the more the company is healthy.

-

Undetermined: it’s impossible to determine the situation.

-

Fragility/Failure: the lower the score value is, the more the company is in danger.

The status are completed which “+/-“ signs.

HideConan & Holder

-0.07

90%

-0.05

80%

-0.06

90%

Description

The Conan and Holder (1979) is a recommended method for industrial companies with a turnover of 150 000 to 75 million euros. It is based only on a balance sheet. This calculation allows a classification of the most perilous situation (Score lower than 0.002) to the healthiest situation (score greater than 0.16):

-

Healthy situation: companies which maintain or develop their activity level.

-

Situation to monitor: companies which has to follow remedial measures or find a new strategy.

-

Perilous situation: companies which could have important cash difficulties and have a failure risk.

HideAltman

-

-

-

-

-

-

Description

The Altman score is a method based only on a complete balance sheet, this calculation allows a classification of the companies in three levels:

-

Good shape: companies which have a low risk (with a score value higher than 2.99).

-

Warning signs: companies which should be approached with caution and with a high risk in the next two years for bankruptcy (with a score value between 2.99 and 1.81).

-

Bankruptcy: companies which are in immediate risk (with a score value lower than 1.81).

Structure and Liquidity

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

SECTOR MEDIAN 2016

Fixed Asset Financing

5.43

55.1%

3.50

14.0%

3.07

3.25

67.1%

Global Debt

348 days

2.1%

341 days

-1.2%

345 days

156 days

123.1%

Working Capital Fund overall net

69 days

76.9%

39 days

21.9%

32 days

84 days

-17.9%

Financial independence

2.20 %

-79.0%

10.49 %

-18.3%

12.84 %

287.13 %

-99.2%

Solvability

0.22 %

-82.4%

1.25 %

-1.6%

1.27 %

34.13 %

-99.4%

Capacity debt futures

-

-

-

-

-

2,134.29 %

-

Coverage of current assets by net working capital overall

17.85 %

56.2%

11.43 %

23.7%

9.24 %

40.24 %

-55.6%

General Liquidity

-

-

-

-

-

0.90

-

Restricted Liquidity

-

-

-

-

-

1.25

-

Management or rotation

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

SECTOR MEDIAN 2016

Need background in operating working capital

-85 days

-9.0%

-78 days

4.9%

-82 days

23 days

-477.8%

Treasury

25 days

19.0%

21 days

2000.0%

1 days

21 days

19.0%

Inventory turnover of goods

63 days

1.6%

62 days

1.6%

61 days

21 days

200.0%

Average length of credit granted to customers

80 days

-7.0%

86 days

-2.3%

88 days

80 days

0%

Average length of credit obtained suppliers

200 days

2.0%

196 days

-3.0%

202 days

64 days

212.5%

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

-

-

-

-

-

0 days

-

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

-

-

-

-

-

2,645 days

-

Rotation tangible assets

-

-

-

-

-

2,222.49 %

-

Profitability of the business

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

SECTOR MEDIAN 2016

Margin trading

-1.74 %

-107.1%

-0.84 %

17.6%

-1.02 %

0.80 %

-317.5%

Profitability of the business

-1.33 %

-226.7%

1.05 %

47.9%

0.71 %

2.37 %

-156.1%

Net profit

-0.90 %

-4600.0%

0.02 %

-77.8%

0.09 %

1.81 %

-149.7%

Growth rate of turnover (excluding VAT)

6.49 %

62.3%

4.00 %

191.7%

-4.36 %

0.64 %

914.1%

Rates integration

6.95 %

-25.8%

9.37 %

1.4%

9.24 %

18.52 %

-62.5%

Rate leasing furniture

0.00 %

0%

0.00 %

0%

0.00 %

0.00 %

0%

Work Factor

109.16 %

35.6%

80.51 %

-4.5%

84.30 %

61.37 %

77.9%

Weight interests

0.18 %

-56.1%

0.41 %

355.6%

0.09 %

0.05 %

260.0%

Return on capital

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

SECTOR MEDIAN 2016

Cash flow from the overall profitability

9.54 %

2705.9%

0.34 %

-33.3%

0.51 %

2.81 %

239.5%

Rates of economic profitability

-12.00 %

-250.0%

8.00 %

33.3%

6.00 %

8.00 %

-250.0%

Financial profitability

1,982,000.00 %

-79.1%

9,463,000.00 %

1.7%

9,307,000.00 %

221,352.00 %

795.4%

Return on investment

-6.50 %

-294.0%

3.35 %

112.0%

1.58 %

8.81 %

-173.8%

Management intermediate balances

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

SECTOR MEDIAN 2016

Turnover

829,919,000

6.5%

779,327,000

4.0%

749,319,000

1,002,882

82653.4%

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

SECTOR MEDIAN 2016

Sales of goods

573,460,000

6.9%

536,202,000

3.9%

516,023,000

-

- Purchase of goods

596,717,000

8.9%

548,011,000

3.1%

531,452,000

-

+/- Stock of goods variation

-8,800,000

-67.6%

-5,250,000

32.6%

-7,792,000

-

Trading margin

-14,457,000 €

-120.4%

-6,559,000 €

14.1%

-7,637,000 €

2,994 €

-482965.7%

-1.74 % CA

-107.1%

-0.84 % CA

17.6%

-1.02 % CA

1.75 % CA

-199.4%

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

SECTOR MEDIAN 2016

Sale of goods produced

256,459,000

5.5%

243,125,000

4.2%

233,296,000

-

+/- Stocked production

0

0%

0

0%

0

-

+ Self-constructed assets

0

0%

0

0%

0

-

Period production

256,459,000 €

5.5%

243,125,000 €

4.2%

233,296,000 €

289,898 €

88365.3%

30.90 % CA

-1.0%

31.20 % CA

0.2%

31.13 % CA

60.54 % CA

-49.0%

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

SECTOR MEDIAN 2016

Trading margin

-14,457,000

-120.4%

-6,559,000

14.1%

-7,637,000

2,994

-482965.7%

+ Period Production

256,459,000

5.5%

243,125,000

4.2%

233,296,000

289,898

88365.3%

- Purchase of raw materials

0

0%

0

0%

0

-

+/- Change in stocks of raw materiels

0

0%

0

0%

0

-

- Other external purchases and charges

184,289,000

12.7%

163,549,000

4.6%

156,413,000

-

Added value

57,713,000 €

-21.0%

73,017,000 €

5.4%

69,246,000 €

204,214 €

28161.0%

6.95 % CA

-25.8%

9.37 % CA

1.4%

9.24 % CA

18.52 % CA

-62.5%

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

SECTOR MEDIAN 2016

Added value

57,713,000 €

-21.0%

73,017,000 €

5.4%

69,246,000 €

204,214 €

28161.0%

+ Operating grants

0

0%

0

0%

0

-

- Tax, duty and similar payments

5,788,000

-4.4%

6,052,000

8.8%

5,561,000

-

- Personal charges

62,999,000

7.2%

58,783,000

0.7%

58,375,000

-

Gross operating surplus

-11,074,000 €

-235.3%

8,182,000 €

54.1%

5,310,000 €

21,655 €

-51238.3%

-1.33 % CA

-226.7%

1.05 % CA

47.9%

0.71 % CA

2.37 % CA

-156.1%

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

SECTOR MEDIAN 2016

Gross operating surplus

-11,074,000 €

-235.3%

8,182,000 €

54.1%

5,310,000 €

21,655 €

-51238.3%

+ Release of reserves and provisions

6,295,000

-7.6%

6,810,000

20.5%

5,653,000

-

+ Other operating income

20,339,000

1999.0%

969,000

2591.7%

36,000

-

- Depreciation/ Amortisation

9,220,000

-8.9%

10,119,000

10.5%

9,154,000

-

- Other charges

6,313,000

87.0%

3,376,000

2.1%

3,306,000

-

Operating result

27,000 €

-98.9%

2,466,000 €

268.8%

-1,461,000 €

20,131 €

34.1%

0.00 % CA

0%

0.32 % CA

268.4%

-0.19 % CA

2.04 % CA

0%

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

SECTOR MEDIAN 2016

 

Operating result

27,000 €

-98.9%

2,466,000 €

268.8%

-1,461,000 €

20,131 €

34.1%

 

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

-

 

+ Financial income

1,605,000

-35.5%

2,489,000

54.3%

1,613,000

-

 

- Financial charges

1,496,000

-53.0%

3,183,000

393.5%

645,000

-

 

Pre-tax result

136,000 €

-92.3%

1,772,000 €

459.4%

-493,000 €

23,512 €

478.4%

 

0.02 % CA

-91.3%

0.23 % CA

428.6%

-0.07 % CA

2.48 % CA

-99.2%

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

SECTOR MEDIAN 2016

Extraordinary income

76,898,000

22517.1%

340,000

359.5%

74,000

115

66867726.1%

- Extraordinary charges

83,751,000

30466.1%

274,000

-40.8%

463,000

-

Extraordinary result

-6,853,000 €

-10483.3%

66,000 €

117.0%

-389,000 €

0 €

0%

-0.83 % CA

-8400.0%

0.01 % CA

120.0%

-0.05 % CA

0.00 % CA

0%

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

SECTOR MEDIAN 2016

Pre-tax result

136,000 €

-92.3%

1,772,000 €

459.4%

-493,000 €

23,512 €

478.4%

Extraordinary result

-6,853,000 €

-10483.3%

66,000 €

117.0%

-389,000 €

0 €

0%

- Employee profit sharing

0

0%

682,000

0%

0

-

- Tax on profits

770,000

-22.8%

997,000

165.0%

-1,535,000

-

Net result

-7,487,000 €

-4808.8%

159,000 €

-75.7%

653,000 €

23,636 €

-31776.3%

-0.90 % CA

-4600.0%

0.02 % CA

-77.8%

0.09 % CA

1.81 % CA

-149.7%

Key Performance Indicators

 

Find below a comparison of the company based on the industry code (primary) with other companies from the same industry. The following analysis has been based on the industry code 4619A - Non food buying groups.

Graphical analysis

Net TurnoverCompany ResultSector Average31/12/201631/12/201531/12/20140M250M500M750M1,000M

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Company Result

829,919,000 €

779,327,000 €

749,319,000 €

Sector Average

34,872,502 €

35,645,432 €

31,640,631 €

 

Net ProfitCompany ResultSector Average31/12/201631/12/201531/12/2014-10M-5M0M5M

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Company Result

-7,483,000 €

154,000 €

650,000 €

Sector Average

327,601 €

312,184 €

274,263 €

Net Export TurnoverCompany ResultSector Average31/12/201631/12/201531/12/20140M1M2M3M4M

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Company Result

0 €

0 €

0 €

Sector Average

1,439,699 €

3,047,369 €

2,919,452 €

 

Account TotalCompany ResultSector Average31/12/201631/12/201531/12/20140M500M1,000M

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Company Result

893,843,000 €

755,384,000 €

733,837,000 €

Sector Average

25,098,359 €

22,396,759 €

19,947,704 €

Shareholders EquityCompany ResultSector Average31/12/201631/12/201531/12/20140M5M10M

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Company Result

1,982,000 €

9,464,000 €

9,310,000 €

Sector Average

5,814,581 €

5,667,380 €

5,262,072 €

 

LiabilitiesCompany ResultSector Average31/12/201631/12/201531/12/20140M250M500M750M1,000M

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Company Result

803,255,000 €

737,289,000 €

717,823,000 €

Sector Average

18,522,228 €

16,319,818 €

14,383,047 €

Need background in operating working capitalCompany ResultSector Average31/12/201631/12/201531/12/2014-100k-50k0k

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Company Result

-85 €

-78 €

-82 €

Sector Average

-90,693 €

-1,350 €

-64 €

 

Gross operating surplus (EBE)Company ResultSector Average31/12/201631/12/201531/12/2014-10M0M10M-20M

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Company Result

-11,074,000 €

8,182,000 €

5,310,000 €

Sector Average

704,402 €

850,671 €

518,002 €

This document is for internal use only. The transmission of it by whatever means to any third party is in breach of the terms and conditions of your contract. Any client who does forward the document is responsible for any use or actions taken by any third party as a result of the information supplied.


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

INR 63.68

UK Pound

1

INR 90.35

Euro

1

INR 79.21

EURO

1

INR 79.02

 

Note : Above are approximate rates obtained from sources believed to be correct

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

PRI

 

 

Report Prepared by :

DNS

 


 

RATING EXPLANATIONS

 

Credit Rating

Explanation

Rating Comments

A++

Minimum Risk

Business dealings permissible with minimum risk of default

A+

Low Risk

Business dealings permissible with low risk of default

A

Acceptable Risk

Business dealings permissible with moderate risk of default

B

Medium Risk

Business dealings permissible on a regular monitoring basis

C

Medium High Risk

Business dealings permissible preferably on secured basis

D

High Risk

Business dealing not recommended or on secured terms only

NB

New Business

No recommendation can be done due to business in infancy stage

NT

No Trace

No recommendation can be done as the business is not traceable

 

NB is stated where there is insufficient information to facilitate rating. However, it is not to be considered as unfavourable.

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors are as follows:

 

·         Financial condition covering various ratios

·         Company background and operations size

·         Promoters / Management background

·         Payment record

·         Litigation against the subject

·         Industry scenario / competitor analysis

·         Supplier / Customer / Banker review (wherever available)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.