MIPL-Logo

3decades

 

MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

487462

Report Date :

22.01.2018

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

INTERSPORT FRANCE

 

 

Registered Office :

Intersport France, Inter Sport, 2 Rue Victor Hugo, 91164 Longjumeau Cedex

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2016

 

 

Date of Incorporation :

January 1964

 

 

Legal Form :

Public limited company with board of directors

 

 

Line of Business :

Non-Food Purchasing Centers

 

 

No. of Employees :

250 to 499

 

 

RATING & COMMENTS

(Mira Inform has adopted New Rating mechanism w.e.f. 23rd January 2017)

 

MIRA’s Rating :

A

 

Credit Rating

Explanation

Rating Comments

A

Acceptable Risk

Business dealings permissible with moderate risk of default

 

Status :

Good

 

 

Payment Behaviour :

Regular

 

 

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List

 

Country Name

Previous Rating

(30.06.2017)

Current Rating

(30.09.2017)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low Risk

 

A2

Moderately Low Risk

 

B1

Moderate Risk

 

B2

Moderately High Risk

 

C1

High Risk

 

C2

Very High Risk

 

D

 


 

FRANCE - ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. Despite terrorist attacks, labor strikes, and bad weather, France is still the most visited country in the world with 83 million foreign tourists in 2016, including 530,000 who came for the 2016 Euro Cup. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that mitigate economic inequality.

France's real GDP grew by 1.6% in 2017, up from 1.2% the year before. The unemployment rate (including overseas territories) increased from 7.8% in 2008 to 10.2% in 2015, before falling to 9.5% in 2017. Youth unemployment in metropolitan France decreased from 24.6% in the fourth quarter of 2014 to 24% in the fourth quarter of 2016.

Lower-than-expected growth and high spending have strained France's public finances. Despite measures to restore public finances since President Francois HOLLANDE took office in 2012, the budget deficit rose from 3.3% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 3.1% of GDP in 2017. Meanwhile, France's public debt rose from 89.5% of GDP in 2012 to 96.1% in 2017.

President HOLLANDE’s policies aimed to enhance French industry’s competitiveness and to lower high jobless figures. The Competitiveness and Employment Tax Credit of 2012, the Responsibility and Solidarity Pact of 2014, the Investment Stimulus Plan, and the Emergency Jobs Plan represent more than $42.6 billion in support for businesses in 2017 by lowering French labor costs, but so far the results of these policies have been marginal on France’s competitiveness and job creation. In an effort to bolster social justice, the 2017 budget bill contained provisions to reduce income taxes for households and for small and medium sized enterprises.

During his mandate, President HOLLANDE oversaw two highly unpopular economic reforms that led to widespread protests. The “Macron Law” of 2015, enacted to boost economic growth, authorized businesses to open some Sundays of each month and allowed flexibility to negotiate pay and working hours. The “El Khomri law,” imposed by decree in 2016, aimed to make it easier for businesses to employ people and gave employers more leeway to negotiate hours, wages, and time off.

 

Source : CIA

 


Company name and summary

SIRET

964 201 123 00020

Name

INTERSPORT FRANCE

Acronym

-

Trade name

-

Status

Economically active

Postal Address

INTERSPORT FRANCE
INTER SPORT
2 RUE VICTOR HUGO
91164 LONGJUMEAU CEDEX
FRANCE

Share Capital

9,500,000 Euros

Telephone

01 69 10 82 00

Activity (APE)

Non-Food Purchasing Centers (4619A)

Formation Date

01/1964

Deregistration Date

-

Court Registry Number

19 6 4B00112

Registration Court

Evry (78)

Nationality

France

RCS Registration

RCS Evry B 964 201 123

EUR VAT Number

FR40964201123

Last account Date

31/12/2016

Incorporiation Date

06/1964

Fax

01 69 10 82 77

Legal form

Public limited company with board of directors

Currency

Euros

 

 

Key Financials

 

Year to date

Turnover

Gross operating surplus

Shareholder's equity

Net result

Employees

31/12/2016

1,020,353,406 €

0.58% Turnover

61,883,805 €

6,271,019 €

250 to 499 employees

31/12/2015

936,978,114 €

0.55% Turnover

53,027,605 €

3,483,814 €

247 employees

31/12/2005

509,529,464 €

-3.10% Turnover

25,181,645 €

1,418,600 €

211 employees

View details

 

Directors

Current Directors

13

View Details

 

 

Ultimate Holding Company

 

Name

Country

Company Number

INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORATION

-

Affiliation links. View Details

1 company in 1 country. View Details

 

 

Judgment and Preferential

Judgment

No judgement

View details

Preferential Right

No social security and tax office preferential right to date

View details

 

 

Establishment Details

 

Type of Establishment

Head Office

Production Role

-

APE/NAF Code

4649Z

Activity

Wholesale trade (B2B) of other household goods

Formation Date

01/1982

Reason for Formation

Formation

Closure Date

-

Reason for Closure

-

Reactivation Date

-

Seasonality

-

Activity Nature

-

Activity Location

Other

Trading Address

2 RUE VICTOR HUGO
91160 LONGJUMEAU

Department

Essonne (91)

Location Surface

-

District

3

City

LONGJUMEAU

Status

Economically active

Business Pages FT®

FABRICATION D'ARTICLES ET D'EQUIPEMENTS DE SPORTS ET LOISIRS

Region

Ile-de-France

Area

11

Size of Urban Area

Paris conglomeration

 

 

Other Establishment(s)

 

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas having at least 80% of workforce in same area

Mono-activity status

Legal unit having all establishments with the same main activity

Branches

3 branch entities in this company

 

Company Name

Company Type

APE/NAF Code

Activity

City

Post Code

INTERSPORT FRANCE

Head Office

4619A

Non-Food Purchasing Centers

LONGJUMEAU

91160

INTERSPORT FRANCE

Branch

4619A

Non-Food Purchasing Centers

SORGUES

84700

INTERSPORT FRANCE

Branch

4619A

Non-Food Purchasing Centers

MORANGIS

91420

 

 

Workforces

 

Workforce at address

250 to 499 employees

Company workforce

250 to 499 employees

 

 

Workforce account

Workforce unknown

 

 

31/12/2016

 

 

 

Commentary

 

The comments are ordered according to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative for another or can change depending on its value. This is a purely statistical decision.

The company has 15 directors

The creditor days are 23.84

The total assets are 187,107,327 €

Low risk workforce size

The net turnover is 1,020,353,406 €

The pre-tax profit is 9,508,121 €

The sales to current assets ratio is 6.27

The net current assets are 162,799,720 €

The liabilities are 120,718,385 €

The risk provisions are 4,505,138 €

The shareholder's equity is 61,883,805 €

The return on total assets employed is 5.08

The stock to turnover ratio is 5.13

The ratio total assets to total liabilities is 1.49

 

 

Industry comparison

 

Activity (APE)

Non-Food Purchasing Centers (4619A)

 

Collective procedures

 

No judgment information for the company

Preferential rights details and history

Summary of preferential rights

Company monitored since

03/02/2009

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

 

 

Preferential rights details and history

 

Summary of preferential rights

Company monitored since

03/02/2009

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

 

Group Data

Ultimate parent company

INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORATION

Direct parent

INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORATION - Majority

Group – Number of companies

6

Linkages – Number of companies

1

Number of countries

1

Group Structure

 

 

Go directly to the current company

Rating Information

 

Name

SIREN

Parts

Last account published

1

INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORATION

-

-

-

2

INTERSPORT FRANCE

964201123

Majority

31/12/2016

3

LOGISTIQUE SPORTS ET LOISIRS

429512213

Majority

31/12/2016

MANUFACTURE FRANCAISE DU CYCLE

791771223

100 %

31/12/2016

INTERSPORT SERVICES

322193335

80 %

30/09/2016

ATHLETE'S FOOT BRANDS LLC

-

100 %

-

 

 

Linkages

 

Rating Information

Company Name

Siren

Last Account Published

Turnover

INTERSPORT BELGIUM CVBA

415533053

31/12/2016

-

 

 

Shareholder(s)

 

Name

GROUPE INTERSPORT

Name of representative

Mme GAUTIER-DELORME MURIEL THÉRÈSE JOËLLE

Manager position

Administrator

Date of birth

27/08/1961

Place of birth

CHOLET

Type

Moral person

Name at birth

 

 

Director(s)

 

Name

M. RIHOUET JACKY ALBERT MARIUS

Manager position

Administrator, Chairman of the Board, Managing director

Date of birth

11/06/1959

Place of birth

SAINT-LÔ

Type

Individual

Name at birth

View Details

Name

Mme. ROSEC MARIE ANNICK

Manager position

Administrator

Date of birth

24/01/1967

Place of birth

BREST

Type

Individual

Name at birth

SALIOU

View Details

 

Name

M. ROLLAND ANTONY GUILLAUME

Manager position

Administrator

Date of birth

21/07/1974

Place of birth

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Type

Individual

Name at birth

View Details

Name

M. LECLERC GÉRARD MARIE PAUL

Manager position

Administrator

Date of birth

27/03/1963

Place of birth

REMIREMONT

Type

Individual

Name at birth

View Details

 

Name

Mme. TAILLET BÉATRICE

Manager position

Administrator

Date of birth

14/07/1956

Place of birth

YVETOT

Type

Individual

Name at birth

BROXOLLE

View Details

Name

M. CASSIGNOL PAUL

Manager position

Administrator

Date of birth

19/09/1964

Place of birth

PAMIERS

Type

Individual

Name at birth

View Details

 

Name

M. FONDON ARNAUD

Manager position

Administrator

Date of birth

19/06/1979

Place of birth

BORDEAUX

Type

Individual

Name at birth

View Details

Name

M. NIVAULT DAVID ERIC JEAN GEORGES

Manager position

Administrator

Date of birth

15/03/1972

Place of birth

LAVAL

Type

Individual

Name at birth

 

 

Statutory Auditor

 

Name

KPMG S.A

Name of representative

Manager position

Statutory auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

Name

SALUSTRO REYDEL

Name of representative

Manager position

Deputy auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

Name

INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC

Name of representative

Manager position

Deputy auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

Name

GRANT THORNTON

Name of representative

Manager position

Statutory auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

 

Previous Directors

 

View the directors history for this company
If you want to view the directors history, please click on the link view details.

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

Chairman of the Board

M. BOUDET LAURENT

-

View Details

Chairman of the Board

M. BOUDET LAURENT

08/04/1948 - BOULOGNE BILLANCOURT

View Details

Chairman of the Board

M. RIHOUET JACKY ALBERT MARIUS

11/06/1959 - SAINT-LÔ

View Details

Chairman of the Board

M. RIHOUET JACKY ALBERT MARIUS

11/06/1959 - ST LO

View Details

Managing director

M. RIHOUET JACKY ALBERT MARIUS

11/06/1959 - SAINT-LÔ

View Details

Managing director

M. RIHOUET JACKY ALBERT MARIUS

11/06/1959 - ST LO

View Details

Vice-president

M. SAVARIEAU THIERRY LOUIS MAURICE

20/10/1960 - THOUARS

View Details

Administrator

M. BERNARD MICHEL

-

View Details

Administrator

M. BERNARD MICHEL LOUIS MARIE

04/09/1951 - DIJON

View Details

Administrator

M. BERNARD MICHEL

04/09/1951 - DIJON

View Details

Administrator

M. BOISSIERE MICHEL GEORGES

22/05/1946 - VERGEZE

View Details

Administrator

M. BOISSIERE MICHEL GEORGES

22/05/1946 - VERGÈZE

View Details

Administrator

M. BOUDET LAURENT

-

View Details

Administrator

M. BOUDET LAURENT

08/04/1948 - BOULOGNE BILLANCOURT

View Details

Administrator

M. CASSIGNOL PAUL

19/09/1964 - PAMIERS

View Details

Administrator

M. DUCHAMBON CLAUDE

-

View Details

Administrator

M. DUCHAMBON CLAUDE

14/09/1952 - CONFOLENS

View Details

Administrator

M. FONDON ARNAUD

19/06/1979 - BORDEAUX

View Details

Administrator

M. GARRIGOU ROLAND MAURICE

18/01/1946 - TOULOUSE

View Details

Administrator

GROUPE INTERSPORT

-

View Details

Administrator

GROUPE INTERSPORT

27/08/1961 - CHOLET

View Details

Administrator

GROUPE INTERSPORT

20/05/1955 - MERS LES BAINS

View Details

Administrator

M. LECLERC GUY JEAN MICHEL

17/06/1942 - URIMENIL

View Details

Administrator

M. LECLERC GUY

17/06/1942 - URIMENIL

View Details

Administrator

M. LECLERC GÉRARD MARIE PAUL

27/03/1963 - REMIREMONT

View Details

Administrator

M. NOLD JEAN-LUC FRANÇIS

03/10/1952 - HAGUENAU

View Details

Administrator

M. RIHOUET JACKY ALBERT MARIUS

11/06/1959 - SAINT-LÔ

View Details

Administrator

M. RIHOUET JACKY ALBERT MARIUS

11/06/1959 - ST LO

View Details

Administrator

M. ROLLAND ANTONY GUILLAUME

21/07/1974 - CHAMBRAY-LÈS-TOURS

View Details

Administrator

Mme. ROSEC MARIE ANNICK

24/01/1967 - BREST

View Details

1 2 next

 

 

 

Status history

No Status History

 

 

Recent publications in Gazettes

 

Publication date

Gazette Name

Description

Hide

09/11/2017

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

91 - ESSONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

12206 - 964201123 RCS. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 2 rue Victor Hugo 91160 Longjumeau. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2016.

Hide

02/11/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

91 - ESSONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1512 - 964 201 123 RCS Evry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur : GROUPE INTERSPORT représenté par GAUTIER-DELORME Muriel Thérèse Joëlle modification le 27 Février 2017 ; Administrateur : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Président du conseil d'administration : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Directeur général : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Administrateur : SALIOU Marie Annick en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : ROLLAND Antony Guillaume en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : LECLERC Gérard Marie Paul en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : BROXOLLE Béatrice en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : CASSIGNOL Paul en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : FONDON Arnaud en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : NIVAULT David Eric Jean Georges en fonction le 27 Octobre 2017. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant..

Hide

24/10/2017

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

La Semaine de l Ile-de-France - L Informateur de seine et Oise


Date de décision : 02/06/2017
La société 964201123 - INTERSPORT FRANCE, 6 AVENUE DESCARTES, A 12, 91420 MORANGIS
Fait l'objet du départ de Monsieur Romain VERGNE

Hide

24/10/2017

JAL

Appointment of the social representative

La Semaine de l Ile-de-France - L Informateur de seine et Oise


Date de décision : 02/06/2017
Nominé : Monsieur David NIVAULT, 53940 ST BERTHEVIN
En la fonction de : Administrateur

Hide

02/03/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

91 - ESSONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

2361 - 964 201 123 RCS Evry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MR RAYMOND JEAN LOUIS ; Administrateur : GROUPE INTERSPORT représenté par SERON Philippe Bernard Albert modification le 29 Septembre 2010 ; Administrateur : LECLERC Guy Jean Michel modification le 04 Octobre 2006 ; Administrateur : BOISSIERE Michel Georges modification le 29 Octobre 2003 ; Commissaire aux comptes suppléant : URBAIN Michel en fonction le 03 Juillet 1997 ; Commissaire aux comptes suppléant : LECLERC Benoît en fonction le 29 Octobre 2003 ; Administrateur : GARRIGOU Roland Maurice en fonction le 29 Octobre 2003 ; Administrateur : NOLD Jean-Luc Françis en fonction le 29 Octobre 2003 ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDULOR GRANT THORNTON en fonction le 29 Octobre 2003 ; Administrateur : BERNARD Michel Louis Marie en fonction le 09 Janvier 2007 ; Administrateur : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Président du conseil d'administration : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Directeur général : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant..

Hide

02/03/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

91 - ESSONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

2365 - 964 201 123 RCS Evry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur : GROUPE INTERSPORT représenté par GAUTIER-DELORME Muriel Thérèse Joëlle modification le 27 Février 2017 ; Administrateur : BOISSIERE Michel Georges modification le 29 Octobre 2003 ; Administrateur : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Président du conseil d'administration : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Directeur général : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Administrateur : VERGNE Romain Marc-Auguste en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : SALIOU Marie Annick en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : ROLLAND Antony Guillaume en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : LECLERC Gérard Marie Paul en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : BROXOLLE Béatrice en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : CASSIGNOL Paul en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : FONDON Arnaud en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 27 Février 2017. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant..

Hide

02/03/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

91 - ESSONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

2360 - 964 201 123 RCS Evry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MR RAYMOND JEAN LOUIS ; Administrateur : GROUPE INTERSPORT représenté par GAUTIER-DELORME Muriel Thérèse Joëlle modification le 27 Février 2017 ; Administrateur : BOISSIERE Michel Georges modification le 29 Octobre 2003 ; Commissaire aux comptes suppléant : URBAIN Michel en fonction le 03 Juillet 1997 ; Administrateur : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Président du conseil d'administration : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Directeur général : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : TAPIE Jean Lucien en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : JOANNIN Bernard Georges en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : VERGNE Romain Marc-Auguste en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : SALIOU Marie Annick en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : ROLLAND Antony Guillaume en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : LECLERC Gérard Marie Paul en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : BROXOLLE Béatrice en fonction le 27 Février 2017. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant..

Hide

02/03/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

91 - ESSONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

2353 - 964 201 123 RCS Evry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MR RAYMOND JEAN LOUIS ; Administrateur : GROUPE INTERSPORT représenté par SERON Philippe Bernard Albert modification le 29 Septembre 2010 ; Administrateur : BOISSIERE Michel Georges modification le 29 Octobre 2003 ; Commissaire aux comptes suppléant : URBAIN Michel en fonction le 03 Juillet 1997 ; Administrateur : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Président du conseil d'administration : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Directeur général : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : TAPIE Jean Lucien en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : JOANNIN Bernard Georges en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : VERGNE Romain Marc-Auguste en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : SALIOU Marie Annick en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : ROLLAND Antony Guillaume en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : LECLERC Gérard Marie Paul en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : BROXOLLE Béatrice en fonction le 27 Février 2017. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant..

Hide

02/03/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

91 - ESSONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

2362 - 964 201 123 RCS Evry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MR RAYMOND JEAN LOUIS ; Administrateur : GROUPE INTERSPORT représenté par GAUTIER-DELORME Muriel Thérèse Joëlle modification le 27 Février 2017 ; Administrateur : BOISSIERE Michel Georges modification le 29 Octobre 2003 ; Commissaire aux comptes suppléant : URBAIN Michel en fonction le 03 Juillet 1997 ; Administrateur : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Président du conseil d'administration : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Directeur général : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : JOANNIN Bernard Georges en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : VERGNE Romain Marc-Auguste en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : SALIOU Marie Annick en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : ROLLAND Antony Guillaume en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : LECLERC Gérard Marie Paul en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : BROXOLLE Béatrice en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : CASSIGNOL Paul en fonction le 27 Février 2017. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant..

Hide

02/03/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

91 - ESSONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

2368 - 964 201 123 RCS Evry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MR RAYMOND JEAN LOUIS ; Administrateur : GROUPE INTERSPORT représenté par SERON Philippe Bernard Albert modification le 29 Septembre 2010 ; Administrateur : BOISSIERE Michel Georges modification le 29 Octobre 2003 ; Commissaire aux comptes suppléant : URBAIN Michel en fonction le 03 Juillet 1997 ; Administrateur : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Président du conseil d'administration : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Directeur général : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Administrateur : HANOT Patrick Dominique en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : DOUESSIN Yolaine Marie-Madeleine Yvette en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : TAPIE Jean Lucien en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : JOANNIN Bernard Georges en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : VERGNE Romain Marc-Auguste en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : SALIOU Marie Annick en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : CASSIGNOL Paul en fonction le 27 Février 2017. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant..

Hide

02/03/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

91 - ESSONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

2369 - 964 201 123 RCS Evry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MR RAYMOND JEAN LOUIS ; Administrateur : GROUPE INTERSPORT représenté par SERON Philippe Bernard Albert modification le 29 Septembre 2010 ; Administrateur : LECLERC Guy Jean Michel modification le 04 Octobre 2006 ; Administrateur : BOISSIERE Michel Georges modification le 29 Octobre 2003 ; Commissaire aux comptes suppléant : URBAIN Michel en fonction le 03 Juillet 1997 ; Administrateur : BERNARD Michel Louis Marie en fonction le 09 Janvier 2007 ; Administrateur : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Président du conseil d'administration : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Directeur général : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Administrateur : HANOT Patrick Dominique en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : DOUESSIN Yolaine Marie-Madeleine Yvette en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : TAPIE Jean Lucien en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : JOANNIN Bernard Georges en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 27 Février 2017. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant..

Hide

02/03/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

91 - ESSONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

2355 - 964 201 123 RCS Evry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MR RAYMOND JEAN LOUIS ; Administrateur : GROUPE INTERSPORT représenté par SERON Philippe Bernard Albert modification le 29 Septembre 2010 ; Administrateur : LECLERC Guy Jean Michel modification le 04 Octobre 2006 ; Administrateur : BOISSIERE Michel Georges modification le 29 Octobre 2003 ; Commissaire aux comptes suppléant : URBAIN Michel en fonction le 03 Juillet 1997 ; Commissaire aux comptes suppléant : LECLERC Benoît en fonction le 29 Octobre 2003 ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDULOR GRANT THORNTON en fonction le 29 Octobre 2003 ; Administrateur : BERNARD Michel Louis Marie en fonction le 09 Janvier 2007 ; Administrateur : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Président du conseil d'administration : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Directeur général : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Administrateur : BONAMI Daniel Gilbert Robert Joseph en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : HANOT Patrick Dominique en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : DOUESSIN Yolaine Marie-Madeleine Yvette en fonction le 27 Février 2017. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant..

Hide

02/03/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

91 - ESSONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

2363 - 964 201 123 RCS Evry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MR RAYMOND JEAN LOUIS ; Administrateur : GROUPE INTERSPORT représenté par SERON Philippe Bernard Albert modification le 29 Septembre 2010 ; Administrateur : LECLERC Guy Jean Michel modification le 04 Octobre 2006 ; Administrateur : BOISSIERE Michel Georges modification le 29 Octobre 2003 ; Commissaire aux comptes suppléant : URBAIN Michel en fonction le 03 Juillet 1997 ; Administrateur : BERNARD Michel Louis Marie en fonction le 09 Janvier 2007 ; Administrateur : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Président du conseil d'administration : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Directeur général : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Administrateur : BONAMI Daniel Gilbert Robert Joseph en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : HANOT Patrick Dominique en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : DOUESSIN Yolaine Marie-Madeleine Yvette en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : TAPIE Jean Lucien en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : JOANNIN Bernard Georges en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 27 Février 2017. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant..

Hide

02/03/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

91 - ESSONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

2364 - 964 201 123 RCS Evry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MR RAYMOND JEAN LOUIS ; Administrateur : GROUPE INTERSPORT représenté par SERON Philippe Bernard Albert modification le 29 Septembre 2010 ; Administrateur : LECLERC Guy Jean Michel modification le 04 Octobre 2006 ; Administrateur : BOISSIERE Michel Georges modification le 29 Octobre 2003 ; Commissaire aux comptes suppléant : URBAIN Michel en fonction le 03 Juillet 1997 ; Commissaire aux comptes suppléant : LECLERC Benoît en fonction le 29 Octobre 2003 ; Administrateur : GARRIGOU Roland Maurice en fonction le 29 Octobre 2003 ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDULOR GRANT THORNTON en fonction le 29 Octobre 2003 ; Administrateur : BERNARD Michel Louis Marie en fonction le 09 Janvier 2007 ; Administrateur : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Président du conseil d'administration : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Directeur général : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Administrateur : BONAMI Daniel Gilbert Robert Joseph en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : HANOT Patrick Dominique en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : DOUESSIN Yolaine Marie-Madeleine Yvette en fonction le 27 Février 2017. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant..

Hide

02/03/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

91 - ESSONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

2356 - 964 201 123 RCS Evry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MR RAYMOND JEAN LOUIS ; Administrateur : GROUPE INTERSPORT représenté par GAUTIER-DELORME Muriel Thérèse Joëlle modification le 27 Février 2017 ; Administrateur : BOISSIERE Michel Georges modification le 29 Octobre 2003 ; Commissaire aux comptes suppléant : URBAIN Michel en fonction le 03 Juillet 1997 ; Administrateur : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Président du conseil d'administration : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Directeur général : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 ; Administrateur : VERGNE Romain Marc-Auguste en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : SALIOU Marie Annick en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : ROLLAND Antony Guillaume en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : LECLERC Gérard Marie Paul en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : BROXOLLE Béatrice en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : CASSIGNOL Paul en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 27 Février 2017 ; Administrateur : FONDON Arnaud en fonction le 27 Février 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 27 Février 2017. Activité : .
Commentaires : Modification de représentant..

Hide

02/02/2017

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

91 - ESSONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

6042 - 964201123 RCS. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Adresse : 2 rue Victor Hugo 91160 Longjumeau. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2015.

Hide

13/04/2014

Bodacc A

Immatriculation

84 - VAUCLUSE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

793 - 799 363 726 RCS Avignon. JS SPORTS. Forme : Société à responsabilité limitée. Administration : Gérant : BOURDIN Stéphane Gérant : GOURDON Judith. Capital : 10000 EUR. Adresse : chemin des Daulands, Zone du Pontet, 84700 Sorgues.
Origine du fonds : Prise en location-gérance. Etablissement : Etablissement principal. Activité : Achat et vente de tous articles produits vêtements et accessoires Lies au sport. Adresse : chemin des Daulands, Zone du Pontet, 84700 Sorgues.
Précédent exploitant : INTERSPORT FRANCE. 964 201 123 RCS Avignon.
A dater du : 01/04/2014. Date de commencement de l’activité : 02/01/2014. Descriptif : Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, mise en activité de la société. Commentaires : Immatriculation d'une personne morale, établissement principal reçu en location-gérance.

Hide

20/02/2014

JAL

End of rent-management

Hebdo le Comtadin


Date de décision : 20/02/2014
Locataire gérant : 539890004 - MAVERICKS SARL, INTERSPORT, CHE DES DAULANDS, 84700 SORGUES
Date d’effet : 31/12/2013

Hide

15/01/2014

JAL

Start of rent-management

TPBM - Semaine de Provence


Date de décision : 02/01/2014
Bailleur : 964201123 - INTERSPORT FRANCE, 2 RUE VICTOR HUGO, 91160 LONGJUMEAU
Locataire gérant : 000000001 - Société inconnue,
Date d’effet : 02/01/2014
pour une durée de 1 mois

Hide

29/03/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

84 - VAUCLUSE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

705 - 964 201 123 RCS Évry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 9500000 EUR. Adresse : 2 rue Victor Hugo, 91160 Longjumeau.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 1045000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : fonds de commerce de vente d'articles de sports réparation dépôt entretien vente location d'articles de sports de camping plein air et l'accomplissement de prestations de services dans les domaines administratif commercial financier et de gestion. Adresse : chemin des Daulands, 84700 Sorgues.
Précédent propriétaire : SPORTS ET LOISIRS. 331 066 399 RCS Avignon.
Date de commencement de l’activité : 01/03/2012. Publication légale : l'hebdo le comtadin du 15/03/2012. Oppositions : Me Goret Lionel -155, rue Lawrence Durrell - Agroparc BP 21275 - 84911 Avignon. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

Hide

15/03/2012

JAL

Activity or goodwill cession

Hebdo le Comtadin


Date de décision : 01/03/2012
Cédant : 331066399 - SARL SPORTS ET LOISIRS, 561 AV JEAN HENRI FABRE, 84200 CARPENTRAS
Cessionnaire : 964201123 - INTERSPORT FRANCE, 2 RUE VICTOR HUGO, 91160 LONGJUMEAU
Prix de vente : 1045000 €
Date d’effet : 01/03/2012

Hide

22/11/2011

JAL

Appointment of the social representative

Semaine de l'Ile-de-France (La)


Société faisant l'objet d'une nomination : 429512213 - LOGISTIQUE SPORTS ET LOISIRS, 2 RUE VICTOR HUGO, 91160 LONGJUMEAU
Nominé :
En la fonction de : Associé
Nominé :
En la fonction de : Associé-Gérant
Date d'effet : 18/05/2011

Hide

10/10/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

91 - ESSONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY

1905 - 964 201 123 RCS Evry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MR RAYMOND JEAN LOUIS Administrateur : GROUPE INTERSPORT représenté par SERON Philippe Bernard Albert modification le 29 Septembre 2010 Administrateur : LECLERC Guy Jean Michel modification le 04 Octobre 2006 Administrateur : BOISSIERE Michel Georges modification le 29 Octobre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : URBAIN Michel en fonction le 03 Juillet 1997 Commissaire aux comptes suppléant : LECLERC Benoît en fonction le 29 Octobre 2003 Administrateur vice-président : SAVARIEAU Thierry Louis Maurice en fonction le 29 Octobre 2003 Administrateur : GARRIGOU Roland Maurice en fonction le 29 Octobre 2003 Administrateur : NOLD Jean-Luc Françis en fonction le 29 Octobre 2003 Commissaire aux comptes titulaire : FIDULOR GRANT THORNTON en fonction le 29 Octobre 2003 Administrateur : BERNARD Michel Louis Marie en fonction le 09 Janvier 2007 Administrateur : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 Président du conseil d'administration : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010 Directeur général : RIHOUET Jacky Albert Marius en fonction le 29 Septembre 2010.
Commentaires : Modification de représentant.

Hide

21/09/2010

JAL

Appointment of the social representative

LA SEMAINE DE L’ILE DE FRANCE


Société faisant l'objet d'une nomination : 964201123 - INTERSPORT FRANCE, 2 RUE VICTOR HUGO, 91160 LONGJUMEAU
Nominé : Monsieur Jacky RIHOUET, 270 RUE LEOPOLD SENGHOR, 50000 ST LO
En la fonction de : Administrateur

Hide

21/09/2010

JAL

Appointment of the social representative

LA SEMAINE DE L’ILE DE FRANCE


Société faisant l'objet d'une nomination : 964201123 - INTERSPORT FRANCE, 2 RUE VICTOR HUGO, 91160 LONGJUMEAU
Nominé : Monsieur Jacky RIHOUET, 270 RUE LEOPOLD SENGHOR, 50000 ST LO
En la fonction de : Président du Conseil d'Administration

Hide

21/09/2010

JAL

Appointment of the social representative

LA SEMAINE DE L’ILE DE FRANCE


Société faisant l'objet d'une nomination : 964201123 - INTERSPORT FRANCE, 2 RUE VICTOR HUGO, 91160 LONGJUMEAU
Nominé : Monsieur Jacky RIHOUET, 270 RUE LEOPOLD SENGHOR, 50000 ST LO
En la fonction de : DG - Directeur Général

Hide

21/09/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

LA SEMAINE DE L’ILE DE FRANCE


Date de décision : 03/06/2010
La société 964201123 - INTERSPORT FRANCE, 2 RUE VICTOR HUGO, 91160 LONGJUMEAU
Fait l'objet du départ de Monsieur Laurent BOUDET

Hide

14/04/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

91 - ESSONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

2693 - 964 201 123 RCS Evry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MR RAYMOND JEAN LOUIS Administrateur : GROUPE INTERSPORT représenté par FORQUET Jean-Claude Amédée Lucien modification le 14 Mars 2007 Administrateur : LECLERC Guy Jean Michel modification le 04 Octobre 2006 Administrateur : BOISSIERE Michel Georges modification le 29 Octobre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : URBAIN Michel en fonction le 03 Juillet 1997 Commissaire aux comptes suppléant : LECLERC Benoît en fonction le 29 Octobre 2003 Administrateur vice-président : SAVARIEAU Thierry Louis Maurice en fonction le 29 Octobre 2003 Administrateur : GARRIGOU Roland Maurice en fonction le 29 Octobre 2003 Administrateur : NOLD Jean-Luc Françis en fonction le 29 Octobre 2003 Commissaire aux comptes titulaire : FIDULOR GRANT THORNTON en fonction le 29 Octobre 2003 Directeur général : ARMARY Joël Jean en fonction le 17 Février 2004 Président du conseil d'administration et administrateur : BOUDET Laurent Philippe en fonction le 04 Octobre 2006 Administrateur : BERNARD Michel Louis Marie en fonction le 09 Janvier 2007.
Commentaires : Modification de représentant.

Hide

14/04/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

91 - ESSONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

2695 - 964 201 123 RCS Evry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MR RAYMOND JEAN LOUIS Administrateur : GROUPE INTERSPORT représenté par FORQUET Jean-Claude Amédée Lucien modification le 14 Mars 2007 Administrateur : LECLERC Guy Jean Michel modification le 04 Octobre 2006 Administrateur : BOISSIERE Michel Georges modification le 29 Octobre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : URBAIN Michel en fonction le 03 Juillet 1997 Commissaire aux comptes suppléant : LECLERC Benoît en fonction le 29 Octobre 2003 Administrateur vice-président : SAVARIEAU Thierry Louis Maurice en fonction le 29 Octobre 2003 Administrateur : GARRIGOU Roland Maurice en fonction le 29 Octobre 2003 Administrateur : NOLD Jean-Luc Françis en fonction le 29 Octobre 2003 Commissaire aux comptes titulaire : FIDULOR GRANT THORNTON en fonction le 29 Octobre 2003 Président directeur général et administrateur : BOUDET Laurent Philippe modification le 31 Mars 2010 Administrateur : BERNARD Michel Louis Marie en fonction le 09 Janvier 2007.
Commentaires : Modification de représentant.

Hide

14/04/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

91 - ESSONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

2694 - 964 201 123 RCS Evry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 9500000 EUR.
Commentaires : Modification du capital.

Hide

28/08/2009

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

72 - SARTHE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS

596 - 512 915 562 RCS Le Mans. LA FLECHE SPORTS. Forme : Société à responsabilité limitée. Enseigne : LA FLECHE SPORTS. Administration : Gérant(e) : NAIS Eric. Capital : 10000 EUR. Adresse : 25 rue Carnot, 72300 Sablé-sur-Sarthe.
Origine du fonds : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 420000 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : L'achat, la vente, la distribution, la fabrication d'articles de sports, vêtements, camping, caravaning, nautisme. Adresse : 6 rue du Levant, Parc de la Monnerie, 72200 La Flèche.
Précédent propriétaire : INTERSPORT FRANCE. 964 201 123 RCS Le Mans.
Précédent exploitant : INTERSPORT FRANCE. 964 201 123 RCS Le Mans.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2009. Publication légale : Les alpes mancelles du 10/07/2009. Oppositions : SCP FRANS-VENISSE 4, rue Bertrand Toutain 72200 La Flèche. Descriptif : Mise en activité de la société. Commentaires : Mise en activité d'une société suite à achat.

Hide

19/08/2009

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

72 - SARTHE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS

1317 - 964 201 123 RCS Évry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 9500000 EUR. Adresse : 2 rue Victor Hugo, 91160 Longjumeau.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 510000 Euros. Etablissement : Établissement principal. Activité : Un fonds de commerce de vente d'articles d'équipement de la personne et/ou d'articles de sport et de loisirs. Adresse : 6 rue du Levant, Parc de la Monnerie, 72200 La Flèche.
Précédent propriétaire : SUPER SPORT. 609 200 977 RCS Rennes.
Date de commencement de l’activité : 30/06/2009. Publication légale : Ouest France du 17/07/2009. Oppositions : Chez Me Oliver GARBAN, Notaire, 72200 La Flèche, 5 rue du Général Galliéni. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

Hide

11/08/2009

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

07 - ARDECHE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS

98 - 964 201 123 RCS Evry. INTERSPORT FRANCE. Forme : Société Anonyme à Conseil d'Administration. Adresse : 2 rue Victor Hugo, 91160 Longjumeau.
Origine du fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 310000 EUR. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Vente d' articles de sport et d' équipement de la personne. Adresse : Zone des Murets, 7130 Saint-Péray.
Précédent propriétaire : SUPER SPORT. 609 200 977 RCS Aubenas.
Date de commencement de l’activité : 30/06/2009. Publication légale : L'Echo et le Valentinois du 18/07/2009. Oppositions : ME OLIVIER CHASTAGNARET, notaire à 07130 SAINT PERAY. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

Hide

07/08/2009

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

72 - SARTHE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS

513 - 512 915 562 RCS Le Mans. LA FLECHE SPORTS. Forme : Société à responsabilité limitée. Enseigne : LA FLECHE SPORTS. Administration : Gérant(e) : NAIS Eric. Capital : 10000 EUR. Adresse : 25 rue Carnot, 72300 Sablé-sur-Sarthe.
Origine du fonds : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 420000 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : L'achat, la vente, la distribution, la fabrication d'articles de sports, vêtements, camping, caravaning, nautisme. Adresse : 6 rue du Levant, Parc de la Monnerie, 72200 La Flèche.
Précédent propriétaire : INTERSPORT FRANCE. 964 201 123 RCS Le Mans.
Précédent exploitant : INTERSPORT FRANCE. 964 201 123 RCS Le Mans.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2009. Publication légale : Les alpes mancelles du 10/07/2009. Oppositions : SCP FRANS-VENISSE 4, rue Bertrand Toutain 72200 La Flèche. Descriptif : Mise en activité de la société. Commentaires : Mise en activité d'une société suite à achat.

Hide

06/08/2009

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

47 - LOT-ET-GARONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN

468 - 964 201 123 RCS Évry. SA INTER SPORT FRANCE. Forme : Société anonyme. Capital : 9500000 EUR. Adresse : 02 rue Victor Hugo, 91160 Longjumeau.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 510000 Euros. Etablissement : Établissement secondaire. Activité : COMMERCE DE VTE EQUIPEMENT PERSONNE ARTICLES SPORTS ET LOISIRS. Adresse : lieu dit Ponservat, 47300 Bias.
Précédent propriétaire : SUPER SPORT. 609 200 977 RCS Rennes.
Date de commencement de l’activité : 30/06/2009. Publication légale : COURRIER FRANCAIS du 17/07/2009. Oppositions : Scp Philippe Samarut - Jean-Philippe Sempol -2ter, place du DR Esquirol - 47000 Agen. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

Hide

05/04/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1910 - RCS Evry B 964 201 123. RC 64-B 112. INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. Capital : 8 500 000 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration. Administration : modification d'un administrateur : GROUPE INTERSPORT, représenté par FORQUET (Jean-Claude, Amédée, Lucien).

Hide

19/01/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

2228 - RCS Evry B 964 201 123. RC 64-B 112. INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : HERMOUET (Gilles, Emile, Auguste). Nomination d'administrateurs : BERNARD (Michel, Louis, Marie) DUCHAMBON (Claude, Pierre).

Hide

21/11/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

5766 - RCS Evry B 964 201 123. RC 64-B 112. INTERSPORT FRANCE. Forme: S.A. Adresse du siège social: 2, rue Victor Hugo,91160 Longjumeau. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

Hide

15/10/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1897 - RCS Evry B 964 201 123. RC 64-B 112. INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : FORQUET (Jean, Claude, Amédée, Lucien). Modification d'un administrateur : LECLERC (Guy, Jean, Michel). Nomination du président du conseil d'administration et administrateur : BOUDET (Laurent, Philippe).

Hide

23/12/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

2803 - RCS Evry B 964 201 123. RC 64-B 112. INTERSPORT FRANCE. Forme: S.A. Adresse du siège social: 2, rue Victor Hugo,91160 Longjumeau. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

Hide

02/03/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Evry B 964201123 RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A Nom commercial: Inter Sport. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : modification du président du conseil d' administration et administrateur : LECLERC (Guy, Jean, Michel). Nomination d'un directeur général : ARMARY (Joel, Jean).

Hide

09/11/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Evry B 964201123 RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A Nom commercial: Inter Sport. Commentaires : modification survenue sur la forme juridique et l'administration. Administration : co-commissaire aux comptes titulaire partant : BERTHON RIVIERE LA TREILLE ET ASSOCIES. Modification d'un administrateur : FORQUET (Jean, Claude, Amédée, Lucien). Membre du conseil de surveillance partant : LECLERC (Guy, Jean, Marcel). Modification d'un administrateur : GROUPE INTERSPORT, représenté par BOUDET (Laurent, Philippe). Membre du directoire partant : PAYEN (Louis, Michel, Marie). Modification du P.-D.G. et administrateur : LECLERC (Guy, Jean, Michel). Directeur général partant : PAYEN (Louis, Michel, Marie). Modification d'un administrateur : BOISSIERE (Michel, Georges). Co- commissaire aux comptes suppléant partant : GROUPE DUHAMEL KAHN ET ASSOCIES. Membres du conseil de surveillance partants : LOUBIERE (Jean, Paul, Lucien, Augustin) FOGAROLO ( Claude, Daniel, Michel). Président du directoire partant : COTTIGNIES ( François, Joseph). Membre du directoire partant : GERSTL (Henri). Membre du conseil de surveillance partant : BURCKBUCHLER (Michel, Georges, Louis). Modification d'un administrateur : HERMOUET (Gilles, Emile, Auguste). Directeur général partant : GERSTL ( Henri). Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : LECLERC (Benoit). Nomination d'un vice-président et administrateur : SAVARIEAU (Thierry, Louis, Maurice). Nomination d' administrateurs : GARRIGOU (Roland, Maurice) NOLD (Jean-Luc, Francis). Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : FIDULOR GRANT THORNTON.

Hide

31/07/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Evry B 964201123 RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance Nom commercial: Inter Sport. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : vice- président du conseil de surveillance partant : LOUBIERRE (Jean, Paul, Lucien, Augustin).

Hide

31/07/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Evry B 964201123 RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance Nom commercial: Inter Sport. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un directeur général : GERSTL (Henri).

Hide

25/01/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Evry B 964201123 RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance Nom commercial: Inter Sport. Commentaires : modification survenue sur le nom commercial.

Hide

26/09/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Evry B 964201123 RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Capital : 8 064 000 euros Nom commercial: Intersport Sport Expert la Halle au Sport. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration. Administration : membres du conseil de surveillance partants : VERGER (Bernard) PERON ( Eric, Marie, Philippe). Nomination des membres du conseil de surveillance : BURCKBUCHLER (Michel, Georges, Louis) HERMOUET (Gilles, Emile, Auguste).

Hide

14/09/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Evry B 964201123 RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance Nom commercial: Intersport Sport Expert la Halle au Sport. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : nomination d'un membre du directoire : GERSTL (Henri).

Hide

03/12/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Evry B 964201123 RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance Nom commercial: Intersport Sport Expert La Halle au Sport. Commentaires : modification survenue sur le nom commercial.

Hide

03/02/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

*. RCS Evry B 964 201 123 RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination en qualité de président du directoire : COTTIGNIES (François, Joseph) Suppression : membre du directoire : LABROUSSE (Xavier, Jean, Michel).

Hide

08/08/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Evry B 964201123 RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président et membre du directoire partant : CIROTTEAU (Benoist, Marie, Bernard).

Hide

08/08/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Evry B 964201123 RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : membre du conseil de surveillance partant : MALLET (Alex). Nomination d'un membre du conseil de surveillance : FOGAROLO ( Claude, Daniel, Michel).

Hide

04/08/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Evry B 964201123 RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : membre du directoire partant : NEFF (Danny, Joel).

Hide

03/04/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Evry B 964 201 123 RC RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Administration : modification : président du conseil de surveillance : LECLERC (Guy, Jean-Michel) Modification vice-président du conseil de surveillance : DEROUBAIX (Maurice). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

03/04/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Evry B 964 201 123 RC RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Administration : nomination en qualité de président du directoire : CIROTTEAU (Benoist, Marie, Bernard) Modification : directeur général : PAYEN (Louis, Michel, Marie). Suppression : vice- président du conseil de surveillance : DEROUBAIX (Maurice). Nomination en qualité de vice-président du conseil de surveillance : LOUBIERRE (Jean-Paul, Lucien, Augustin). Suppression : membre du conseil de surveillance : DEROUBAIX (Maurice). Nomination en qualité de membre du conseil de surveillance : LOUBIERE (Jean-Paul, Lucien, Augustin). Modification : membre du directoire : PAYEN (Louis, Michel, Marie). Nomination en qualité de membres du directoire : CIROTTEAU ( Benoist, Marie, Bernard) LABROUSSE ( Xavier, Jean-Michel). Commentaires : modification survenue sur l' administration.

Hide

17/07/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Evry B 964 201 123 RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un membre du directoire : NEFF (Danny, Joel).

Hide

17/07/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Evry B 964 201 123 RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : membre du conseil de surveillance partant : RABOUAN ( Philippe, Yves). Nomination d'un membre du conseil de surveillance : BOISSIERE ( Michel, Georges). Modification du co- commissaire aux comptes titulaire : BERTHON RIVIERE LA TREILLE ET ASSOCIES. Nomination du co-commissaire aux comptes suppléant : GROUPE DUHAMEL KAHN ET ASSOCIES. Nomination du commissaire aux comptes suppléant : URBAIN (Michel).

Hide

16/03/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Evry B 964 201 123 RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Administration : démission d'un membre du directoire : DURAND (Paul, Marie, Joseph). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

14/03/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Evry B 964 201 123 RC RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Administration : modification : membre du conseil de surveillance : GROUPE INTERSPORT. Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

14/03/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Evry B 964 201 123 RC RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Administration : nomination en qualité de président du directoire : PAYEN ( Louis, Michel). Commentaires : modification survenue sur l' administration.

Hide

14/03/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Evry B 964 201 123 RC RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Administration : démission : président du directoire : JANTET (Claude) Démission : membre du directoire : JANTET (Claude). Commentaires : modification survenue sur l' administration.

Hide

23/10/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Corbeil B 964 201 123 RC RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. Administration : président et membre du conseil de surveillance : DEROUBAIX ( Maurice). Président et membre du directoire : JANTET (Claude) Vice- président du conseil de surveillance : LECLERC (Guy, Jean, Michel). Membres du conseil de surveillance : RABOUAN ( Philippe, Yves) VERGER (Bernard) MALLET (Alex) RABOUAN (Philippe, Yves) FORQUET (Jean, Claude, Amédée, Lucien) LECLERC (Guy, Jean, Marcel) PERON (Eric, Marie, Philippe) GROUPE INTERSPORT Membres du directoire : PAYEN (Louis-Michel, Marie) DURAND ( Paul, Marie, Joseph). Commissaire aux comptes titulaire : RAYMOND (Jean, Louis). Commissaire aux comptes suppléant : BERTHON RIVIERE LA TREILLE ET ASSOCIES. Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

28/07/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Corbeil-Essonnes B 964 201 123 RC 64-B 112 INTERSPORT FRANCE. Forme : S.A. à directoire. Capital : 20 160 000 F. Adresse du siège social : 2 rue Victor- Hugo 91160 Longjumeau. Administration : président du conseil de surveillance : DEROUBAIX (Maurice). Vice-président du conseil de surveillance : RABOUAN ( Philippe, Yves). Membres du conseil de surveillance : VERGER (Bernard) MALLET (Alex) RABOUAN (Philippe, Yves) FORQUET (Jean, Claude, Amédée, Lucien) LECLERC (Guy, Jean, Marcel) PERON ( Eric, Marie, Philippe) GROUPE INTERSPORT DEROUBAIX (Maurice). Président du directoire : JANTET ( Claude). Membres du directoire : PAYEN ( Louis-Michel, Marie) BURCKBUCHLER ( Michel, Georges, Louis) JANTET ( Claude). Commissaire aux comptes titulaire : RAYMOND (Jean, Louis). Commissaire aux comptes suppléant : BERTHON RIVIERE LA TREILLE ET ASSOCIES. Commentaires : modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, le capital et l'administration. Augmentation du capital de 15 500 000 F à 20 160 000 F par suite d'apport partiel d'actif de la STE CENTRE ACHATS HUTTE INTERSPORT FRANCE. Date d'effet : 20 mai 1996.

Hide

26/04/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Corbeil B 964 201 123 RC RC 64-B 112 LA HUTTE. Forme : S.A. Administration : président-directeur général et administrateur : DEROUBAIX ( Maurice) Vice-président et administrateur : RABOUAN (Philippe). Directeur général non administrateur : JANTET (Claude). Administrateurs : HANOT (Didier) VERGER (Bernard) GUEGUEN (Pascualina) MALLET (Alex) SAUTAREL (Christian) FESLER (Franz) BOYRIE (Françoise, Jeanne, Marie) FORQUET (Jean-Claude, Amédée, Lucien) LECLERC (Guy, Jean, Marcel) PERON ( Eric, Marie, Philippe). Commissaire aux comptes titulaire : RAYMOND (Jean- Louis). Commissaire aux comptes suppléant : BERTHON RIVIERE LA TREILLE ET ASSOCIES. Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

26/04/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Corbeil-Essonnes B 964 201 123 RC 64-B 112 LA HUTTE. Forme : S.A. Administration : P.-D.G. et administrateur : DEROUBAIX (Maurice). Directeur général non administrateur : JANTET (Claude). Vice-présidents : RABOUAN (Philippe) BOUDET (Laurent, Philippe). Administrateurs : RABOUAN ( Philippe) DANO (Pierrick) HANOT ( Didier) VERGER (Bernard) Mme GUEGUEN (Pascualina) MALLET (Alex) SAUTAREL (Christian) FESLER (Franz) BOUDET (Laurent, Philippe). Commissaire aux comptes titulaire : RAYMOND (Jean, Louis). Commissaire aux comptes suppléant : BERTHON RIVIERE LA TREILLE ET ASSOCIES. Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

23/04/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Corbeil B 964 201 123 RC RC 64-B 112 LA HUTTE. Forme : S.A. Administration : président-directeur général : DANO (Pierrick) Directeur général non administrateur : JANTET ( Claude). Administrateurs : RABOUAN ( Philippe) DANO (Pierrick) DEROUBAIX (Maurice) PANCIERA ( Raphael) HANOT (Didier) VERGER ( Bernard) Mme GUEGUEN (Pascualina) MALLET (Alex) SAUTAREL (Christian) JANSEN (Eddy) FESLER (Franz). Commissaire aux comptes titulaire : RAYMOND (Jean-Louis). Commissaire aux comptes suppléant : BERTHON RIVIERE LA TREILLE ET ASSOCIES. Commentaires : modification survenue sur l' administration.

Hide

23/04/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Corbeil B 964 201 123 RC RC 64-B 112 LA HUTTE. Forme : S.A. Administration : président-directeur général : DANO (Pierrick) Directeur général non administrateur : JANTET ( Claude). Administrateurs : RABOUAN ( Philippe) DANO (Pierrick) DEROUBAIX (Maurice) PANCIERA ( Raphael) HANOT (Didier) VERGER ( Bernard) GUEGUEN (Pascualina) MALLET (Alex) SAUTAREL (Christian) FESLER (Franz). Commissaire aux comptes titulaire : RAYMOND (Jean- Louis). Commissaire aux comptes suppléant : BERTHON RIVIERE LA TREILLE ET ASSOCIES. Commentaires : modification survenue sur l'administration.

 

 

Company events history

 

Date

Description

14/11/2017

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

09/11/2017

Bodacc C : Deposit accounts notice

02/11/2017

Bodacc B: Various editing or changing

27/10/2017

Minutes of general meeting of shareholders

27/10/2017

Changes to the Board of Directors

24/10/2017

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

02/06/2017

Legal Gazette: Appointment of the social representative

02/03/2017

Bodacc B: Various editing or changing

27/02/2017

Minutes of general meeting of shareholders

27/02/2017

Minutes of Board meeting

27/02/2017

Changes to the Board of Directors

27/02/2017

Amendment

27/02/2017

New auditor

02/02/2017

Bodacc C : Deposit accounts notice

26/01/2017

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

31/12/2016

New accounts available

31/12/2015

New accounts available

05/09/2014

New subsidiarie(s) detected

13/04/2014

Bodacc A : Registration

20/02/2014

Legal Gazette: End of rent-management

02/01/2014

Formation of Establishment

02/01/2014

Legal Gazette: Start of rent-management

02/11/2012

Disengagement of the group

02/11/2012

New ultimate parent

02/11/2012

New parent detected

29/03/2012

Bodacc A : Sale and transfer

02/03/2012

New subsidiarie(s) detected

01/03/2012

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

18/05/2011

Legal Gazette: Appointment of the social representative

10/10/2010

Bodacc B: Various editing or changing

29/09/2010

New chairman (CEO, CoB)

29/09/2010

Minutes of Board meeting

29/09/2010

Changes to the Board of Directors

29/09/2010

Amendment

29/09/2010

Private document

29/09/2010

Appointment/resignation of company officers

21/09/2010

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

03/06/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

14/04/2010

Bodacc B: Various editing or changing

31/03/2010

Minutes of general meeting of shareholders

31/03/2010

Minutes of Board meeting

31/03/2010

Changes to the Board of Directors

31/03/2010

Capital increase

31/03/2010

Audit or Management Report

31/03/2010

Appointment/resignation of company officers

31/03/2010

Amendment

31/03/2010

Updated articles of association

28/08/2009

Bodacc A : Sale and transfer

19/08/2009

Bodacc A : Sale and transfer

11/08/2009

Bodacc A : Sale and transfer

07/08/2009

Bodacc A : Sale and transfer

06/08/2009

Bodacc A : Sale and transfer

03/02/2009

Collection of preferential rights activated for this company

22/12/2008

Payment incident closed

20/10/2008

Payment incident detected

15/09/2008

Payment incident closed

12/08/2008

Payment incident detected

14/03/2007

Private document

14/03/2007

Private document

14/03/2007

Minutes of Board meeting

14/03/2007

Minutes of Board meeting

14/03/2007

Updated articles of association

14/03/2007

Capital increase

14/03/2007

Appointment/resignation of company officers

14/03/2007

Amendment

14/03/2007

Fund deposit certificate

09/01/2007

Updated articles of association

09/01/2007

Updated articles of association

09/01/2007

Private document

09/01/2007

Minutes of general meeting of shareholders

09/01/2007

Minutes of general meeting of shareholders

09/01/2007

Changes to the Board of Directors

09/01/2007

Changes to the Board of Directors

09/01/2007

Capital increase

09/01/2007

Capital increase

09/01/2007

Amendment

09/01/2007

Appointment/resignation of company officers

23/11/2006

Other modification of Establishment

04/10/2006

Appointment/resignation of company officers

04/10/2006

Appointment/resignation of company officers

04/10/2006

Changes to the Board of Directors

04/10/2006

Minutes of Board meeting

04/10/2006

New chairman (CEO, CoB)

04/10/2006

Private document

04/10/2006

Amendment

04/10/2006

Minutes of Board meeting

31/12/2005

New accounts available

31/12/2004

New accounts available

17/02/2004

Appointment/resignation of company officers

17/02/2004

Minutes of Board meeting

17/02/2004

Private document

17/02/2004

Amendment

17/02/2004

Changes to the Board of Directors

31/12/2003

New accounts available

29/10/2003

Amendment

29/10/2003

Appointment/resignation of company officers

29/10/2003

Changes to the Board of Directors

29/10/2003

Minutes of Board meeting

29/10/2003

Minutes of general meeting of shareholders

29/10/2003

New auditor

29/10/2003

New chairman (CEO, CoB)

29/10/2003

New legal form – new category

29/10/2003

Private document

29/10/2003

Updated articles of association

18/07/2002

Minutes of general meeting of shareholders

18/07/2002

Appointment/resignation of company officers

18/07/2002

Amendment

18/07/2002

Private document

13/09/2001

Appointment/resignation of company officers

13/09/2001

Updated articles of association

13/09/2001

Private document

13/09/2001

Minutes of general meeting of shareholders

13/09/2001

Conversion of equity to euro

13/09/2001

Capital increase

31/08/2001

Private document

31/08/2001

Amendment

31/08/2001

Appointment/resignation of company officers

31/08/2001

Minutes of general meeting of shareholders

20/01/2000

Private document

20/01/2000

New chairman (CEO, CoB)

20/01/2000

Minutes of general meeting of shareholders

20/01/2000

Amendment

20/01/2000

Appointment/resignation of company officers

26/07/1999

New auditor

26/07/1999

Minutes of general meeting of shareholders

26/07/1999

Appointment/resignation of company officers

26/07/1999

Amendment

26/07/1999

Private document

23/07/1999

Amendment

23/07/1999

Private document

23/07/1999

Minutes of general meeting of shareholders

23/07/1999

Appointment/resignation of company officers

22/07/1999

Amendment

22/07/1999

Private document

22/07/1999

Minutes of general meeting of shareholders

22/07/1999

Appointment/resignation of company officers

19/03/1998

Minutes of general meeting of shareholders

19/03/1998

Appointment/resignation of company officers

19/03/1998

Amendment

19/03/1998

Private document

18/03/1998

Minutes of general meeting of shareholders

18/03/1998

New chairman (CEO, CoB)

18/03/1998

Private document

18/03/1998

Amendment

18/03/1998

Appointment/resignation of company officers

03/07/1997

Private document

03/07/1997

Minutes of general meeting of shareholders

03/07/1997

New auditor

03/07/1997

Amendment

03/07/1997

Appointment/resignation of company officers

28/02/1997

Minutes of general meeting of shareholders

28/02/1997

Private document

28/02/1997

Appointment/resignation of company officers

27/02/1997

New chairman (CEO, CoB)

27/02/1997

Minutes of general meeting of shareholders

27/02/1997

Appointment/resignation of company officers

27/02/1997

Amendment

27/02/1997

Private document

26/02/1997

Amendment

26/02/1997

Appointment/resignation of company officers

26/02/1997

Minutes of general meeting of shareholders

26/02/1997

Private document

25/02/1997

Appointment/resignation of company officers

25/02/1997

Amendment

25/02/1997

Minutes of Board meeting

08/10/1996

Private document

08/10/1996

Minutes of general meeting of shareholders

08/10/1996

Minutes of Board meeting

08/10/1996

Appointment/resignation of company officers

08/10/1996

Amendment

16/07/1996

Declaration of conformity

16/07/1996

Updated articles of association

16/07/1996

Private document

16/07/1996

New legal form – new category

16/07/1996

New company name

16/07/1996

Minutes of general meeting of shareholders

16/07/1996

Minutes of Board meeting

16/07/1996

Change to the administration of a public limited company

16/07/1996

Capital increase

16/07/1996

Appointment/resignation of company officers

16/07/1996

Amendment

09/07/1996

Audit or Management Report

09/07/1996

Amendment

10/05/1996

Amendment

10/05/1996

Audit or Management Report

09/04/1996

Amendment

09/04/1996

Appointment/resignation of company officers

09/04/1996

Minutes of general meeting of shareholders

09/04/1996

Changes to the Board of Directors

20/02/1996

Amendment

20/02/1996

Application and court order

06/04/1995

Amendment

06/04/1995

Changes to the Board of Directors

06/04/1995

Minutes of Board meeting

06/04/1995

New chairman (CEO, CoB)

06/04/1995

Appointment/resignation of company officers

05/04/1995

Amendment

05/04/1995

Minutes of Board meeting

05/04/1995

Changes to the Board of Directors

04/04/1995

Amendment

04/04/1995

Minutes of Board meeting

04/04/1995

Changes to the Board of Directors

23/08/1993

Amendment

23/08/1993

Appointment/resignation of company officers

23/08/1993

Changes to the Board of Directors

23/08/1993

Minutes of general meeting of shareholders

01/02/1993

Minutes of Board meeting

 

 

Establishment events history

 

Date

Description

26/03/2017

Update of phone numbers

20/11/2016

Update of phone numbers

31/03/2016

Update of phone numbers

25/12/2014

Update of phone numbers

22/02/2014

Update of phone numbers

02/01/2014

Modification of Head office

12/01/2013

Update of phone numbers

 

 

Financials

 

Synthesized Accounts

Annual Accounts

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2005

Account period (month)

12

12

12

Account Type

Normal

Normal

Normal

Date of capture

13/11/2017

25/01/2017

-

Activity Code

4619A

4619A

4619A

Employees

0

247

211

 

Active account

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Sector Average 2016

Sector Median 2016

Capital not called

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

969.08 0.97 K

0%

0 0 K

0%

Total fixed assets

24,307,607 24,308 K

23.6%

19,667,363 19,667 K

63.9%

12,001,539 12,002 K

5,053,126.95 5,053.13 K

381.0%

37,348 37 K

64985.0%

Intangible assets

6,909,135 6,909 K

17.8%

5,863,923 5,864 K

569.2%

876,197 876 K

578,982.59 578.98 K

1093.3%

8 0 K

86364087.5%

Tangible assets

10,385,422 10,385 K

-0.3%

10,417,832 10,418 K

78.1%

5,848,833 5,849 K

570,033.23 570.03 K

1721.9%

8,536 9 K

121573.3%

Financial assets

7,013,048 7,013 K

107.1%

3,385,609 3,386 K

-35.8%

5,276,509 5,277 K

3,904,274.12 3,904.27 K

79.6%

3,953 4 K

177310.8%

Net current assets

162,799,720 162,800 K

4.3%

156,123,594 156,124 K

36.8%

114,134,123 114,134 K

20,357,878.05 20,357.88 K

699.7%

842,780 843 K

19217.0%

Stocks

52,351,944 52,352 K

-13.4%

60,421,958 60,422 K

238.1%

17,873,036 17,873 K

2,189,817.71 2,189.82 K

2290.7%

0 0 K

0%

Advanced payments

2,250,725 2,251 K

258.9%

627,177 627 K

-74.6%

2,471,449 2,471 K

137,250.67 137.25 K

1539.9%

0 0 K

0%

Receivables

106,171,217 106,171 K

14.1%

93,079,451 93,079 K

0.3%

92,824,433 92,824 K

15,413,002.36 15,413.00 K

588.8%

440,285 440 K

24014.2%

Securities and cash

2,025,835 2,026 K

1.5%

1,995,007 1,995 K

106.7%

965,205 965 K

2,617,701.34 2,617.70 K

-22.6%

82,051 82 K

2369.0%

Prepaid expenses

- -

-

- -

-

- -

846.49 0.85 K

-

0 0 K

-

Accounts of regularization

0 0 K

0%

316,968 317 K

0%

0 0 K

5,881.89 5.88 K

0%

0 0 K

0%

Total Assets

187,107,327 187,107 K

6.2%

176,107,925 176,108 K

39.6%

126,135,662 126,136 K

25,416,936.55 25,416.94 K

636.2%

901,495 901 K

20655.2%

 

Passive Account

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Sector Average 2016

Sector Median 2016

Shareholders' equity

61,883,805 61,884 K

16.7%

53,027,605 53,028 K

110.6%

25,181,645 25,182 K

5,883,417.78 5,883.42 K

951.8%

241,515 242 K

25523.2%

Share capital

9,500,000 9,500 K

0%

9,500,000 9,500 K

11.8%

8,500,000 8,500 K

2,157,063.17 2,157.06 K

340.4%

50,000 50 K

18900.0%

Other capital resources

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

110,273.48 110.27 K

0%

0 0 K

0%

Risk Provisions

4,505,138 4,505 K

-5.8%

4,782,960 4,783 K

657.6%

631,292 631 K

672,986.92 672.99 K

569.4%

0 0 K

0%

Liabilities

120,718,385 120,718 K

2.0%

118,297,360 118,297 K

17.9%

100,322,727 100,323 K

18,763,014.19 18,763.01 K

543.4%

495,447 495 K

24265.6%

Financial liabilities

24,576,940 24,577 K

22.5%

20,060,341 20,060 K

56.0%

12,860,963 12,861 K

3,465,549.62 3,465.55 K

609.2%

22,085 22 K

111185.9%

Advanced payments received

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

126,690.63 126.69 K

0%

0 0 K

0%

Trade account payables

66,645,660 66,646 K

-9.7%

73,785,920 73,786 K

-8.6%

80,742,254 80,742 K

7,276,547.69 7,276.55 K

815.9%

166,271 166 K

39982.6%

Tax and social liabilities

7,274,717 7,275 K

-25.7%

9,785,129 9,785 K

151.8%

3,885,595 3,886 K

1,231,824.38 1,231.82 K

490.6%

103,426 103 K

6933.7%

Other debts and fixed assets liabilities

21,927,678 21,928 K

49.5%

14,665,971 14,666 K

621.8%

2,031,826 2,032 K

6,671,058.73 6,671.06 K

228.7%

21,735 22 K

100786.5%

Account regularization

293,390 293 K

0%

0 0 K

0%

802,089 802 K

184,181.83 184.18 K

59.3%

0 0 K

0%

Total liabilities

187,107,328 187,107 K

6.2%

176,107,925 176,108 K

39.6%

126,135,662 126,136 K

25,417,070.68 25,417.07 K

636.1%

901,494 901 K

20655.2%

 

Results

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Sector Average 2016

Sector Median 2016

Sales of Goods

1,029,841,948 1,029,842 K

8.4%

949,967,720 949,968 K

76.5%

538,278,514 538,279 K

35,999,328.16 35,999.33 K

2760.7%

1,115,923 1,116 K

92186.1%

Net turnover

1,020,353,406 1,020,353 K

8.9%

936,978,114 936,978 K

83.9%

509,529,464 509,529 K

35,309,157.55 35,309.16 K

2789.8%

999,258 999 K

102011.1%

of which net export turnover

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1,459,474.83 1,459.47 K

0%

0 0 K

0%

Operating charges

1,027,156,179 1,027,156 K

8.8%

943,834,380 943,834 K

75.3%

538,511,707 538,512 K

35,135,735.01 35,135.74 K

2823.4%

1,137,527 1,138 K

90197.3%

Operating profit/loss

2,685,769 2,686 K

-56.2%

6,133,340 6,133 K

2730.2%

-233,193 -233 K

863,590.32 863.59 K

211.0%

20,460 20 K

13027.2%

Financial income

20,242,115 20,242 K

45.3%

13,930,326 13,930 K

149.4%

5,585,963 5,586 K

570,009.21 570.01 K

3451.2%

678 1 K

2987666.1%

Financial charges

9,132,154 9,132 K

-35.6%

14,190,425 14,190 K

324.6%

3,342,188 3,342 K

668,298.85 668.30 K

1266.5%

418 0 K

2187242.3%

Financial profit/loss

11,109,961 11,110 K

4371.4%

-260,099 -260 K

-111.6%

2,243,775 2,244 K

-98,289.67 -98.29 K

11403.3%

0 0 K

0%

Pretax net operating income

13,959,853 13,960 K

130.2%

6,063,262 6,063 K

152.1%

2,405,539 2,406 K

695,068.51 695.07 K

1908.4%

25,795 26 K

54018.4%

Extraordinary income

286,000 286 K

1067.2%

24,503 25 K

-48.7%

47,755 48 K

369,395.39 369.40 K

-22.6%

108 0 K

265946.5%

Extraordinary charges

4,044,412 4,044 K

61816.9%

6,532 7 K

-97.2%

230,559 231 K

492,329.19 492.33 K

721.5%

744 1 K

543503.8%

Extraordinary profit/loss

-3,758,412 -3,758 K

-21013.8%

17,971 18 K

109.8%

-182,804 -183 K

-122,933.79 -122.93 K

-2957.3%

0 0 K

0%

Net result

6,271,019 6,271 K

80.0%

3,483,814 3,484 K

145.6%

1,418,600 1,419 K

334,636.65 334.64 K

1774.0%

24,275 24 K

25733.8%

 

Accounts - Active

Normal Account

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2005

Months

12

12

12

 

Grand Total - Active Accounts (I to VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Grand Total (I to VI)

Net

187,107,327 187,107 K

6.2%

176,107,925 176,108 K

39.6%

126,135,662 126,136 K

Gross

CO

240,449,560 240,450 K

8.3%

222,077,723 222,078 K

51.7%

146,383,761 146,384 K

Amortisation

1A

53,342,233 53,342 K

16.0%

45,969,798 45,970 K

127.0%

20,248,100 20,248 K

 

Non declared distributed capital (I)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Non declared distributed capital (I)

AA3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

AA

0 0 K

0%

0 0 K

-

- -

 

Active fixed asset (II)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Total Active fixed asset (II)

Net

24,307,607 24,308 K

23.6%

19,667,363 19,667 K

63.9%

12,001,539 12,002 K

Gross

BJ

63,123,461 63,123 K

18.0%

53,493,051 53,493 K

107.5%

25,776,895 25,777 K

Amortisation

BK

38,815,854 38,816 K

14.8%

33,825,688 33,826 K

145.6%

13,775,356 13,775 K

 

Intangible fixed assets

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Start-up cost

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

AB

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

AC

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

R&D expenses

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

CX

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

CQ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Distributorships, patents

Net

6,007,359 6,007 K

3.8%

5,787,566 5,788 K

612.9%

811,842 812 K

Gross

AF

28,406,407 28,406 K

16.2%

24,451,273 24,451 K

211.6%

7,847,634 7,848 K

Amortisation

AG

22,399,048 22,399 K

20.0%

18,663,707 18,664 K

165.3%

7,035,792 7,036 K

Goodwill

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

AH

484,917 485 K

0%

484,917 485 K

0%

0 0 K

Amortisation

AI

484,917 485 K

0%

484,917 485 K

0%

0 0 K

Other intangible fixed assets

Net

901,776 902 K

1081.0%

76,357 76 K

18.6%

64,355 64 K

Gross

AJ

901,776 902 K

1081.0%

76,357 76 K

18.6%

64,355 64 K

Amortisation

AK

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Pre-payments and downpayments

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

AL

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

AM

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Sub Total Intangible asset

Net

6,909,135 6,909 K

17.8%

5,863,923 5,864 K

569.2%

876,197 876 K

 

Tangible fixed assets

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Lands

Net

1,667,577 1,668 K

-2.6%

1,711,900 1,712 K

399.1%

343,010 343 K

Gross

AN

2,014,322 2,014 K

0%

2,014,322 2,014 K

422.5%

385,534 386 K

Amortisation

AO

346,745 347 K

14.7%

302,423 302 K

611.2%

42,524 43 K

Buildings

Net

7,367,061 7,367 K

-4.3%

7,698,246 7,698 K

63.5%

4,709,509 4,710 K

Gross

AP

16,896,010 16,896 K

3.0%

16,404,300 16,404 K

88.7%

8,691,484 8,691 K

Amortisation

AQ

9,528,948 9,529 K

9.5%

8,706,054 8,706 K

118.6%

3,981,975 3,982 K

Plant

Net

12,915 13 K

144.0%

5,292 5 K

-89.9%

52,512 53 K

Gross

AR

527,694 528 K

2.4%

515,522 516 K

59.8%

322,573 323 K

Amortisation

AS

514,779 515 K

0.9%

510,230 510 K

88.9%

270,061 270 K

Other tangible fixed assets

Net

1,114,978 1,115 K

12.4%

992,323 992 K

33.4%

743,802 744 K

Gross

AT

6,656,396 6,656 K

8.2%

6,150,680 6,151 K

92.9%

3,188,805 3,189 K

Amortisation

AU

5,541,417 5,541 K

7.4%

5,158,357 5,158 K

111.0%

2,445,003 2,445 K

Fixed assets in construction

Net

222,891 223 K

2113.2%

10,071 10 K

0%

0 0 K

Gross

AV

222,891 223 K

2113.2%

10,071 10 K

0%

0 0 K

Amortisation

AW

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Advances and payments on account

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

AX

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

AY

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Sub Total Tangible asset

Net

10,385,422 10,385 K

-0.3%

10,417,832 10,418 K

78.1%

5,848,833 5,849 K

 

Financial assets

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Associates at equity

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

CS

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

CT

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other participations

Net

6,177,617 6,178 K

438.3%

1,147,705 1,148 K

-73.7%

4,360,909 4,361 K

Gross

CU

6,177,617 6,178 K

438.3%

1,147,705 1,148 K

-73.7%

4,360,909 4,361 K

Amortisation

CV

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Inter-company receivables

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

915,600 916 K

Gross

BB

0 0 K

0%

0 0 K

0%

915,600 916 K

Amortisation

BC

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other investment securities

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

BD

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

BE

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Loans

Net

1,673 2 K

0%

1,673 2 K

0%

0 0 K

Gross

BF

1,673 2 K

0%

1,673 2 K

0%

0 0 K

Amortisation

BG

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other financial assets

Net

833,758 834 K

-62.7%

2,236,231 2,236 K

0%

0 0 K

Gross

BH

833,758 834 K

-62.7%

2,236,231 2,236 K

0%

0 0 K

Amortisation

BI

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Sub Total Financial assets

Net

7,013,048 7,013 K

107.1%

3,385,609 3,386 K

-35.8%

5,276,509 5,277 K

 

Current Assets (III)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Total Current Assets

Net

162,799,720 162,800 K

4.3%

156,123,594 156,124 K

36.8%

114,134,123 114,134 K

Gross

CJ

177,326,099 177,326 K

5.4%

168,267,704 168,268 K

39.5%

120,606,867 120,607 K

Amortisation

CK

14,526,379 14,526 K

19.6%

12,144,110 12,144 K

87.6%

6,472,744 6,473 K

 

Stocks

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Raw materials

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

59,796 60 K

Gross

BL

0 0 K

0%

0 0 K

0%

59,796 60 K

Amortisation

BM

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Work in progress (goods)

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

BN

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

BO

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Work in progress (services)

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

BP

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

BQ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Semi-finished and finished products

Net

351,023 351 K

-54.6%

773,930 774 K

0%

0 0 K

Gross

BR

552,212 552 K

-39.1%

906,121 906 K

0%

0 0 K

Amortisation

BS

201,190 201 K

52.2%

132,191 132 K

0%

0 0 K

Goods for resale

Net

52,000,921 52,001 K

-12.8%

59,648,028 59,648 K

234.9%

17,813,240 17,813 K

Gross

BT

57,096,991 57,097 K

-8.3%

62,257,671 62,258 K

230.5%

18,836,650 18,837 K

Amortisation

BU

5,096,070 5,096 K

95.3%

2,609,643 2,610 K

155.0%

1,023,410 1,023 K

Sub Total Stocks

Net

52,351,944 52,352 K

-13.4%

60,421,958 60,422 K

238.1%

17,873,036 17,873 K

 

Advance payments to suppliers

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Advance payments to suppliers

Net

2,250,725 2,251 K

258.9%

627,177 627 K

-74.6%

2,471,449 2,471 K

Gross

BV

2,250,725 2,251 K

258.9%

627,177 627 K

-74.6%

2,471,449 2,471 K

Amortisation

BW

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Debtors

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Trade accounts receivable

Net

88,496,408 88,496 K

46.9%

60,246,470 60,246 K

-28.0%

83,654,288 83,654 K

Gross

BX

97,626,068 97,626 K

40.4%

69,549,286 69,549 K

-21.8%

88,961,002 88,961 K

Amortisation

BY

9,129,660 9,130 K

-1.9%

9,302,816 9,303 K

75.3%

5,306,714 5,307 K

Other debtors

Net

17,258,753 17,259 K

-47.1%

32,620,265 32,620 K

259.7%

9,069,154 9,069 K

Gross

BZ

17,358,212 17,358 K

-46.9%

32,719,724 32,720 K

255.2%

9,211,774 9,212 K

Amortisation

CA

99,459 99 K

0%

99,459 99 K

-30.3%

142,620 143 K

Capital subscribed and called up

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

CB

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

CC

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Sub Total debtors

Net

105,755,161 105,755 K

13.9%

92,866,735 92,867 K

0.2%

92,723,442 92,723 K

 

Divers

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Investment securities

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

CD

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

CE

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Cash and cash equivalents

Net

2,025,835 2,026 K

1.5%

1,995,007 1,995 K

106.7%

965,205 965 K

Gross

CF

2,025,835 2,026 K

1.5%

1,995,008 1,995 K

106.7%

965,205 965 K

Amortisation

CG

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Sub Total Divers

Net

2,025,835 2,026 K

1.5%

1,995,007 1,995 K

106.7%

965,205 965 K

 

Prepaid expenses

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Prepaid expenses

Net

416,056 416 K

95.6%

212,716 213 K

110.6%

100,991 101 K

Gross

CH

416,056 416 K

95.6%

212,716 213 K

110.6%

100,991 101 K

Amortisation

CI

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Equalization accounts (IV to VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Expenses of loan issue to be spread

CW3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

0 0 K

0%

0 0 K

-

- -

Premiums on redemption of bonds

CM3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

0 0 K

0%

0 0 K

-

- -

Currency differential gain

CN3

0 0 K

0%

316,968 317 K

0%

0 0 K

Gross

0 0 K

0%

316,968 317 K

-

- -

 

References

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Due within one year

CP

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Due after one year

CR

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Accounts - Passive

Grand Total - Passive Accounts (I to V)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Grand Total (I to V)

EE

187,107,328 187,107 K

6.2%

176,107,925 176,108 K

39.6%

126,135,662 126,136 K

 

Shareholder Equity (I)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Total shareholders' equity (Total I)

DL

61,883,805 61,884 K

16.7%

53,027,605 53,028 K

110.6%

25,181,645 25,182 K

Equity and shareholders' equity

DA

9,500,000 9,500 K

0%

9,500,000 9,500 K

11.8%

8,500,000 8,500 K

Issue and merger premiums

DB

2,678,259 2,678 K

0%

2,678,259 2,678 K

77.9%

1,505,202 1,505 K

Revaluation differentials

DC

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Of which equity differential

EK

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Legal reserve

DD

950,000 950 K

0%

950,000 950 K

35.3%

702,207 702 K

Statutory or contractual reserve

DE

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Special regulated reserves

DF

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other reserves

DG

39,832,987 39,833 K

9.6%

36,349,173 36,349 K

179.7%

12,997,345 12,997 K

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Profits or losses brought forward

DH

3,391 3 K

0%

0 0 K

0%

-8,068 -8 K

Profit or loss for the period

DI

6,271,019 6,271 K

80.0%

3,483,814 3,484 K

145.6%

1,418,600 1,419 K

Investment grants

DJ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Special tax-allowable reserves

DK

2,648,149 2,648 K

3890.6%

66,359 66 K

0%

66,359 66 K

 

Other capital resources (II)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Total other capital resources (Total II)

DO

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Income from participating securities

DM

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Conditional loans

DN

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Provisions for risks and charges (III)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

4,505,138 4,505 K

-5.8%

4,782,960 4,783 K

657.6%

631,292 631 K

Risk provisions

DP

4,465,712 4,466 K

-5.9%

4,743,534 4,744 K

696.8%

595,322 595 K

Reserves for charges

DQ

39,426 39 K

0%

39,426 39 K

9.6%

35,970 36 K

 

Liabilities (IV)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Total Liabilities (Total IV)

EC

120,718,385 120,718 K

2.0%

118,297,360 118,297 K

17.9%

100,322,727 100,323 K

Convertible debentures

DS

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other debentures

DT

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Bank loans and liabilities

DU

22,833,035 22,833 K

29.4%

17,646,227 17,646 K

486.5%

3,008,743 3,009 K

Sundry loans and financial liabilities

DV

1,743,905 1,744 K

-27.8%

2,414,114 2,414 K

-75.5%

9,852,220 9,852 K

Of which participating loans

EI

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Advance payments received for current orders

DW

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Trade accounts payables

DX

66,645,660 66,646 K

-9.7%

73,785,920 73,786 K

-8.6%

80,742,254 80,742 K

Tax and social security liabilities

DY

7,274,717 7,275 K

-25.7%

9,785,129 9,785 K

151.8%

3,885,595 3,886 K

Fixed asset liabilities

DZ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

390,265 390 K

Other debts

EA

21,927,678 21,928 K

49.5%

14,665,971 14,666 K

793.4%

1,641,561 1,642 K

 

Translation loss (V)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Translation loss (Total V)

ED

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Equalization accounts

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Deferred income

EB

293,390 293 K

0%

0 0 K

0%

802,089 802 K

 

References

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Of which tax-allowable reserve

EF

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Deferred income and liabilities

EG

0 0 K

0%

0 0 K

0%

97,603,915 97,604 K

Of which current bank facilities

EH

0 0 K

0%

2,904,358 2,904 K

532.8%

458,999 459 K

 

Result account

1 - Operating result (I-II)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Operating result (Total I-II)

GG

2,685,769 2,686 K

-56.2%

6,133,340 6,133 K

2730.2%

-233,193 -233 K

 

2 - Financial result (V-VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Financial result (Total V-VI)

GV

11,109,961 11,110 K

4371.4%

-260,099 -260 K

-111.6%

2,243,775 2,244 K

 

3 - Pre-tax net operating income result (I to VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

13,959,853 13,960 K

130.2%

6,063,262 6,063 K

152.1%

2,405,539 2,406 K

 

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

-3,758,412 -3,758 K

-21013.8%

17,971 18 K

109.8%

-182,804 -183 K

 

Profit or loss

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Profit or loss

HN

6,271,019 6,271 K

80.0%

3,483,814 3,484 K

145.6%

1,418,600 1,419 K

 

Total Income (I+III+V+VII)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Total Income (Total I+III+V+VII)

HL

1,050,534,186 1,050,534 K

9.0%

964,112,570 964,113 K

77.1%

544,307,832 544,308 K

 

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

1,044,163,166 1,044,163 K

8.7%

960,628,755 960,629 K

76.9%

542,889,231 542,889 K

 

Operating income (I)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Total operating income (Total I)

FR

1,029,841,948 1,029,842 K

8.4%

949,967,720 949,968 K

76.5%

538,278,514 538,279 K

 

Operating income (details)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Sale of goods for resale

FC

968,817,194 968,817 K

8.7%

890,998,604 890,999 K

557.5%

135,515,835 135,516 K

France

FA

968,817,194 968,817 K

8.7%

890,998,604 890,999 K

557.5%

135,515,835 135,516 K

Export

FB

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Sale of goods produced

FF

1,438,755 1,439 K

-36.1%

2,251,003 2,251 K

0%

0 0 K

France

FD

1,438,755 1,439 K

-36.1%

2,251,003 2,251 K

0%

0 0 K

Export

FE

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Sale of services

FI

50,097,457 50,097 K

14.6%

43,728,507 43,729 K

-88.3%

374,013,629 374,014 K

France

FG

50,097,457 50,097 K

14.6%

43,728,507 43,729 K

-88.3%

374,013,629 374,014 K

Export

FH

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Net turnover

FL

1,020,353,406 1,020,353 K

8.9%

936,978,114 936,978 K

83.9%

509,529,464 509,529 K

France

FJ

1,020,353,406 1,020,353 K

8.9%

936,978,114 936,978 K

83.9%

509,529,464 509,529 K

Export

FK

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Stocked production

FM

-353,909 -354 K

-139.1%

906,121 906 K

-65.5%

2,623,796 2,624 K

Self-constructed assets

FN

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Operating grants

FO

1,000 1 K

118.3%

458 0 K

0%

0 0 K

Release of reserves and provisions

FP

9,618,495 9,618 K

-20.4%

12,082,639 12,083 K

347.8%

2,698,317 2,698 K

Other income

FQ

222,956 223 K

57511.4%

387 0 K

-100.0%

23,426,937 23,427 K

 

Operating charges (II)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Total operating charges (Total II)

GF

1,027,156,179 1,027,156 K

8.8%

943,834,380 943,834 K

75.3%

538,511,707 538,512 K

 

Exploitation charges

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Purchase of goods for resale

FS

923,884,436 923,884 K

7.0%

863,711,509 863,712 K

592.4%

124,746,233 124,746 K

Change in stocks of goods for resale

FT

5,160,667 5,161 K

168.9%

-7,488,325 -7,488 K

0%

0 0 K

Purchase of raw materials

FU

1,038,540 1,039 K

-57.8%

2,462,784 2,463 K

0%

0 0 K

Change in stocks of raw materials

FV

0 0 K

0%

484,810 485 K

0%

0 0 K

Other external purchases and charges

FW

61,982,018 61,982 K

14.5%

54,114,402 54,114 K

-86.2%

391,783,974 391,784 K

Tax, duty and similar payments

FX

2,091,845 2,092 K

21.4%

1,722,436 1,722 K

76.7%

974,577 975 K

Payroll

FY

13,848,845 13,849 K

13.4%

12,210,298 12,210 K

69.5%

7,202,417 7,202 K

Social security costs

FZ

6,041,350 6,041 K

9.2%

5,530,354 5,530 K

69.9%

3,254,859 3,255 K

 

Depreciation

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Depreciation of fixed assets

GA

4,207,964 4,208 K

63.9%

2,568,164 2,568 K

27.3%

2,016,834 2,017 K

Amortisation of fixed assets

GB

7,124,930 7,125 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Depreciation/amortisation of current assets

GC

1,360,281 1,360 K

-74.4%

5,315,432 5,315 K

307.4%

1,304,750 1,305 K

Provisions for risks and charges

GD

0 0 K

0%

1,428,472 1,428 K

-9.8%

1,583,846 1,584 K

 

Other charges

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Other charges

GE

415,303 415 K

-76.6%

1,774,043 1,774 K

-68.6%

5,644,217 5,644 K

 

Operating charges (III-IV)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

164,123 164 K

-13.6%

190,021 190 K

-52.0%

395,600 396 K

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0 0 K

0%

0 0 K

0%

642 1 K

 

Financial income (V)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Total financial income (Total V)

GP

20,242,115 20,242 K

45.3%

13,930,326 13,930 K

149.4%

5,585,963 5,586 K

Share financial income

GJ

212,586 213 K

-40.8%

359,160 359 K

0%

0 0 K

Other investment income & capitalised receivables

GK

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other interest and similar income

GL

10,042,803 10,043 K

19.5%

8,404,045 8,404 K

50.4%

5,585,963 5,586 K

Released provisions and transferred charges

GM

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Exchange gains

GN

9,986,726 9,987 K

93.3%

5,167,120 5,167 K

0%

0 0 K

Net income from disposal of investment securities

GO

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Financial charge (VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Total financial charge (Total VI)

GU

9,132,154 9,132 K

-35.6%

14,190,425 14,190 K

324.6%

3,342,188 3,342 K

Financial reserves and provisions

GQ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Interest and similar charges

GR

8,042,812 8,043 K

11.9%

7,187,632 7,188 K

115.1%

3,342,188 3,342 K

Exchange losses

GS

1,089,342 1,089 K

-84.4%

7,002,793 7,003 K

0%

0 0 K

Net loss from disposal of investment securities

GT

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Extraordinary income (VII)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Total extraordinary income (Total VII)

HD

286,000 286 K

1067.2%

24,503 25 K

-48.7%

47,755 48 K

Extraordinary operating income

HA

286,000 286 K

1486.6%

18,026 18 K

-51.0%

36,798 37 K

Extraordinary income from capital transactions

HB

0 0 K

0%

6,477 6 K

-40.9%

10,957 11 K

Released provisions and transferred charges

HC

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Extraordinary charges (VIII)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

4,044,412 4,044 K

61816.9%

6,532 7 K

-97.2%

230,559 231 K

Extraordinary operating charges

HE

1,462,622 1,463 K

449937.5%

325 0 K

-96.0%

8,113 8 K

Extraordinary charges from capital transactions

HF

0 0 K

0%

6,207 6 K

227.5%

1,895 2 K

Extraordinary reserves and provisions

HG

2,581,790 2,582 K

0%

0 0 K

0%

220,552 221 K

 

Employee profit sharing (IX)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

593,319 593 K

82.5%

325,125 325 K

329.0%

75,785 76 K

 

Tax on profits (X)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Tax on profits (Total X)

HK

3,237,102 3,237 K

42.5%

2,272,294 2,272 K

212.0%

728,350 728 K

 

References

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Of which equipment leases

HP

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Of which property leases

HQ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Of which transferred charges

A1

0 0 K

0%

2,886,948 2,887 K

0%

0 0 K

Of which trader's own contributions

A2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Other incomes tax return forms

Fixed Assets

Grand Total Fixed Assets (I to IV)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Gross value at begin of period

OG

0 0 K

0%

0 0 K

0%

26,483,048 26,483 K

Increasess due to revaluation

OH

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

2,394,815 2,395 K

Decreasess by budget item transfer

OK1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by transfers

OK2

0 0 K

0%

5,945,046 5,945 K

91.7%

3,100,970 3,101 K

Gross value at the end of period

OL

60,065,932 60,066 K

12.3%

53,493,050 53,493 K

107.5%

25,776,895 25,777 K

 

Research and development Charge (Total I)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Gross value at begin of period

CZ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increasess due to revaluation

KB

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by budget item transfer

CO1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by transfers

CO2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross value at the end of period

DO

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Gross value at begin of period

KD

25,012,546 25,013 K

18.6%

21,081,973 21,082 K

169.2%

7,832,287 7,832 K

Increasess due to revaluation

KE

5,086,443 5,086 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

305,889 306 K

-95.4%

6,612,986 6,613 K

1824.1%

343,693 344 K

Decreasess by budget item transfer

LV1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by transfers

LV2

0 0 K

0%

2,682,412 2,682 K

916.1%

263,990 264 K

Gross value at the end of period

LW

30,404,878 30,405 K

21.6%

25,012,547 25,013 K

216.1%

7,911,989 7,912 K

 

Tangible fixed assets (Total III)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Gross value at begin of period

LN

22,300,083 22,300 K

-7.9%

24,216,798 24,217 K

83.5%

13,196,424 13,196 K

Increasess due to revaluation

LO

953,965 954 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

29,389 29 K

-99.3%

4,138,610 4,139 K

264.5%

1,135,400 1,135 K

Decreasess by budget item transfer

NG1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by transfers

NG2

0 0 K

0%

3,260,514 3,261 K

87.0%

1,743,428 1,743 K

Gross value at the end of period

NH

23,283,437 23,283 K

-7.2%

25,094,894 25,095 K

99.3%

12,588,396 12,588 K

 

Financial assets (Total IV)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Gross value at begin of period

LQ

1,147,705 1,148 K

-33.7%

1,731,171 1,731 K

-68.3%

5,454,338 5,454 K

Increasess due to revaluation

LR

5,129,912 5,130 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

100,000 100 K

-94.0%

1,656,558 1,657 K

80.9%

915,722 916 K

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by transfers

NJ2

0 0 K

0%

2,120 2 K

-99.8%

1,093,551 1,094 K

Gross value at the end of period

NK

6,377,617 6,378 K

88.4%

3,385,609 3,386 K

-35.8%

5,276,509 5,277 K

 

Reserve for depreciation

Situation and movement of reserve for depreciation - Grand total (I-II-III)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Reserve for depreciation value at begin of period

ON

0 0 K

0%

0 0 K

0%

13,531,111 13,531 K

Increases

OP

0 0 K

0%

0 0 K

0%

2,237,387 2,237 K

Decreasess

OQ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

1,993,141 1,993 K

Reserve for depreciation value at the end of period

OR

0 0 K

0%

0 0 K

0%

13,775,356 13,775 K

 

Research and development charge (Total I)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increases

PB

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess

PC

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by budget item transfer

PD

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Other intangible assets (Total II)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

0 0 K

0%

0 0 K

0%

5,996,540 5,997 K

Increases

PF

0 0 K

0%

0 0 K

0%

1,290,860 1,291 K

Decreasess

PG

0 0 K

0%

0 0 K

0%

251,608 252 K

Decreasess by budget item transfer

PH

0 0 K

0%

0 0 K

0%

7,035,792 7,036 K

 

Total fixed assets amotisation (Total III)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

16 0 K

0%

0 0 K

0%

7,534,571 7,535 K

Increases

QV

60 0 K

0%

0 0 K

0%

946,527 947 K

Decreases

QW

0 0 K

0%

0 0 K

0%

1,741,533 1,742 K

Decreasess by budget item transfer

QX

76 0 K

0%

0 0 K

0%

6,739,563 6,740 K

 

Movements during period affecting charge allocated over several period

Deferred charges and debt issuance costs

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Gross value at begin of period

Z91

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increases

Z92

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by budget item transfer

B1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Premium refund of obligations

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Net value at begin of period

SP1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increases

SP2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Depreciation of fixed assets during period

SP

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Net value at the end of period

SR

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Provisions included in balance sheet

Grand Total (I-II-III)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Value at begining of period

7C

4,913,616 4,914 K

0%

0 0 K

0%

7,175,916 7,176 K

Increases

UB

9,239,330 9,239 K

0%

0 0 K

0%

2,888,596 2,889 K

Decreases

UC

3,454,804 3,455 K

0%

0 0 K

0%

2,894,117 2,894 K

Value at the end of period

UD

10,698,142 10,698 K

0%

0 0 K

0%

7,170,395 7,170 K

 

Includes Total allocations

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Operating

UE

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Financial

UG

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Exceptional

UJ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Includes Total Withdrawal

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Operating

UF

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Financial

UH

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Exceptional

UK

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Total regulated provisions (Total I)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Value at begining of period

3Z

66,359 66 K

0%

0 0 K

0%

66,359 66 K

Increases

TS

2,581,790 2,582 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreases

TT

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Value at the end of period

TU

2,648,149 2,648 K

0%

0 0 K

0%

66,359 66 K

 

Total risk and charge provisions (Total II)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Value at begining of period

5Z

2,005,964 2,006 K

0%

0 0 K

0%

621,056 621 K

Increases

TV

1,360,281 1,360 K

0%

0 0 K

0%

560,436 560 K

Decreases

TW

712,970 713 K

0%

0 0 K

0%

550,200 550 K

Value at the end of period

TX

2,653,275 2,653 K

0%

0 0 K

0%

631,292 631 K

 

Total Provision for depreciation (Total III)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Value at begining of period

7B

2,841,293 2,841 K

0%

0 0 K

0%

6,488,501 6,489 K

Increases

TY

5,297,259 5,297 K

0%

0 0 K

0%

2,328,160 2,328 K

Decreases

TZ

2,741,834 2,742 K

0%

0 0 K

0%

2,343,917 2,344 K

Value at the end of period

UA

5,396,718 5,397 K

0%

0 0 K

0%

6,472,744 6,473 K

 

State deadlines claims and debts at the end of period

State claims

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Gross value

VT

20,107,268 20,107 K

-80.8%

104,719,631 104,720 K

3.0%

101,660,816 101,661 K

1 year at most

VU

18,271,542 18,272 K

-82.2%

102,603,956 102,604 K

1340.9%

7,120,805 7,121 K

More than one year

VV

1,835,726 1,836 K

-13.2%

2,115,675 2,116 K

-97.8%

94,540,011 94,540 K

 

State of loans

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Claims related to holdings (gross)

UL

0 0 K

0%

0 0 K

0%

915,600 916 K

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0 0 K

0%

0 0 K

0%

915,600 916 K

Loans (gross)

UP

1,673 2 K

0%

1,673 2 K

0%

0 0 K

Loans (1 year at most)

UR

1,673 2 K

0%

1,673 2 K

0%

0 0 K

Other financial assets (gross)

UT

0 0 K

0%

2,236,231 2,236 K

0%

0 0 K

Other financial assets (1 year at most)

UV

0 0 K

0%

2,236,231 2,236 K

0%

0 0 K

 

Receivables statement of assets

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Customers doubtful or disputed

VA

1,835,726 1,836 K

-97.4%

69,549,286 69,549 K

0%

0 0 K

Other claims customer

UX

0 0 K

0%

0 0 K

0%

88,961,002 88,961 K

Receivables represent Loaned Securities

UU

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Provision for depreciation previously established

UQ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Personnel and associated accounts

UY

9,386 9 K

-53.6%

20,235 20 K

0%

0 0 K

Social Security and other social organizations

UZ

849 1 K

124.6%

378 0 K

0%

0 0 K

Income taxes

VM

471,098 471 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Value added tax

VB

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other taxes and payments assimilated

VN

24,504 25 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

State and other public - Miscellaneous

VP

2,122,765 2,123 K

-51.8%

4,404,656 4,405 K

0%

0 0 K

Group and Associates

VC

7,882,323 7,882 K

-51.9%

16,392,283 16,392 K

0%

0 0 K

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

7,342,888 7,343 K

-38.3%

11,902,172 11,902 K

381.6%

2,471,449 2,471 K

 

Prepaid

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Prepaid

VS

416,056 416 K

95.6%

212,716 213 K

110.6%

100,991 101 K

 

State Debt

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Total debt (gross)

VY

125,271,953 125,272 K

1.5%

123,455,758 123,456 K

23.1%

100,322,725 100,323 K

1 year at most

VZ2

114,471,086 114,471 K

3.2%

110,967,928 110,968 K

12.8%

98,406,005 98,406 K

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

9,769,438 9,769 K

69.1%

5,777,146 5,777 K

293.6%

1,467,709 1,468 K

More than 5 years

VZ4

1,031,429 1,031 K

-84.6%

6,710,684 6,711 K

1394.5%

449,012 449 K

 

Details

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Convertible bonds (gross)

7Y1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

7Y2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other bonds (gross)

7Z1

0 0 K

0%

5,158,397 5,158 K

0%

0 0 K

1 year at most

7Z2

0 0 K

0%

5,158,397 5,158 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

8,321,697 8,322 K

186.4%

2,905,906 2,906 K

533.1%

458,999 459 K

1 year at most

VG2

8,321,697 8,322 K

186.4%

2,905,906 2,906 K

533.1%

458,999 459 K

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

14,511,338 14,511 K

-1.6%

14,740,321 14,740 K

478.1%

2,549,744 2,550 K

1 year at most

VH2

3,710,471 3,710 K

64.7%

2,252,491 2,252 K

205.9%

736,410 736 K

More than 1 year and 5 years at most

VH3

9,769,438 9,769 K

69.1%

5,777,146 5,777 K

323.4%

1,364,321 1,364 K

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

3,837 4 K

-89.8%

37,782 38 K

-99.6%

9,852,220 9,852 K

1 year at most

8A2

3,837 4 K

-89.8%

37,782 38 K

-99.6%

9,748,833 9,749 K

More than 1 year and 5 years at most

8A3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

103,387 103 K

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

66,645,660 66,646 K

-9.7%

73,785,920 73,786 K

-8.6%

80,742,254 80,742 K

1 year at most

8B2

66,645,660 66,646 K

-9.7%

73,785,920 73,786 K

-8.6%

80,742,254 80,742 K

More than 1 year and 5 years at most

8B3

66,645,660 66,646 K

-9.7%

73,785,920 73,786 K

0%

0 0 K

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

2,554,628 2,555 K

20.5%

2,120,013 2,120 K

0%

0 0 K

1 year at most

8C2

2,554,628 2,555 K

20.5%

2,120,013 2,120 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

8,513,688 8,514 K

11.1%

7,665,116 7,665 K

97.3%

3,885,595 3,886 K

1 year at most

8D2

8,513,688 8,514 K

11.1%

7,665,116 7,665 K

97.3%

3,885,595 3,886 K

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Taxes on profits (gross)

8E1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

8E2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

VAT (Gross)

VW1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

VW2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Backed Obligations (gross)

VX1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

VX2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

759,969 760 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

VQ2

759,969 760 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

390,265 390 K

1 year at most

8J2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

390,265 390 K

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 5 years

8J4

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Groups and associates (gross)

VI1

1,740,068 1,740 K

-26.8%

2,376,332 2,376 K

0%

0 0 K

1 year at most

VI2

1,740,068 1,740 K

-26.8%

2,376,332 2,376 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 5 years

V14

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other liabilities (gross)

8K1

21,927,678 21,928 K

49.5%

14,665,971 14,666 K

793.4%

1,641,561 1,642 K

1 year at most

8K2

21,927,678 21,928 K

49.5%

14,665,971 14,666 K

793.4%

1,641,561 1,642 K

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

SZ2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Products in advance (gross)

8L1

293,390 293 K

0%

0 0 K

0%

802,089 802 K

1 year at most

8L2

293,390 293 K

0%

0 0 K

0%

802,089 802 K

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

References

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Loans made during the period

VJ

591,208,141 591,208 K

10006.1%

5,850,000 5,850 K

0%

0 0 K

Debt repaid during the period

VK

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Table allocation results and other information

Dividends distributed

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Dividends

ZE

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Commitments

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Commitments leasing furniture

YQ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Commitments Real Estate Leasing

YR

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Other charges Externes

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Subcontracting

YT

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Staff outside the company

YU

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Fees, commissions and brokerage

YV

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other accounts

ST

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Total Other purchases and external

ZJ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Taxes and Fees

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Business tax

YW

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other taxes and payments assimilated

9Z

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Total taxes and fees

YX

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

VAT

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Amount VAT collected

YY

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Total VAT on goods and services

YZ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

 

Average number of employees

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Average number of employees

YP

0 0 K

0%

247 0 K

17.1%

211 0 K

 

Groups and Shareholders

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Groups and Shareholders

ZR

0 0 K

-

- -

-

- -

 

Ratios

Synthetic financial performance indicators

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2005

Score

Situation

Score

Situation

Score

Situation

Hide AFDCC 2

-

-

-

-

-

-

Description

The AFDCC 2 score uses sectors of activity and company sizes for companies with a turnover of 150 000 to 75 million euros. This calculation allows a classification of the companies in three levels:

-

Healthy: the higher the score value is, the more the company is healthy.

-

Undetermined: it’s impossible to determine the situation.

-

Fragility/Failure: the lower the score value is, the more the company is in danger.

The status are completed which “+/-“ signs.

Hide Conan & Holder

0.05

60%

0.03

60%

0.27

0%

Description

The Conan and Holder (1979) is a recommended method for industrial companies with a turnover of 150 000 to 75 million euros. It is based only on a balance sheet. This calculation allows a classification of the most perilous situation (Score lower than 0.002) to the healthiest situation (score greater than 0.16):

-

Healthy situation: companies which maintain or develop their activity level.

-

Situation to monitor: companies which has to follow remedial measures or find a new strategy.

-

Perilous situation: companies which could have important cash difficulties and have a failure risk.

Hide Altman

-

-

-

-

-

-

Description

The Altman score is a method based only on a complete balance sheet, this calculation allows a classification of the companies in three levels:

-

Good shape: companies which have a low risk (with a score value higher than 2.99).

-

Warning signs: companies which should be approached with caution and with a high risk in the next two years for bankruptcy (with a score value between 2.99 and 1.81).

-

Bankruptcy: companies which are in immediate risk (with a score value lower than 1.81).

 

Structure and Liquidity

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Sector Average 2016

Sector Median 2016

Fixed Asset Financing

2.06

1.5%

2.03

0.5%

2.02

29.48

-93.0%

3.34

-38.3%

Global Debt

43 days

-4.4%

45 days

-36.6%

71 days

2,247,401.96 days

-100.0%

157 days

-72.6%

Working Capital Fund overall net

24 days

14.3%

21 days

10.5%

19 days

666,020.47 days

-100.0%

86 days

-72.1%

Financial independence

251.80 %

-4.7%

264.34 %

35.0%

195.80 %

28,329.71 %

-99.1%

282.88 %

-11.0%

Solvability

33.07 %

9.8%

30.11 %

50.9%

19.96 %

-9.70 %

440.9%

34.13 %

-3.1%

Capacity debt futures

514.32 %

-50.0%

1,027.99 %

-51.2%

2,106.53 %

235,521.23 %

-99.8%

2,126.90 %

-75.8%

Coverage of current assets by net working capital overall

37.68 %

14.5%

32.91 %

51.3%

21.75 %

-4.52 %

933.6%

40.14 %

-6.1%

General Liquidity

0.16

-82.6%

0.92

1214.3%

0.07

1.90

-91.6%

0.90

-82.2%

Restricted Liquidity

0.18

-80.9%

0.94

1075.0%

0.08

3.10

-94.2%

1.25

-85.6%

 

Management or rotation

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Sector Average 2016

Sector Median 2016

Need background in operating working capital

24 days

71.4%

14 days

0%

14 days

-91,747.40 days

100.0%

23 days

6.7%

Treasury

1 days

0%

0 days

0%

0 days

716,089.56 days

-100.0%

21 days

-95.2%

Inventory turnover of goods

22 days

-15.4%

26 days

-51.9%

54 days

161.00 days

-86.3%

21 days

4.8%

Average length of credit granted to customers

34 days

25.9%

27 days

-57.1%

63 days

2,139,674.13 days

-100.0%

80 days

-57.2%

Average length of credit obtained suppliers

24 days

-17.2%

29 days

-48.2%

56 days

491.64 days

-95.1%

64 days

-62.5%

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

0 days

0%

0 days

-

-

722.03 days

0%

0 days

0%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

4,382 days

17.4%

3,734 days

-

-

7,109.67 days

-38.4%

2,645 days

65.7%

Rotation tangible assets

4,382.31 %

17.4%

3,733.74 %

-7.8%

4,047.61 %

35,671.30 %

-87.7%

2,241.24 %

95.5%

 

Profitability of the business

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Sector Average 2016

Sector Median 2016

Margin trading

3.90 %

5.1%

3.71 %

75.8%

2.11 %

-2,744,716.21 %

100.0%

0.80 %

387.5%

Profitability of the business

0.58 %

5.5%

0.55 %

117.7%

-3.10 %

42,415.78 %

-100.0%

2.37 %

-75.5%

Net profit

0.61 %

64.9%

0.37 %

32.1%

0.28 %

29,513.28 %

-100.0%

1.90 %

-67.9%

Growth rate of turnover (excluding VAT)

8.90 %

-89.4%

83.89 %

3064.3%

-2.83 %

8.22 %

8.3%

0.86 %

934.9%

Rates integration

2.74 %

4.2%

2.63 %

405.8%

-0.86 %

73,743.57 %

-100.0%

18.52 %

-85.2%

Rate leasing furniture

0.00 %

0%

0.00 %

0%

0.00 %

0.11 %

0%

0.00 %

0%

Work Factor

71.20 %

-1.3%

72.12 %

130.2%

-238.92 %

205.41 %

-65.3%

61.32 %

16.1%

Weight interests

0.89 %

-41.1%

1.51 %

128.8%

0.66 %

1.43 %

-37.8%

0.04 %

2125.0%

 

Return on capital

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Sector Average 2016

Sector Median 2016

Cash flow from the overall profitability

1.98 %

204.6%

0.65 %

-9.7%

0.72 %

30,539.39 %

-100.0%

2.81 %

-29.5%

Rates of economic profitability

7.00 %

0%

7.00 %

116.7%

-42.00 %

8.36 %

-16.3%

8.00 %

-12.5%

Financial profitability

61,883,805.00 %

16.7%

53,027,605.00 %

110.6%

25,181,645.00 %

5,946,352.39 %

940.7%

219,883.00 %

28044.0%

Return on investment

17.82 %

-26.3%

24.18 %

93.3%

12.51 %

8.43 %

111.4%

9.16 %

94.5%

 

Management intermediate balances

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Sector Average 2016

Sector Median 2016

Turnover

1,020,353,406 1,020,353 K

8.9%

936,978,114 936,978 K

83.9%

509,529,464 509,529 K

35,309,157.55 35,309.16 K

2789.8%

999,258 999 K

102011.1%

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Sector Average 2016

Sector Median 2016

Sales of goods

968,817,194 968,817 K

8.7%

890,998,604 890,999 K

557.5%

135,515,835 135,516 K

-

-

- Purchase of goods

923,884,436 923,884 K

7.0%

863,711,509 863,712 K

592.4%

124,746,233 124,746 K

-

-

+/- Stock of goods variation

5,160,667 5,161 K

168.9%

-7,488,325 -7,488 K

0%

0 0 K

-

-

Trading margin

39,772,091 € 39,772 K €

14.4%

34,775,420 € 34,775 K €

222.9%

10,769,602 € 10,770 K €

1,459,511.32 € 1,459.51 K €

2625.0%

3,180 € 3 K €

1250594.7%

3.90 % CA 3.90 % CA

5.1%

3.71 % CA 3.71 % CA

75.8%

2.11 % CA 2.11 % CA

-2,941,377.85 % CA -2,941,377.85 % CA

100.0%

1.75 % CA 1.75 % CA

122.9%

 

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Sector Average 2016

Sector Median 2016

Sale of goods produced

51,536,212 51,536 K

12.1%

45,979,510 45,980 K

-87.7%

374,013,629 374,014 K

-

-

+/- Stocked production

-353,909 -354 K

-139.1%

906,121 906 K

-65.5%

2,623,796 2,624 K

-

-

+ Self-constructed assets

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

-

-

Period production

51,182,303 € 51,182 K €

9.2%

46,885,631 € 46,886 K €

-87.6%

376,637,425 € 376,637 K €

7,082,818.49 € 7,082.82 K €

622.6%

284,553 € 285 K €

17886.9%

5.02 % CA 5.02 % CA

0.4%

5.00 % CA 5.00 % CA

-93.2%

73.92 % CA 73.92 % CA

2,998,265.84 % CA 2,998,265.84 % CA

-100.0%

59.61 % CA 59.61 % CA

-91.6%

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Sector Average 2016

Sector Median 2016

Trading margin

39,772,091 39,772 K

14.4%

34,775,420 34,775 K

222.9%

10,769,602 10,770 K

1,459,511.32 1,459.51 K

2625.0%

3,180 3 K

1250594.7%

+ Period Production

51,182,303 51,182 K

9.2%

46,885,631 46,886 K

-87.6%

376,637,425 376,637 K

7,082,818.49 7,082.82 K

622.6%

284,553 285 K

17886.9%

- Purchase of raw materials

1,038,540 1,039 K

-57.8%

2,462,784 2,463 K

0%

0 0 K

-

-

+/- Change in stocks of raw materiels

0 0 K

0%

484,810 485 K

0%

0 0 K

-

-

- Other external purchases and charges

61,982,018 61,982 K

14.5%

54,114,402 54,114 K

-86.2%

391,783,974 391,784 K

-

-

Added value

27,933,836 € 27,934 K €

13.6%

24,599,055 € 24,599 K €

662.0%

-4,376,947 € -4,377 K €

2,654,788.87 € 2,654.79 K €

952.2%

205,176 € 205 K €

13514.6%

2.74 % CA 2.74 % CA

4.2%

2.63 % CA 2.63 % CA

405.8%

-0.86 % CA -0.86 % CA

73,743.57 % CA 73,743.57 % CA

-100.0%

18.52 % CA 18.52 % CA

-85.2%

 

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Sector Average 2016

Sector Median 2016

Added value

27,933,836 € 27,934 K €

13.6%

24,599,055 € 24,599 K €

662.0%

-4,376,947 € -4,377 K €

2,654,788.87 € 2,654.79 K €

952.2%

205,176 € 205 K €

13514.6%

+ Operating grants

1,000 1 K

118.3%

458 0 K

0%

0 0 K

-

-

- Tax, duty and similar payments

2,091,845 2,092 K

21.4%

1,722,436 1,722 K

76.7%

974,577 975 K

-

-

- Personal charges

19,890,195 19,890 K

12.1%

17,740,652 17,741 K

69.6%

10,457,276 10,457 K

-

-

Gross operating surplus

5,952,796 € 5,953 K €

15.9%

5,136,425 € 5,136 K €

132.5%

-15,808,800 € -15,809 K €

712,990.46 € 712.99 K €

734.9%

21,217 € 21 K €

27956.7%

0.58 % CA 0.58 % CA

5.5%

0.55 % CA 0.55 % CA

117.7%

-3.10 % CA -3.10 % CA

42,415.78 % CA 42,415.78 % CA

-100.0%

2.37 % CA 2.37 % CA

-75.5%

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Sector Average 2016

Sector Median 2016

Gross operating surplus

5,952,796 € 5,953 K €

15.9%

5,136,425 € 5,136 K €

132.5%

-15,808,800 € -15,809 K €

712,990.46 € 712.99 K €

734.9%

21,217 € 21 K €

27956.7%

+ Release of reserves and provisions

9,618,495 9,618 K

-20.4%

12,082,639 12,083 K

347.8%

2,698,317 2,698 K

-

-

+ Other operating income

222,956 223 K

57511.4%

387 0 K

-100.0%

23,426,937 23,427 K

-

-

- Depreciation/ Amortisation

12,693,175 12,693 K

36.3%

9,312,068 9,312 K

89.8%

4,905,430 4,905 K

-

-

- Other charges

415,303 415 K

-76.6%

1,774,043 1,774 K

-68.6%

5,644,217 5,644 K

-

-

Operating result

2,685,769 € 2,686 K €

-56.2%

6,133,340 € 6,133 K €

2730.2%

-233,193 € -233 K €

863,574.17 € 863.57 K €

211.0%

20,460 € 20 K €

13027.2%

0.26 % CA 0.26 % CA

-60.0%

0.65 % CA 0.65 % CA

1400.0%

-0.05 % CA -0.05 % CA

44,119.27 % CA 44,119.27 % CA

-100.0%

2.06 % CA 2.06 % CA

-87.4%

 

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Sector Average 2016

Sector Median 2016

Operating result

2,685,769 € 2,686 K €

-56.2%

6,133,340 € 6,133 K €

2730.2%

-233,193 € -233 K €

863,574.17 € 863.57 K €

211.0%

20,460 € 20 K €

13027.2%

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

164,123 164 K

-13.6%

190,021 190 K

-51.9%

394,958 395 K

-

-

+ Financial income

20,242,115 20,242 K

45.3%

13,930,326 13,930 K

149.4%

5,585,963 5,586 K

-

-

- Financial charges

9,132,154 9,132 K

-35.6%

14,190,425 14,190 K

324.6%

3,342,188 3,342 K

-

-

Pre-tax result

13,959,853 € 13,960 K €

130.2%

6,063,262 € 6,063 K €

152.1%

2,405,540 € 2,406 K €

695,052.30 € 695.05 K €

1908.5%

25,796 € 26 K €

54017.4%

1.37 % CA 1.37 % CA

110.8%

0.65 % CA 0.65 % CA

38.3%

0.47 % CA 0.47 % CA

44,178.53 % CA 44,178.53 % CA

-100.0%

2.55 % CA 2.55 % CA

-46.3%

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Sector Average 2016

Sector Median 2016

Extraordinary income

286,000 286 K

1067.2%

24,503 25 K

-48.7%

47,755 48 K

369,395.39 369.40 K

-22.6%

108 0 K

265946.5%

- Extraordinary charges

4,044,412 4,044 K

61816.9%

6,532 7 K

-97.2%

230,559 231 K

-

-

Extraordinary result

-3,758,412 € -3,758 K €

-21013.8%

17,971 € 18 K €

109.8%

-182,804 € -183 K €

-122,933.80 € -122.93 K €

-2957.3%

0 € 0 K €

0%

-0.37 % CA -0.37 % CA

0%

0.00 % CA 0.00 % CA

0%

-0.04 % CA -0.04 % CA

-132.68 % CA -132.68 % CA

99.7%

0.00 % CA 0.00 % CA

0%

 

 

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2005

Sector Average 2016

Sector Median 2016

Pre-tax result

13,959,853 € 13,960 K €

130.2%

6,063,262 € 6,063 K €

152.1%

2,405,540 € 2,406 K €

695,052.30 € 695.05 K €

1908.5%

25,796 € 26 K €

54017.4%

Extraordinary result

-3,758,412 € -3,758 K €

-21013.8%

17,971 € 18 K €

109.8%

-182,804 € -183 K €

-122,933.80 € -122.93 K €

-2957.3%

0 € 0 K €

0%

- Employee profit sharing

593,319 593 K

82.5%

325,125 325 K

329.0%

75,785 76 K

-

-

- Tax on profits

3,237,102 3,237 K

42.5%

2,272,294 2,272 K

212.0%

728,350 728 K

-

-

Net result

6,371,020 € 6,371 K €

82.9%

3,483,814 € 3,484 K €

145.6%

1,418,601 € 1,419 K €

334,919.86 € 334.92 K €

1802.3%

24,275 € 24 K €

26145.7%

0.62 % CA 0.62 % CA

67.6%

0.37 % CA 0.37 % CA

32.1%

0.28 % CA 0.28 % CA

29,514.15 % CA 29,514.15 % CA

-100.0%

1.90 % CA 1.90 % CA

-67.4%

 

 

Key Performance Indicators

 

Find below a comparison of the company based on the industry code (primary) with other companies from the same industry. The following analysis has been based on the industry code 4619A - Non food buying groups.

Key Performance Indicators

Graphical analysis

Net Turnover

 

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2005

Company Result

1,020,353,406 €

936,978,114 €

509,529,464 €

Sector Average

35,309,158 €

35,732,539 €

35,019,071 €

Net Profit

 

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2005

Company Result

6,271,019 €

3,483,814 €

1,418,600 €

Sector Average

334,637 €

312,951 €

977,346 €

Net Export Turnover

 

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2005

Company Result

0 €

0 €

0 €

Sector Average

1,459,475 €

3,054,820 €

649,112 €

Account Total

 

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2005

Company Result

187,107,328 €

176,107,925 €

126,135,662 €

Sector Average

25,417,071 €

22,451,213 €

21,349,879 €

Shareholders Equity

 

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2005

Company Result

61,883,805 €

53,027,605 €

25,181,645 €

Sector Average

5,883,418 €

5,681,122 €

4,919,865 €

Liabilities

 

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2005

Company Result

120,718,385 €

118,297,360 €

100,322,727 €

Sector Average

18,763,014 €

16,359,529 €

16,101,202 €

Need background in operating working capital

 

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2005

Company Result

24 €

14 €

14 €

Sector Average

-91,747 €

-1,349 €

258 €

Gross operating surplus (EBE)

 

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2005

Company Result

5,952,796 €

5,136,425 €

-15,808,800 €

Sector Average

712,990 €

852,755 €

970,176 €

 

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

INR 63.72

UK Pound

1

INR 88.64

Euro

1

INR 78.14

Euro

1

INR 78.19

 

Note : Above are approximate rates obtained from sources believed to be correct

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

PRA

 

 

Report Prepared by :

SYL

                                                


 

RATING EXPLANATIONS

 

Credit Rating

Explanation

Rating Comments

A++

Minimum Risk

Business dealings permissible with minimum risk of default

A+

Low Risk

Business dealings permissible with low risk of default

A

Acceptable Risk

Business dealings permissible with moderate risk of default

B

Medium Risk

Business dealings permissible on a regular monitoring basis

C

Medium High Risk

Business dealings permissible preferably on secured basis

D

High Risk

Business dealing not recommended or on secured terms only

NB

New Business

No recommendation can be done due to business in infancy stage

NT

No Trace

No recommendation can be done as the business is not traceable

 

NB is stated where there is insufficient information to facilitate rating. However, it is not to be considered as unfavourable.

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors are as follows:

 

·         Financial condition covering various ratios

·         Company background and operations size

·         Promoters / Management background

·         Payment record

·         Litigation against the subject

·         Industry scenario / competitor analysis

·         Supplier / Customer / Banker review (wherever available)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.